logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1198

8 juin 2010

SOMMAIRE

Ademus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57459

Äischer Pompjeeën asbl  . . . . . . . . . . . . . . . .

57489

Alcanada S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57504

Amadelux International S.à r.l.  . . . . . . . . . .

57487

Amazon Insurance & Pension Services S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57500

Aradco Holdings, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

57485

ARIA Structured Investments SICAV-SIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57503

Artbo SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57496

Association Luxembourgeoise de Crimino-

logie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57460

Azul Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57488

Azul Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

57488

Bâloise Assurances Luxembourg S.A.  . . . .

57499

Bâloise Europe Vie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

57499

Bâloise Vie Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . .

57496

Banque Privée Edmond de Rothschild Eu-

rope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57497

Banque Privée Edmond de Rothschild Eu-

rope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57497

Bellivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57498

Business Consulting Group, en abrégé

BCG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57502

Cofhylux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57503

Copri 3 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57498

Crosscapital Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57501

Dimmi Si Mersch S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57459

Encore Plus Real Estate Bad Cannstatt S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57460

Financière Star 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57488

Holmes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57495

Horacio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57499

House of Arts & Design S.à r.l.  . . . . . . . . . .

57459

Hyosung Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .

57501

Immobilière du 3 Joseph II  . . . . . . . . . . . . . .

57498

ING Belgium International Finance S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57502

International Helicopters S.A.  . . . . . . . . . . .

57461

International Helicopters S.à r.l. . . . . . . . . .

57461

JP Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57486

Kredietcorp S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57500

LCF Edmond de Rothschild Conseil . . . . . .

57497

Locationlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57458

Luxinvest S.A.Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57458

Majicaule International s.à r.l.  . . . . . . . . . . .

57500

Marcom House S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57503

Miladi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57503

Nordea Multi Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57501

Novotek Luxembourg Participations S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57484

Pian Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57458

PRI Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57486

Reipa Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57504

Remapa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57484

Scala IRP Capital Partners  . . . . . . . . . . . . . .

57496

Schloss Berkenburg Holding AG . . . . . . . . .

57460

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57472

Stardust Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

57471

Thermo-San S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57487

TM.A S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57472

Tropical Island S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57487

T.S.R. (Time Share Renting) S.A.  . . . . . . . .

57504

UPC DTH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57486

Vantage EBS Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57502

WE Brand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57472

Wigre S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57504

Worms & Cie S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57489

Xiam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57485

57457

Locationlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.209.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 26 mars 2010

- Il est pris acte de la démission de Monsieur Julien BELLONY de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.
- Madame Servane PAOLONI, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Julien BELLONY, démissionnaire, avec
ce jour, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2015.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2010.

Certifié sincère et conforme
LOCATIONLUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010059833/18.
(100059069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Luxinvest S.A.Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 6.537.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2010

Re-élection de Madame Arlette KORESH, née le 18 août 1956 à Metz, France, demeurant professionnellement à 6D

route de Trèves, 3 

e

 étage, L-2633 Senningerberg en tant que commissaire aux comptes à compter du 8 avril 2008 au 30

novembre 2012.

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
6D, route de Trèves
L-2633 SENNINGERBERG
LUXEMBOURG
<i>The domiciliation agent
Signature

Référence de publication: 2010059836/17.
(100059178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Pian Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 110.955.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 février 2010

Le mandat d'administrateur de Madame Sandrine ANTONELLI vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat d'administrateur de Madame Sandrine ANTONELLI est reconduit

jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

L'assemblée  générale  constate  le  changement  de  forme  juridique  de  la  société  TrustAudit  Sàrl,  commissaire  aux

comptes, suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue devant Maître Karine REUTER le 3 décembre 2008.

Extrait sincère et conforme
PIAN LUXEMBOURG S.A.
<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2010059838/18.
(100059213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57458

House of Arts &amp; Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 12, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.601.

<i>Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 28. Februar 2010

Ort: Geschäftslokal, Bereldange
Anwesende: Bazzucchi Rosanna, Wolff Alexander
Die Versammlung repräsentiert 99% des Gesellschaftskapitals und ist beschlussfähig.
Folgender Beschluss wurde gefällt:
1. Herr Wolff wird ab 01.03.2010 mit der alleinigen Geschäftsführung beauftragt und hat vollumfängliche Zeichnungs-

befugnisse für die Gesellschaft.

Herr Alexander Wolff ist wohnhaft in Route de Differdange 71, L-4437 Soleuvre.

Bereldange, den 28. Februar 2010.

Bazzucchi Rosanna / Wolff Alexander

Référence de publication: 2010059839/17.
(100059250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Ademus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.363.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 94.947.

EXTRAIT

En date du 28 avril 2010, Renestad Management Ltd, l'associé unique de la Société, a transféré toutes les 10.904 parts

sociales détenues dans la Société à Swanton Consulting Ltd, une limited company constituée sous les lois du Belize, ayant
son siège social à Suite 102 Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre &amp; Huston Streets, Belize City, Belize, inscrite
auprès du Companies Registry du Belize sous le numéro 77.611.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2010059842/17.
(100059294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Dimmi Si Mersch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7525 Mersch, 1, rue de Colmar-Berg.

R.C.S. Luxembourg B 142.194.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Mersch, le 15 avril 2010 à

11.00 heures.

Le conseil d'Administration a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
Est nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2014 statuant sur

les comptes de l'exercice social 2013:

la société à responsabilité limitée 'Bureau MODUGNO s.à. r.l., avec siège social à L-3313 BERGEM, 130, Grand-Rue,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 35889.

Et Lecture faite, le Conseil d'Administration a signé.

Mersch, le 15 avril 2010.

Signature
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010059843/19.
(100059358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57459

Encore Plus Real Estate Bad Cannstatt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.208.200,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.651.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 15 février 2010, que:
- M. William Gilson, ayant son adresse professionnelle au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 15 février 2010.

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet au 15 février 2010.

A Luxembourg, le 28 avril 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010059845/17.
(100059404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

ALC, Association Luxembourgeoise de Criminologie, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, Place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg F 490.

<i>Modification de statuts

Figurent ci-dessous les articles ou parties d'articles modifiés ou remplacés lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire,

du 18 novembre 2009, dûment convoquée et ayant délibéré conformément aux statuts et à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée.

(...)

Chapitre IV.- Administration

Art. 11. L'association est gérée par un conseil d'administration, ci-après dénommé «conseil», composé de trois mem-

bres au moins et de treize membres au plus, élus par l'assemblée générale. Le conseil comprend un/e présidente, un/e
secrétaire, un/e trésorier/e.

Les membres actifs sont électeurs et éligibles.
(...)

<i>Pour le Comité

Référence de publication: 2010059846/19.
(100059066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Schloss Berkenburg Holding AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 133.468.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung

<i>vom 28.04.2010 um 10.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1. Herr Fabrice BECQUER wurde aus seinem Amt als Verwaltungsrat abberufen.
2. Zum neuen Verwaltungsrat wurde bestellt:
Ute KLIMEK,
geb. am 04.08.1966 in Halle,
11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Das Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahr 2013 stattfindet.

Luxembourg, den 28.04.2010.

Unterschrift.

Référence de publication: 2010059902/17.
(100059781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57460

International Helicopters S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. International Helicopters S.A.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 152.881.

In the year two thousand and ten, on the seventh day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of INTERNATIONAL HELICOPTERS

S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and organised under the laws of Luxembourg,
having  its  registered  office  at  51,  avenue  J.-F.  Kennedy,  L-1855  Luxembourg,  in  the  process  of  registration  with  the
Luxembourg Register of Commerce and Companies, incorporated pursuant to a deed enacted by the undersigned notary
on 28 April 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

The Meeting is chaired by Marieke Kernet, attorney, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary, Annick Braquet, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer, Hana Witzke, attorney, with professional address in Luxembourg.
The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to as the Board of the Meeting.
The Board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to record that:
I The shareholders of the Company (the Shareholders) present or represented and the number of their shares are

shown on an attendance list. Such list and proxies, signed ne varietur by the Board of the Meeting and the undersigned
notary, shall remain attached to the present minutes;

II As appears from the attendance list, the three hundred and ten thousand (310,000) shares, representing the entire

share capital of the Company are represented at the present Meeting so that the Meeting can validly deliberate and decide
on all the items of the agenda of which the participants have been beforehand informed;

III The agenda of the Meeting is as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. change of the Company’s legal form from a public limited liability company (société anonyme) into a private limited

liability company (société à responsabilité limitée);

3. subsequent amendment and full restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the

above changes;

4. resignation of the directors of the Company under SA form; appointment of the same as managers of the Company

for an undetermined period;

5. revocation of KPMG Audit as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company;
6. amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration
of the above resolutions in the register of shareholders of the Company; and

7. miscellaneous.
IV Now, therefore, the Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company considering themselves duly

convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the legal form of the Company without discontinuance from its current legal form as

a public limited liability company (société anonyme) to change into a private limited liability company (société à respon-
sabilité  limitée).  It  furthermore  decides  the  denomination  into  International  Helicopters  S.àr.l.,  the  share  capital  and
purpose of the Company remaining unchanged.

As a result of the said transformation of the legal form of the Company into a private limited liability company (société

à responsabilité limitée), the three hundred and ten thousand (310,000) shares (actions) shall be exchanged against the
same number of new shares (parts sociales).

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to fully restate the articles of association of the

Company which shall henceforth be reworded as follows:

I. “Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “International Helicopters S.à r.l.” (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,

57461

in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated com-
panies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,
and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not to be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten thousand

(310,000) shares having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3 A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4 The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that

purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.

57462

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1 The Company is managed by the Board, appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of

their office. The managers need not be shareholders.

7.2 The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board.
8.1 Powers of the Board
8.1.1 All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence

of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

8.1.2 Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2 Procedure
8.2.1 The Board meets upon the request of any manager, at the registered office of the Company or at the place

indicated in the convening notice, which in principle, is in Luxembourg.

8.2.2 Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

8.2.3 No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full

knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a
meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.

8.2.4 A manager may grant a power of attorney to any other manager in order to be represented at any meeting of

the Board.

8.2.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.

8.2.6 Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

8.2.7 Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3 Representation
8.3.1 The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers.
8.3.2 The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be

read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3 The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1 Powers and voting rights
11.1.1 Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by

way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

11.1.2 Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions

is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the sha-
reholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

11.1.3 Each share entitles to one (1) vote.
11.2 Notices, quorum, majority and voting procedures

57463

11.2.1 The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

11.2.2 Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date

of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the
meeting.

11.2.3 General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
11.2.4 If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of

the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

11.2.5 A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in

order to be represented at any General Meeting.

11.2.6 Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

11.2.7 The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

11.2.8 Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2 Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions

is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1 The financial year begins on the first (1 

st

 ) of January and ends on the thirty-first (31 

st

 ) of December of each

year.

13.2Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1 The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises, when so required by

law.

14.2 The shareholders appoint the réviseurs d’entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d’entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

57464

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of the shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint
one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to
realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

Art. 17. General Provisions.
17.1 Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4 All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to accept the resignation, at the date hereof, of the directors of the Company, and to grant them

discharge for the performance of their duties. The Meeting further resolves to appoint the same as managers to the
Company for an unlimited period of time, being:

1. Mrs. Virginie Boussard, born on July 17, 1977 in Strasbourg, France, residing professionally at 51, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg;

2. Mr. Marco Pierettori, born on May 28, 1972 in Civitavecchia, Rome, Italy, residing professionally at 5, Via Nassa,

CH-6900 Lugano;

3. Mr. Michel Thill, born on June 8, 1965 in Arlon, Belgium, residing professionally at 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg;

4. Mr. Roger Neil Smith, born on June 17, 1956 in Darwen, United Kingdom, residing professionally at 1, Duchess

Street, GB – W1W 6AN London; and

5. Mr. John Mowinckel, born on July 6, 1950 in Rome, Italy, residing professionally at 1, Duchess Street, GB – W1W

6AN London.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to revoke KPMG Audit as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company effective

as the date hereof, and grant them discharge for the performance of their duties.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with

power and authority to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the above resolutions in the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately EUR 1,200.-.

57465

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between the
English and the French version, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le sept mai.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de INTERNATIONAL HELICOP-

TERS S.A., une société anonyme constituée et organisée selon le droit Luxembourgeois ayant son siège social au 51,
avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en cours d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 28 avril 2010, pas encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

L’assemblée est présidée par Marieke Kernet, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’Assemblée a choisit comme scrutateur Hana Witzke, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président, le secrétaire et le scrutateur sont collectivement désignés comme le Bureau de l’Assemblée.
Le Bureau de l’Assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I Les actionnaires de la Société (les Actionnaires) présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détien-

nent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, après avoir été signées ne
varietur par le Bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte;

II Tel qu’il ressort de la liste de présence, les trois cent dix mille (310.000) actions, représentant la totalité du capital

social de la Société, sont représentées à la présente Assemblée de sorte que l’Assemblée peut valablement délibérer sur
tous les points de l’ordre du jour, dont les participants ont été préalablement informés.

III L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. changement de la forme juridique de la Société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée;
3. modification subséquente et refonte totale des statuts de la Société afin de refléter les changements susmentionnés;
4. démission des administrateurs de la Société sous la forme juridique d’une SA; nomination de ceux-ci en qualité de

gérants de la Société pour une durée indéterminée;

5. révocation de KPMG Audit en tant que commissaire aux comptes de la Société;
6. modification des livres et registres de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, et pouvoir et autorité

donnés a tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l’enregistre-
ment des résolutions susmentionnées dans le registre des associés de la Société;

7. divers.
IV Sur ce, l’Assemblée a prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société se considérant eux-

mêmes  comme  ayant  été  dûment  convoqués  et  ayant  une  parfaite  connaissance  de  l’ordre  du  jour  qui  leur  a  été
communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de changer la forme juridique de la Société sans cessation de celle-ci de sa forme juridique actuelle

de société anonyme en une société à responsabilité limitée. Elle décide par ailleurs de changer la dénomination en Inter-
national Helicopters S.à r.l., le capital social et l’objet de la Société ne faisant pas l’objet de modifications.

En conséquence de ladite transformation de la forme juridique de la Société en une société à responsabilité limitée,

les trois cent dix mille (310.000) actions seront échangées contre le même nombre de nouvelles parts sociales.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l’Assemblée décide de reformuler intégralement les statuts de la Société

qui auront désormais le libellé suivant:

57466

I. "Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est “International Helicopters S.à r.l.” (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier, par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans la commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modifi-
cation des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

d’obligations et de titres et instruments de dette de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris
notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut
également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur la totalité
ou sur une partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trois cent dix mille (310.000) parts

sociales ayant une valeur nominale de dix centimes d’euros (EUR 0,10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

57467

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par le Conseil, dont les membres sont nommés par une résolution des associés, qui fixe la

durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance.
8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
8.1.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

8.1.2 Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2 Procédure
8.2.1 Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant, au siège soical de la Société ou au lieu indiqué dans l’avis de

convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

8.2.2 Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées dans la
convocation à la réunion.

8.2.3 Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à
une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions qui sont tenues dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

8.2.4 Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
8.2.5 Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

8.2.6 Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre

moyen de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre
et de se parler. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée
et tenue.

8.2.7 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation
8.3.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) gérants.
8.3.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est administrée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit

être considérée le cas échéant comme une référence à ce gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
11.1.1 Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par

voie de résolutions circulaires (les Résolutions circulaires des Associés).

57468

11.1.2 Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions

est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

11.1.3 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
11.2.1 Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou

des associés représentant plus de la moitié du capital social.

11.2.2 Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées
dans la convocation à ladite assemblée.

11.2.3 Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.
11.2.4 Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent eux-mêmes comme ayant été dûment

convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut être tenue sans convocation pré-
alable.

11.2.5 Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter

à toute Assemblée Générale.

11.2.6 Les décisions à adopter en Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées

par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social représenté.

11.2.7 Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

11.2.8 Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans

la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1 Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l’Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1 L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3 Chaque associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de résultats sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires

des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice social.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2 Les associés nomment les réviseurs d’entreprises, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation

cesse d’être exigée lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2 Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter conformément aux dispositions légales appli-
cables.

15.3 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
15.3.1 les comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

57469

15.3.2 ces comptes intérimaires montrent que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime

d’émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

15.3.3 la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

15.3.4 les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
15.3.5 si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice

social, les associés doivent reverser l’excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés, adoptée avec le consentement de

la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 17. Dispositions générales.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par l’un des moyens mentionnés ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions

du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
même document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’accepter la démission, à la date des présentes, des administrateurs de la Société, et de leur

accorder quitus pour l’exécution de leurs fonctions. L’Assemblée décide par ailleurs de nommer ceux-ci en qualité de
gérants de la Société pour une durée indéterminée, soit:

1. Mlle. Virginie Boussard, née le 17 juillet 1977 à Strasbourg, France, de résidence professionnelle au 51, avenue J.-F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg;

2. M. Marco Pierettori, né le 28 mai 1972 à Civitavecchia, Rome, Italie, de résidence professionnelle au 5, via Nassa,

CH-6900 Lugano;

3. M. Michel Thill, né le 8 juin 1965 à Arlon, Belgique, de résidence professionnelle au 51, avenue J.-F. Kennedy, L-1855

Luxembourg;

4. M. Roger Neil Smith, né le 17 juin 1956 à Darwen, Royaume-Uni, de résidence professionnelle au 1, Duchess street,

W1W 6AN, Londres; et

5. M. John Mowinckel, né le 6 juillet 1950 à Rome, Italie, de résidence professionnelle au 1, Duchess street, W1W

6AN, Londres.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de révoquer KPMG Audit de son mandat de commissaire aux comptes de la Société avec effet à

la date des présentes, et de leur accorder quitus pour l’exécution de leurs fonctions.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et donne

pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l’enregistrement des résolutions susmentionnées dans le registre des associés de la Société

57470

<i>Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte, s’élèvent à environ EUR 1.200,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente, qu’à la requête des parties

comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. KERNET, A. BRAQUET, H. WITZKE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 mai 2010. Relation: LAC/2010/21300. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 mai 2010.

Référence de publication: 2010059779/550.

(100074029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Stardust Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 142.807.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

<i>des actionnaires de STARDUST LUXEMBOURG SA tenue à Luxembourg le 14 avril 2010 à 15.00 heures

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 14 avril 2010 que:

Les Administrateurs suivants donnent leur démission:

- Monsieur Alain Robillard,

- Madame Pauline Baumgartner, et

- Madame Stéphanie David.

L'Assemblée décide à l'unanimité de la nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée qui prendra fin

à l'issue de l'Assemblée qui se tiendra en l'année 2014:

- Monsieur Matthieu BAUMGARTNER, Administrateur de société, né le 04.01.1969 à Paris, France; domicilié profes-

sionnellement au 9, rue Sainte Zithe, à L-2763 Luxembourg;

- Monsieur Jerome DAVID, Administrateur de société, né le 18.08.1971 à Caen, France; domicilié professionnellement

au 9, rue Sainte Zithe, à L-2763 Luxembourg;

- Monsieur Jales Bradley UNSWORTH, Administrateur de sociétés, né le 10.04.1959 à Kentville, Canada; domicilié

professionnellement au 208, Val des Bons Malades, à L-2121 Luxembourg.

L'Assemblée confirme que les mandats d'Administrateurs de Mademoiselle Valérie CZAPLA-STOEHR et de Monsieur

Kuy Ly ANG restent valides.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la société AUDIEX SA immatriculée au registre de commerce de

Luxembourg avec le n° B 65.469, ayant son siège social à 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg; pour une durée
qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Valérie CZAPLA-STOEHR.

Référence de publication: 2010059858/30.

(100059051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57471

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-

milial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 61.855.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 avril 2010

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2010:

- Monsieur Ramsay Abdallah EL KHOURY, demeurant professionnellement 1, Al-Arz, Saifi, Beyrouth 1107 2070, Liban,

administrateur-délégué, Président;

- Madame Doris EL KHOURY, demeurant professionnellement 1, Al-Arz, Saifi, Beyrouth 1107 2070, Liban;
- Madame Youmna EL KHOURY, demeurant Villa Khoury, RL-BP11-1036 Yarzé, Liban.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire sur les comptes

annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 avril 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010059860/20.
(100059016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

TM.A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 90.616.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration en date du 13 avril 2010

Est élu Président du Conseil d'administration Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

qui déclare accepter.
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010059854/16.
(100059077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

WE Brand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 152.680.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twelfth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Waalfin Holding S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg with registered office at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 57.449,

represented by Mr. Alexander Koch, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

by virtue of a proxy, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned
notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation

of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which it declares to establish as follows:

57472

Chapter I. Form, Corporate Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscriber and all those who may become

owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended,
and by the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company exists under the name of "WE Brand S.à r.l.".

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the

case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the
municipality of the Company's registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,

economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons
abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such
temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer
of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Corporate Object. The object of the Company is the acquisition, assignment, development, ownership and

exploitation of patents, licenses, designs, trademarks, copyrights, and other rights of intellectual property as well as the
exercise of all rights deriving from or pertaining to any of the aforesaid.

This includes, but is not limited to the registration, protection, maintenance of the intellectual property rights as well

as registering the trademarks and other the intellectual property rights, controlling such registration and their terms and
use as well as the identification of and legal action against any infringement of intellectual property rights.

The Company shall also be in charge of the strategic management of the intellectual property rights including but not

limited to the management of the relationship with all existing and prospective licensees and the management of the sub-
licensing contracts and activities.

The Company shall invoice, collect and disburse royalties.
The Company shall further accomplish, in Luxembourg or abroad, in its own name and on its own behalf or in the

name and on behalf of third parties all operations which are directly or indirectly related to the purchase and sale,
importation and exportation, trade, fabrication, transformation and repair of all fashion material and accessories.

In general, the Company may carry out any industrial, commercial or financial operations and engage in such other

activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accom-
plishment and development of the foregoing.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of

indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may, in any manner, acquire an interest in or co-operate or merge with any association, business,

enterprise or company having an identical, similar or related purpose or one that is liable to facilitate its business and /
or develop the sale of its services.

The Company may realize its object in any manner and in accordance with such terms as it finds suitable.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Share Capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at one million euro (EUR 1,000,000.-) divided into one

million (1,000,000) shares, with a par value of one euro (EUR 1) each.

In addition to the share capital a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition

to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any
shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to
the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. All the shares will be and remain in registered form.
When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst share-

holders.  The  shares  may  be  transferred  to  non-shareholders  only  with  the  authorisation  of  the  general  meeting  of
shareholders representing at least three quarters of the share capital.

The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance
with article 1690 of the Civil Code.

57473

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the

Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The subscribed share capital of the Company may be increased

or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any
amendment of these Articles.

Chapter III. Management, Board of Managers, Auditors

Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the

"Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of
Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of share-

holders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate.
The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of
the general meeting of shareholders.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental

to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise

the power granted by the Law to the Board of Managers.

The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman. The Chairman will preside at all meetings of the

Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore
by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.

The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his

representative.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In

case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a duly convened

and held meeting of the Board of Managers. Such a decision can be constituted of a single document or of several separate
documents all having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as

the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at
the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board

of Managers or by any two Managers.

Art. 11. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with

the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal
nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to
the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers

and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a

57474

Manager or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and

determine their composition and purpose.

Art. 13. Representation of the Company. Should only one Manager have been appointed, the Company will be bound

toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any
person(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Should the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards

third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint signatures or single signature of any person
(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other
company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm
with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically
prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the

Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company,
concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of
any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's
interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of share-
holders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party,
other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Com-
pany's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is
conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder or,
as the case may be, the general meeting of shareholders.

Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and her/his heirs, executors and administrators,

for expenses reasonably incurred by her/him in connection with any action, suit or procedure to which s/he may be made
a party by reason of her/his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of
which the Company is a shareholder or creditor and by which s/he is not entitled to be indemnified, except for such
action, suit or procedure in relation to matters for which s/he be held liable for gross negligence or misconduct. In the
event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal
counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which the relevant person may be entitled.

Art. 16. Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be if the Company has more

than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of

shareholders, which will determine the number of auditors, if applicable, the remuneration of the auditors and the duration
of their mandate. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of
their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as
the case may be, of the general meeting of shareholders.

Chapter IV. Meetings of Shareholders

Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than

twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the meeting on 10 June of each year, at 10 a.m.

If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The shareholders may hold general meetings of shareholders to be

convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s),
if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not

compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretion

of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

57475

The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.

Art. 20. Procedure, Vote. The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the

case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share
capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.

The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the date, time, place and agenda of the

meeting.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his

proxy who need not be a shareholder.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled

in order to take part in a general meeting of shareholders.

Any general meeting of shareholders shall be presided by the chairman of the Board of Managers or, in his absence,

by any other person appointed by the general meeting of shareholders.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).
The chairman of the meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed, form

the bureau of the general meeting.

An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the

name of their representatives, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as
the case may be, their representatives.

One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.
Except if is otherwise required by the Law, any amendment to the present Articles shall be approved by a majority of

shareholders representing three-quarters of the corporate capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by the majority

of shareholders representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at
the first meeting, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

Art. 21. Minutes of Shareholders' Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case

may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may
be, by the bureau of the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general

meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of
Managers or by any two Managers.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the

last day of the month of December every year.

Art. 23. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager or,

as the case may be, the Board of Managers, draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit
and loss account of the Company in accordance with the Law and submits them to the sole shareholder or, as the case
may be, to the general meeting of shareholders and, as the case may be, the auditor(s), for approval.

Each shareholder or its/her/his representative may inspect these financial documents at the registered office of the

Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised
within a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 24. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to

the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts
to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder

of the annual net profits will be allocated. It/s/he may decide to use the whole or part of the remainder to existing losses,
if any, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as dividend.

Art. 25. Interim Dividends. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim

dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the
Company has sufficient available funds for such a distribution.

57476

Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the Company

Art. 26. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case

may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these
Articles, unless otherwise provided for by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining

to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro
rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the ap-

plicable Law.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed and fully paid, including a

share premium in the amount of sixty-two million six hundred and eighty thousand euro (EUR 62,680,000), by a contri-
bution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of (i) all rights, title and interest held by the appearing party in the
trademark "WE" filed on 8 May 2004 under trademark application no. 4048144 and registered on 28 December 2007 in
class 25 with the China Trademark Office, any applicable priority rights pertaining to said trademark, registrations ensuing
from applications for said trademark and any unregistered rights held by the appearing party in the trademark "WE", to
be transferred to the Company at their aggregate value amounting to one hundred and fifty thousand euro (EUR 150,000),
(ii) the trademark rights including applications for the registration of such rights and applicable priority rights described
in Annex 1 to this notarial deed, (iii) the trademark rights including applications for the registration of such rights and
applicable priority rights described in Annex 2 to this notarial deed and (iv) all intellectual property rights, such as copy-
rights and design rights with respect to the products such as store designs created on the basis of designing work as to
the interior and exterior appearance of the property consisting of the Nijmegen store (the Netherlands) and the Brussels
Woluwe store (Belgium) of WE Europe, a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands
whose registered office is at Reactorweg 101, 3542 AD, Utrecht, the Netherlands, each with approximately 700 sq.m.,
performed by Wonderwall Inc., a company incorporated under the laws of Japan whose registered office is at 1-21-18
Ebisu-minami Shibuya-ku, Tokyo, Japan and Mr. Masamichi Katayama, the aforementioned rights under items (ii), (iii) and
(iv) to be transferred to the Company at their aggregate value amounting to sixty-three million five hundred and thirty
thousand euro (EUR 63,530,000), the number of shares mentioned hereafter:

Shareholders

Number

of shares

Subscribed

capital

Waalfin Holding S.A., mentioned above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 EUR 1,000,000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 EUR 1,000,000

The appearing party, represented as above mentioned, declared that there exist no impediments to the free disposal

of the Contribution in Kind and to undertake to do whatever is necessary to transfer full ownership of the Contribution
in Kind to the Company.

The appearing party, represented as above mentioned, further declared that the aggregate value of the Contribution

in Kind is sixty-three million six hundred and eighty thousand euro (EUR 63,680,000). This aggregate value has been
confirmed by the appearing party in a declaration of contribution dated 12 April 2010.

The undersigned notary states that the conditions set forth in article 183 of the Law have been fulfilled and expressly

bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this deed are estimated at approximately 7,000.- EUR.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2010.

<i>Extraordinary General Meeting

The abovementioned shareholder, representing the entire subscribed capital, immediately held a first general meeting

of shareholders and passed the following resolutions:

1. Resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for

an unlimited period:

57477

- Mr. Raymond Hegarty, company director, born on 21 July 1964 in Cork, Ireland, with professional address at 17, rue

Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Gert van Noord, company director, born in Punta Cardon, Venezuela, on 27 November 1952, with professional

address at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Victor Hoogstraal, born in Zurich, Switzerland, on 10 December 1951, with professional address at 26, Heuels-

trasse, 8032 Zurich, Switzerland.

2. Resolved that the registered office shall be at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above person,

the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person present, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzehn, am zwölften April.
Vor Uns, Joseph Elvinger, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Waalfin Holding S.A., eine unter luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit einge-

tragenem Sitz in der 17, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen
Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 57.449,

vertreten durch Herrn Alexander Koch, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

aufgrund einer Vollmacht, die, nach Paraphierung und Unterzeichnung "ne varietur" durch den Bevollmächtigten und den
unterzeichnenden Notar, zur Eintragung an diese Urkunde angeheftet bleibt.

Diese Partei, vertreten wie oben ausgeführt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die folgende Gründungssatzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) auszufertigen, die, wie sie erklärt, folgen-
dermaßen lautet:

Kapitel I. Form, Firma, Eingetragener Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Firma. Es wird hiermit von dem Zeichner und all denjenigen, die Eigentümer der hiernach begebenen

Geschäftsanteile werden mögen, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée) gegründet (die "Gesellschaft"), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, und insbesondere
der geänderten Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 bzgl. Handelsgesellschaften (das "Gesetz"), der geänderten
Fassung des Artikels 1832 des Zivilgesetzbuches, und der vorliegenden Satzung unterliegen wird (die "Satzung").

Die Gesellschaft besteht unter der Firma "WE Brand S.à r.l.".

Art. 2. Eingetragener Sitz. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Alleinge-

schäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung ist berechtigt, die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft
innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft zu ändern.

Zweigstellen und andere Geschäftsstellen können entweder in dem Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland

durch Beschluss des Alleingeschäftsführers bzw. der Gesamtgeschäftsführung errichtet werden.

Falls  nach  Ansicht  des  Alleingeschäftsführers  bzw.  der  Gesamtgeschäftsführung  außergewöhnliche  politische,  wirt-

schaftliche oder soziale Entwicklungen auftreten oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Aktivitäten der
Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die Kommunikation mit besagtem Sitz oder zwischen besagtem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen würden, kann dieser bzw. können diese vorübergehend den eingetragenen Sitz ins
Ausland  verlegen,  bis  zum  Ende  dieser  ungewöhnlichen  Umstände.  Solche  vorübergehende  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des eingetragenen
Sitzes, eine dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftsgegenstand. Gesellschaftsgegenstand ist der Erwerb, die Abtretung, die Entwicklung, der Besitz

und  die  Verwertung  von  Patenten,  Lizenzen,  Mustern,  Marken,  Urhueberrechten  und  anderen  Rechten  an  geistigem
Eigentum sowie die Ausübung aller aus dem Vorstehendem abgeleiteten oder betreffenden Rechte.

Dies schließt den Schutz, die Verwaltung der Rechte an geistigem Eigentum sowie die Registrierung von Marken und

anderen Rechten an geistigem Eigentum, die Kontrolle solcher Registrierung und ihrer Bedingungen und den Gebrauch
wie auch die Ermittlung von jedwedem und das gerichtliche Vorgehen gegen jedweden Verstoß gegen Rechte an geistigem
Eigentum ein, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein.

Die Gesellschaft ist zudem zuständig für das strategische Management der Rechte an geistigem Eigentum einschließlich,

ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, des Managements der Beziehungen zu allen bestehenden und zukünftigen Lizenz-
nehmern und des Managements der Unterlizenzverträge und der Tätigkeiten bzgl. der Unterlizenzen.

57478

Die Gesellschaft wird Lizenzgebühren in Rechnung stellen, einziehen und ausbezahlen.
Die Gesellschaft wird des Weiteren, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung oder im Namen und auf Rechnung

Dritter, alle Tätigkeiten, in Luxemburg und im Ausland, durchführen, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den Kauf
und Verkauf, Import und Export, Handel, Herstellung, Umwandlung und Ausbesserung jedweder Modeartikel und Ac-
cessoires beziehen.

Allgemein kann die Gesellschaft jedwede industrielle, gewerbliche oder Finanztätigkeiten ausüben und solch anderen

Tätigkeiten betreiben wie sie die Gesellschaft für notwendig, ratsam, dienlich für, zusammenhängend mit, oder nicht
unvereinbar mit, dem Erreichen und der Entwicklung des Vorhergehenden hält.

Die Gesellschaft kann Pfand geben, Garantien, dingliche Sicherungsrechte, Hypotheken und jede andere Form von

Sicherheiten sowie jede Form von Haftungsfreistellung gewähren, hinsichtlich ihrer eigenen Verpflichtungen und Schulden.

Die Gesellschaft kann, auf jede beliebige Art, Beteiligungen an jedweder Vereinigung, jedwedem Geschäft, Unterneh-

men oder jedweder Gesellschaft mit identischem, ähnlichem oder verwandtem Zweck, oder an einer bzw. einem solchen,
die bzw. das ihr Geschäft zu erleichtern und / oder den Verkauf ihrer Dienstleistungen zu fördern geeignet ist erwerben
oder mit einer bzw. einem solchen zusammenarbeiten oder fusionieren.

Die Gesellschaft kann ihren Zweck auf jede beliebige Art und in Einklang mit den Bedingungen, die sie für angemessen

hält, umsetzen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.

Kapitel II. Stammkapital, Anteile

Art. 5. Stammkapital. Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-),

unterteilt in eine Million Euro (1.000.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1).

Zusätzlich zu dem Stammkapital kann ein Prämienkonto eingerichtet werden, auf welches das auf jedweden Anteil über

den jeweiligen Nennwert hinaus gezahlte Aufgeld überwiesen wird. Der Betrag des Prämienkontos kann zur Bezahlung
jedweder Anteile, die die Gesellschaft von ihren Anteilseigner(n) zurückkaufen kann, zur Aufrechnung mit realisierten
Nettoverlusten, zu Ausschüttungen an die Anteilseigner oder zur Zuteilung an die gesetzliche Rücklage verwendet wer-
den.

Art. 6. Anteile. Alle Anteile sind und bleiben in eingetragener Form.
Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, kann der Alleingesellschafter seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, können die Anteile nur unter den Anteilseignern frei übertragen

werden. Anteile an Nichtanteilseigner können nur mit Genehmigung der Hauptversammlung der Anteilseigner, die min-
destens 3/4 des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten, übertragen werden.

Die Übertragung der Anteile erfolgt durch notarielle oder Privaturkunde. Eine solche Übertragung bindet die Gesell-

schaft und Dritte nur, wenn die Gesellschaft ordnungsgemäß benachrichtigt oder von der Gesellschaft akzeptiert wurde,
gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuchs.

Jeder Anteil ist unteilbar, insoweit es die Gesellschaft betrifft. Miteigentümer müssen gegenüber der Gesellschaft durch

einen gemeinsamen Bevollmächtigten, ob unter ihnen ernannt oder nicht, vertreten werden. Die Gesellschaft ist berech-
tigt, die Ausübung aller Rechte bezüglich des jeweiligen Anteils auszusetzen, bis ein gemeinsamer Bevollmächtigter ernannt
worden ist.

Art. 7. Erhöhung und Reduzierung des Stammkapitals. Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft kann durch

Beschluss des Alleingesellschafters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mit dem Quorum und den Mehr-
heitsregeln gemäß dieser Satzung bzw. des Gesetzes abstimmt, ein- oder mehrmalig erhöht oder reduziert werden.

Kapitel III. Geschäftsführung, Gesamtgeschäftsführung, Abschluss-Prüfer

Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem (der "Alleingeschäftsführer") oder mehreren Geschäfts-

führern geleitet, ob Gesellschafter oder nicht (der / die "Geschäftsführer"). Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt
worden sind, bilden die Geschäftsführer ein Leitungsgremium (die "Gesamtgeschäftsführung").

Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung wird von dem Alleingesellschafter bzw. von der Haupt-

versammlung der Gesellschafter ernannt, der bzw. die ihre Anzahl, ihre Bezahlung und die befristete oder unbefristete
Dauer ihres Mandats festlegt. Die Geschäftsführer üben ihr Amt bis zur Wahl ihrer Nachfolger aus. Sie können am Ende
ihres Mandats wiedergewählt und mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters bzw. der Haupt-
versammlung der Gesellschafter abgelöst werden.

Der bzw. die Geschäftsführer sind auch nach Ablauf ihrer Amtszeit gehalten, ihnen zugänglich gemachte Informationen

über die Gesellschaft, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, nicht offen zu legen, außer wenn eine solche
Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist.

Art. 9. Sitzungen der Geschäftsführung. Wenn die Gesellschaft aus einem Alleingeschäftsführer besteht, übt dieser die

Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesamtgeschäftsführung zugesteht.

57479

Die Gesamtgeschäftsführung ernennt aus ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Sie kann zudem

einen Schriftführer ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und verantwortlich für die Protokollierung der Sitzungen
der Gesamtgeschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Gesamtgeschäftsführung versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden. Der Vorsitzende führt den

Vorsitz bei allen Sitzungen der Gesamtgeschäftsführung. In seiner / ihrer Abwesenheit kann die Gesamtgeschäftsführung
durch Mehrheitswahl der bei dieser Sitzung Anwesenden oder Vertretenen einen anderen Geschäftsführer als Vorsit-
zenden pro tempore ernennen.

Außer bei Dringlichkeit oder bei vorheriger Zustimmung aller zur Teilnahme Berechtigter, ist über Sitzungen der

Gesamtgeschäftsführung mit einer Frist von mindestens vierundzwanzig (24) Stunden schriftlich zu benachrichtigen. Jede
solche schriftliche Benachrichtigung gibt den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung an.

Auf die Benachrichtigung kann durch einstimmiges schriftliches Einverständnis aller Geschäftsführer in der Sitzung oder

anderweitig verzichtet werden. Eine gesonderte Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten
abgehalten werden, die in einem durch Geschäftsführungsbeschluss vorher genehmigten Zeitplan enthalten sind.

Jede Sitzung der Gesamtgeschäftsführung ist in Luxemburg oder an dem in der Einladung angegebenen Ort abzuhalten.
Jeder Geschäftsführer kann auf jeder Sitzung der Gesamtgeschäftsführung handeln, indem er/sie schriftlich einen an-

deren Geschäftsführer als seinen/ihren Vertreter ernennt.

Die Gesamtgeschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der amtierenden Geschäftsführer

anwesend oder vertreten ist.

Geschäftsführungsbeschlüsse werden mit Stimmemehrheit der an der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen

Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Die Teilnahme einer oder mehrerer Geschäftsführer an einer Sitzung per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder

ähnlichem Kommunikationsmittel, die eine simultane Verständigung der daran teilnehmenden Personen miteinander ge-
währleistet, ist zulässig. Diese Arten der Teilnahme stehen einer physischen Anwesenheit in der Sitzung gleich.

Ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss ist zulässig und wirksam wie wenn er bei einer

ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung der Gesamtgeschäftsführung gefasst worden wäre. Ein solcher Be-
schluss kann entweder in einem einzelnen Dokument oder in mehreren gesonderten Dokumenten, die alle den gleichen
Inhalt haben und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben werden, festgehalten werden.

Art. 10. Protokoll der Sitzung der Gesamtgeschäftsführung. Das Sitzungsprotokoll der Gesamtgeschäftsführung bzw.

die schriftlichen Beschlüsse des Alleingeschäftsführers werden von allen bei der Sitzung anwesenden Geschäftsführern
bzw. dem Alleingeschäftsführer aufgesetzt und unterzeichnet. Sämtliche Vollmachten bleiben daran angeheftet.

Kopien davon oder Auszüge daraus werden von dem Alleingeschäftsführer bzw. vom Vorsitzenden der Gesamtge-

schäftsführung oder zweier beliebiger Geschäftsführer beglaubigt.

Art. 11. Allgemeine Befugnisse der Geschäftsführer. Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung hat

die weitesten Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln und um sämtliche Verwaltungs- oder Verfügungs-
maßnahmen durchzuführen oder dazu zu ermächtigen, die notwendig oder nützlich zur Erreichung des Gesellschaftsge-
genstandes  sind.  Sämtliche  Befugnisse,  welche  nicht  ausdrücklich  vom  Gesetz  oder  durch  diese  Satzung  dem
Alleingesellschafter bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des
Alleingeschäftsführers bzw. der Gesamtgeschäftsführung.

Art. 12. Übertragung von Befugnissen. Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung kann jedem Mitglied

bzw. Mitgliedern der Gesamtgeschäftsführung oder jeder anderen Person(en), die nicht Geschäftsführer oder Gesell-
schafter der Gesellschaft sein muss (müssen), allein oder gemeinsam handelnd, bestimmte Befugnisse übertragen und/
oder spezielle Mandate erteilen, unter den Bedingungen und mit den Befugnissen, wie sie der Alleingeschäftsführer bzw.
die Gesamtgeschäftsführung festlegt.

Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung kann zudem ein oder mehrere Beratungskomitees ernen-

nen und deren Zusammensetzung und Zweck festlegen.

Art. 13. Vertretung der Gesellschaft. Im Falle der Ernennung eines Alleingeschäftsführers wird die Gesellschaft Dritten

gegenüber durch die alleinige Unterschrift dieses Geschäftsführers sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift
jedweder Person(en), der (denen) der Geschäftsführer eine solche Zeichnungsvollmacht erteilt hat, in den Grenzen dieser
Vollmacht, verpflichtet.

Im Falle der Leitung der Gesellschaft durch eine Gesamtgeschäftsführung wird die Gesellschaft Dritten gegenüber

durch die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Geschäftsführern sowie durch die gemeinsame oder alleinige
Unterschrift jedweder Person(en), der (denen) die Gesamtgeschäftsführung eine solche Zeichnungsvollmacht erteilt hat,
in den Grenzen dieser Vollmacht, verpflichtet.

Art. 14. Interessenkonflikt. Verträge oder sonstige Transaktionen zwischen der Gesellschaft und einer anderen Ge-

sellschaft oder eines anderen Unternehmens werden nicht durch die bloße Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass
ein ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter der Gesellschaft, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, jedes Ge-

57480

schäftsführers, ein persönliches Interesse an genannter anderer Gesellschaft oder genanntem anderen Unternehmen hat
oder deren ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter ist.

Vorbehaltlich anderer nachstehender Regelungen ist jeder ordnungsgemäß ermächtigte Vertreter der Gesellschaft,

einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, jedes Geschäftsführers, der als ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter der
anderen Gesellschaft oder des anderen Unternehmens, gegenüber der sich die Gesellschaft vertraglich verpflichtet oder
mit der oder dem sie anderweitig Geschäfte tätigt, dient, automatisch aufgrund dieser Verbindung zu dieser anderen
Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen von der Beratung an und Beschlussfassung über sowie von Handlungen
hinsichtlich jedweder Angelegenheit mit Bezug zu diesem Vertrag oder diesen anderen Geschäften ausgeschlossen.

Ungeachtet des Vorstehenden muss ein Geschäftsführer, falls er/ sie ein persönliches Interesse an jedweder Transak-

tion, an der die Gesellschaft beteiligt ist, ausgenommen solche Transaktionen, die in den Bereich der täglichen Geschäfts-
führung  der  Gesellschaft  fallen,  unter  normalen  Umständen  und  zu  Marktbedingungen  getätigt  werden,  die
Gesamtgeschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und darf nicht an der Beratung oder an
der Beschlussfassung über eine solche Transaktion teilnehmen. Eine solche Transaktion und ein solches Interesse des
Geschäftsführers daran werden dem Alleingesellschafter bzw. der nächsten Hauptversammlung der Gesellschafter mit-
geteilt.

Falls die Gesellschaft einen Alleingeschäftsführer hat, ist jede Transaktion, an der die Gesellschaft Partei werden soll,

ausgenommen solche Transaktionen, die in den Bereich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft fallen, unter
normalen Umständen und zu Marktbedingungen getätigt werden, und an der der Alleingeschäftsführer ein persönliches
Interesse hat, das mit dem Interesse der Gesellschaft daran kollidiert, von dem Alleingesellschafter bzw. der Hauptver-
sammlung der Gesellschafter zu genehmigen.

Art. 15. Entschädigung. Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer und seine/ihre Erben, Testamentsvollstre-

cker und Nachlassverwalter für Aufwendungen, die er/sie vernünftigerweise in Verbindung mit einem Verfahren, einer
Klage oder einem sonstigem Rechtsstreit erlitten hat, an dem er/sie Streitpartei wurde aufgrund seiner/ihrer Stellung als
amtierender oder ehemaliger Geschäftsführer oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, an der die
Gesellschaft Gesellschafter oder gegenüber der sie Gläubiger ist und gegenüber der er/sie kein Recht auf Entschädigung
hat, ausgenommen solcher Verfahren, Klagen oder sonstigem Rechtsstreit bezüglich Gegenstände, für die er/sie rechts-
kräftig verurteilt wird wegen grober Fahrlässigkeit oder schuldhaftem Verhalten. Im Falle eines Vergleichs wird Entschä-
digung nur für Gegenstände geleistet, in Bezug auf die die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistandes beraten wurde, dass
keine Pflichtverletzung seitens des zu Entschädigenden vorliegt. Das vorstehende Entschädigungsrecht schließt andere
der jeweiligen Person zustehende Rechte nicht aus.

Art. 16. Abschlussprüfer. Mit der Überwachung der Tätigkeiten der Gesellschaft kann/ können und, falls die Gesellschaft

mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss/ müssen ein oder mehrere Abschlussprüfer betraut werden.

Die Abschlussprüfer, falls vorhanden, werden von dem Alleingesellschafter bzw. der Hauptversammlung der Gesell-

schafter ernannt, der bzw. die die Anzahl der Abschlussprüfer, gegebenenfalls die Bezahlung der Abschlussprüfer und die
Dauer ihres Amtes festsetzt bzw. festsetzen. Die Abschlussprüfer führen ihr Amt bis zur Wahl ihrer Nachfolger fort. Am
Ende ihrer Amtszeit können sie wiedergewählt werden, und sie können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch Beschluss
des Alleingesellschafters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter, aus ihrem Amt entlassen werden.

Kapitel IV. Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jahreshauptversammlung der Gesellschafter. Die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter, abzuhalten falls

die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an
jedem anderen in der Einladung angegebenen Ort am 10. Juni jeden Jahres um 10.00 Uhr abgehalten.

Falls dieser Tag kein Werktag in dem Großherzogtum Luxemburg ist, wird die Versammlung am ersten darauffolgenden

Werktag abgehalten.

Art. 18. Weitere Hauptversammlungen der Gesellschafter. Die Gesellschafter können Gesellschafterhauptversamm-

lungen abhalten, die gemäß dem Gesetz von dem Alleingeschäftsführer bzw. der Gesamtgeschäftsführung, von dem (den)
Abschlussprüfer(n), falls vorhanden, oder von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft
besitzen, einberufen werden.

Falls  sich  die  Gesellschaft  aus  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschaftern  zusammensetzt,  sind  Hauptver-

sammlungen  der  Gesellschafter  nicht  zwingend,  und  die  Gesellschafter  können  ihre  Stimme  für  die  vorgeschlagenen
Beschlüsse schriftlich abgeben.

Hauptversammlungen der Gesellschafter, einschließlich der Jahreshauptversammlung der Gesellschafter, können im

Ausland nur dann abgehalten werden, wenn, nach dem Ermessen des Alleingeschäftsführers bzw. der Gesamtgeschäfts-
führung Umstände höherer Gewalt dies erfordern.

Art. 19. Befugnisse der Gesellschafterversammlungen. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung

vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die ihr durch das Gesetz und diese Satzung übertragenen Befugnisse.

57481

Art. 20. Verfahren, Stimmrecht. Die Hauptversammlung der Gesellschafter wird durch Benachrichtigung durch den

Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung, durch den (die) Abschlussprüfer, falls vorhanden, oder durch
Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, gemäß dem Gesetz und der vorlie-
genden Satzung einberufen.

Die im Einklang mit dem Gesetz an die Gesellschafter verschickte Benachrichtigung gibt das Datum, die Zeit, den Ort

und die Tagesordnung der Versammlung an.

Falls alle Gesellschafter bei einer Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und falls sie

bestätigen, von der Tagesordnung der Versammlung Kenntnis zu haben, kann diese ohne vorherige Benachrichtigung
abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann auf jeder Hauptversammlung der Gesellschafter Handlungen vornehmen durch schriftliche

Ernennung eines Stellvertreters, der nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss, oder durch dessen Ernennung per
Fax.

Ein oder mehrere Gesellschafter kann oder können an Versammlungen per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder

ähnlicher Kommunikationsmittel, die die simultane Verständigung mehrerer daran teilnehmender Personen miteinander
ermöglichen, teilnehmen. Diese Teilnahme steht einer physischen Anwesenheit bei der Versammlung gleich.

Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die erfüllt sein

müssen, um an einer Hauptversammlung der Gesellschafter teilzunehmen.

Jeder Hauptversammlung der Gesellschafter sitzt der Vorsitzende der Gesamtgeschäftsführung oder, in seiner Abwe-

senheit, jede andere von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannte Person vor.

Der Vorsitzende der Gesamtgeschäftsführung ernennt einen Schriftführer.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter ernennt einen oder mehrere Wahlprüfer.
Der Vorsitzende der Hauptversammlung der Gesellschafter bildet zusammen mit dem Schriftführer und dem (den)

Wahlprüfer(n), so ernannt, das Büro der Hauptversammlung.

Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Gesellschafter, die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile, und gegebe-

nenfalls der Name ihrer Vertreter angibt, wird vom Büro der Hauptversammlung der Gesellschafter bzw. ihrer Vertreter
erstellt und unterzeichnet.

Jeder Anteil verfügt über eine Stimme, außer das Gesetz ist anderslautend.
Wenn das Gesetz nichts anderes vorschreibt, wird jede Änderung der vorliegenden Satzung mit Mehrheit der Ge-

sellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, beschlossen.

Außer das Gesetz oder die vorliegende Satzung schreibt anderes vor, werden alle anderen Beschlüsse von der Mehrheit

der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten, gefasst. Falls das Quorum nicht
in der ersten Versammlung erreicht wird, werden die Gesellschafter, mittels eingeschriebenem Brief, ein zweites Mal
versammelt  oder  hinzugezogen,  und  Entscheidungen  werden  von  der  Mehrheit  der  abgegebenen  Stimmen  getroffen,
ungeachtet der Anteils der vertretenen Kapitals.

Art. 21. Protokoll der Gesellschafterbeschlüsse. Das Protokoll der schriftlichen Entscheidungen des Alleingesellschaf-

ters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter werden von dem Alleingesellschafter bzw. dem Büro der Haupt-
versammlung aufgesetzt und unterzeichnet.

Kopien der oder Auszüge aus dem Protokoll der vom Alleingesellschafter bzw. der Hauptversammlung der Gesell-

schafter gefassten Beschlüsse werden von dem Alleingesellschafter bzw. dem Vorsitzenden der Gesamtgeschäftsführung
oder zweier beliebiger Geschäftsführer beglaubigt.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Dividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 23. Verabschiedung des Jahresabschlusses. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen,

der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung stellt ein Inventar der Aktiva und Passiva, die Bilanz und das
Gewinn- und Verlustkonto der Gesellschaft gemäß dem Gesetz auf und legt sie dem Alleingesellschafter bzw. der Haupt-
versammlung der Gesellschafter und gegebenenfalls dem (den) Abschlussprüfer(n) zur Billigung vor.

Jeder Gesellschafter oder sein Vertreter kann in diese finanziellen Dokumente am eingetragenen Sitz der Gesellschaft

Einblick nehmen. Falls sich die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern zusammensetzt, kann dieses
Recht nur innerhalb von fünfzehn Tagen vor dem für die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter gesetzten Zeitpunkt
ausgeübt werden.

Art. 24. Verteilung des Gewinns. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) für die

Bildung der vom Gesetz vorgeschriebenen Rücklage bereitgestellt. Diese Bereitstellung wird nicht mehr verlangt, sobald
und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft beträgt.

Der Alleingesellschafter bzw. die Hauptversammlung der Gesellschafter bestimmt, wie der Restbetrag des jährlichen

Nettogewinns verteilt wird. Er bzw. sie kann entscheiden, den gesamten Restbetrag oder einen Teil davon für bestehende

57482

Verluste, falls vorhanden, zu verwenden, zum nächstfolgenden Geschäftsjahr vorzutragen oder als Dividende an die Ge-
sellschafter auszuschütten.

Art. 25. Zwischendividende. Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung ist berechtigt, Zwischendi-

videnden ausschütten, vorausgesetzt, dass die aktuellen Zwischenkonten erstellt worden sind und besagte Zwischen-
konten zeigen, dass die Gesellschaft ausreichend verfügbare Mittel für eine solche Ausschüttung hat.

Kapitel VI. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

Art. 26. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch Entscheidung des Alleingesellschafters bzw. der Haupt-

versammlung der Gesellschafter mit demselben Quorum und derselben Mehrheit, die für die Änderung dieser Satzung
gelten, aufgelöst werden, außer das Gesetz schreibt etwas anderes vor.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt,

die von dem Alleingesellschafter bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter bestellt, der bzw. die deren Aufgaben
und Vergütung festsetzt.

Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden der und Forderungen gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und

Kosten des Liquidationsprozesses, wird das verbleibende Nettovermögen der Gesellschaft gleichmäßig unter den Ge-
sellschaftern anteilig der Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile verteilt.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 27. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Gegenstände werden gemäß dem anwend-

baren Gesetz bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nachdem die Satzung folglich von der erschienenen Partei erstellt worden ist, hat diese Partei die hiernach genannte

Anzahl an Anteilen gezeichnet und, einschließlich eines Agios in Höhe von zweiundsechzig Millionen sechshundertun-
dachtzigtausend Euro (EUR 62,680,000), vollständig einbezahlt mittels Sacheinlage (die "Sacheinlage") bestehend aus (i)
allen Rechten, Titeln und Ansprüchen der erschienenen Partei an der Marke "WE", die am 8. Mai 2004 unter der Mar-
kenanmeldung  Nr.  4048144  eingereicht  und  am  28.  Dezember  2007  in  Klasse  25  bei  dem  chinesischen  Markenamt
registriert wurde, alle maßgeblichen Prioritätsrechte bzgl. genannter Marke, aus Anwendungen genannter Marke folgende
Registrierungen und alle nicht registrierten Rechte der erschienenen Partei an der Marke "WE", an die Gesellschaft zu
ihrem Gesamtwert in Höhe von einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000) zu übertragen, (ii) den Markenrechten
einschließlich Registrierungsanmeldungen von solchen Rechten und maßgeblichen Prioritätsrechten wie in Anlage 1 zu
dieser notariellen Urkunde beschrieben, (iii) den Markenrechten einschließlich Registrierungsanmeldungen von solchen
Rechten und maßgeblichen Prioritätsrechten wie in Anlage 2 zu dieser notariellen Urkunde beschrieben und (iv) allen
gewerblichen Schutzrechten, wie Urheberrechte und Geschmacksmusterrechte bzgl. Produkten wie Store Design, die
auf der Basis von Entwurfs- und Konstruktionsarbeiten geschaffen wurden hinsichtlich des Innen- und Außendesigns der
Liegenschaft bestehend aus dem Geschäft in Nijmegen (Niederlande) und in Brüssels Woluwe (Belgien) von WE Europe,
einer gemäß den niederländischen Gesetzen gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit eingetragenem Sitz
im Reactorweg 101, 3542 AD, Utrecht, Niederlande, mit jeweils ca. 700 m 

2

 , und von Wonderfall Inc., einer gemäß den

japanischen Gesetzen gegründeten Gesellschaft, mit eingetragenem Sitz in 1-21-18 Ebisu-minami Shibuya-ku, Tokio, Japan,
und Herrn Masamichi Katayama durchgeführt wurden, die vorgenannten Rechte unter den Punkten (ii), (iii) und (iv) sind
an die Gesellschaft zu ihrem Gesamtwert in Höhe von dreiundsechzig Millionen fünfhundertdreißigtausend Euro (EUR
63.530.000) zu übertragen:

Gesellschafter

Anzahl der

Anteile

Gezeichnetes

Kapital

Waalfin Holding S.A., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 EUR 1.000.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 EUR 1.000.000

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärte, dass keine Hindernisse bzgl. der freien Verfügbarkeit

der Sacheinlage bestehen und alles Notwendige zu unternehmen, um das Volleigentum der Sacheinlage an die Gesellschaft
zu übertragen.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärte weiter, dass der Gesamtwert der Sacheinlage dreiund-

sechzig Millionen sechshundertachtzigtausend Euro (EUR 63.680.000) ist. Dieser Gesamtwert ist von der erschienenen
Partei in einer Einlageerklärung vom 12. April 2010 bestätigt worden.

Der unterzeichnende Notar bestätigt, dass die Voraussetzungen des Artikel 183 des Gesellschaftsgesetzes erfüllt sind

und ausdrücklich ihre Erfüllung bezeugt.

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft zu tragenden Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen jedweder Art, die von der

Gesellschaft als Folge dieser Urkunde zu tragen sind, werden auf schätzungsweise 7.000,- Euros veranschlagt.

57483

<i>Übergangsvorschriften

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tag und endet zum 31. Dezember 2010.

<i>Außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter

Der obengenannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hielt unmittelbar eine außerordentliche

Hauptversammlung ab und verabschiedete folgende Beschlüsse:

1. Beschluss, die Zahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzusetzen und Beschluss weiter, die Nachfolgenden als Ge-

schäftsführer für unbegrenzte Zeit zu ernennen:

- Herr Raymond Hegarty, Geschäftsführer, geboren in Cork, Irland, am 21. Juli 1964, berufsansässig am 17, rue Beau-

mont, L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Gert van Noord, Geschäftsführer, geboren in Punta Cardón, am 27. November 1952, berufsansässig in 17, rue

Beaumont, L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Herr Victor Hoogstraal, Geschäftsführer, geboren in Zürich, Schweiz, am 10. Dezember 1951, berufsansässig in 26,

Heuelstrasse, 8032 Zürich, Schweiz.

2. Beschluss, dass der eingetragene Sitz in der 17, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg ist.

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, das auf Antrag der obengenannten

Person diese notarielle Urkunde in Englisch verfasst wurde, mit einer deutschen Übersetzung im Anschluss; auf Antrag
der gleichen Person ist im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text
maßgeblich.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die anwesende Person, die dem Notar nach Namen, Vornamen,

Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrie-
ben.

Unterzeichnet: A. KOCH, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 avril 2010. Relation: LAC/2010/15937. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (unterzeichnet): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010059409/653.
(100058799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Remapa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 32.149.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentant permanent de ses administrateurs:

- Monsieur Gerard VAN HUNEN, résidant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, a

été nommé en date du 15 janvier 2009 en tant que représentant permanent de Lux Business Management S.à.r.l.

- Monsieur Peter VAN OPSTAL, résidant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, a été

nommé en date du 15 janvier 2009 en tant que représentant permanent de Lux Konzern S.à.r.l.

Luxembourg, le 16 avril 2010.

Lux Business Management S.à.r.l. / Lux Konzern S.à.r.l.
<i>Représentée par Gerard VAN HUNEN / <i>Représentée par Peter VAN OPSTAL

Référence de publication: 2010059901/16.
(100059793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Novotek Luxembourg Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 88.732.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale tenue extraordinairement du 18 décembre 2009

Acceptation de la démission de YOMATO LIMITED, avec siège social à 109, Gouchester Place, Londres W1U 6JW,

Royaume-Uni, représentée par Zamir HAIM, avec effet au 1 

er

 août 2009.

Acceptation de la démission de TRAINSPORT LIMITED, avec siège social à 109, Gouchester Place, Londres W1U

6JW, Royaume-Uni, représentée par Daniel EDGAR, avec effet au 1 

er

 août 2009.

57484

Nomination de l'administrateur, membre du Conseil d'Administration, Monsieur Daniel EDGAR, né le 5 août 1948 à

Singapour, demeurant à Maygrove Road 73, NW6 2EG Londres, Royaume-Uni, à compter du 1 

er

 août 2009 jusqu'à

l'assemblée générale des actionnaires décidant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.

Nomination de l'administrateur, membre du Conseil d'Administration, Monsieur Zamir HAIM, né le 3 avril 1948 en

Iraq, demeurant à Maygrove Road 73, NW6 2EG Londres, Royaume-Uni, à compter du 1 

er

 août 2009 jusqu'à l'assemblée

générale des actionnaires décidant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Novotek Participations Luxembourg SA
Marleen Watté-Bollen

Référence de publication: 2010059837/21.
(100059174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Aradco Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 119.272.

SHRM Corporate Services S.à r.l., ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Luxembourg, en-

registrée au RCS Luxembourg sous le numéro B 78.100, démissionne, par la présente, du mandat de Gérant B de la
société à responsabilité limitée Aradco Holdings, S.à r.l., ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,
Luxembourg.

M. Jason Toshi Taketa résidant au 53 Sunset Avenue 6, CA 90291 Venice, Etats-Unis d'Amérique, née le 20 février

1976 à Stanford, Etats-Unis d'Amérique, démissionne, par la présente, du mandat de Gérant A de la société à responsabilité
limitée Aradco Holdings, S.à r.l., ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétés
Signature

Référence de publication: 2010059848/19.
(100059381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Xiam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 57.977.

Lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire tenue en date du 20 avril 2010, les actionnaires ont décidé de:
1. renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Patrice Cavrois, avec adresse au 238, Rue du Quesne, 59700 Marcq-en-Baroeul, France
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social

se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

2. de ne pas renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Lu-

xembourg en tant que commissaire.

3. de nommer PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg au mandat de

réviseur d'entreprises pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2010.

Référence de publication: 2010059850/21.
(100059720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57485

JP Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 89.785.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21/01/10

En date du 21 janvier 2010, l'assemblée a décidé d'accepter la démission de Monsieur Fernando Zanoni, né à Vérone

(Italie) le 29 mai 1943, demeurant Rosenheimer Strasse 111 à D-81667 Munich (Allemagne) de son mandat de gérant
unique de la société et a accepté son remplacement pour une durée indéterminée par Monsieur Philippe Vanderhoven,
né à Rocourt (Belgique) le 2 juillet 1971, demeurant rue Basse 9 à L-4963 Clemency (Luxembourg).

Clemency, le 28 avril 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME
Signature

Référence de publication: 2010059849/15.

(100059662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

PRI Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 88.591.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg le 18 mars 2010

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide:

- le renouvellement du mandat d'administrateur de Messieurs Geoffroy Linard de Guertechin, Reggie Van Leer et de

Monsieur Stanislas Kervyn de Marcke ten Driessche, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale de
2011.

- la réélection du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., pour une nouvelle période d'un an prenant

fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2010.

Stanislas Kervyn de Marcke ten Driessche / Geoffroy Linard de Guertechin
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2010059861/20.

(100059410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

UPC DTH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 28.418.016,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 87.905.

L'adresse du gérant suivant Nils Magnus Ternsjö a changé et se trouve à présent au: 52, Am Bongert, L-1270 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2010.

Référence de publication: 2010059853/12.

(100059719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57486

Amadelux International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 125.629.

EXTRAIT

1) En date du 26 mars 2010, l'associé unique de la Société, Amadelux Investments S.A., a changé sa forme juridique en

société à responsabilité limitée. Par conséquent, sa dénomination doit se lire comme suit: "Amadelux Investments S.à r.l.".

2) En date du 27 avril 2010, Amadelux Investments S.à r.l. a transféré toutes les 1.200 parts sociales détenues dans la

Société à Amarillo Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
152576.

3) En date du 27 avril 2010, la Société a transféré son siège social à l'adresse suivante: 5, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2010059927/21.
(100059306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Thermo-San S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 13, rue Kalchesbrück.

R.C.S. Luxembourg B 140.453.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de
l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue
le 9 avril 2010:
01 L'intégralité du capital social est représentée.
02 L'assemblée générale prend connaissance de la démission de Monsieur FRANCEQUIN Philippe et Monsieur ARO-

MATARIO Bernard de leur postes d'administrateurs.

03 Nomination de nouveaux membres du conseil d'administration:
- Monsieur BATTANI Patrick, demeurant à 28B, rue de Boismont, FR-54400 LONGWY;
- Monsieur GUILLAUME Eric, demeurant à rue du Banquillon 14, FR-54430 REHON.
Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Pascal BENEDET
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010059855/19.
(100059031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Tropical Island S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.330.000,00.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 94.905.

Par résolutions circulaires signées en date du 8 mars 2010, les associés ont décidé de renouveler le mandat de Price-

waterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprise, pour
une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se
clôturant au 31 janvier 2010 et qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2010.

Référence de publication: 2010059856/14.
(100059717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57487

Financière Star 1, Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 89.404.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 15 décembre 2009 que:
- le mandat de Madame Gaëlle D'ENGREMONT, en sa qualité d'administrateur de la Société, a été renouvelé jusqu'à

l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010059864/14.
(100059393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Azul Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 128.384.

<i>Extrait des résolutions adoptées par écrit par les associés de la Société en date du 29 janvier 2010:

Il résulte des résolutions adoptées par écrit par les associés de la Société en date du 29 janvier 2010:
- que les associés ont accepté la démission de M. Francisco-Javier Auguets Pratsobrerroca de ses fonctions de membre

du conseil de gérance de la Société avec effet au 29 janvier 2010

- que les associés ont nommé Invercartera International S.L.U., avec adresse à C/Roure N°6, 08820, El Prat de Llo-

bregat, Espagne, comme nouveau membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 29 janvier 2010 et pour une
durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

Azul Management S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010059862/19.
(100059403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Azul Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 131.006.

<i>Extrait des résolutions adoptées par écrit par les associés de la Société en date du 29 janvier 2010:

Il résulte des résolutions adoptées par écrit par les associés de la Société en date du 29 janvier 2010:
- que les associés ont accepté la démission de M. Francisco-Javier Auguets Pratsobrerroca de ses fonctions de membre

du conseil de gérance de la Société avec effet au 29 janvier 2010

-  que  les  associés  ont  nommé  Invercartera  International  S.L.U.,  avec  adresse  à  C/Roure  N°  6,  08820,  El  Prat  de

Llobregat, Espagne, comme nouveau membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 29 janvier 2010 et pour
une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

Azul Finance S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010059863/19.
(100059399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57488

Worms &amp; Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 150.878.

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 13 avril 2010

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Worms ("la Société"), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège de la Société du 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 21 Allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, avec effet au 14 avril 2010;

- de nommer Leilani Investments Ltd, ayant son siège social au 115 Griva Digeni, 3101 Limassol, Chypre, immatriculée

auprès du Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies, sous la référence HE
184766, en tant que membre du Conseil de Surveillance avec effet immédiat, son mandat expirant durant l'Assemblée
Générale Annuelle devant être tenue en 2011;

- de nommer L'Alliance Révision Sàrl, ayant son siège social au 54, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en tant que réviseur d'entreprise avec effet immédiat,
son mandat expirant durant l'Assemblée Générale Annuelle devant être tenue en 2011.

Luxembourg, le 19 avril 2010.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Administrateur-Délégué
Fabrice Geimer
<i>Représentant Permanent

Référence de publication: 2010059933/23.
(100059738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Äischer Pompjeeën asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9747 Enscheringen, 6, Am Burreneck.

R.C.S. Luxembourg F 8.330.

STATUTEN

Am 26. Februar 2010 (sechsundzwanzigsten Februar zwei tausend und zehn) wird zwischen den in Kapitel IV defi-

nierten, sowie im Anhang A der Satzung aufgeführten Gründungsmitgliedern und allen Personen, welche zu einem späteren
Zeitpunkt laut den Bestimmungen dieser Satzung als Mitglieder aufgenommen werden, eine Vereinigung ohne Gewinnz-
weck gegründet, welche durch das abgeänderte Gesetz vom 21. April 1928 betreffend Vereinigungen und Stiftungen ohne
Gewinnzweck bzw. dessen Nachfolgegesetzgebung sowie durch folgende Statuten geregelt wird.

Kapitel I - Natur und Wesen

Art. 1. Die freiwillige Feuerwehr ist der freiwillige Zusammenschluss von Männern, Frauen und Jugendlichen zu einer

Hilfsorganisation  bei  Bränden  und  anderen  Notständen  sowie  zu  einer  kulturellen  Vereinigung  welche  sich  aktiv  am
kulturellen Leben in- und außerhalb der Gemeinde beteiligt.

Art. 2. Sie gehört über den Kantonalverband Wiltz dem Luxemburger Landesfeuerwehrverband an und steht freiwillig,

ehrenamtliche und autonom im Dienste der Gemeinde Kiischpelt.

Art. 3. Auch in ihrer inneren Verwaltung und in ihrer Tätigkeit ist die autonom, jedoch nur im Rahmen des Gesetzes

vom 21.04.1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzwecke und die Institute öffentlichen Nutzens und der Satzung des
Luxemburger Landes-Feuerwehrverbandes.

Kapitel II - Zweck und Aufgabe

Art. 4. Aufgabe der Feuerwehr ist die geordnete Hilfeleistung und Prävention bei Bränden, Rettungseinsätzen, Unfällen

und anderen Notständen.

Art. 5. Zur Erfüllung der unter Art. 4 dieses Paragraphen angesprochenen Aufgabe dienen die theoretische und prak-

tische Ausbildung der aktiven Wehrmitglieder auf lokaler, kantonaler und nationaler Ebene.

Art. 6. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Mitglieder zur Hilfsbereitschaft anzuregen, sowie des weiteren Kame-

radschaft unter ihnen zu fördern und zu pflegen.

Art. 7. Sie hat dafür Sorge zu tragen dass die Zukunft des Vereins gesichert wird indem eine Jugendfeuerwehr nach

den Reglementen der Nationalen Jugendfeuerwehrkommission geführt und verwaltet wird.

Kapitel III - Name, Sitz und Geschäftsjahr

Art. 8. Die Vereinigung trägt den Namen „Äischer Pompjeeen asbl".

57489

Art. 8bis. Als Hilfsorganisation ist die freiwillige Feuerwehr von Enscheringen unter dem Namen „Äischer Pompjeeen,

Gemeng Kiischpelt" sowie "Service d'Incendie et de Sauvetage de la Commune de Kiischpelt " eingetragen, gemäß dem
Großherzoglichen Reglement vom 7. Mai 1992.

Art. 9. Sie hat ihren Sitz in 6, am Burreneck in L-9747 Enscheringen.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt und endigt mit jedem Kalenderjahr. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr

am Datum der Unterzeichnung vorliegender Statuten und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Die Dauer der
Vereinigung ist unbegrenzt

Kapitel IV - Bestand

Art. 11. Die Wehr besteht aus:
- aktiven Mitgliedern,
- inaktiven Mitgliedern,
- Jugendfeuerwehrmitgliedern,
- Ehrenmitgliedern.
Die Anzahl der Mitglieder ist unbegrenzt, darf jedoch die Zahl von 5 stimmberechtigten Mitgliedern nicht unterschrei-

ten.

Aktive Mitglieder

Art. 12. Aktives Mitglied kann jeder unbescholtene, weibliche oder männliche Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde

werden. In bestimmten Fällen kann auch jemand der seinen Wohnsitz außerhalb der Gemeinde hat, aktives Mitglied
werden. Die aktiven Feuerwehrmitglieder gehören sowohl der Hilfsorganisation als auch der kulturellen Vereinigung an.
Der Beitritt zur kulturellen Vereinigung ist den Feuerwehrmitgliedern vorbehalten.

Art. 13. Jedes neue aktive Mitglied von 16 bis 65 Jahren, muss auf Verlangen des Vorstandes, ein Atest vom Arzt, sowie

ein Auszug aus dem Strafregister vorzeigen. Es wird sofort beim Nationalen Feuerwehrverband als aktives Mitglied ge-
meldet, bekommt jedoch erst nach einer Probezeit von mindestens 12 Monaten Anrecht auf eine endgültige Mitgliedschaft.

Art. 14. Neue jugendliche Mitglieder von 8 bis 16 Jahren bekommen das Anrecht auf die Mitgliedschaft schon nach

drei Monaten Probezelt.

Art. 15. Jedes aktive Mitglied verpflichtet sich jederzeit für den Ernstfall bereit zu sein und nach bestem Willen und

Können zu helfen, die Anordnungen dieser Statuten zu befolgen, regelmäßig an den angesetzten praktischen und theo-
retischen Übungen, Vereinsveranstaltungen und sonstigen Anlässen teilzunehmen.

Art. 16. Außerdem verpflichtet jedes neue Mitglied sich, der vom Feuerwehrverband vorgeschriebenen medizinischen

Untersuchungen zu unterziehen. Alle Neuzugänge verpflichten sich außerdem die Feuerwehrgrundausbildung, sowie alle
weiteren, vom Gesetzgeber vorgeschriebene Ausbildungen, in der hierfür festgelegten Frist zu absolvieren. Ist dies nicht
der Fall kann die Mitgliedschaft vom Vorstand der Hilfsorganisation gekündigt werden oder nach Anhörung des Mitglieds
für weitere Zeit verlängert werden.

Art. 17. Es muss den Anweisungen des Chef de Corps oder seines Vertreters Folge leisten. Außerdem soll es die

Disziplin und Kameradschaft in, sowie außerhalb der Wehr wahren, um dem Ansehen derselben nicht zu schaden.

Art. 18. Jedes aktive Mitglied hat das Recht die Uniformen zu tragen, dies jedoch im Rahmen der Bestimmungen des

Feuerwehrverbandes. Außerhalb der Einsätze, Übungen und sonstigen Veranstaltungen der Wehr oder des Feuerwehr-
verbandes ist es strengstens untersagt dieselben zu tragen.

Inaktive Mitglieder

Art. 19. Die inaktiven Feuerwehrmitglieder gehören sowohl der Hilfsorganisation als auch der kulturellen Vereinigung

an.

Art. 20. Jedes Mitglied gilt als inaktiv beim Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren oder wenn es ihm über einen

längeren Zeitraum hinaus unmöglich ist, regelmäßig an den festgelegten Übungen oder sonstigen Veranstaltungen teilzu-
nehmen, z.B. entfernter Wohnsitz, ungünstige Arbeitszeiten, längere Krankheit, Invalidität, u.s.w.

Außer beim Erreichen der Altersgrenze kann die Inaktivität vom Vorstand bestimmt werden. Die inaktiven Mitglieder

sind gehalten, die Wehr stets mit Rat und Tat zu unterstützen und überall deren Interesse zu vertreten. Sie behalten die
erworbenen Rechte auf Ehrenabzeichen, Sterbegeld und Veteranenzulage.

Jugendfeuerwehrmitglieder

Art. 21.  Jugendfeuerwehrmitglied  kann  jeder  Jugendliche  zwischen  8  und  16  Jahren  werden,  wenn  die  schriftliche

Zustimmung der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten vorliegt.

Art. 22. Die Jugendfeuerwehrmitglieder gehören sowohl der Hilfsorganisation als auch der kulturellen Vereinigung an.

Sie sind nicht stimmberechtigt.

57490

Art. 23. Die Anordnung dieser Statuten ist zu befolgen. Es ist Pflicht regelmäßig an den angesetzten praktischen und

theoretischen Übungen sowie an den Vereinsveranstaltungen und sonstigen Anlässen teilzunehmen.

Art. 24. Jedes Jugendfeuerwehrmitglied hat das Recht die Uniformen zu tragen, dies jedoch im Rahmen der Bestim-

mungen des Feuerwehrverbandes. Außerhalb der Übungen und sonstigen Veranstaltungen der Wehr oder des Feuer-
wehrverbandes ist es untersagt Gesellschafts-beziehungsweise Gemeindeeigene Uniformen zutragen.

Art. 25. Jugendliche, die sich in der Jugendfeuerwehr bewährt haben, werden ab dem 16. Lebensjahr automatisch in

die Erwachsenenabteilung übernommen.

Ehrenmitglieder

Art. 26. Jede Person kann Ehrenmitglied werden, wenn sie freiwillig den jährlichen festgesetzten Mindestbetrag mit

Erwerb einer Ehrenmitgliedkarte leistet. Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt.

Art. 27. Verlust der Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft der aktiven und inaktiven Feuerwehrmitglieder, sowie der Ju-

gendfeuerwehrmitglieder erlischt durch:

- Tod,
- freiwilliger Austritt,
- Ausschluss (gemäß Art. 50 dieser Statuten).

Kapitel V - Leitung

Art. 28. Die Leitung der Wehr sowie der Vereinigung „Äischer Pompjeeën asbl" geschieht durch den Vorstand, an

dessen Spitze der Chef de Corps steht.

Art. 29. Der Vorstand besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern die, ihr 18. Lebensjahr erreicht haben. Die Posten

von Chef de Corps, Chef de Corps adjoint und Jugendleiter können ausschließlich von aktiven Mitgliedern besetzt werden.
Die Posten des Sekretärs, des Kassierers und der Beisitzenden können aktive oder inaktive Mitglieder sein.

Art. 30. Der Vorstand setzt sich aus mindestes 3 und maximal 9 Mitgliedern zusammen, darunter:
- der Chef de Corps (Wehrchef);
- der Chef de Corps adjoint (Wehrchefstellvertreter);
- der Jugendleiter oder Vertreter;
- der Sekretär;
- der Kassierer;
- die Beisitzenden.

Art. 31. Da die aktiven Feuerwehrleute das Recht haben, mehrere Posten gleichzeitig zu besetzen, jedoch nicht mehr

als zwei Posten, muss der Vorstand einen oder mehrere Beisitzende wählen lassen, um das Mindesteffektiv des Vorstandes
gemäß Art. 30 dieser Statuten zu erreichen.

Art. 32. Der Chef de Corps, Chef de Corps adjoint, und der Jugendleiter werden auf unbestimmte Zeit mit einfacher

Stimmenmehrheit von der Generalversammlung in geheimer Wahl bestimmt. Sie müssen alle vier Jahre von der Gene-
ralversammlung im Amt bestätigt werden.

Die Posten des Sekretärs, des Kassierers, sowie die der Beisitzenden werden auf die Dauer von vier Jahren durch die

Generalversammlung bestimmt.

Die Bestätigung der Posten des Wehrchef und des Jugendleiters sowie die Bestimmung des Kassierers werden in

verschränkter Reihenfolge mit jenen der Wehrchefstellvertreter, des Sekretärs und der Beisitzenden vorgenommen.

Art. 33. Laut großherzoglichem Reglement vom 7. Mai 1992 wird der angehende Chef de Corps von der Wehr vor-

geschlagen. Der aktuelle Chef de Corps kann in einer Generalversammlung oder auch durch Einberufung einer außerge-
wöhnlichen  Generalversammlung  wieder  seines  Amtes  provisorisch  enthoben  werden.  Beides,  die  Neuwahl  und  die
Amtsenthebung muss der Gemeindeverwaltung mitgeteilt werden, welche den Chef de Corps dann offiziell ernennt oder
von seinem Amt enthebt. Anschließend wird die Wahl dem Generalsekretariat des Luxemburger Landesverbandes über
den zuständigen Kantonalverband schriftlich gemeldet. (Gemeindegesetz vom 13. Dezember 1988 &amp; großherzogliches
Reglement vom 7. Mai 1992)

Art. 34. Bei Stimmengleichheit und gleichem Ausbildungsstand entscheidet das Dienstalter.

Art. 35. Um sich für einen unter Art. 30 zitierten Vorstandsposten zu bewerben, muss der Kandidat nachstehende

Bedingungen erfüllen:

- Der Kandidat muss seit mindestens 2 Jahren aktiv in der Wehr/Jugendwehr Dienst geleistet haben
- Der Kandidat muss ein Mindestalter von 18 Jahren haben.
- Für die Posten des Chef de Corps, Chef de Corps adjoint, Sektionschef sowie des Jugendleiters muss er die für diese

Posten vorgesehenen Lehrgänge absolviert haben und im Besitz aller sonstigen vom Verband oder vom Gesetz vorges-
chriebenen Diplome sein.

57491

Art. 36. Die Mitglieder des Vorstandes treten aus ihrem Amt aus:
- durch Tod,
- durch freiwilligen Abgang,
- durch Abwahl,
- durch Erreichen, der vom Landesverband vorgeschriebenen Altersgrenze,
- durch Nichterreichen der vom Landesverband vorgeschriebenen Mindest-Ausbildung.
Wird ein Vorstandsposten während dem Geschäftsjahr frei, so kann der Vorstand den Posten vorläufig neu besetzen,

unbeschadet der Bestätigung durch die nächste Generalversammlung. Im Falle einer Neubesetzung vor Ablauf der nor-
malen Mandatsdauer übernimmt das neue Vorstandsmitglied den Posten für die restliche Mandatsdauer.

Im Falle des Wehrchefs übernimmt der dienstälteste Stellvertreter das Amt bis zur nächsten Generalversammlung.

Art. 37. Die Aufgaben des Vorstandes:
- Die Geschäftsführung der Hilfsorganisation, sowie der kulturellen Vereinigung
- die Aufnahme respektiv der Ausschluss von Mitgliedern,
- die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlungen und die Festsetzung der Tagesordnung,
- der Fortbestand der Feuerwehr mittels einer Jugendfeuerwehr zu garantieren
- jede Tätigkeit, die nicht ausdrücklich durch die Satzung der Wehr, die Satzung des Luxemburger Landes-Feuerwehr-

verbandes oder das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 38. Der Vorstand ist beschlussfähig wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine

Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Chef de Corps.

Art. 39. Die Aufgaben des Chef de Corps:
- die Leitung des Ausbildungs-, Übungs-, Feuerschutz- und Rettungsdienstes,
- die Leitung der Vorstandssitzungen und der Generalversammlung,
- die Beurkundung, mit dem Sekretär, der Sitzungsberichte, der Korrespondenz und aller wichtigen Schriftstücke,
- die Aufsicht über statutenmäßigen Auftritt und vorschriftsmäßige Bekleidung der Feuerwehrleute bei Ausgängen der

Wehr,

- die Beratung der Gemeinde in allen Angelegenheiten des Feuerschutzes, der Anschaffung von Feuerlöschgeräten, und

die Anregung von Verbesserungsmassnahmen,

- die Vertretung der Wehr bei öffentlichen Anlässen,
- die Überwachung einer ordnungsmäßigen Führung von Inventar- und Dienstbuch, sowie von Abwesenheits- und

Mitgliederliste.

Art. 40. Die Aufgaben des Chef de Corps adjoint:
Er unterstützt den Chef de Corps bei der Ausführung seiner Mission und ersetzt ihn im Abwesenheits- und Verhin-

derungsfalle.

Art. 41. Die Aufgaben der Sektionschefs:
- Sie unterstützen den Chef de Corps bei der Ausbildung der Wehr,
- Bei Ausbildung und Einsatz werden ihnen je eine Mannschaft von 8 Mann zugeteilt,
- Sie unterstützen den Chef de Corps und den Chef de Corps adjoint bei der Ausführung ihrer Mission und ersetzen

sie im Abwesenheits- und Verhinderungsfall.

Art. 42. Die Aufgaben des Jugendleiters:
- Unter Aufsicht des Chef de Corps unterrichtet er die Jugendabteilung der Feuerwehr nach den Reglementen und

Vorschriften der nationalen Jugendfeuerwehrkommission

- Die Aufsicht über statutengemäßen Auftritt und die vorschriftsmäßige Bekleidung der Jugendfeuerwehrmitglieder bei

Ausgängen der Wehr.

- Ihm stehen ein oder mehrere Jugendleiter adjoint(s) zur Seite. Diese müssen die Bedingungen der nationalen Ju-

gendfeuerwehrkommission erfüllen, müssen aktives Feuerwehrmitglied sein und werden vom Vorstand der Hilfsorgani-
sation bestimmt.

Art. 43. Die Aufgaben des Sekretärs
- Führt das Mitgliederverzeichnis (Stammrolle). Diese muss, außer den Personalangaben wie Name, Vorname, Ge-

burtsort und -datum sowie Wohnort der Mitglieder, auch die stets fortlaufende Stammrollennummer, das Eintritts- und
das Austrittsdatum derselben beinhalten. Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden im Mitgliederverzeichnis genauso ge-
führt wie die Erwachsenen.

- Erledigt schriftliche Arbeiten, wie Korrespondenz, Einberufung zur Generalversammlung, Vorstandssitzung, Ausgän-

gen, Veranstaltungen, Übungen und Kursen.

57492

- Verfasst Berichte über Vorstandssitzungen und Generalversammlungen.
- Er kann bei Bedarf auf einen Sekretär-adjoint zurückgreifen welcher vom Vorstand ernannt wird.

Art. 44. Die Aufgaben des Kassierers
- Das Kassenwesen wird vom Kassierer der Wehr versehen,
- Er führt ordnungsgemäß Buch über Einnahmen und Ausgaben und legt Rechung ab. Kassen- und Buchführung sind

jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres abzuschließen und von den Kassenrevisoren auf ihre Richtigkeit zu prüfen sowie
abzuzeichnen,

- Nach erfolgter Prüfung berichten die Kassenrevisoren dem Vorstand und der Generalversammlung. Der Kassierer

erhält Entlastung durch die Generalversammlung,

- Der Kassierer hält das Kassen- und Kontenbuch dem Vorstand jeder Zeit zur Einsicht zur Verfügung,
- Er hat Zeichnungsberechtigung für alle Bankgeschäfte.

Art. 45. Die Kassenrevisoren:
In der Generalversammlung werden für die Dauer von 4 Jahren, 2 Kassenrevisoren, welche dem Vorstand auf keinen

Fall und der Wehr nicht unbedingt angehören, ernannt. Sie haben das Recht zu jeder Zeit eine Revision der Kasse vor-
zunehmen. Der Kassierer muss innerhalb von 5 Tagen auf Antrag von wenigstens 2 Kassenrevisoren, Kasse und Buchung
für eine Revision bereitstellen. Revisor kann nur werden, wer nicht der Familie des Kassierers angehört.

Art. 46. Die Beisitzenden
Die Beisitzenden haben eine stimmberechtigte Funktion innerhalb des Vorstandes.

Art. 47. Der/die Gerätewart(e)
Der Vorstand ernennt aus den Reihen der aktiven Mitglieder einen oder mehrere kompetente(n) Gerätewart(e), der/

die das vorhandene Material stets in einem einwandfreien Zustand zu halten hat/haben. Hierbei kann die Arbeit auch
spezifisch aufgeteilt werden. Der Vorstand hat das Recht, den Gerätewart jederzeit seines Postens zu entheben

Kapitel VI - Rechte und Pflichten der aktiven Mitglieder

Art. 48. Jedes aktive Mitglied hat das Recht:
- bei der Gestaltung des Wehrgeschehens aktiv mitzuwirken,
- in eigener Sache gehört zu werden,
- ab dem 16. Lebensjahr an der Wahl der Vorstandsmitglieder teilzunehmen.

Art. 49. Jedes aktive sowie Jugendfeuerwehrmitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung:
- die im Rahmen der Statuten gegebenen Anordnungen genau zu befolgen,
- an den angesetzten praktischen und theoretischen Übungen und Wehrveranstaltungen regelmäßig pünktliche und

aktiv teilzunehmen,

- Disziplin und Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten sowie Kameradschaft innerhalb der Mannschaft zu respektieren,
- aktiv am Gedeihen und Ansehen der Feuerwehr teilzunehmen.

Kapitel VII - Ordnungsmaßnahmen

Art.  50.  Bei  Verstößen  gegen  die  Statuten  der  Wehr  oder  des  Landesverbandes  können  nachfolgende

Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden:

- Verweis unter vier Augen durch den Chef de Corps,
- Verweis vor den Vorstand,
- Ausschluss aus der Wehr durch den Vorstand, gemäß Art. 37. dieser Statuten ,
- Alle Vorstandsmitglieder können ihres Postens durch die Generalversammlung enthoben werden, wenn sie gegen

die Statuten der Wehr oder des Landesverbandes verstoßen, ihren Pflichten nicht gewachsen sind oder sie vernachläs-
sigen.

Art. 51. Gegen die Ordnungsmaßnahmen steht jedem aktiven und inaktiven Mitglied der Wehr das Recht auf Besch-

werde zu. Sie muss spätestens 7 Tage nach dem Ausspruch der Ordnungsmaßnahme beim Vorstand eingebracht werden,
der darüber entscheidet.

Kapitel VIII - Die Generalversammlung

Art. 52. Die Generalversammlung muss mindestens einmal jährlich vom Vorstand mit 14 Tagen Frist und Bekanntgabe

der Tagesordnung einberufen werden.

Eine außerordentliche Generalversammlung kann vom Vorstand einberufen werden, wenn die Umstände dies verlan-

gen. Bei schriftlicher Anfrage von 1/5 der Mitglieder muss eine außergewöhnliche Generalversammlung innerhalb von
zwei Monaten einberufen werden.

Art. 53. Sie wird vom Chef de Corps geleitet und ist öffentlich.

57493

Art. 54. Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über nur eine Stimme, bei Abwesenheit kann es seine Stimme per

Vollmacht an ein anderes stimmberechtigte Mitglied seiner Wahl übertragen. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/2
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist dies nicht der Fall, so kann sofort eine außergewöhnliche General-
versammlung einberufen werden, welche in jedem Fall beschlussfähig ist.

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, sofern die vorliegenden Statuten es nicht anders bestim-

men. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Chef de Corps.

Art. 55. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:
- die geheime Wahl von den Vorstandsmitgliedern und den Kassenrevisoren,
- die geheime Abberufung von Vorstandsmitgliedern,
- die Genehmigung der Tätigkeits-, Kassen- und Kassenprüferberichte,
- die Entlastung des Kassierers,
- die Festlegung der Beiträge für Mitglieder,
- die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge,
- die Abänderung der Wehrstatuten gemäß Art. 8 des Gesetzes vom 21. April 1928, mit einer 2/3 Stimmenmehrheit,

wenn 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind,

- die Beratung und Entscheidung über sonstige wichtige Angelegenheiten innerhalb der Wehr, die der Vorstand nicht

verabschieden kann,

- die Auflösung der Wehr, gemäß Art. 20 des Gesetzes vom 21. April 1928.

Kapitel IX - Das Wappen der Vereinigung

Art. 56. Die Vereinigung führt das in Anlage 1 abgebildete Wappen. Das Vereinswappen zeigt das Wappen der Familie

von Enscheringen, ehemalige Herrschaftsfamilie der Ortschaft - neun mal gold-rot geteilt, belegt mit einem schwarzen,
rotgezungten Löwen - umgeben von Lanze, Schlauch und Beil. Das Wappen trägt die Inschrift 1891, Gründungsjahr der
Freiwilligen Feuerwehr von Enscheringen.

Kapitel X - Das Feuerwehrlokal

Art. 57. Im Feuerwehrlokal dürfen einzig und allein Lösch-, Rettungs-, Ausbildungs-, und das vereinseigene Material

untergebracht sein. Ausnahmen können durch Beschluss des Vorstandes genehmigt werden. Es ist untersagt das Material
zu anderen Zwecken zu nutzen, sowie Lösch-, Rettungs- und sonstiges Material, das der Wehr gehört, ohne die Geneh-
migung der Führungskräfte zu entfernen.

Kapitel XI - Fusion und Auflösung der Wehr

Art. 58. Gemäß Art. 20 des Gesetzes vom 21. April 1928, kann die Fusion oder die Auflösung der Wehr nur dann

geschehen, wenn eine eigens zu diesem Zweck einberufene Generalversammlung, 2/3 der Gesamtzahl der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend sind. Wenn keine 2/3 der Mitglieder anwesend sind kann eine zweite Generalversammlung
einberufen werden, wobei die Hälfte der Mitglieder anwesend sein muss. Die Fusion oder Auflösung der Wehr kann nur
durch eine Stimmenmehrheit von 3/4 angenommen werden.

Des Weiteren erfolgt die Auflösung, wenn die Zahl der aktiven Mitglieder unter die in Art.11 vorgesehene Mindest-

mitgliederanzahl sinkt und die Wehr außer Standes ist, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.

Art. 59. Im Falle der Auflösung wird das Liquidationsverfahren von der Generalversammlung festgelegt. Nach Beglei-

chung aller Schulden wird das Vermögen der Wehr der Gemeindeverwaltung anvertraut, mit dem Auftrag, dasselbe einer
neuen Feuerwehr, die dieselben Ziele verfolgt, zu übergeben. Im Falle der Fusion wird der gesamte Besitz der Wehr der
neuen Fusionswehr überschrieben.

Kapitel XII - Allgemeine Verfügungen

Art. 60. Beim Austritt oder Ausschluss eines aktiven oder inaktiven Mitgliedes, sowie bei der Auflösung der Wehr,

besteht kein Anrecht auf jedwede Aus- oder Rückzahlung.

Art. 61. Das austretende Mitglied ist verpflichtet, das zu seiner Verfügung gestellte Eigentum der Wehr unvermittelt

dem Vorstand auszuhändigen. Für etwaigen böswillig verursachten Schaden muss es aufkommen.

Art. 62. Für alle in den gegenwärtigen Statuten nicht ausdrücklich vorgesehenen Fällen gelten die allgemeinen Bestim-

mungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck, die Satzungen und Richtlinien des
Landesfeuerwehrverbandes, die großherzoglichen und ministeriellen Réglemente betreffend das Feuerlösch- und Ret-
tungswesen, sowie die diesbezüglichen Reglemente der Gemeinde Kiischpelt.

Art. 63. Die Statuten wurden von der außerordentlichen Generalversammlung am 26. Februar 2010 angenommen und

ersetzen alle vorherigen Satzungen, die seit der Gründung gültig waren. Sie treten sofort nach Hinterlegung bei der
Gemeindeverwaltung in Kraft.

57494

Die unterzeichnenden Mitglieder des Vorstandes bestätigen hiermit, dass die Statuten, in der vorher aufgeführten

Form, in der Generalversammlung vom 26. Februar 2010 angenommen wurden.

Boumans Jean-Marie / Boumans Daniel / Michels Carlo / Weimersklrch Sam / L'Ortye Philippe / Tosseng Ingo.

ANHANG A:

<i>Gründungsmitglieder

Die Gründungsmitglieder des Vereins sind:
Arend Ralph, 16, op de Leeen L-9760 Lellingen, luxemburgisch;
Bock Josy, 6, um Sandbierg L-9776 Wilwerwiltz, luxemburgisch;
Boumans Daniel, 4, am Gronn L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
Boumans Jean-Marie ,4, am Gronn L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
Boumans Jimi, 4, am Gronn L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
Boumans Luc, 9, Schoulbierg L-9767 Pintsch, luxemburgisch;
Boumans Patrick, 9, ierwescht Duerf L-9747 Enscheringen, niederländisch;
Boumans Tim, 4, am Gronn L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
Chevallier Alain , 17, ierwescht Duerf L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
De Rond Sascha , 10, ierwescht Duerf L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
Fischbach Roland, 23, ierwescht Duerf L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
Gaudron Elisabeth, 5 an der Gaass L-9638 Pommerloch, luxemburgisch;
Huijben Jean , 5, am Grëndchen L-9776 Wilwerwiltz, luxemburgisch;
Joly Rene, 19, am Burreneck L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
L'Ortye Philippe, 4, um Aecker L-9767 Pintsch, luxemburgisch;
Lucas Joe , 2, um Bierg L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
Lucas Marc, 4, neie Wee L-9651 Eschweiler, luxemburgisch;
Marx Cecile , 7, op der Tom L-9760 Lellingen, luxemburgisch;
Marx Katharina, 7, op der Tom L-9760 Lellingen, luxemburgisch;
Michels Carlo , 18, Cité bei der Kapell L-9767 Pintsch, luxemburgisch;
Scharll Roland , 3, op Héisbrich L-9760 Lellingen, luxemburgisch;
Schaus Steve, 1, Klierwerstrooss L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
Tosseng Ingo, 1, op der Schleckt L-9747 Enscheringen, luxemburgisch;
Weimersklrch Sam, 3, ierwescht Duerf L-9760 Lellingen, luxemburgisch;
Zens Marco, 5, rue des Romains L-2444 Luxembourg, luxemburgisch;

ANHANG B:

<i>Vereinswappen

Référence de publication: 2010059464/328.
(100059235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Holmes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 47.221.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 mars 2010 que:
La cooptation de Monsieur Luc GERONDAL en date du 5 mars 2008 décidée par le Conseil d'Administration est

ratifiée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010059865/14.
(100059387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57495

Scala IRP Capital Partners, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 92-1A, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 144.614.

En date du 23 mars 2010, Monsieur Robert Akkerman a démissionné de son poste de gérant de la Société.
A cette même date, Monsieur Anthony Green a également démissionné de son poste de gérant de la Société.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Scala IRP Capital Partners
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2010059883/14.
(100059368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Bâloise Vie Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 54.686.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2010

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs Annemie D'Hulster, Peter Zutter, Jan De Meulder, German Egloff, et André Bredimus

venant à échéance, l'Assemblée décide de procéder au renouvellement de leurs mandats pour une période d'un an. Leurs
mandats expirent donc à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2010.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège

à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, venant à échéance, pour la période expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur l'exercice 2010.

André BREDIMUS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010059893/18.
(100059661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Artbo SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 115, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 150.529.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil

<i>d'administration en date du 26 avril 2010

L'an deux mille dix, le vingt-six avril à 18.30 heures.
S'est réuni le conseil d'Administration de la société ARTBO SA, établie et ayant son siège social à L-8077 Bertrange,

115, rue de Luxembourg.

L'ordre du jour est le suivant:
1. Démission de Me Bréart comme administrateur.
2. Nomination de Me Lhomme Blandine comme administrateur.
3. Nomination de M. Jacques Dimitri comme administrateur.
4. Nomination de Me Charlier Irène comme administrateur.
5. Nomination de Me Lhomme Blandine comme administrateur délégué.
Tous demeurant à l'adresse suivante: 115, rue de Luxembourg, L-8077 Bertange.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour, la séance est levée a 19.00 heures.
Référence de publication: 2010059884/20.
(100059472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57496

LCF Edmond de Rothschild Conseil, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 59.956.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg le 25 mars 2010

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide le renouvellement, pour un nouveau terme d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordi-

naire de 2011,

- des mandats des administrateurs suivants:
MM. Frédéric Otto, Marc Ambroisien, Pierre-Marie Valenne et Geoffroy Linard de Guertechin.
- du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. en qualité de réviseur d'entreprises.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2010.

Marc Ambroisien / Frédéric Otto
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2010059885/19.
(100059504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 19.194.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1 

<i>er

<i> avril 2010 à Luxembourg

2.3 Réviseur d'Entreprises (PricewaterhouseCoopers SARL)
Le Conseil décide de renouveler son mandat de réviseur de la Banque pour un nouveau terme d'une année expirant

à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes sociaux 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2010.

Luc Grégoire / Frédéric Otto
<i>Secrétaire Général / <i>Administrateur - Directeur Général

Référence de publication: 2010059887/15.
(100059490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 19.194.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

<i>des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg le 13 avril 2010

<i>Quatrième résolution

A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de réélire en tant qu'administrateurs pour un terme d'un an expirant à

l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011 les personnes suivantes:

Baron Benjamin de Rothschild,
Messieurs John Alexander, Luc Baatard, Didier Bottge, Laurent Dassault, José-Luis de Vasconcelos e Sousa, Claude

Messulam, Frédéric Otto, Yves Repiquet, E. Trevor Salathé et Daniel-Yves Trèves.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2010.

Luc Grégoire / Frédéric Otto
<i>Secrétaire Général / <i>Administrateur - Directeur Général

Référence de publication: 2010059886/19.
(100059490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57497

Immobilière du 3 Joseph II, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 64.565.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg le 1 

<i>er

<i> mars 2010

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide:
- le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec

l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011;

- la nomination de PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. en qualité de Commissaire aux comptes pour une période d'un an

prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2010.

Philippe Postal / Luc Grégoire
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2010059888/19.
(100059566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Bellivo, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 57.656.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination de la personne suivante en tant que représentant permanent de son administrateur:

- Monsieur Gerard VAN HUNEN, résidant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, a

été nommé en date du 15 janvier 2009 en tant que représentant permanent de Lux Business Management S.à.r.l.

- Monsieur Peter VAN OPSTAL, résidant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, a été

nommé en date du 15 janvier 2009 en tant que représentant permanent de Lux Konzern S.à.r.l.

Luxembourg, le 9 avril 2010.

Lux Business Management S.à.r.l. / Lux Konzern S.à.r.l.
<i>Représentée par Gerard VAN HUNEN / <i>Représentée par Peter VAN OPSTAL

Référence de publication: 2010059903/16.
(100059773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Copri 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 37.477.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg le 1 

<i>er

<i> mars 2010

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide:
-  le  renouvellement  des  mandats  des  Administrateurs  pour  une  nouvelle  période  d'un  an  prenant  fin  à  l'issue  de

l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011. Le Conseil d'administration sera donc composé de Messieurs Geoffroy Linard
de Guertechin, Luc Grégoire, Martin Leuthold et Denis de Montigny.

- la nomination de PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. en qualité de Commissaire aux comptes pour une période d'un an

prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

57498

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2010.

Luc Grégoire / Geoffroy Linard De Guertechin
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2010059890/20.
(100059571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Bâloise Europe Vie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 45.918.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2010

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs Annemie d'Hulster, Peter Zutter, Jan De Meulder, German Egloff, et André Bredimus

venant à échéance, l'Assemblée décide de procéder au renouvellement de leurs mandats pour une période d'un an. Leurs
mandats expirent donc à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2010.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège à

L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, venant à échéance, pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire
statuant sur l'exercice 2010.

André BREDIMUS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010059894/18.
(100059621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Horacio, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 147.228.

Par contrat daté du 20 janvier 2010, Monsieur Jean Marc BONDY, associé unique de la Société a vendu toutes ses

cent (100) parts sociales, représentant la totalité du capital social de la Société, à Monsieur Jean Bastien PASQUINI, né
le 25 juillet 1965 à Sarlat La Caneda, France, demeurant au 36, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, avec effet
au 20 janvier 2010.

En conséquence, à partir du 20 janvier 2010, Monsieur Jean Bastien PASQUINI est l'associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Horacio
M. Jean Bastien PASQUINI

Référence de publication: 2010059908/16.
(100059447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Bâloise Assurances Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 68.065.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2010

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs Annemie D'Hulster, Peter Zutter, Jan De Meulder, German Egloff, et André Bredimus

venant à échéance, l'Assemblée décide de procéder au renouvellement de leurs mandats pour une période d'un an. Leurs
mandats expirent donc à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2010.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège

à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, venant à échéance, pour la période expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur l'exercice 2010.

57499

André BREDIMUS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010059895/18.
(100059682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Majicaule International s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 129.262.

<i>Extrait des résolutions prises suite à une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 22 avril 2010

Il résulte de la convention de cession de parts sociales tenue sous seing privé en date du 22 avril 2010 que:
- Marc THEISEN, avocat, né le 5 novembre 1954 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

291 route d'Arlon, cède et transport au cessionnaire, Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences
économiques, demeurant professionnellement au L-1150 Luxembourg, 291 route d'Arlon, qui accepte 100 (cent) parts
sociales d'une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt cinq euros) chacune, entièrement libérées dont il est propriétaire
au sein de la société.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées à compter de ce jour avec tous les droits y attachés.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010059896/19.
(100059413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Kredietcorp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 14.223.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 avril 2010

Monsieur Johan Thijs, né à Genk (Belgique) le 28 juillet 1965 et domicilié 260, Moorsemsestraat à B-3130 Betekom,

est nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de Kredietcorp S.A. pour un mandat débutant à la présente
Assemblée Générale et venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 pour approuver les
comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Kredietcorp S.A.
Marc Stevens / Ivo Bauwens
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2010059900/17.
(100059731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Amazon Insurance &amp; Pension Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 110.340.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2010

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Daniel Frank, demeurant à

L-8357 Goeblange, 20, Domaine du Beauregard, venant à échéance, pour la période expirant à l'Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur l'exercice 2010.

Marco MOES
<i>Gérant technique

Référence de publication: 2010059899/14.
(100059670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57500

Crosscapital Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 114.057.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle

<i>des Actionnaires tenue au siège social à Hesperange le jeudi 15 avril 2010

<i>Résolution 7

L'Assemblée ratifie la nomination de M. Raffaele Rossetti au poste d'administrateur de la Société en remplacement de

M. Carlo Gallina.

L'Assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur de M. Roberto Crippa, M. Raffaele Rossetti et M. Mas-

simo Paolo Gentili pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

<i>Résolution 8

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg

pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2010059904/19.
(100059810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Nordea Multi Label, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 131.121.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 24 septembre 2009

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le Conseil d'Administration a pris note de la démission, à compter du 24 septembre 2009, de:
* M. Christophe Girondel, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
- Le Conseil d'Administration a décidé de coopter au poste d'administrateur et Président vacant:
* M. Lars Erik Høgh, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2010.

Luxembourg, le 23 février 2010.

Nordea Investment Funds S.A.
Michael Maldener / Andrea Martin
<i>Compliance Officer / -

Référence de publication: 2010059912/18.
(100059700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Hyosung Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 13.220.000,00.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Z.I. Piret.

R.C.S. Luxembourg B 121.171.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 31 mars 2010

Il résulte desdites résolutions que:
- la démission de Monsieur Jae II Chung avec effet au 31 mars 2010 en tant qu'administrateur unique de la Société a

été acceptée;

- Monsieur Hee Chul Shin, né à Séoul, Corée du Sud, le 6 juillet 1966, demeurant au 5A, rue des Celtes, L-1318

Luxembourg, a été nommé administrateur unique de la Société avec effet au 1 

er

 avril 2010. Son mandat expirera à l'issue

de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

57501

Luxembourg, le 26 avril 2010.

Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010059905/19.
(100059278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

ING Belgium International Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 49.080.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2010

L'Assemblée  constatant  que  les  mandats  d'administrateur  de  Messieurs  Rik  VANDENBERGHE,  Eric  LOMBAERT

(l'adresse professionnelle de ces derniers étant sise 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg), Bertrand SOENEN et Bernard
CANIVET (l'adresse professionnelle de ces derniers étant sise 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles) sont arrivés à leur
terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période d'un an, qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Le Président prend acte de l'acceptation de leur mandat, par les administrateurs.
D'autre part, l'assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d'Entreprises, la société anonyme ERNST &amp; YOUNG, Parc

d'Activité Syrdall 7 à L-5365 Munsbach, pour une période d'un an, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Signatures.

Référence de publication: 2010059906/19.
(100059312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Business Consulting Group, en abrégé BCG, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 148.624.

EXTRAIT

- Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 4 décembre 2009

que Monsieur Jean Pierre VIELLEVOYE, industriel, demeurant CH-3963 CRANS MONTANA, 5, Allée Elisée Bonvin a
été nommé aux fonctions de président du Conseil d'administration durant la durée de son mandat d'administrateur, soit
jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010059916/16.
(100059261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Vantage EBS Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 137.931.

Il résulte de lettres recommandées adressées à la société que les gérants Christian Gaillot et Koen De Vleeschauwer

ont démissionné de leur mandat de gérants A de la société avec effet au 23 mars 2010.

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010059907/11.
(100059318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

57502

Cofhylux, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 7.128.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 mars 2010

Suite à la proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale décide de confier le mandat de commissaire

aux comptes à la société MAZARS, pour une nouvelle période d'une année.

Suite à la décision du Conseil d'administration, l'Assemblée générale prend note de la prolongation du mandat de

directeur de Monsieur Robert ELTER ainsi que du mandat du sous-directeur de Monsieur Carlo KIRSCH pour une période
d'une année.

L'Assemblée générale est également informée du renouvellement du mandat de mandataire de Monsieur Roby THILL,

Monsieur Michel GONÇALVES, Monsieur André FORESTI et Madame Stéphanie MARBEHANT pour une période d'une
année. Ces fonctions sont dédiées à la gestion journalière de COFHYLUX S.A..

Luxembourg, le 12 mars 2010.

Laurent JANSEN / Carlo GOERES / Marc LENERT.

Référence de publication: 2010059909/17.
(100059577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

ARIA Structured Investments SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SI-

CAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 130.369.

Le gérant, Aria Structured Investments S.àr.l., de la Société a désormais l'adresse suivante:
L-2340 Luxembourg, 6 rue Philippe II.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Aria Structured Investments SICAV-SIF
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010059910/14.
(100059618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Miladi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 47, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 146.023.

EXTRAIT

- Il résulte de la cession de parts du 14 décembre 2009 que la répartition est désormais la suivante,
* M. Miladi Mohamméd, propriétaire de 125 parts.
* M. Guiorgui Ivanovitch ROMANOV-ROSMAN, propriétaire de 125 parts.

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Référence de publication: 2010059911/12.
(100059690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Marcom House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 104.443.

Lors de l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires tenue le 31 mars 2010, il a été résolu ce qui suit:
1. D'approuver la démission de M. Peter ENGELBERG comme administrateur au conseil d'administration;
2. D'élire M. Torben MADSEN demeurant professionnellement au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

comme administrateur au conseil d'administration.

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

At the Extraordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on March 31st,

2010, it has been resolved the following:

1 To accept the resignation of Mr Peter ENGELBERG as director of the company;

57503

2 To appoint Mr Torben MADSEN residing professionally at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, as a

new director of the company.

Fiona Finnegan / Gilles Wecker.

Référence de publication: 2010059917/18.
(100059264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

T.S.R. (Time Share Renting) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 49.901.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 21 avril 2010

Le mandat du commissaire aux comptes HRT REVISION S.A., a été révoqué avec effet au 21 avril 2010. Est nommée

nouveau commissaire aux comptes, la société JENVILLE S.A., avec siège social à Mossfon Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

Street, Panama-City, République de Panama jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010059918/13.
(100059274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Reipa Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 38.578.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 21 avril 2010

Le mandat du commissaire aux comptes HRT REVISION S.A., a été révoqué avec effet au 21 avril 2010. Est nommé

nouveau commissaire aux comptes, la société JENVILLE S.A., avec siège social à Mossfon Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

Street, Panama-City, République de Panama jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010059919/13.
(100059275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Alcanada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 83.617.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010059940/10.
(100059159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Wigre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 71.604.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire tenue le 01/04/2010

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire

Pour avis sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2010059920/12.
(100059293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

57504


Document Outline

Ademus S.à r.l.

Äischer Pompjeeën asbl

Alcanada S.A.

Amadelux International S.à r.l.

Amazon Insurance &amp; Pension Services S.à r.l.

Aradco Holdings, S.à r.l.

ARIA Structured Investments SICAV-SIF

Artbo SA

Association Luxembourgeoise de Criminologie

Azul Finance S.à r.l.

Azul Management S.à r.l.

Bâloise Assurances Luxembourg S.A.

Bâloise Europe Vie S.A.

Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Bellivo

Business Consulting Group, en abrégé BCG

Cofhylux

Copri 3 S.A.

Crosscapital Sicav

Dimmi Si Mersch S.A.

Encore Plus Real Estate Bad Cannstatt S.à r.l.

Financière Star 1

Holmes S.A.

Horacio

House of Arts &amp; Design S.à r.l.

Hyosung Luxembourg S.A.

Immobilière du 3 Joseph II

ING Belgium International Finance S.A.

International Helicopters S.A.

International Helicopters S.à r.l.

JP Finance S.à r.l.

Kredietcorp S.A.

LCF Edmond de Rothschild Conseil

Locationlux S.A.

Luxinvest S.A.Holding

Majicaule International s.à r.l.

Marcom House S.A.

Miladi S.à r.l.

Nordea Multi Label

Novotek Luxembourg Participations S.A.

Pian Luxembourg S.A.

PRI Investment

Reipa Immobilière S.A.

Remapa Holding S.A.

Scala IRP Capital Partners

Schloss Berkenburg Holding AG

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A.

Stardust Luxembourg S.A.

Thermo-San S.A.

TM.A S.A.

Tropical Island S.à r.l.

T.S.R. (Time Share Renting) S.A.

UPC DTH S.à r.l.

Vantage EBS Holding

WE Brand S.à r.l.

Wigre S.A.

Worms &amp; Cie S.C.A.

Xiam S.A.