This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 875
28 avril 2010
SOMMAIRE
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41967
Athic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41971
BCD Travel Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
41983
cominvest Asset Management S.A. . . . . . .
41967
Coney S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41997
Deloitte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41966
Dexia Quant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41964
Dimocharous S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41983
Fiduciaire du Grand-Duché de Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41982
Genevrieres European Finance S.A. . . . . .
41998
Imperatriz Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
41999
IMY S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41954
International Pension Administration S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41981
Julius Baer Multicash Advisory . . . . . . . . . .
41997
Julius Baer Multicooperation Advisory . . .
41983
Julius Baer Multiinvest Advisory . . . . . . . . .
41982
Julius Baer Multiopportunities Advisory
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41982
Julius Baer Multipartner Advisory . . . . . . .
41982
Julius Baer Multiselect Advisory . . . . . . . . .
41983
Julius Baer Multistock Advisory . . . . . . . . . .
41981
Julius Baer Sicav II Advisory . . . . . . . . . . . . .
41981
Julius Baer Strategy Fund Advisory . . . . . .
41981
Longevity Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42000
Magadom International S.A. . . . . . . . . . . . .
41999
Manuel Silva Immobilière S.à r.l. . . . . . . . .
42000
Mare Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41972
MB CONSULT s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41971
Michelangelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41969
MusicEnterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41999
Nosbusch-Kohnen s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
41999
PEME 09 - ITM S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . .
41955
Piscadera Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
41965
Prestige 2001 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41971
Progx S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41998
Promexis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41998
QS Geo Pep S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . .
41964
R.E.W.-Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41998
Ril Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41954
Russian Style Investments S.à r.l. . . . . . . . .
41998
Sewerin Schiltz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41981
Sicav Patrimoine Investissements . . . . . . .
41955
Space Liner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41969
Sudring Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41965
Swiss & Global Multicash Advisory S.A.H.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41997
Swiss & Global Multicooperation Advisory
S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41983
Swiss & Global Multiinvest Advisory S.A.H.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41982
Swiss & Global Multiopportunities Adviso-
ry S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41982
Swiss & Global Multipartner Advisory
S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41982
Swiss & Global Multiselect Advisory S.A.H.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41983
Swiss & Global Multistock Advisory S.A.H.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41981
Swiss & Global Sicav II Advisory S.A.H. . .
41981
Swiss & Global Strategy Fund Advisory
S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41981
Valengilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41980
Valmis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41997
Valorinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41954
Vista S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41980
Wachsund Handelsgesellschaft A.G. . . . . .
42000
WWK Rolling Protect . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41966
WWK Rolling Protect . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41967
Xtreme Equipment Group . . . . . . . . . . . . . .
41984
Yaletipart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41955
Zork S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41965
41953
Ril Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.663.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social le <i>18 mai 2010i> à 20.00 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport du Conseil d'Administration;
- Rapport du Commissaire aux Comptes;
- Approbation des Comptes 2009;
- Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Renouvellement éventuel des mandats sociaux;
- Divers.
Luxembourg, le 9 avril 2010.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi> .
Référence de publication: 2010036681/1559/17.
Valorinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 53.010.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am <i>6. Mai 2010i> um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:
<i>Tagesordnung:i>
1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates und des Bericht des Abschlussprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses und der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2009
3. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Satzungsgemäße Ernennungen
5. Verschiedenes
Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der
Gesellschaft verfügbar.
Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien einen Arbeitstag vor dem Datum der
Versammlung bei der KBL European Private Bankers, 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg hinterlegen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2010041736/755/20.
IMY S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.786.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2010i> à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Ratification de la cooptation d'un administrateur
5. Décharge spéciale à un administrateur démissionnaire
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2010040798/795/17.
41954
Sicav Patrimoine Investissements, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 54.954.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui sera tenue au siège social de la Société le <i>10 mai 2010i> à 10.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
I. Modification statutaire
Modification de la première phrase du premier paragraphe de l'article 10 des statuts afin de lui donner la teneur
suivante:
«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social de la
Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quatrième jeudi d'avril à
seize heures.»
II. Divers.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que la résolution ci-dessus requiert un quorum de 50% des
actions en circulation et la résolution ne sera valablement votée que si elle est prise à la majorité des deux tiers des
actions présentes ou représentées.
Si le quorum de 50% des actions en circulation n'est pas atteint lors de l'assemblée, l'assemblée générale des action-
naires sera ré-convoquée pour 25 juin 2010 à 10.45 heures et, à cette nouvelle assemblée, les décisions seront prises
sans exigences de quorum à la majorité simple des actions présentes et représentées à l'assemblée.
Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à l'assemblée sont informés qu'une procuration est disponible
sans frais au siège social de la Société. Celle-ci restera valable, le cas échéant, pour l'assemblée générale extraordinaire
telle que re-convoquée.
Le texte des modifications des statuts peut être consulté, sans frais, au siège social de la Société.
<i>Pour le compte du Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2010040285/755/28.
Yaletipart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.633.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra anticipativement le <i>7 mai 2010i> à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2010040801/795/15.
PEME 09 - ITM S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Inves-
tissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 152.466.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzehn, am einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung von Notar Henri
HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt.
41955
Sind erschienen:
1. Institutional Trust Management Company S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger
Recht, mit Sitz in 18, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
hier ordnungsgemäß vertreten durch Julia Blunck, Rechtsanwältin, berufsansässig in Luxemburg, gemäß privatschrift-
licher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 25. März 2010.
2. FPE Private Equity Beteiligungs-Treuhand GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht
mit Sitz in c/o Pöllath + Partner, Kardinal-Faulhaber Strasse 10, D-80333 München,
hier ordnungsgemäß vertreten durch Julia Blunck, Rechtsanwältin, berufsansässig in Luxemburg, gemäß privatschrift-
licher Vollmacht, ausgestellt in Bad Homburg, am 24. März 2010.
Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung und Paraphierung "ne varietur" durch die erschienenen Parteien und
den unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselbigen bei den für Registrierungen
zuständigen Behörden eingereicht zu werden.
Die erschienenen Parteien haben den beurkundenden Notar ersucht, die nachfolgende Satzung einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien in Form einer Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital
à risque, SICAR), zu beurkunden, die wie folgt unter den Parteien gegründet werden soll:
Art. 1. Name. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Inhaber auszugebender
Aktien (die "Aktien") werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in der Form einer Investmentgesellschaft
zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque, SICAR) unter dem Namen PEME 09 - ITM S.C.A.,
SICAR (die "Gesellschaft") gegründet.
Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital,
einschließlich der Änderungen und Ergänzungen dieses Gesetzes (das "Gesetz von 2004").
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können durch Beschluss des Komplementärs sowohl
im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. Innerhalb ein und derselben Gemeinde kann der
Sitz durch einfachen Beschluss des Komplementärs verlegt werden.
Sollten nach Ansicht des Komplementärs außergewöhnliche politische oder wirtschaftliche Ereignisse vorliegen oder
bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die ungestörte Kommunikation
zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, so kann bis zur vollständigen Behebung dieser ungewöhnlichen
Umstände der Sitz zeitweilig ins Ausland verlegt werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung
auf die Zugehörigkeit der Gesellschaft zu Luxemburg; letztere bleibt ungeachtet einer solchen zeitweiligen Sitzverlegung
eine Luxemburger Gesellschaft.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Gelder in
Risikokapital im weitesten Sinne von Artikel 1 des Gesetzes von 2004.
Die Gesellschaft kann die ihr zur Verfügung stehenden Gelder auch in andere gesetzlich zulässige und im Einklang mit
der Satzung stehenden Vermögenswerten anlegen.
Überdies kann die Gesellschaft solche Maßnahmen ergreifen und solche Geschäfte durchführen, die sie für die Erfüllung
und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für angebracht erachtet und die im Sinne des Gesetzes von 2004 in seiner
weitesten Auslegungsmöglichkeit zulässig sind.
Art. 5. Haftung. Die Institutional Trust Management Company S.à r.l. ist Komplementär der Gesellschaft (der "Kom-
plementär"). Als solches ist er Geschäftsführer (gérant) und Aktionär der Gesellschaft. Er hält eine Aktie - die
"Komplementärsaktie" -, die nicht übertragbar ist und weder zu Dividendenzahlungen noch zu Kapitalrückführungen
berechtigt. Der Komplementär haftet persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht
aus deren Vermögen bezahlt werden können.
Die Kommanditaktionäre (im folgenden die "Aktionäre") haben keinerlei Vertretungsbefugnisse im Zusammenhang
mit der Gesellschaft. Einzig im Rahmen der Hauptversammlung können die Aktionäre ihre Aktionärsrechte ausüben. Sie
haften Dritten gegenüber nur in der Höhe ihrer Einlage.
Art. 6. Bestimmung der Anlageziele sowie der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen. Im Einklang mit dem Inhalt
des Verkaufsprospektes und den Bestimmungen vorliegend anwendbarer Gesetze und Rechtsvorschriften bestimmt der
Komplementär nach Gründung der Gesellschaft durch Beschluss sowohl die Anlageziele, die Anlagepolitik und die Anla-
gebeschränkungen der Gesellschaft, als auch die Art und Weise der diesbezüglichen Geschäftsführung und Geschäftstä-
tigkeiten der Gesellschaft.
Art. 7. Kapital.
(a) Das Kapital der Gesellschaft wird durch Aktien ohne Nennwert verkörpert und entspricht zu jeder Zeit dem
Gesamtwert des Nettovermögens der Gesellschaft gemäß Artikel 13 dieser Satzung. Der Mindestbetrag des Kapitals der
Gesellschaft liegt gemäß den gesetzlichen Vorschriften bei einer Million Euro (EUR 1.000.000,-), erhöht um den Ausga-
41956
beaufschlag und ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft als Investmentgesellschaft zur
Anlage in Risikokapital gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts zu erreichen.
(b) Das Gründungskapital beträgt 31.000 Euro (einunddreissigtausend Euro) und ist in eine (1) Aktie, die durch den
Komplementär gehalten wird (die "Komplementärsaktie"), und in 30 (dreissig) Kommanditaktien der Aktienklasse A
jeweils ohne Nennwert eingeteilt. Bei der Gesellschaftsgründung wurden die Komplementärsaktie und die Kommandi-
taktien der Aktienklasse A vollständig eingezahlt.
(c) Der Komplementär kann im Einklang mit den Bestimmungen und entsprechend den Anforderungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungen und Ergänzungen dieses Gesetzes (das
"Gesetz von 1915") durch Beschluss Aktienklassen bilden. Deren Merkmale, Modalitäten und Bedingungen werden durch
den Komplementär bestimmt und in den Verkaufsprospekt mit aufgenommen.
(d) Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit des Nettovermögens der Gesellschaft. Das Ge-
sellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien
durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.
Art. 8. Aktien und Aktienzertifikate. Die Kommanditaktien (nachfolgend die "Aktien") sind ausschließlich sachkundigen
Anlegern im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 vorbehalten.
Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.
Für die Aktien wird ein Aktionärsregister am Firmensitz der Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen
eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum der Über-
tragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Komplementär durch
Beschluss bestimmte Person(en) unterzeichnet.
Aktienzertifikate zu Aktien werden lediglich auf Antrag und Kosten des Aktionärs ausgestellt. Es wird dem Aktionär
jedoch immer eine Bestätigung der Eintragung im Aktionärsregister zugestellt. Beantragte Aktienzertifikate werden binnen
eines Monats nach Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen der gezeichneten Aktien eingegangen sind.
Aktienzertifikate werden durch zwei vom Komplementär durch Beschluss bestimmte und bevollmächtigte Personen un-
terzeichnet.
Die Übertragung einer Namensaktie wird, nach vorheriger Zustimmung durch den Komplementär, durch eine schrift-
liche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister eingetragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder
durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen unterschrieben wird, sowie durch Einreichung des Aktienzertifi-
kates, falls ausgegeben, durchgeführt. Die Gesellschaft kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender
Weise die Übertragung belegen. Aktien der Gesellschaft können nur an sachkundige Anleger im Sinne des Artikels 2 des
Gesetzes von 2004 übertragen werden, sofern der jeweilige Erwerber voll und ganz die restlichen Verpflichtungen ge-
genüber der Gesellschaft übernimmt.
Werden Aktien an der Gesellschaft im Sicherungsvermögen eines deutschen Versicherungsunternehmens geführt, darf
das betreffende Versicherungsunternehmen über diese Aktien nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des gemäß §
70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes ("VAG") bestellten Treuhänders für das Sicherungsvermögen oder sei-
nes Stellvertreters verfügen, oder (im Falle von Niederlassungen von Versicherungsunternehmen mit Sitz außerhalb des
EWR) gemäß § 110 VAG nur mit Zustimmung der zuständigen deutschen Aufsichtsbehörde.
Jeder Aktionär muss der Gesellschaft seine Adresse zwecks Eintragung im Aktionärsregister mitteilen. Weicht diese
von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und An-
kündigungen der Gesellschaft zugunsten von Aktionären können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt
werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderung seiner Adresse im Register beantragen.
Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das
Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein,
bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder
eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeit-
punkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und
Nießbraucher gegenüber der Gesellschaft vertritt. Sofern eine Einigung auf einen solchen Stellvertreter nicht innerhalb
von 2 Monaten gelingt, gilt die im Alphabet zuerst genannte Person automatisch als Stellvertreter gegenüber der Gesell-
schaft.
Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht,
berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata Basis.
Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zahlung, wie im Verkaufsprospekt näher erläutert, eingegangen ist.
Falls ein Aktionär Aktien der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so
muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 sein.
Art. 9. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugen-
der Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat über eine ihm gehörende Aktie abhanden gekommen oder zerstört
worden ist, wird die Gesellschaft auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den von der
41957
Gesellschaft aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkunden-
forderung, die durch eine Bank, einen Börsenmakler oder eine andere Partei zur Zufriedenheit der Gesellschaft
unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein
Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.
Beschädigte Aktienzertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Aktienzertifikate ausgetauscht werden. Die
beschädigten Aktienzertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und werden von derselben sofort für ungültig
erklärt.
Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Aktionär Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten
zu verlangen, die durch die Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates oder durch die Annullierung des Originalaktienzerti-
fikates entstanden sind.
Art. 10. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern im Sinne
des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 vorbehalten. Des weiteren wird die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz
ihrer Aktien durch bestimmte Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:
- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Gesellschaft geht; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird.
Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft:
(a) die Ausgabe von Aktien verweigern, wenn offenkundig ist, dass diese Ausgabe zur Folge haben würde, den Aktien-
besitz auf eine andere Person zu übertragen, die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen,
(b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer Person, der es nicht erlaubt ist,
Aktien der Gesellschaft zu besitzen (wie etwa Personen, welche keine sachkundigen Anleger im Sinne des Gesetzes von
2004 darstellen), entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,
(c) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer oder mehreren Personen zu einem
solchen Anteil gehalten werden, der die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstiger Gesetze anderer Länder als
Luxemburg zur Folge hat,
(d) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimm-
recht aberkennen.
In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:
i. Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (im folgenden "Rückkaufsbena-
chrichtigung" genannt) zusenden. Die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien und den zu bezah-
lenden Rückkaufspreis an. Die Rückkaufsbenachrichtigung kann dem Aktionär durch Einschreibebrief an seine benannte
Versandadresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden. Der betroffene Aktionär ist
verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate zurückzugeben, die die in der Rückkaufsbena-
chrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern. Mit Büroschluss des in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Tages
ist der Aktionär nicht mehr Besitzer der in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien. Die Aktienzertifikate, die
die entsprechenden Aktien verkörpern, werden annulliert.
ii. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden
"Rückkaufspreis" genannt), entspricht dem zuletzt berechneten Nettovermögenswert der ausgegeben Aktien, so wie
gemäß Artikel 13 der vorliegenden Satzung festgesetzt. Für den Fall, dass jedoch der zuletzt berechnete Nettovermö-
genswert bei Null Euro oder niedriger liegen sollte, wird der Rücknahmepreis 1 (einen) Cent pro Aktie betragen.
iii. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo
ansässigen Bank, welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkaufs-
preis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der eventuell ausgegeben Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufsbe-
nachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern, auszahlen. Nach Hinterlegung des Rückkaufspreises gemäß diesen
Bedingungen, können Personen, die an den in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert sind, keine
Ansprüche auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon aus-
genommen ist das Recht des sich als rechtmäßiger Besitzer der Aktien ausweisenden Aktionärs, den hinterlegten
Rückkaufspreis gegen Rückgabe des oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, wie zuvor erläutert, ausgezahlt
zu bekommen.
iv. Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestandenen
Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden.
Art. 11. Ausgabe von Aktien. Die Zeichnung von Aktien ist sowohl für bestehende als auch für potentielle Aktionäre
einem oder mehreren bestimmten Zeichnungszeitpunkt(en) oder Zeichnungszeitra(ä)um(en) unterworfen. Sie werden
durch Beschluss des Komplementärs festgelegt und im Verkaufsprospekt sowohl genannt als auch ausführlich beschrieben.
Der Ausgabepreis der Aktien ist auf die Weise zu entrichten, wie sie der Komplementär durch Beschluss bestimmt
und im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben hat.
Der Komplementär ist berechtigt durch Beschluss zusätzliche Zeichnungsbedingungen pro Aktienklasse zu bestimmen,
wie beispielsweise das Erreichen von Mindestzeichnungsbeträgen, die Zahlung von Verzugszinsen oder das Bestehen von
41958
Eigentumsbeschränkungen. Ferner können sich die Merkmale der verschiedenen Aktienklassen dahingehend unterschei-
den, dass z.B. unterschiedliche Investorenkreise oder eine spezifische Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik verfolgt
wird. Diese unterschiedlichen Bedingungen und/oder Merkmale werden im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich
beschrieben.
Der Komplementär durch Beschluss kann jedem Mitglied der Geschäftsleitung, jedem Direktor oder Generalbevoll-
mächtigten sowie jedem anderen ordnungsgemäß hierzu Ermächtigten die Aufgabe übertragen, Zeichnungsanträge
entgegenzunehmen, sowie Aktien den entsprechenden Zeichnern gutzuschreiben.
Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere
ein Bewertungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von
Wertpapieren ausgeben, unter der Bedingung, dass diese Wertpapiere der Anlageziele und -strategie der Gesellschaft
entsprechen. Sämtliche Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von
Wertpapieren sind von den betreffenden Aktionären zu tragen.
Der Komplementär behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise durch Beschluss zurück-
zuweisen oder jederzeit, ohne vorherige Mitteilung, die Ausgabe von Aktien auszusetzen. Der Komplementär kann die
Häufigkeit der Aktienausgabe durch Beschluss limitieren.
Art. 12. Rücknahme von Aktien. Die Rücknahme von Aktien auf einseitige Anfrage des Aktionärs ist nicht vorgesehen.
- Der Komplementär wird aber durch Beschluss eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen,
wenn er der Ansicht ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betreffenden Aktionärs zu Lasten der Interessen der übrigen
Aktionäre oder der Gesellschaft geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
mit sich ziehen kann (wie z.B., dass es sich bei dem betreffenden Aktionär nicht um einen sachkundigen Anleger handelt)
oder (iii) bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig
wird. Der Rücknahmepreis entspricht stets dem Nettovermögenswert am Tag der zwangsweisen Rücknahme. Für den
Fall, dass jedoch der zuletzt berechnete Nettovermögenswert bei Null Euro oder niedriger liegen sollte, wird der Rück-
nahmepreis 1 (einen) Cent pro Aktie betragen.
- Des Weiteren kann der Komplementär beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft zurückzukaufen,
um auf diese Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft an die Aktionäre auszuzahlen.
Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am
Kapital der Gesellschaft (sog. freiwillige Rücknahme). Der Rücknahmepreis entspricht stets dem Nettovermögenswert
am Tag der freiwilligen Rücknahme. Für den Fall, dass jedoch der zuletzt berechnete Nettovermögenswert bei Null Euro
oder niedriger liegen sollte, wird zunächst keine Rücknahme der Aktien erfolgen. Die Aktien werden vielmehr erst nach
Verkauf genügender Vermögenswerte und nach Eingang der entsprechenden Mittel zurückgenommen, dies unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre.
Die von der Gesellschaft zurückgenommenen Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rück-
nahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknah-
mepreises ausbezahlt.
Art. 13. Berechnung des Nettovermögenswerts. Der Nettovermögenswert der Aktien (je Aktienklasse) (der "Net-
tovermögenswert") wird unter der Verantwortung des Komplementärs an jedem Bewertungstag - definiert in dem
Verkaufsprospekt der Gesellschaft - berechnet und in der Referenzwährung (entsprechend den Bestimmungen des Ver-
kaufsprospektes) ausgedrückt.
Der Nettovermögenswert pro Aktie wird für jede Aktie (je Aktienklasse) dadurch bestimmt, dass das Nettovermögen,
d.h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen
Aktien (je Aktienklasse) geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktie (je Aktienklasse) wird auf die zweite Dezimal-
zahl abgerundet.
Im Falle von Dividendenzahlungen, Kapitalrückführungen, Kapitalabrufen, Aktienausgaben und -rückkäufen wird das
Nettovermögen der Gesellschaft wie folgt angepasst:
- falls eine Dividende je Aktie (je Aktienklasse) ausgezahlt oder Kapital zurückgeführt wird, verringert sich der Net-
tovermögenswert der Gesellschaft (je Aktienklasse) um den Betrag der Dividendenausschüttung bzw. Kapitalrückführung;
- falls Aktien ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich das Nettovermögen der Gesell-
schaft um den erhaltenen oder eingezahlten Betrag.
Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten:
- alle flüssigen Mittel einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- alle ausstehenden Forderungen einschließlich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften,
aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;
- alle Vermögenswerte, die von der Gesellschaft gehalten werden oder zu ihren Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.
Die Aktiva der Gesellschaft werden gemäß Artikel 5 (3) des Gesetzes von 2004 auf Grundlage des nach billigem
Ermessen bestimmten Wertes bewertet.
Dementsprechend finden die nachfolgenden Regeln Anwendung:
41959
- Der Wert der Anteile an Zielfonds sowie etwaiger Direktinvestitionen wird an Hand der letzten der Gesellschaft
zur Verfügung stehenden Berichte und gemäß den Richtlinien der jeweiligen Private Equity oder Venture Capital Verbände
bestimmt. Im Zweifelsfall werden EVCA Richtlinien zugrunde gelegt.
- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, voraus-
bezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem
jeweiligen vollen zeitanteiligen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden
kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen
Wert zu erhalten.
Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurch-
führbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien
konsequent anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens der Gesellschaft zu erzielen, dies unter
Anwendung des Marktwert- (fair value) und Vorsichtsprinzips sowie des Prinzips von Treu und Glauben.
Vermögenswerte, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden in Euro umgerechnet zum Wechselkurs am betref-
fenden Bewertungstag. Der Nettovermögenswert der Gesellschaft ist an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Gesellschaft
erhältlich.
Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:
- sämtliche Kredite und Forderungen gegen die Gesellschaft;
- angefallene und zu zahlende Kosten (einschließlich Kosten für die Zentralverwaltungsstelle, Beratungs- und Anlage-
beraterkosten, Kosten für die Depotbank);
- sämtliche bekannte und definierbare gegenwärtige und zukünftige Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverp-
flichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden der Gesell-
schaft;
- vom Komplementär durch Beschluss genehmigte und angenommene Verpflichtungen der Gesellschaft;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Art. 14. Aussetzung der Nettovermögenswertberechnung. Der Komplementär ist ermächtigt, die Berechnung des
Nettovermögenswertes der Aktien in folgenden Fällen durch Beschluss vorübergehend auszusetzen:
- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen,
eine normale Verfügung über das Nettovermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu
beeinträchtigen;
- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträcht-
lichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;
- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung der Gesell-
schaft verhindern;
- wenn eine Hauptversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.
Die Aussetzung der Berechnung der Nettovermögenswerte wird den Aktionären per Post an die im Aktionärsregister
eingetragenen Adressen mitgeteilt.
Art. 15. Komplementär. Die Gesellschaft wird von der Institutional Trust Management Company S.à r.l. als Komple-
mentär geführt.
Der Komplementär ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger
Recht. Der Komplementär besitzt die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz von 1915
oder die Satzung der Gesellschaft nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Hauptversammlung vorbehält.
Der Komplementär ist für die Ausführung der Anlagepolitik der Gesellschaft umfassend verantwortlich.
Der Komplementär kann, mit Ausnahme der in Artikel 26 beschriebenen Fälle nicht durch die Hauptversammlung
abberufen und/oder ersetzt werden.
Art. 16. Befugnisse des Komplementärs. Der Komplementär verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-
und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der im Verkaufsprospekt näher
beschriebenen Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen durch Beschluss vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Hauptversammlung vorbe-
halten sind, können durch den Komplementär getroffen werden.
Der Komplementär kann, unter seiner Überwachung und Verantwortung, die tägliche Geschäftsführung sowie die
Ausführung der täglichen Anlagepolitik der Gesellschaft durch Beschluss auf eine oder mehrere, natürliche oder juristische
Personen übertragen. Diese Personen werden namentlich im Verkaufsprospekt benannt. Die Handlungs- und/oder Ver-
tretungsbefugnis, sowie die Befugnis wiederum Unterbevollmächtigte einzusetzen, wird durch Beschluss des Komple-
mentärs festgesetzt.
Der Komplementär kann durch Beschluss auch schriftliche oder notariell beurkundete Spezialvollmachten erteilen.
Der Komplementär kann Dienstleistungsverträge im Namen und für Rechnung der Gesellschaft abschließen.
41960
Unbeschadet solcher Übertragungen, Bevollmächtigungen und Verträge bleibt der Komplementär für die Überwachung
der übertragenen Aufgaben verantwortlich.
Art. 17. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch den Komplementär oder
durch einen oder mehrere Bevollmächtigte, die dieser durch Beschluss bestimmt, verpflichtet.
Art. 18. Haftung und Freistellung. Die Gesellschaft stellt den Komplementär, seine Geschäftsführer, (leitenden) An-
gestellten, Gremienmitglieder und Beauftragten sowie den Anlageberater (zusammen die "Freistellungsberechtigten") voll
umfänglich von jeder Haftung frei, die den Freistellungsberechtigten aus ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft erwachsen
können. Die Freistellung umfasst auch die Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Die Freistellung hat auf
erstes Anfordern zu erfolgen. Ein Anspruch auf Freistellung ist hinsichtlich des Komplementärs ausgeschlossen, wenn
dieser vorsätzlich oder fahrlässig und hinsichtlich der übrigen Freistellungsberechtigten, wenn diese vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt haben. Bei Meinungsverschiedenheiten darüber, ob ein Freistellungsberechtigter vorsätzlich oder
(grob) fahrlässig gehandelt hat, hat der Freistellungsberechtigte Anspruch auf Freistellung bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung über die Meinungsverschiedenheit; wird Vorsatz oder (grobe) Fahrlässigkeit festgestellt, hat der betreffende
Freistellungsberechtigte die empfangenen Leistungen zurückzugewähren.
Die Gesellschafter der Gesellschaft haften für diese Freistellungsverpflichtung bis zur Höhe der von der Gesellschaft
empfangenen Ausschüttungen.
Art. 19. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer
Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, einschließlich der Änderungen und Ergänzungen
dieses Gesetzes (die "Depotbank") abschließen.
Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.
Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit
dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Komplementär alle Anstrengungen unternehmen, um inne-
rhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank zu
bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Ak-
tionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
Art. 20. Hauptversammlung. Die Hauptversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie
hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen,
auszuführen oder zu genehmigen. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, unter der Voraussetzung, dass
der Komplementär diese Beschlüsse genehmigt, es sei denn vorliegende Satzung würde dieses Genehmigungserfordernis
ausdrücklich nicht verlangen.
Die Hauptversammlung tritt auf Einladung des Komplementärs zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,
zusammentreten.
Die jährliche Hauptversammlung wird jeweils am 21. Juni um 15:30 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen
in der Einladung angegebenen Ort abgehalten. Ist dieser Tag ein Feiertag, findet die Hauptversammlung am ersten Ban-
karbeitstag vor dem 21. Juni statt. Die erste jährliche Hauptversammlung der Aktionäre, welche über den ersten
Jahresbericht abstimmen soll, findet innerhalb von 18 Monaten nach Gründung der Gesellschaft statt.
Die Einladung zu den Hauptversammlungen enthält die Tagesordnung und wird per Einschreiben wenigstens acht Tage
vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär und an dessen in dem Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt.
Der Zugang der Einladung an die Aktionäre muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung
wird von dem Komplementär vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der
Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Komplementär jedoch eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.
Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die
Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Hauptversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.
Der Komplementär kann sämtliche sonstige Bedingungen durch Beschluss festlegen, welche von den Aktionären zur
Teilnahme an einer Hauptversammlung erfüllt werden müssen.
Auf der Hauptversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind
(die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu solchen
Vorgängen gehören.
Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und dieser Satzung, ist jede Aktie, unabhängig von der Aktienklasse,
zu einer Stimme berechtigt.
Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, welche
kein Aktionär sein muss, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung, werden die Beschlüsse im Rahmen
der Hauptversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
41961
Soweit Beschlüsse der Hauptversammlung die Modifizierung der vorliegenden Satzung zum Gegenstand haben, bedarf
es (i) eines Anwesenheitsquorums von fünfzig Prozent (50%) des Kapitals - falls dieses Quorum bei einer ersten Ver-
sammlung jedoch nicht erreicht wird, bedarf es bei der nachfolgenden Versammlung dieses Quorums nicht mehr - und
in jedem Fall (ii) einer Zustimmungsmehrheit von mindestens Zwei-Dritteln (2/3) der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre. Unbeschadet dessen muss ein Beschluss der Hauptversammlung, der die Aufgabe des Status der Gesellschaft
als SICAR im Sinne des Gesetzes von 2004 zur Folge hat, einstimmig von allen Aktionären gefasst und zuvor von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier genehmigt werden.
Art. 21. Hauptversammlung der Aktionäre in einer Aktienklasse. Die Aktionäre einer Aktienklasse können zu jeder
Zeit Hauptversammlungen abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diese Aktienklasse betreffen.
Die relevanten Bestimmungen in Artikel 20 sind auf solche Hauptversammlungen analog anwendbar. Jede Aktie be-
rechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Satzung. Aktionäre
können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss,
aber ein Mitglied des Geschäftsführerrates des Komplementärs sein kann, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Hauptversamm-
lung einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2010.
Art. 23. Jahresbericht. Die Gesellschaft veröffentlicht ihren Jahresbericht jeweils innerhalb von sechs (6) Monaten nach
Ende des entsprechenden Geschäftsjahres. Der Jahresbericht enthält gemäß Artikel 24 (2) des Gesetzes von 2004 die
Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, einen Bericht über die Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie
alle wesentlichen Informationen, die es dem Anleger ermöglichen, sich in vollständiger Sachkenntnis ein Urteil über die
Entwicklung der Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnisse der Gesellschaft zu bilden.
Art. 24. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschafts-
prüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Hauptversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt
wird.
Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 25. Ausschüttungen. Die Verwendung des Bilanzgewinns wird von der Hauptversammlung auf Vorschlag des
Komplementärs festgelegt bzw. genehmigt.
Ausschüttungen werden in Euro zu einem Zeitpunkt ausbezahlt, wie dies der Komplementär durch Beschluss zu ge-
gebener Zeit bestimmt. Die Ausschüttungsreihenfolge wird durch den Komplementär bestimmt und im Verkaufsprospekt
sowohl genannt als auch ausführlich beschrieben.
Der Komplementär kann durch Beschluss Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen
beschließen. Dieser Beschluss bedarf keiner Beschlussfassung der Hauptversammlung.
Die Zahlung von Ausschüttungen erfolgt an die Adressen der Aktionäre, die im Namensregister vermerkt sind und an
die dort ggf. hinterlegte Bankverbindung. Der Komplementär kann verschiedene Eigenkapitalkonten einrichten, um die
steuerliche Klassifizierung der Ausschüttungen nach deutschem Recht widerspiegeln zu können. Um diesen Zweck zu
erreichen, kann er Regeln definieren, die z.B. bei jeder Ausschüttung und/oder Zwischenausschüttung festlegen, welches
Konto jeweils angesprochen werden soll.
Der Komplementär kann im Wege der Beschlussfassung über unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüt-
tungen innerhalb der Voraussetzungen und Bedingungen, wie sie vom Komplementär festgelegt werden, entscheiden.
Ferner kann der Komplementär im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und nach freiem Ermessen jederzeit
Kapitalrückführungen beschließen.
Bei der Vornahme von Ausschüttungen ist zu beachten, dass das Mindestkapital der Gesellschaft keinesfalls den Betrag
von 1.000.000 Euro unterschreiten darf.
Art. 26. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Haupt-
versammlung und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse, wie sie für Satzungsänderungen gemäß
dem Gesetz von 1915 gelten, aufgelöst und anschließend liquidiert werden.
Eine automatische Auflösung und anschließend Liquidation der Gesellschaft erfolgt, für den Fall, dass die Rechtsfähigkeit
des Komplementärs endet, der Komplementär liquidiert wird oder sich eine andere Situation ereignet, die ihn daran
hindert, die Gesellschaft zu führen und nach außen zu vertreten (z.B. ein Insolvenzverfahren eröffnet wird), es sei denn
die Hauptversammlung bestellt einen neuen Komplementär unter Einhaltung des für Satzungsänderungen vorgesehenen
Anwesenheitsquorums und Zustimmungserfordernisses, wie sie in Artikel 20 dieser Satzung beschrieben sind. Ein Zus-
timmungserfordernis des Komplementärs besteht in diesem Zusammenhang nicht.
Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen
sein können und die ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Hauptversammlung ernannt wer-
den müssen. Letztere beschließt auch über die Befugnisse und eventuelle Vergütung der Liquidatoren.
41962
Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem
Aktienbesitz an der Gesellschaft verteilt.
Wird die Gesellschaft liquidiert, so erfolgt die Liquidation in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
Diese Bestimmungen spezifizieren die Schritte, die unternommen werden müssen, um die Aktionäre an der Verteilung
der Liquidationserlöse teilhaben zu lassen und sehen die Hinterlegung bei der Caisse de Consignation für alle Beträge,
die bei Abschluss der Liquidation von den Aktionären nicht eingefordert wurden, vor. Beträge, die dort innerhalb der
gesetzlichen Fristen nicht eingefordert werden, verfallen gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts.
Art. 27. Verschmelzung von Aktienklassen. Eine Verschmelzung von Aktienklassen ist nicht möglich.
Art. 28. Interessenwahrung / Interessenskonflikte. Der Komplementär sowie der Analgeberater der Gesellschaft ver-
walten bzw. beraten auch andere Gesellschaften und Dachfonds mit ähnlichen Investitionskriterien. Für den Fall, dass
entweder (i) diese anderen Gesellschaften und Dachfonds und/oder (ii) der Komplementär, der Initiator/ oder der An-
lageberater der Gesellschaft, sowie (iii) die Gesellschaft selbst beabsichtigen, in dasselbe Vehikel zu investieren, kann ein
Interessenskonflikt entstehen, der wie folgt zu lösen ist: Die Gesellschaft wird nur dann investieren, wenn es dem Kom-
plementär bzw. dem Anlageberater gelingt, im Verhältnis zu den anderen Investoren, marktübliche Konditionen auszu-
handeln.
Sofern sich herausstellt, dass einer der Aktionäre der Gesellschaft an einem Vehikel beteiligt ist, in welches die Ge-
sellschaft wünscht zu investieren oder ggfs. bereits investiert ist, wird der Komplementär unverzüglich das für solche
Konstellationen eigens eingerichtet Investment Advisory Board (bestehend aus den Aktionären der Aktienklasse A)
schriftlich informieren, welches anschließend darüber abzustimmen hat, ob eine Investition getätigt oder nicht getätigt
wird bzw. ob die Gesellschaft eine bereits getätigte Investition behalten oder vielmehr versuchen soll, eine solche rück-
gängig zu machen oder sich ihrer durch Übertragung auf Dritte oder sonstige Weise zu entledigen.
Art. 29. Anwendbares Recht. In dieser Satzung nicht geregelte Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes
von 1915 und des Gesetzes von 2004 geregelt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Das Grundkapital wurde wie folgt gezeichnet:
Aktionär
Anzahl der gezeichneten Aktien
1. Institutional Trust Management Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 (Komplementärs-)Aktie
2. FPE Private Equity Beteiligungs-Treuhand GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 A-(Kommandit-)Aktien
Nach der Gründung wurden die Komplementärsaktie und die Aktien der Aktienklasse A vollständig einbezahlt, so dass
ein Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) von nun an zum Beweis des unterzeichneten Notars frei zur
Verfügung steht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.
Die erste jährliche Hauptversammlung der Aktionäre, welche über den ersten Jahresbericht abstimmen soll, findet
innerhalb von 18 Monaten nach Gründung der Gesellschaft statt.
Der erste geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft wird mit Datum 31. Dezember 2010 erscheinen.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, welcher Art auch immer, welche von der Gesellschaft zu tragen
sind und ihr in Verbindung mit der Gründung entstanden sind, werden auf EUR 3.500,- geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die Aktionäre Folgendes beschlossen:
I. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in 18, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
II. Die nachfolgende Person wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer für eine Dauer von einem Jahr bis zum Abhalten
der nächsten Jahreshauptversammlung bestellt:
BDO Audit, Aktiengesellschaft, mit Sitz in Le Dôme, Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg,
RCS Luxembourg B 147.570.
Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg am Datum wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde den erschienenen Parteien, die dem Notar alle mit ihrem Nachnamen, Vornamen, nach Per-
sonenstand und Wohnsitz bekannt sind, verlesen wurde, haben sie gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: J. BLUNCK und C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 avril 2010. Relation: LAC/2010/15076. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
41963
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 19. April 2010.
Référence de publication: 2010042417/464.
(100053542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2010.
QS Geo Pep S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investis-
sement en Capital à Risque.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 135.186.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of QS GEO PEP S.C.A., SICAR (the "Company") for the financial year ended on 31 December 2009 (the "AGM") will
be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 84, Grand-rue, on <i>6 May 2010i> at 11.00 a.m. local time
for the purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To approve the report of QS GEO S.à r.l. as general partner of the Company (the "General Partner") and the
report of the external auditors (the "Auditors") for the year ended on 31 December 2009.
2. To approve the annual accounts for the year ended on 31 December 2009.
3. To grant discharge to the General Partner and the Auditors with respect to the performance of their respective
duties for the year ended on 31 December 2009.
4. To re-appoint the Auditors for a period ending on 31 December 2010.
The shareholders are advised that no quorum is required to resolve on the items set out in the agenda of the AGM
and that resolutions will be taken on simple majority of the shares present or represented and favourably voting for such
resolutions at the AGM.
Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy form is available at the Company's registered office at 84,
Grand-rue, L-1660 Luxembourg (fax: +352 22 60 56).
Proxy forms should be returned to the registered office of the Company to the attention of Mr Jean-Benoît Lachaise
before 05.00 pm (Luxembourg time) on May 4, 2010 as further detailed on the proxy form.
<i>For and on behalf of QS GEO PEP S.C.A., SICAR
The General Partner of the Companyi>
Référence de publication: 2010040835/1628/28.
Dexia Quant, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.647.
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires («l'Assemblée») de Dexia Quant aura lieu au siège social de la société, 69, route d'Esch, L - 1470
Luxembourg le <i>6 mai 2010i> à 15 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre
2009
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre
2009
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2009
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de
s'inscrire jusqu'au 4 mai 2010 auprès de Dexia Quant, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de Fund Cor-
porate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331).
41964
Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l'Assemblée aux guichets de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L - 1470 Luxem-
bourg.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2010041728/755/27.
Piscadera Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 75.904.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 mai 2010i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2009.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2010041750/1023/16.
Zork S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 50.110.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 mai 2010i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2009.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2010041753/1023/17.
Sudring Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken.
R.C.S. Luxembourg B 107.508.
Messieurs les actionnaires de la Société sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi, 5 mai 2010 à 11.00 heures au siège social de la société à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de
Warken.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2010042157/750/16.
41965
WWK Rolling Protect, Fonds Commun de Placement.
Das Sondervermögen WWK Rolling Protect wurde von der WWK Investment S.A. nach Teil I des Luxemburger
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die Anforderungen
der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.
Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 1. April 2010 in Kraft trat und zwecks Veröf-
fentlichung am 28. April 2010 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, beim Handels- und Gesellschaftsre-
gister hinterlegt wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 1. April 2010.
WWK Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2010041906/15.
(100052701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2010.
Deloitte S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 67.895.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 15 décembre 2009 que:
1- La démission de Monsieur Philippe Bruneton de son mandat d'administrateur a été acceptée.
2- Le mandat des administrateurs suivants a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur
les comptes de l'exercice 2010:
- Dan Arendt
- Manuel Baldauff
- Stéphane Césari
- Georges Deitz
- Dirk Dewitte
- Yves Francis
- Thierry Hoeltgen
- Georges Kioes
- Maurice Lam
- Benjamin Lam
- Sonja Linz
- Erwan Loquet
- Olivier Maréchal
- Barbara Michaelis
- Vafa Moayed
- Pascal Noël
- Franz Prost
- Gilbert Renel
- Benoit Schaus
- Eric Van de Kerkhove
- Johnny Yip
3- Les personnes suivantes ont été nommées en tant qu'Administrateur:
- Monsieur Vincent Gouverneur, né le 6 février 1968 à Longlier, Belgique, avec adresse professionnelle au 560, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg;
- Monsieur Raymond Krawczykowski, né le 18 avril 1969 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle au 560, rue
de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
- Madame Sophie Mitchell, née le 28 mars 1969 à Meulan, France, avec adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg.
Le mandat des nouveaux administrateurs se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur
les comptes arrêtés au 31 mai 2010.
41966
4- Le mandat du réviseur a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale devant approuver les comptes de l'exercice
2010, la société:
- PKF ABAX AUDIT, RC B 142.867, avec siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2010.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2010028393/49.
(100024830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.
WWK Rolling Protect, Fonds Commun de Placement.
Das Sondervermögen WWK Rolling Protect wurde von der WWK Investment S.A. nach Teil I des Luxemburger
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die Anforderungen
der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.
Für den WWK Rolling Protect ist das Allgemeine Verwaltungsreglement, das am 1. April 2010 in Kraft trat, integraler
Bestandteil. Dieses Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxembourg hinterlegt, und
der diesbezügliche Hinterlegungsvermerk wurde am 28. April 2010 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
veröffentlicht.
Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des Sonderreglements des WWK Rolling Protect, das am 1.
April 2010 in Kraft trat und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 1. April 2010.
WWK Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2010041908/18.
(100052700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2010.
cominvest Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 28.610.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 27.856.
VERSCHMELZUNGSPLAN
Im Jahre zweitausendzehn, dem zwanzigsten April, um 10.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Capellen.
SIND ERSCHIENEN:
(1) COMINVEST Asset Management S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) Luxemburger Rechts, mit Ge-
sellschaftssitz in L-2540 Luxemburg, 25, rue Edward Steichen, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in
Luxemburg unter Sektion B Nummer 28.610 (die übertragende Gesellschaft), vertreten durch Herrn André Marc, avocat
à la Cour, mit beruflichem Wohnsitz in L-1855 Luxemburg, 33, avenue J.F. Kennedy, handelnd in seiner Eigenschaft als
Bevollmächtigter des Verwaltungsrats der übertragenden Gesellschaft gemäß einer Vollmacht ausgestellt durch einen
Beschluss des Verwaltungsrats der übertragenden Gesellschaft vom 19 April 2010; eine Kopie des Beschlusses des Ver-
waltungsrats, nachdem dieser ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit
derselben einregistriert zu werden.
Die übertragende Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, mit
Amtssitz in Luxemburg, am 8. August 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Amtsblatt
des Großherzogtums Luxemburg, Nummer 246 vom 16. September 1988.
Die Satzung wurde letztmalig abgeändert durch Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, vom
6. Oktober 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Amtsblatt des Großherzogtums
Luxemburg, Nummer 485 vom 7. März 2006.
(2) Allianz Global Investors Luxembourg S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) Luxemburger Rechts, mit
Gesellschaftssitz in L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in
Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter Sektion B Nummer 27.856 (die übernehmende
41967
Gesellschaft), vertreten durch Herrn André Marc, avocat à la Cour, mit beruflichem Wohnsitz in L-1855 Luxemburg, 33,
avenue J.F. Kennedy, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Verwaltungsrats der übernehmenden Ge-
sellschaft gemäß einer Vollmacht ausgestellt durch einen Beschluss des Verwaltungsrats der übernehmenden Gesellschaft
vom 19. April 2010; eine Kopie des Beschlusses des Verwaltungsrats, nachdem dieser ne varietur unterzeichnet wurde,
bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Gesellschaft wurde ursprünglich unter der Bezeichnung dresdnerbank asset management S.A. gegründet, gemäß
Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, vom 21. April 1988, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Nummer 138 vom 25.
Mai 1988.
Die Satzung wurde letztmalig abgeändert durch Urkunde des Notars André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in
Luxemburg, vom 15. November 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Amtsblatt des
Großherzogtums Luxemburg, Nummer 1254 vom 8. Dezember 2004.
Die Erschienenen haben den amtierenden Notar gebeten, folgende Bestimmungen des von den zuständigen Organen
der oben genannten Gesellschaften aufgestellten Verschmelzungsplans aufzunehmen, gemäß den Bestimmungen der Ar-
tikel 261 ff. des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften (das Gesetz):
1. Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. und die COMINVEST Asset Management S.A. beabsichtigen, eine
Verschmelzung durchzuführen, mittels Aufnahme der COMINVEST Asset Management S.A., in ihrer Eigenschaft als über-
tragende Gesellschaft, durch die Allianz Global Investors Luxembourg S.A., in ihrer Eigenschaft als übernehmende
Gesellschaft.
2. Durch Gesellschafterbeschlüsse vom 19. April 2010, haben die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. und die
COMINVEST Asset Management S.A. im Vorfeld beschlossen, gemäß Artikel 266 (5) des Gesetzes, auf die Bestellung
eines sachverständigen Verschmelzungsprüfers, und demnach auf die Prüfung der geplanten Verschmelzung, bzw. auf die
Erstellung eines schriftlichen Berichtes gemäß Artikel 266 (1) des Gesetzes, zu verzichten.
3. Da die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesell-
schaftssitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt a.M. unter der Nummer HRB
9340, alleiniger Gesellschafter der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft ist, wird beschlossen, nach
Durchführung der geplanten Verschmelzung keine Kapitalerhöhung bei der übernehmenden Gesellschaft vorzunehmen
und demnach auch keine neuen Aktien der übernehmenden Gesellschaft an den alleinigen Gesellschafter (der übertra-
genden Gesellschaft) auszugeben.
Das Gesellschaftskapital der übertragenden Gesellschaft in Höhe von EUR 13.000.000 (dreizehn Millionen), wird im
Zuge der geplanten Verschmelzung an die übernehmende Gesellschaft übertragen und der freien Rücklage der überneh-
menden Gesellschaft zugeführt.
4. Keinerlei Vorteil wurde den Verwaltungsratsmitgliedern der beteiligten Gesellschaften zugeteilt.
Es bestehen weder Aktionäre mit Sonderrechten noch Inhaber anderer Wertpapiere bei der übernehmenden oder
der übertragenden Gesellschaft.
5. Die über die Verschmelzung beschließende Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft wird voraussicht-
lich am 31. Mai 2010 oder an einem kurz darauffolgenden Datum stattfinden.
6. Betreffend die Buchführung, sowie die Beteiligung an der Gewinnausschüttung der übertragenden Gesellschaft,
erfolgt die Verschmelzung mit Wirkung zum 1. Januar 2010.
7. Die unter Artikel 267 (1) des Gesetzes angeführten Dokumente und Informationen können vom alleinigen Aktionär
der übernehmenden und der übertragenden Gesellschaft am Gesellschaftssitz der jeweiligen Gesellschaft zur Kenntnis
genommen werden, dies innerhalb eines Monats ab Veröffentlichung des Verschmelzungsplans, und bis zum Inkrafttreten
der Verschmelzung.
Eine Kopie der oben genannten Dokumente und Informationen kann ebenfalls kostenlos vom alleinigen Aktionär der
übernehmenden und der übertragenden Gesellschaft beantragt werden.
8. Der alleinige Aktionär der übernehmenden Gesellschaft kann, innerhalb eines Monats ab Veröffentlichung des
Verschmelzungsplans, und bis zum Inkrafttreten der Verschmelzung, die Einberufung einer Generalversammlung des al-
leinigen Aktionärs der übernehmenden Gesellschaft beantragen, welche über die Billigung der Verschmelzung befindet.
9. In Abwesenheit der Einberufung einer Generalversammlung des alleinigen Aktionärs der übernehmenden Gesell-
schaft, welche über die Verschmelzung befinden soll, bzw. im Falle der Billigung der Verschmelzung, gilt die Verschmelzung
am 31. Mai 2010 als durchgeführt.
10. Die Gesellschaftsdokumente der übertragenden Gesellschaft werden am Gesellschaftssitz der übernehmenden
Gesellschaft hinterlegt und aufbewahrt, dies für die gesetzlich festgeschriebene Dauer.
Der amtierende Notar bestätigt die Rechtsmäßigkeit des Verschmelzungsplans gemäß den anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere Artikel 271 des Gesetzes.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
41968
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben zusammen mit dem
amtierenden Notar, dem sie nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. MARC, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 21 avril 2010. Relation: CAP/2010/1359. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. Neu.
POUR COPIE CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication.
Capellen, le 21 avril 2010.
Camille MINES.
Référence de publication: 2010043222/95.
(100055925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2010.
Michelangelo, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Die Liquidation des Luxemburger Investmentfonds Michelangelo (WKN: A0M61K) wurde mit Wirkung zum 22. April
2010 vollständig abgeschlossen.
Luxemburg, im April 2010.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Référence de publication: 2010045468/1999/9.
Space Liner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 33.380.
L'an deux mil dix, le vingt avril.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert, soussignée.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
Space Liner S.A.
établie et ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot,
constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 mars 1990, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 348 du 26 septembre 1990,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Marc LECUIT, notaire de résidence
à Mersch, en date du 31 décembre 2007, respectivement acte rectificatif reçu par le même notaire en date du 29 février
2008,
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 15 février 2008, numéro 393, page 18855,
respectivement 17 avril 2008, numéro 950, page 45562,
dont le capital social s'élève à la somme de trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) divisé en trois cent trente (330)
actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-),
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 33.380.
L'assemblée est présidée par Madame Joëlle WURTH, demeurant à Beckerich, 27, Huewelerstrooss, qui assume éga-
lement la fonction de scrutateur, suivant décision de l'assemblée générale.
Le président désigne comme secrétaire Madame Helena RAMOS, demeurant professionnellement à Redange/Attert,
19, Grand-rue.
Le président prie le notaire d'acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enre-
gistrée avec l'acte.
II. - Il ressort de la liste de présence que les 330 (trois cent trente) actions, représentant l'intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-8522 BECKERICH, 6, Jos Seylerstrooss, et
modification subséquente de l'article 2 première phrase des statuts afin de le mettre en conformité avec cette décision
de transfert de siège.
41969
2. Constatation de ce que toutes les actions sont détenues par un seul actionnaire, de façon que la société peut être
administrée par un administrateur unique, le tout conformément aux stipulations de l'article 6 des statuts
3. Révocation des actuels administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes actuellement en fonc-
tion et ce avec effet au jour des présentes.
4. Nomination de Monsieur Jos Verbeken, demeurant à B-9310 Meldert-Aalst, 11, Walburgaweg, né le 29 septembre
1944 à Meldert (Belgique), à la fonction d'administrateur unique et ce avec effet au jour des présentes et pour une durée
indéterminée.
5. Fixation des pouvoirs de signature de la société.
Sur ce, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de transférer le siège de la société à la nouvelle adresse
sise à L-8522 BECKERICH, 6, Jos Seylerstrooss et décide de donner dorénavant la teneur suivante à l'article 2 première
phrase des statuts:
« Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Beckerich (Grand-Duché de Luxembourg).»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale constate à l'unanimité des voix que toutes les actions de la société sont actuellement détenues
par un seul actionnaire, de façon que les conditions de l'article 6 des statuts sont remplies aux fins de nommer un seul
et unique administrateur.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de révoquer les administrateurs, administrateurs-délégués
et commissaire aux comptes actuellement en fonction et ce avec effet au jour des présentes.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix Monsieur Jos Verbeken, demeurant à B-9310 Meldert-Aalst, 11,
Walburgaweg, né le 29 septembre 1944 à Meldert (Belgique), à la fonction d'administrateur unique et ce avec effet au
jour des présentes et pour une durée indéterminée.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale confère à l'unanimité des voix à l'administrateur unique les pouvoirs d'engager la société pré-
qualifiée par sa seule signature individuelle et ce en toutes circonstances, y compris toutes opérations bancaires. La société
ne saurait par conséquent plus être engagée par la signature d'une autre personne que celle de l'administrateur unique.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge,
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (850.-), frais pour lesquels
toutes les parties comparantes ainsi que l'administrateur unique Monsieur Jos VERBEKEN s'engagent solidairement et
personnellement à l'égard du notaire instrumentant.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Redange/Attert, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Wurth, Ramos, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, le 20 avril 2010. Relation: RED/2010/497. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de la publication au Mémorial.
Redange/Attert, le 20 avril 2010.
Karine REUTER.
Référence de publication: 2010044366/80.
(100055391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2010.
41970
Prestige 2001 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 37.223.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 15 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:
PRESTIGE 2001 S.à r.l., avec siège social au 47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, dénoncé en date du 9 septembre
1998.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole Kugener, juge, et liquidateur Maître Benjamin Rossi-
gnon, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mai 2010 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Maître Benjamin Rossignon
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2010045018/20.
(100056964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.
MB CONSULT s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 7, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 35.407.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 15 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:
MB CONSULT S.à r.l., avec siège social au 7, Côte d'Eich, L-2014 Luxembourg, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole Kugener, juge, et liquidateur Maître Benjamin Rossi-
gnon, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mai 2010 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Maître Benjamin Rossignon
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2010045019/20.
(100056970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.
Athic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.
R.C.S. Luxembourg B 50.075.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 15 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:
ATHIC S.à r.l., avec siège social au 21, rue Vauban, L-2663 Luxembourg, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole Kugener, juge, et liquidateur Maître Benjamin Rossi-
gnon, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mai 2010 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
41971
Pour extrait conforme
Maître Benjamin Rossignon
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2010045020/20.
(100056966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.
Mare Foundation, Fondation.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg G 207.
In the year two thousand and ten, on the twenty-fourth day of the month of March.
Before Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg,
Appeared:
Mare Foundation, represented by Mr. Francois Diederik Rosendaal, general counsel, residing in 11 Avenue d'Alsace,
06240 Beausoleil, France, pursuant to a proxy dated 24
th
March 2010 which shall remain annexed to the present deed
to be registered therewith.
Mare Foundation (the "Foundation"), having its registered seat at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, and which
has transferred its registered seat from Switzerland to Luxembourg by deed of Maître Joseph Gloden, notary, residing in
Grevenmacher, in the process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, declared that
pursuant to a unanimous resolution taken by its board of directors (the "Board") on 24
th
March 2010, a copy of which
has been produced to the notary and which shall remain annexed to the present deed to be registered therewith, it had
been resolved to restate the articles of association (the "Articles") of the Foundation as follows set out in that resolution.
The appearing party, in the capacity in which he acts, requested the undersigned notary, to restate as follows the
Articles of the Foundation:
Name - Seat - Governing law - Objects - Duration
Art. 1. The name of the Foundation is: MARE FOUNDATION.
It has its seat in Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 2. The Foundation is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the Law of 21
April 1928 on non-profit associations and foundations, as amended (the "Law of 21 April 1928").
Art. 3.
3.1. The objects of the Foundation are to develop initiatives, activities and projects, both foreign and domestic, in one
or more of the following fields or with one or more of the following objectives as well as to provide financial and other
support to organizations, activities and projects with the same or similar objects:
a. art, culture and media;
b. education and science;
c. promotion of the social and economical development and the physical and mental well-being of population groups,
both foreign and domestic and in particular of the inhabitants of the greater metropolitan area of Rotterdam, The Ne-
therlands;
d. promotion of the efficiency and the competitiveness of Dutch merchant shipping by direct donations or by supporting
the initiatives of others for the purpose of the improvement of seagoing ships by the promotion of research inter alia in
the field of the propulsion of ships also in connection with the shape or design and construction of ships by contact with
foreign institutions engaged in those fields and in other fields relating to maritime navigation;
e. development aid;
f. to perform all that is conducive to or connected with the provisions under a. through e., all in the broadest sense.
3.2. The objects of the Foundation do not include the making of profit.
3.3. The Foundation may not make any distributions to any founder or to any of those forming part of its constituent
bodies.
3.4. Neither a legal entity nor a natural person can dispose over the assets of the Foundation as if those were the
assets of that legal entity or natural person.
3.5. The Foundation may also achieve its objects by transferring its assets to an institution in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad which has the same or similar objects as the Foundation or by providing donations to other public
benefit organizations that pursue one or more objects of the Foundation.
Art. 4. The Foundation has been formed for an unlimited duration.
41972
Funds
Art. 5. The funds of the Foundation shall consist of donations, dividends and other revenues of funds invested, as well
as any other revenues. As from the date of the Grand Ducal Decree approving the present Articles, the funds of the
Foundation shall amount to Euro 1 million.
Administration
Art. 6.
6.1. The Board is the supreme governing body of the Foundation. The Board is charged with the management of the
Foundation and may pass resolutions to enter into agreements to acquire, dispose of or encumber registered property
and to enter into agreements whereby the Foundation assumes liability as surety or joint and several co-debtor, guarantees
obligations of third parties or undertakes to give security for debts of another party.
6.2. The primary duties of the Board shall be to:
- determine the strategy, policies and the objectives of the Foundation;
- identify and resolve issues relevant for the achievement of the objects of the Foundation;
- oversee the progress of the activities and the programmes set up by the Foundation;
- adopt the annual budget and the balance sheet and statement of income and expenditure;
- appoint staff members and determine their signing authority;
- appoint the external expert to audit the accounts of the Foundation.
6.3. The Foundation will be bound by the signature of the chairman of the Board or by the joint signatures of any two
members of the Board.
6.4. The Board may adopt rules with respect to such matters as the Board may resolve. In the event that a provision
of the rules of the Board conflicts with these Articles, the Articles shall prevail.
6.5. The Board shall have the authority to establish permanent or ad-hoc advisory committees to deal with specific
issues. These may include committees dealing with analysing requests for donations, public relations, human resources
and investment policies. Members of these committees may or may not be members of the Board, but at least one member
of the Board shall be a member of each committee.
The Board - Composition
Art. 7.
7.1. The Board of the Foundation shall consist of three Board members: one Board member A, one Board member B
and one Board member C. Only natural persons can be Board members.
7.2. Only descendants of the late Nicolaas van der Vorm, born in Rotterdam, the Netherlands on the 25
th
day of
November 1927 or Otto Jan van der Vorm, born in Rotterdam on the 8
th
day of September 1924 or a descendant of
Otto Jan van der Vorm can be Board member A or Board member B. The Board member B cannot be a member of the
same family branch as the Board member A.
The Board member C may not be related by blood or marriage to any of the two different family groups mentioned
in the preceding sentence.
The Board - Functions - Term of office - Advisor - Appointments
Art. 8.
8.1. The Board member A shall be the chairman of the Board. The Board shall appoint a secretary and a treasurer.
The positions of secretary and treasurer can be performed by one Board member.
8.2. The Board shall be assisted by an advisor, who will be appointed and dismissed by the Board member A. The
advisor shall be invited to attend the Board meetings, unless the chairman determines that his attendance to a specific
meeting shall not be required.
8.3. Board members and the advisor are not entitled to receive any remuneration for their activities on behalf of the
Foundation. Reasonable expenses directly related to their activities shall be reimbursed.
8.4. The term of office of the Board member A shall be indefinite. The term of office of the Board member B shall be
five years and the term of office of the Board member C shall be three years. Board members B or C may be reappointed.
The term of office of a successor Board member B or C who has been appointed to fill a vacancy, shall be the remaining
term of office of his predecessor.
8.5. The Board member A may, as long as he is Board member A, appoint his successor, with due observance of article
7.2. As long as he is a Board member A, he may at any time revoke such an appointment.
8.6. If a Board member A ceases to be a Board member without having appointed his successor or if the successor
appointed by him has died or is not available to serve on the Board, the advisor will appoint the successive Board member
A, with due observance of article 7.2.
41973
8.7. Board members B and C are appointed and dismissed by the Board. A resolution to appoint or dismiss a Board
member B or C requires the affirmative vote of the chairman of the Board.
8.8. If there is a vacancy on the Board as a result of which the number of directors would be reduced below three,
the remaining director(s) may fill any vacancy, except for the vacancy of Board member A, who may only be appointed
in accordance with article 8.6. As long as the Board is constituted of only two members, the Board may only consider
urgent matters which may not be deferred prior to completing the Board by appointing members to fill any vacancy.
Resignation of a Board member
Art. 9. A Board member shall cease to be a Board member:
a. if he dies;
b. on his voluntary resignation or, in case of a Board member B or C, at the end of his term of office;
c. because his bankruptcy becomes final, he loses the free control over his estate other than as a result of a suspension
of payments granted to him, or because he is placed under guardianship;
d. in case of a Board member B or C by dismissal pursuant to a Board resolution taken with due observance of article
8.7;
e. in case of the Board member B, in the event that a person is appointed as Board member A and such person is a
member of the same branch, as referred to in article 7.2, as the Board member B.
Board meetings
Art. 10.
10.1. Board meetings shall be held at least once a year and whenever a Board member so requests.
Board meetings will be held at such place as the chairman shall determine, it being understood that each year at least
one Board meeting shall be held in Luxembourg. Board meetings shall be convened by the chairman of the Board or by
the Board member who has requested that the meeting be held, by sending a letter or a legible and reproducible com-
munication to all other Board members and the advisor. The chairman may determine that the advisor shall not be invited
for a specific Board meeting, in which case the advisor shall not receive the notice for a meeting. The notice shall specify
the place and time of the meeting and shall list the matters to be dealt with at the meeting.
The notice period for convening a meeting shall be at least fourteen days, not including the day of the notice letter
and the day of the meeting.
Meetings may also be held by electronic means of communication, provided all participating Board members and the
advisor (unless the chairman determines that the advisor does not need to participate) can communicate simultaneously
with each other.
10.2. The Board meetings shall be chaired by the chairman of the Board, who may however designate another Board
member to chair the meeting.
If the chairman of the Board is absent and no other person has been designated by him to chair the meeting, the Board
meeting shall be chaired by a Board member so designated at that meeting. In such meeting resolutions described in
article 13.1 cannot be adopted.
The secretary of the Board shall keep the minutes of the Board meetings. If the secretary of the Board is absent, the
Board shall designate a Board member as secretary, who shall keep the minutes of the meeting.
10.3. The minutes of a meeting shall be adopted and signed in evidence thereof by the chairman and the secretary, or
they shall be adopted by a subsequent meeting and signed in evidence thereof by the chairman of the Board and the
secretary of that subsequent meeting.
10.4. Each Board member shall be entitled to cast one vote.
10.5. Valid resolutions can only be adopted if at least the majority of the Board members is present or represented
and all Board members have been invited to attend the meeting in accordance with the provisions of these Articles. If
the requirements for convening the meeting have not been met, valid resolutions may be adopted by unanimous vote in
a meeting at which all Board members are present or represented. A Board member may be represented at a meeting
by another Board member who has been given a written proxy; the requirement that the proxy must be in written form
is fulfilled when the proxy is recorded electronically.
10.6. The Board shall adopt resolutions by an absolute majority of votes cast unless these Articles provide otherwise.
In the event of a tie vote in a Board meeting the chairman of the Board has a casting vote. If the meeting will be chaired
by another person than the chairman of the Board, no resolution shall be adopted in the event of a tie vote.
10.7. The Board may also adopt resolutions without holding a meeting, provided that it does so in writing or in a legible
and reproducible manner by electronic means of communication and provided that all Board members express themselves
in favour of the proposal concerned.
The documents evidencing the adoption of such a resolution shall be kept with the minute book.
41974
Director - Staff
Art. 11. The Board may appoint one or more staff members and may grant them the title of director or another title
and may grant them general or specific power of attorney to represent the Foundation at law and otherwise. The director,
if so appointed and the other staff members will be charged with the day-to-day affairs of the Foundation or any specific
part thereof, as well as the preparation and implementation of resolutions of the Board.
Financial year, Balance sheet and Statement of Income and Expenditure
Art. 12.
12.1. The financial year coincides with the calendar year.
12.2. The Board must keep records of the financial position of the Foundation and of everything related to the Foun-
dation's activities, in accordance with the requirements arising out of those activities, and keep the related books,
documents and other data carriers in such a way that the rights and obligations of the Foundation can be ascertained at
all times.
12.3. Each year the Board must prepare and adopt the Foundation's balance sheet and statement of income and
expenditure as well as the budget for the subsequent year.
12.4. The Board may instruct an expert as provided by law to audit the balance sheet and the statement of income
and expenditure.
12.5. The Board shall keep the books, records and other data carriers referred to in this article during the applicable
statutory period.
Specific resolutions
Art. 13.
13.1. The Board may only validly adopt a resolution to:
a. amend the Articles;
b. enter into a legal merger or legal demerger to the extent permitted by law;
c. dissolve the Foundation;
d. enter into a commitment or any other legal act in excess of one hundred thousand euro (EUR 100,000) or a series
of connected commitments or other legal acts which in the aggregate exceed one hundred thousand euro (EUR 100,000);
e. approve a major change in a matter of policy;
if the chairman of the Board votes in favour of the relevant proposal.
13.2. These Articles can only be amended pursuant to a resolution of the Board, adopted with due observance of the
provisions of article 13.1 and the provisions of Article 32 of the law of 21 April 1928, Amendments to the Articles must
be effected by notarial deed. Every Board member may execute such deed.
The Board may dissolve the Foundation, with due observance of the provisions of article 13.1. The liquidation shall be
effected by the Board.
During the liquidation procedure, the provisions of these Articles shall remain in force to the extent possible.
The Board shall determine the allocation of any positive liquidation balance, which allocation shall, in as much as
possible, be in conformity with the objects of the Foundation and shall always be for the benefit of the public interest by
transferring any positive liquidation balance to a foundation organised under the Law of 21 April 1928 or a recognized
charitable organisation organised under the Law of 21 April 1928, in each case recognized by Grand Ducal Decree.
13.3. After the Foundation has ceased to exist, its books, records and other data carriers shall remain in the custody
of the person designated for that purpose by the Board during the applicable statutory period.
Miscellaneous
Art. 14.
14.1. All matters not specifically dealt with in these Articles shall be governed by the Law of 21 April 1928.
14.2. Effective the date of this amendment of the Articles:
a. Mr. Martinus Van der Vorm, residing professionally in 28-30 Boulevard des Moulins, 98000 Monaco, shall serve as
the Board member A and therefore as chairman of the Board for an unlimited period;
b. Mr. Otto Jan van der Vorm, residing in Sowley House, Sowley near Lymington, Hampshire, United Kingdom, shall
serve as the Board member B for a period of 5 years expiring at the adoption of the financial statement of the Foundation
for the period ending 2009;
c. Mr. François Diederik Rosendaal, residing in 11 Avenue d'Alsace, 06240 Beausoleil, France, shall serve as Board
member C for a period of 3 years expiring at the adoption of the financial statement of the Foundation for the period
ending 2009;
d. Mr. Hartgert Langman shall serve as advisor.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into German.
41975
In case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said appearing party signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.
Folgt die deutsche Übersetzung des Textes:
Neuformulierung der Satzung
vom 24. März 2010
Im Jahre zweitausendzehn, am vierundzwanzigsten Tage des Monats März.
Vor Uns, Maître Joseph Gloden, Notar, mit dem Amtssitz zu Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Mare Foundation, vertreten durch François Diederik Rosendaal, Chefjustiziar, wohnhaft zu 11, avenue d'Alsace, 06240,
Beausoleil, Frankreich, aufgrund einer Vollmacht gegeben am 24. März 2010 welche gegenwärtiger Urkunde beigebogen
bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Mare Foundation (die "Stiftung"), mit eingetragenem Sitz in 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, und welche ihren
eingetragenen Sitz von der Schweiz nach Luxemburg transferiert hat durch eine Urkunde von Maître Joseph Gloden,
Notar, mit dem Amtssitz zu Grevenmacher, dabei im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht zu
werden, verkündigte, dass gemäß eines einstimmigen Beschlusses welcher von ihrem Stiftungsrat genommen wurde am
24. März 2010, eine Kopie dieses Beschlusses wurde dem Notar vorgelegt und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen
um mit derselben einregistriert zu werden, es beschlossen wurde die Satzung der Stiftung wie im Beschluss dargestellt
neu zu formulieren.
Der Erschienene, handelnd in seiner vorerwähnten Eigenschaft, ersuchte den Notar, wie folgt die Satzung der Stiftung
neu zu formulieren:
Name - Sitz - Maßgebendes Recht - Zweck - Dauer
Art. 1. Der Name der Stiftung ist: MARE FOUNDATION.
Sie hat ihren Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Art. 2. Die Stiftung wird durch die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg geregelt, und insbesondere durch das
Gesetz vom 21. April 1928 über gemeinnützige Vereine und Stiftungen, in seiner jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz
vom 21. April 1928").
Art. 3.
3.1. Der Zweck der Stiftung besteht darin Initiativen, Aktivitäten und Projekte auszuarbeiten, im In- und Ausland, in
einem oder mehreren der folgenden Bereiche oder mit einem oder mehreren der folgenden Ziele, sowie finanzielle und
anderweitige Unterstützung an Organisationen, Aktivitäten und Projekte zu erbringen welche den gleichen oder einen
ähnlichen Zweck haben:
a. Kunst, Kultur und Medien;
b. Bildung und Wissenschaft;
c. Förderung des sozialen und ökonomischen Entwicklung und des physischen und mentalen Wohlbefindens von Be-
völkerungsgruppen, im In- und Ausland und insbesondere der Einwohner des Großraums Rotterdam, Niederlande;
d. Förderung der Effizienz und der Wettbewerbsfähigkeit der Niederländischen Handelsschifffahrt durch direkte Zu-
wendungen oder durch Unterstützung der Bestrebungen von Anderen zum Zwecke der Verbesserung von Seeschiffen
durch die Förderung von Forschung unter anderem im Bereich von Schiffsantrieben sowie hinsichtlich der Form oder
dem Design und Bauart von Schiffen durch Kontakt mit ausländischen Institutionen welche in diesem Bereich und in
anderen Gebieten der Hochseeschifffahrt tätig sind;
e. Entwicklungshilfe;
f. Alles durchzuführen welches dienlich ist für oder zusammenhängend mit den Bestimmungen a. bis e. ist, alles im
weitesten Sinne.
3.2. Der Zweck der Stiftung beinhaltet nicht das Erwirtschaften von Gewinn.
3.3. Die Stiftung hat nicht das Recht Ausschüttungen an Gründer oder an solche welche Bestandteil der Arbeitsorgane
sind, vorzunehmen.
3.4. Weder eine Rechtsperson, noch eine natürliche Person kann über die Aktiven der Stiftung verfügen als wären
diese die Aktiven dieser Rechts- oder natürlichen Person.
3.5. Die Stiftung kann ihren Zweck auch erreichen indem sie ihre Aktiven an eine Institution im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland überträgt, welche den gleichen oder einen ähnlichen Zweck wie die Stiftung hat.
41976
Art. 4. Die Stiftung ist gegründet für eine unbeschränkte Dauer.
Finanzmittel
Art. 5. Die Finanzmittel der Stiftung bestehen aus Zuwendungen, Dividenden und anderen Einnahmen von investierten
Finanzmitteln, sowie aus anderen Einnahmen. Ab dem Datum des Großherzoglichen Dekrets welches die gegenwärtige
Satzung gutheißt, werden die Finanzmittel der Stiftung 1 Million Euro betragen.
Verwaltung
Art. 6.
6.1. Der Stiftungsrat ist das oberste Steuerorgan der Stiftung. Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die Leitung der
Stiftung und kann Stiftungsratsbeschlüsse fassen um in Vereinbarungen einzutreten um eingetragene Gegenstände zu
erwerben, um darüber zu verfügen oder zu belasten und um in Vereinbarungen einzutreten wonach die Stiftung Haftung
übernimmt als Bürge oder Co-Gesamtschuldner, Verpflichtungen von Dritten garantiert oder sich verpflichtet Sicher-
heiten zu stellen für Schulden eines Dritten.
6.2. Die Hauptaufgaben des Stiftungsrats sind:
- die Strategie, die Grundsätze und die Zielsetzung der Stiftung zu bestimmen;
- wichtige Fragen zur Erreichung der Stiftungszielsetzungen zu identifizieren und zu beantworten;
- den Fortschritt der Stiftungsaktivitäten und des Stiftungsprogramms zu überwachen;
- das Budget, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zu verabschieden;
- Personal zu ernennen und die Zeichnungs-berechtigung dieser Personen festzusetzen;
- die Wirtschaftprüfer zu ernennen um die Konten der Stiftung zu prüfen.
6.3. Die Stiftung wird durch die Unterschrift des Vorsitzenden des Stiftungsrates oder der gemeinsamen Unterschrift
von zwei Mitgliedern des Stiftungsrats verpflichtet.
6.4. Der Stiftungsrat kann Regeln einführen mit Bezug auf Angelegenheiten welche der Stiftungsrat beschließt. Im Falle
wo eine Bestimmung der Stiftungsratsregeln sich mit dieser Satzung widerspricht, ist diese Satzung maßgebend.
6.5. Der Stiftungsrat hat die Befugnis dauerhafte oder ad-hoc Beratungsausschüsse zu bilden um spezifische Fragen zu
behandeln. Diese können Ausschüsse beinhalten welche Zuwendungsanfragen, Öffentlichkeitsarbeit, den Personalbestand
und die Anlagepolitik behandeln. Mitglieder dieser Ausschüsse können Mitglieder oder Nichtmitglieder des Stiftungsrates
sein, jedoch muss mindestens ein Stiftungsratsmitglied Mitglied jedes Ausschusses sein.
Stiftungsrat - Zusammenstellung
Art. 7.
7.1. Der Stiftungsrat besteht aus drei Mitgliedern: Ein Stiftungsratsmitglied A, ein Stiftungsratsmitglied B und ein Stif-
tungsratsmitglied C. Nur natürliche Personen können Stiftungsratsmitglieder sein.
7.2. Nur Nachkommen des verstorbenen Nicolaas van der Vorm, geboren in Rotterdam, Niederlande am 25. No-
vember 1927 oder Otto Jan van der Vorm, geboren am 8. September 1924 oder ein Nachkomme von Otto Jan van der
Vorm kann Stiftungsratsmitglied A oder Stiftungsratsmitglied B sein. Stiftungsratsmitglied B kann kein Mitglied vom gleichen
Familienzweig sein wie Stiftungsratsmitglied A.
Stiftungsratsmitglied C darf nicht blutsverwandt oder verschwägert sein mit einem von den zwei Familiengruppen
welche im vorherigen Satz erwähnt wurden.
Stiftungsrat - Funktionen - Amtsdauer - Berater - Ernennungen
Art. 8.
8.1. Stiftungsratsmitglied A wird der Vorsitzende des Stiftungsrats sein. Der Stiftungsrat ernennt einen Sekretär und
einen Schatzmeister. Der Posten des Sekretärs und des Schatzmeisters können von einem einzigen Stiftungsratsmitglied
ausgeübt werden.
8.2. Der Stiftungsrat wird von einem Berater unterstützt, welcher durch Stiftungsratsmitglied A ernannt, und von seiner
Funktion entbunden wird. Der Berater wird eingeladen um an den Stiftungsratssitzungen teilzunehmen, außer der Vor-
sitzende entscheidet, dass die Teilnahme des Beraters bei einer spezifischen Sitzung nicht erforderlich ist.
8.3. Stiftungsratsmitglieder und der Berater sind nicht berechtigt jegliche Entlohnung für ihre Aktivitäten im Namen
der Stiftung zu erhalten. Angemessene Spesen welche im direkten Zusammenhang mit ihren Aktivitäten stehen, werden
rückerstattet.
8.4. Die Amtsdauer des Stiftungsratsmitglieds A ist unbeschränkt. Die Amtsdauer des Stiftungsratsmitglieds B beträgt
fünf Jahre und die Amtsdauer des Stiftungsratsmitglieds C beträgt drei Jahre. Stiftungsratsmitglieder B oder C können
wiederernannt werden. Die Amtsdauer eines Nachfolgers von einem Stiftungsratsmitglied B oder C, welcher ernannt
wurde um einen freien Posten zu besetzen, ist die verbleibende Dauer seines Vorgängers.
8.5. Stiftungsratsmitglied A kann, solange es Stiftungsratsmitglied A ist, mit der nötigen Beachtung von Artikel 7.2.,
seinen Nachfolger ernennen. Solange er Stiftungsratsmitglied A ist, kann er zu jeder Zeit solch eine Ernennung widerrufen.
41977
8.6. Falls Stiftungsratsmitglied A aufhört ein Stiftungsratsmitglied zu sein, ohne seinen Nachfolger ernannt zu haben,
oder falls der von ihm ernannte Nachfolger gestorben ist oder nicht verfügbar ist um im Stiftungsrat zu dienen, wird der
Berater, mit der nötigen Beachtung von Artikel 7.2, das nachfolgende Stiftungsratsmitglied A ernennen.
8.7. Stiftungsratsmitglieder B und C werden durch den Stiftungsrat ernannt und von ihrer Funktion entbunden. Der
Beschluss ein Stiftungsratsmitglied B oder C zu ernennen oder von seiner Funktion zu entbinden bedarf der Zustimmung
des Stiftungsratsvorsitzenden.
8.8. Falls es einen offenen Posten im Stiftungsrat gibt, welcher als Konsequenz hat, dass die Zahl der Direktoren auf
weniger wie drei fällt, können der (die) verbleibende(n) Direktor(en) den offenen Posten besetzen, mit Ausnahme des
Posten vom Stiftungsratsmitglied A, welcher nur in Einklang mit Artikel 8.6. ernannt werden kann. Solange der Stiftungsrat
aus nur zwei Mitgliedern besteht, kann der Stiftungsrat nur dringende Angelegenheiten behandeln, welche nicht verscho-
ben werden können bis neue Mitglieder ernannt sind um den/die unbesetzten Posten zu besetzen.
Amtsniederlegung eines Stiftungsratsmitglieds
Art. 9. Ein Stiftungsratsmitglied hört auf ein Stiftungsratsmitglied zu sein:
a. falls es stirbt;
b. falls es freiwillig sein Amt niederlegt oder, im Falle eines Stiftungsratsmitglieds B oder C, am Ende seiner Amtsdauer;
c. weil seine Insolvenz rechtskräftig wird, es die freie Kontrolle über sein Vermögen verliert durch einen anderen
Grund als durch Zahlungseinstellungen welche ihm eingeräumt werden, oder weil es unter Vormundschaft gestellt wurde;
d. im Falle eines Stiftungsratsmitglieds B oder C, durch Entlassung gemäß eines Stiftungsratsbeschlusses welcher, mit
der nötigen Beachtung von Artikel 8.7, angenommen wurde;
e. im Falle eines Stiftungsratsmitglieds B, falls eine Person als Stiftungsratsmitglied A ernannt wird und diese Person
Mitglied des gleichen Zweiges ist, so wie in Artikel 7.2. bezeichnet, als das Stiftungsratsmitglied B.
Stiftungsratsversammlungen
Art. 10.
10.1. Stiftungsratsversammlungen werden mindestens einmal im Jahr abgehalten und immer dann wenn ein Stiftungs-
ratsmitglied dies erwünscht.
Stiftungsratsversammlungen werden an dem vom Vorsitzenden bestimmten Ort abgehalten, wovon jedes Jahr min-
destens eine Stiftungsratsversammlung in Luxemburg abgehalten wird. Stiftungsratssitzungen werden vom Stiftungsrats-
vorsitzenden oder vom Stiftungsratsmitglied welches eine Versammlung verlangt hat, per Brief oder durch eine lesbare
und reproduzierbare Mitteilung an alle anderen Stiftungsratsmitglieder und den Berater einberufen. Der Stiftungsrats-
vorsitzende kann entscheiden, dass der Berater nicht zu einer spezifischen Stiftungsratsversammlung eingeladen wird, in
welchem Falle der Berater keine Mitteilung für die Versammlung erhält. Die Mitteilung weist den Ort und die Zeit der
Versammlung aus und führt die Angelegenheiten auf, welche in der Versammlung behandelt werden.
Die Mitteilungsfrist um eine Versammlung einzuberufen beträgt mindestens vierzehn Tage, nicht eingeschlossen den
Tag der Mitteilung und den Tag der Versammlung.
Versammlungen können auch durch elektronische Kommunikationsmittel abgehalten werden, sofern alle teilnehmen-
den Stiftungsratsmitglieder und der Berater (außer der Vorsitzende beschließt, dass der Berater nicht teilzunehmen
braucht) gleichzeitig miteinander kommunizieren können.
10.2. Stiftungsratsversammlungen werden vom Stiftungsratsvorsitzenden geleitet werden, welcher jedoch ein anderes
Stiftungsratsmitglied bestimmen kann um die Versammlung zu leiten.
Falls der Stiftungsratsvorsitzende abwesend ist und keine andere Person von ihm bestimmt wurde um die Versammlung
zu leiten, wird die Stiftungsratsversammlung von einem Stiftungsratsmitglied geleitet werden welches bei dieser Ver-
sammlung bestimmt wurde. Bei solch einer Versammlung können Beschlüsse wie in Artikel 13.1. beschrieben, nicht
angenommen werden.
Der Stiftungsratssekretär führt das Protokoll der Stiftungsratsversammlung. Falls der Stiftungsrats-sekretär abwesend
ist, bestimmt der Stiftungsrat ein Stiftungsratsmitglied als Sekretär welches Protokoll der Versammlung führt.
10.3. Das Protokoll wird angenommen und vom Vorsitzenden und dem Sekretär unterschrieben. Alternativ wird das
Protokoll in einer nachfolgenden Versammlung angenommen und als Bestätigung vom Stiftungsratsvorsitzenden und dem
Sekretär dieser nachfolgenden Versammlung unterschrieben.
10.4. Jedes Stiftungsratsmitglied ist befugt eine Stimme abzugeben.
10.5. Gültige Beschlüsse können nur angenommen werden wenn mindestens die Mehrheit der Stiftungsratsmitglieder
anwesend oder vertreten ist und alle Stiftungsratsmitglieder, im Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung eingeladen
wurden an der Versammlung teilzunehmen. Falls die Erfordernisse zur Einberufung der Versammlung nicht erfüllt sind,
können gültige Beschlüsse durch eine einstimmige Wahl, bei einer Versammlung wo alle Stiftungsratsmitglieder anwesend
oder vertreten sind, angenommen werden. Ein Stiftungsratsmitglied kann sich bei einer Versammlung per schriftliche
Vollmacht durch ein anderes Stiftungsratsmitglied vertreten lassen; die Erfordernis, dass die Vollmacht in schriftlicher
Form sein muss ist erfüllt wenn diese elektronisch verfasst ist.
41978
10.6. Der Stiftungsrat nimmt Beschlüsse durch eine absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen an, außer diese
Satzung sieht etwas anderes vor.
Im Fall einer Stimmengleichheit in einer Stiftungsratsversammlung hat der Stiftungsratsvorsitzende eine entscheidende
Stimme. Falls die Versammlung von einer anderen Person geleitet wird als dem Stiftungsratsvorsitzenden, wird bei Stim-
mengleichheit kein Beschluss angenommen.
10.7. Der Stiftungsrat kann auch ohne das Abhalten einer Versammlung Beschlüsse annehmen, vorausgesetzt er macht
dies schriftlich oder in einer lesbaren oder reproduzierbaren Art durch elektronische Kommunikationsmittel und vo-
rausgesetzt, dass alle Stiftungsratsmitglieder sich für den betroffenen Vorschlag aussprechen. Die Dokumente, welche die
Annahme eines solchen Beschlusses bestätigen, werden mit dem Protokollbuch aufbewahrt.
Direktor - Personal
Art. 11. Der Stiftungsrat kann Personal ernennen und ihnen den Titel Direktor oder einen anderen Titel verleihen und
kann ihnen eine spezifische oder generelle Vollmacht vergeben um die Stiftung gerichtlich und anderweitig zu vertreten.
Der Direktor, falls mit solch einer Vollmacht ernannt, und die anderen Personalmitglieder werden mit der tagtäglichen
Geschäftsführung oder Teilbereichen dieser Geschäftsführung beauftragt, sowie mit der Vorbereitung und Umsetzung
der Stiftungsratsbeschlüsse betraut.
Bilanzjahr, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Art. 12.
12.1. Das Finanzjahr entspricht dem Kalenderjahr.
12.2. Der Stiftungsrat muss Aufzeichnungen von der finanziellen Position der Stiftung und von allen Aspekten der
Stiftungsaktivitäten anfertigen, in Einklang mit den Bestimmungen welche sich aus diesen Aktivitäten ergeben, und die
zugehörigen Geschäftsbücher, Dokumente und andere Datenträger aufbewahren, sodass die Rechte und Verpflichtungen
der Stiftung zu jeder Zeit nachgeprüft werden können.
12.3. Jedes Jahr muss der Stiftungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Stiftung, sowie das Budget
für das folgende Jahr vorbereiten und annehmen.
12.4. Der Stiftungsrat kann einen wie vom Gesetz vorgesehenen Experten beauftragen die Bilanz und die Gewinn- und
Verlustrechnung zu prüfen.
12.5. Der Stiftungsrat bewahrt die in diesem Artikel genannten Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und andere Daten-
träger während der zutreffenden gesetzlichen Frist auf.
Spezifische Beschlüsse
Art. 13.
13.1. Der Stiftungsrat kann folgende Beschlüsse nur gültig annehmen wenn der Stiftungsratsvorsitzende zugunsten des
betroffenen Vorschlags wählt:
a. die Satzung abzuändern;
b. in eine rechtmäßige Verschmelzung oder Spaltung einzutreten soweit dies vom Gesetze erlaubt ist;
c. die Stiftung aufzulösen;
d. in eine Verpflichtung oder jedes andere Rechtsgeschäft einzutreten welcher die Summe von einhunderttausend Euro
überschreitet (EUR 100.000) oder eine Reihe von zusammenhängenden Verpflichtungen oder anderen Rechtsgeschäften
welche im Ganzen die Summe von einhunderttausend Euro (EUR 100.000) überschreiten;
e. eine bedeutende Änderung in einer Grundsatzan-gelegenheit gutzuheißen.
13.2. Diese Satzung kann nur umgeändert werden gemäß eines Stiftungsratsbeschlusses, welcher mit der nötigen Be-
achtung der Bestimmungen von Artikel 13.1. und den Bestimmungen von Artikel 32 des Gesetzes vom 21. April 1928,
angenommen wurde. Änderungen der Satzung müssen durch eine notarielle Urkunde durchgeführt werden. Jedes Stif-
tungsratsmitglied darf eine solche Urkunde unterzeichnen.
Der Stiftungsrat kann die Stiftung auflösen, mit der nötigen Beachtung der Bestimmungen von Artikel 13.1. Die Liqui-
dation wird vom Stiftungsrat durchgeführt.
Während der Liquidationsprozedur, bleiben die Bestimmungen dieser Satzung soweit wie möglich in Kraft.
Der Stiftungsrat bestimmt die Zuwendung von jeder positiven Liquidationsbilanz, welche soweit wie möglich in Über-
einstimmung mit dem Zweck der Stiftung und immer für die Gemeinnützigkeit sein sollte, indem jegliche positive
Liquidationsbilanz weitergeleitet wird an eine gemäß Gesetz vom 21. April 1928 aufgestellte und durch Großherzoglichen
Beschluss anerkannte Stiftung oder karikative Organisation.
13.3. Nachdem die Stiftung aufgehört hat zu bestehen, bleiben ihre Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und andere
Datenträger während der zutreffenden gesetzlichen Frist bei der Person welche zu diesem Zwecke vom Stiftungsrat
bestimmt wurde in Aufbewahrung.
41979
Allgemeines
Art. 14.
14.1. Für alle Punkte welche nicht in dieser Satzung behandelt wurden, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
21.April 1928 hingewiesen.
14.2. Wirksam am Datum der Abänderung dieser Satzung:
a. Herr Martinus van der Vorm, Direktor, geboren am 20. August 1958 in Rhoon, Niederlande, Niederländischer
Staatsbürger, geschäftsansässig zu 28-30 Boulevard des Moulins, 98000 Monaco wird als Stiftungsratsmitglied A und somit
Stiftungsratsvorsitzender für eine unbegrenzte Dauer ernannt;
b. Herr Otto Jan van der Vorm, pensioniert, geboren am 8. September 1924 in Rotterdam, Niederländischer Staats-
bürger, wohnhaft zu Sowley House, Sowley near Lymington, Hampshire, Vereinigtes Königreich wird als Stiftungsrats-
mitglied B für die Dauer von fünf Jahren nach Annahme vom Jahresabschluss für 2009 ernannt;
c. Herr Francois Diederik Rosendaal, Chefjustiziar, geboren am 27. Mai 1952 in Rotterdam, Niederländischer Staats-
bürger, wohnhaft in 11 Avenue d'Alsace, 06240 Beausoleil, Frankreich, wird als Stiftungsratsmitglied C für die Dauer von
drei Jahren nach Annahme vom Jahresabschluss für 2009 ernannt;
d. Herr Hartgert Langman wird als Berater ernannt.
Die gegenwärtige Urkunde, welche in deutscher Sprache abgefasst wurde, folgt einer Übersetzung ins Englische.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg-Stadt, zum eingangs erwähnten Datum.
In diesem Glauben hat der unterzeichnete Notar diese Urkunde mit seinem Siegel versehen, zum eingangs erwähnten
Datum.
Nach Vorlesung der Urkunde an den Erschienenen, welcher den Wunsch geäußert hatte, dass die gegenwärtige Ur-
kunde in englischer Sprache abgefasst wird, hat der Erschienene die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, welcher die
englische Sprache versteht und spricht unterschrieben.
Gezeichnet: F. D. ROSENDAAL, J. GLODEN.
Approuvée par Arrêté Grand-Ducal en date du 11 avril 2010.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 avril 2010. Relation: GRE/2010/1327. Reçu douze euros (12,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, den 21. April 2010.
Joseph GLODEN.
Référence de publication: 2010044365/458.
(100056630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2010.
Vista S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 54.810.
Le Bilan au 30.11.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010041454/10.
(100041630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Valengilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 64.225.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010041455/10.
(100041274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
41980
Sewerin Schiltz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 300, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 61.578.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010041473/11.
(100041768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Swiss & Global Sicav II Advisory S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. Julius Baer Sicav II Advisory).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 87.873.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041474/10.
(100041687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Swiss & Global Strategy Fund Advisory S.A.H., Société Anonyme,
(anc. Julius Baer Strategy Fund Advisory).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 85.425.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041477/10.
(100041688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Swiss & Global Multistock Advisory S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. Julius Baer Multistock Advisory).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 85.426.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041478/10.
(100041686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
International Pension Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 68.230.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution adoptée par l'actionnaire unique le 22 décembre 2009
- que depuis le 15 décembre 2009, le siège social de la société a été transféré du 11 Avenue Guillaume L-1651 Lu-
xembourg vers le 9A Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg
- que depuis le 15 décembre 2009, l'adresse professionnelle de la gérante, Madame Nete Stejn Mortensen, est au 39,
rue Goethe L-1637 Luxembourg
- que la démission de Madame Helle Nymann Dueholm en tant que gérant a été acceptée avec effet au 31 décembre
2009.
- que Monsieur Hans Nelén, Administrateur Délégué de la société Global Assurance S.A., domicilié au 39, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg, est élu gérant de catégorie B pour une durée indéterminée avec effet au 1
er
janvier 2010.
41981
- que la société "International Audit Services S. à r.l." a démissionné en tant que commissaire aux comptes avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 22 décembre 2009.
Pour extrait conforme
Natacha Hainaux
Référence de publication: 2010041479/22.
(100041776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Swiss & Global Multiinvest Advisory S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. Julius Baer Multiinvest Advisory).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 85.423.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041481/10.
(100041682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 142.674.
<i>Décision de l'associé unique du 18 mars 2010.i>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société du 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg au 63,
rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2010.
Référence de publication: 2010041482/12.
(100041110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Swiss & Global Multiopportunities Advisory S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. Julius Baer Multiopportunities Advisory).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 108.330.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041483/10.
(100041683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Swiss & Global Multipartner Advisory S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. Julius Baer Multipartner Advisory).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 85.424.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041484/10.
(100041684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
41982
Dimocharous S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 141.968.
<i>Extrait de résolutions de l'associé unique de la société prises extraordinairement en date du 8 mars 2010i>
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique accepte la démission des gérants actuellement en fonction, Monsieur Didier Mc Gaw, Monsieur
Stéphane Lataste, Madame Isabelle Pairon
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé unique décide de nommer Monsieur Reinhard KRAFFT, né le 21 Juillet 1964, à Athen, Greece, demeurant
à 1, rue du Genêt, L-8023 Strassen, gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société au 291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg.
Pour Extrait Sincère et conforme
L'agent domiciliataire
Référence de publication: 2010041485/18.
(100041365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Swiss & Global Multiselect Advisory S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. Julius Baer Multiselect Advisory).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 85.428.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041486/10.
(100041685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Swiss & Global Multicooperation Advisory S.A.H., Société Anonyme,
(anc. Julius Baer Multicooperation Advisory).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 85.421.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041487/10.
(100041681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
BCD Travel Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 36.786.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal des résolutions des actionnaires de la Société, prises le 20 novembre 2009:
- de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy, à
l'adresse suivante, Bâtiment K2 F1, 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 20 novembre 2009.
<i>Pour la Société
i>Alex SCHMITT
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010041507/14.
(100041329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
41983
Xtreme Equipment Group, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.988.
STATUTES
In the year two thousand ten, on the fifteenth day of March;
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
There appeared:
1. Xtreme (Luxembourg), a société anonyme duly incorporated and validly existing under the law of the Grand-Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5 avenue Gaston Diderich, Luxembourg, and registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés under number BO 121024; and
2. Suhayl Abdul Mohsin Al Shoaibi & Sons Holding Company Limited, a limited liability company duly incorporated and
validly existing under the law of the Kingdom of Saudi Arabia, having its registered office at Shoaibi Building, King Abdul
Aziz Street, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia, and registered under CR number 2050003487;
each of them here represented by Christophe Maillard, Avocat à la Cour, with a professional address in Luxembourg,
by virtue of powers of attorney.
The said powers of attorney, each having been initialled ne varietur by the relevant attorney acting on behalf of the
relevant grantor, shall remain annexed to this act to be filed together with this act with the registration authorities.
Such parties, appearing in the capacity in which they act and represented as stated above, have requested the under-
signed notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a société anonyme, which is hereby
incorporated:
ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY
Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Form. The company is a société anonyme (public company limited by shares) governed by laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg (the "Company") as well as by the present articles of association (the "Articles").
Art. 2. Name. The Company's name is "Xtreme Equipment Group".
Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-
soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the
Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in
part, for such consideration as the Company may think fit.
In addition, the Company may also hold any interest in whatever form in any movable or immovable property, in
Luxembourg or abroad, by direct or indirect means, and may acquire, sell, lease or rent immovable or movable properties
either in Luxembourg or abroad and perform all operations relating to such properties, including investing or acquiring
directly or indirectly any participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign
companies or entities and acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any
securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally hold,
manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may
think fit.
The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity
that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance,
loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as
borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.
Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its
purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by means of a resolution
of the board of directors in accordance with these Articles.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of the Shareholders (as hereinafter defined) taken in the manner provided for amendments of the
Articles.
The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.
41984
Title II - Capital - Shares
Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at USD 50,000 (fifty thousand U.S. dollars) divided into 50,000
ordinary shares ("Ordinary Shares").
In addition, the Company may issue non-voting mandatory redeemable preferred shares ("Non-Voting MRPS").
The Non-Voting MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter collectively referred to as the "Shares" and individually
as a "Share", and the holders of Shares are hereinafter collectively referred to as the "Shareholders".
All the Shares have a nominal value of USD 1 each and are fully paid-up.
All the Shares are in nominative form.
A Shareholders' register shall be kept by the Company at its registered office. The Shareholders' register shall mention
the name and the address of each Shareholder as notified by that Shareholder to the Company, the number of the Shares
held by each Shareholder, the amount paid-up on each Share, and, as the case may be, the date and details of any Share
transfer or conversion. Each Shareholder shall notify in writing to the Company its address and any change thereof.
The share capital and the authorized share capital, as the case may be, may be increased or reduced from time to time
by means of a resolution of the extraordinary general meeting of the Shareholders taken in the manner provided for an
amendment of the Articles.
The board of directors may delegate to any director or any other duly authorized person, the power of acknowledging
the contribution and receiving payment for the Shares representing all or part of the increase of capital within the au-
thorized capital.
Share premium paid on Ordinary Shares or Non-Voting MRPS shall be booked in specific share premium accounts, as
follows:
- any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Share share premium account (the
"Ordinary Share Share Premium Account") and such share premium shall remain attached to those Ordinary Shares upon
which the share premium was paid;
- any share premium paid on a Non-Voting MRPS shall be booked in a Non-Voting MRPS share premium account (the
"Non-Voting MRPS Share Premium Account") and such share premium shall remain attached to the Non-Voting MRPS
upon which the share premium was paid;
Art. 7. Authorized Capital. The Company's authorized capital is set at USD 10,000,000 (ten million U.S. dollars) which
shall be represented by 10,000,000 (ten million) Shares with a nominal value of USD 1 (one U.S. dollars) each.
Furthermore, in accordance with article 32 of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as
amended (the "Law"), the board of directors is authorized for a period of five years as of the date of publication of these
Articles, to increase, from time to time, the share capital within the limits of the authorized capital and to amend the
Articles to reflect such increase. Such authorization may be renewed by means of a resolution of the extraordinary general
meeting of the Shareholders taken in the manner provided for amendments of the Articles.
The board of directors shall have the broadest powers to determine the conditions and modalities of issuance, sub-
scription and payment of the new Shares, and to determine whether the Shares to be issued will be Ordinary Shares or
MRPS, which could be issued in particular, with or without share premium, and paid up by contribution in kind or cash,
or in any other way to be determined by the board of directors.
The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the existing Share-
holders a preferential right to subscribe to the Shares to be issued.
Art. 8. Voting Rights. Each Ordinary Share is entitled to an identical voting right and each holder of Ordinary Share(s)
has voting rights commensurate to such holder's ownership of Ordinary Shares.
Each Non-Voting MRPS does not entitle its holder to any voting right except in the situations laid-down under articles
44 (2) and 46 of the Law, i.e.:
- Non-Voting MRPS holders are entitled to vote in any general meeting called upon to deal with the following matters:
- Issuance of new Shares entitled to preferential right(s);
- Determination of the preferential cumulative dividend attached to the Non-Voting MRPS;
- Conversion of the Non-Voting MRPS into Ordinary Shares;
- Decrease of the share capital of the Company;
- Any amendment to the purpose of the Company;
- Issuance of convertible bonds;
- Dissolution of the Company;
- Transformation of the Company into a company of another legal form in the meaning of article 46 (1) of the Law;
or
- Non-Voting MRPS shall have the same voting rights as the Ordinary Shares at all meetings, in the event that the
Preferred Dividends (as defined below under article 19) to which their holder(s) are entitled, have not been paid in their
41985
entirety despite the existence of profits available for that purpose during two successive financial years and until those
Preferred Dividends have been paid in full.
Other than the situations listed above, Non-Voting MRPS are not taken into consideration in order to determine the
conditions as to quorum and majority at general meetings.
Non-Voting MRPS holders are entitled to receive the same convening notice, documents, reports and information on
the Company as the Ordinary Shares holders.
Art. 9. Indivisibility of Shares. Towards the Company, the Shares are indivisible and the Company will recognize only
one owner per Share. If any Share is jointly owned or if the ownership of that Share is disputed, a joint attorney shall be
appointed to represent the joint owners or the persons claiming to have a right on that Share, as if they were a sole
person owner of that Share, failing which any right attached to that Share will be suspended.
Art. 10. Transfer and Redemption of Shares. Shares are freely transferable.
Shares can be redeemed under the conditions laid-down by the Law.
Non-Voting MRPS are redeemable shares within the meaning of, and their redemption shall be governed by, article
49-8 of the Law.
Outstanding Non-Voting MRPS shall be redeemed by the Company:
- at any time, upon its request and at its sole discretion;
- at the latest on the tenth anniversary of the issue date of the Non-Voting MRPS (the "Maturity Date").
The redemption of the Non-Voting MRPS is subject to the following conditions:
1. it can only be made by using either sums available for distribution in accordance with the Law or the proceeds of a
new issue made with a view to carry out such redemption;
2. except in the event of a new issue made with a view to carry out such redemption, an amount equal to the nominal
value, or, in the absence thereof, the par value of all the outstanding Non-Voting MRPS to be redeemed must be allocated
to a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the event of a decrease of the subscribed share
capital of the Company; except in this specific case, the reserve can only be used to increase the subscribed share capital
of the Company by capitalization of this reserve;
3. each holder of redeemed Non-Voting MRPS is entitled to receive a payment in cash or in kind per redeemed Non-
Voting MRPS (the "Redemption Price") equal to:
i.the nominal value, or, in the absence thereof, the par value of its redeemed Non-Voting MRPS; plus
ii.an amount corresponding to a portion of the Non-Voting MRPS Share Premium Account equal to the balance of the
Non-Voting MRPS Share Premium Account divided by the number of outstanding Non-Voting MRPS prior to the re-
demption; plus
iii.all and any accrued but unpaid Preferred Dividend that the redeemed Non-Voting MRPS is entitled to receive at the
time of the redemption; plus finally
iv.an amount corresponding to the portion of the Non-Voting MRPS Reserve Account equal to the balance of the
Non-Voting MRPS Reserve Account divided by the number of outstanding Non-Voting MRPS prior to the redemption;
4. the payment of the amounts under 3.ii. to 3.iv. above may only be paid from sums available for distribution in
accordance with article 72-1 of the Law (the "Available Sums").
However, on the Maturity Date, if Available Sums are insufficient for the Company to redeem all the Non-Voting
MRPS, the redemption of all the Non-Voting MRPS will not be hindered; such insufficiency only entails the deferment of
the payment of the Redemption Price due on the Maturity Date (the "Redemption Price at Maturity"). In this latter case,
the Company shall pay to the holders of the redeemed Non-Voting MRPS only a portion of the Redemption Price at
Maturity up to the amount of the Available Sums on the Maturity Date; the remaining part of the Repurchase Price will
be paid in one or several installments as soon as the Company will have sufficient Available Sums for this purpose.
As long as the Redemption Price at Maturity has not been paid in full, no dividend shall be paid to the Shareholders.
Title III - Management
Art. 11. Appointment of the directors. The Company is managed by a board of directors composed of at least three
directors.
Where the Company has a sole Shareholder, it may be managed by a sole director having the powers of the board of
directors. In this case, any reference made hereunder to the board of directors of the Company, shall be read as a
reference to the sole director of the Company, if appropriate.
No director need be a Shareholder of the Company. The directors shall be appointed for a six year period by resolution
of the sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders by a resolution of Shareholders representing more than
50% (fifty percent) of the share capital of the Company taken during a general meeting. The remuneration, if any, of the
directors shall be determined in the same manner.
Directors will be re-eligible for successive period(s) of six years, without any restriction.
41986
However, in case of vacancy in the office of director, the remaining directors may by way of co-option elect another
director to fill the vacancy until the next Shareholders' meeting in accordance with the Law.
If a legal person is appointed as director of the Company, it shall inform the Company of the name and details of the
individual who shall serve as its permanent representative in order to exercise its director's duties.
A director may be removed, with or without cause, at any time by resolution of Shareholders representing more than
50% (fifty percent) of the share capital of the Company taken during a general meeting.
Art. 12. Powers of the directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts
necessary or useful for accomplishing the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the
Articles to the sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders, to the general meeting of Shareholders, fall within
the competence of the sole director, or in case of plurality of directors, within the competence of the board of directors.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, or in case of plurality of directors, by the joint
signature of any two directors.
The board of directors may from time to time delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents
who need not be Shareholder(s) or director(s) of the Company. The board of directors will determine the powers and
remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.
The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect
thereto may be delegated to one or more directors, officers, and/or agents, who need not be Shareholder(s) of the
Company.
Art. 13. Board of directors. The board of directors elects among the directors a chairman who shall preside at all
meetings of the board of directors. In case of absence of the chairman, the board of directors shall be chaired by a director
present and appointed for that purpose.
The board of directors may also appoint a secretary who need not be director or Shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.
The board of directors shall meet when convened by the chairman or by request of two directors.
Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all directors at least 24 hours in
advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each director, or where all the directors
are present or represented.
Any director may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another
director as his proxy. A director may represent more than one director.
Any and all directors may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication
means allowing all directors participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed
equivalent to a participation in person.
A meeting of the board of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there
are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of directors.
Decisions of the board of directors are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of directors
of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the directors present and represented who voted and
did not abstain.
In the event of a tied vote, the chairman shall not have a casting vote.
Deliberations of the board of directors shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two directors.
Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two directors.
Circular resolutions of the board of directors can be validly taken if approved in writing and signed by all directors in
person in order to evidence their unanimous consent. Such approval may be in a single document or in several separate
documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at a
directors' meeting, duly convened.
When a sole director is validly appointed, resolutions are taken at the place and time determined by him as being the
most appropriate and formalized in a written document executed by the sole director.
Art. 14. Liability of the directors. No director assumes any personal liability in relation with any commitment validly
made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a director of
the Company.
Title IV - Shareholder meetings
Art. 15. Sole Shareholder. A sole Shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of Shareholders in
accordance with the Law. In this case, any reference made hereunder to the general meeting of the Shareholders of the
Company, shall be read as a reference to the sole Shareholder of the Company.
The contracts concluded between the sole Shareholder and the Company must be recorded on minutes or drawn-
up in writing.
41987
Art. 16. General meetings. The board of directors and the statutory auditor(s) are entitled to convene a general
meeting of Shareholders. They shall convene it so that it is held within a period of one month when Shareholders re-
presenting one-tenth of the share capital of the Company require such convening by a written request indicating the
agenda of the meeting.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each Shareholder at least 8
(eight) days before the meeting, specifying the time and place of the meeting.
If all the Shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed
on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any Shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as
such Shareholder's proxy, which person needs not be a Shareholder of the Company.
Any Shareholder may participate in any general meeting by telephone, videoconference, or any other suitable method
of telecommunication allowing his identification and an effective participation in the meeting. Such participation is deemed
equivalent to participation in person.
Resolutions of the ordinary general meetings of Shareholders are validly taken at the majority of votes cast, by Sha-
reholder(s), present or represented and entitled to cast a vote.
The extraordinary general meeting of Shareholders validly decides where more than 50% (fifty percent) of the share
capital of the Company is represented. If the quorum is not reached at a first meeting, the Shareholders shall be convened
by registered letter to a second meeting.
Resolutions will be validly taken at this second meeting regardless of the portion of share capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken during an extraordinary general
meeting by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented who voted and did not abstain
or which vote is not null.
A general Shareholders' meeting convened in order to approve the last closed financial accounts of the Company shall
be held annually in Luxembourg at the registered office of the Company on the third Friday of May at 3:00 p.m. or on
the following business day if such day is a public holiday.
Minutes of the general meeting of Shareholders shall be signed by the chairman, or if applicable by his substitute, and
the scrutineer(s) of the meeting and Shareholders who request to do so.
Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit
Art. 17. Financial year. The financial year of the Company runs from the first of January to the thirty-first of December,
with the exception of the first financial year, which will start today and end on the 31
st
December 2010.
Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of directors shall draw up a balance
sheet and a profit and loss account and their annex in accordance with the Law. The annual accounts will then be submitted
to the annual general Shareholders' meeting for approval.
Fifteen days before the annual general meeting of Shareholders, each Shareholder may inspect at the Company's
registered office, the balance sheet and the profit and loss account as well as the documentation mentioned under article
73 of the Law.
Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions, such as approved by the sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders, by the general
meeting of the Shareholders, represents the net profit of the Company.
The net profits of the Company may be distributed by the general meeting of the Shareholders as follows:
Each year, 5% (five percent) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This
allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.
Each financial year, out of the remaining profits after allocation to the legal reserve, calculated in accordance with
Luxembourg GAAP (the "Available Profits"), each Non-Voting MRPS holder is entitled to such preferred dividend as was
specified at the time of issue of the Non-Voting MRPS (the "Preferred Dividend").
The Preferred Dividend shall be increased by the amount of any Preferred Dividend that has not been distributed,
whether in full or in part, over the past financial years.
Should the Available Profits be sufficient to distribute the Preferred Dividend, in whole or in part, and the sole Sha-
reholder, or in case of plurality of Shareholders, the general meeting of the Shareholders, take no distribution resolution
with respect to such Preferred Dividend, the amount of the Preferred Dividend that should have been distributed to the
holders of the Non-Voting MRPS, shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a Non-Voting MRPS
reserve account (the "Non-Voting MRPS Reserve Account").
After distribution or allocation of the Preferred Dividend the remainder of the Available Profits may be distributed to
the holders of Ordinary Shares.
The remaining profit shall be allocated by the sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders, by a resolution
taken during a general meeting of one or more Shareholders present or represented and holding more than half of the
41988
share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the Shares he/they hold, to carry it forward, or
to transfer it to a distributable reserve.
Each holder of Ordinary Share(s) is entitled to a fraction of the total profit distributed to all the Ordinary Shares in
proportion of the Ordinary Share(s) he holds in the Company.
Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the board of directors may decide, in accordance
with article 72-2 of the Law and subject to the conditions laid down by the Law and these Articles to pay interim dividends
to be paid in cash or in kind.
Art. 21. Audit. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditors (commissaire
(s)) who need not to be Shareholder.
Each statutory auditor shall be appointed by the general meeting of Shareholders for a period which shall not exceed
six years.
Statutory auditors are re-eligible without any restriction.
A statutory auditor may be removed, with or without cause, at any time by resolution of the general meeting of
Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the share capital of the Company.
Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register
as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more authorised qualified auditors (réviseurs d'entreprises agrées) appointed by the sole Shareholder
or, in case of plurality of Shareholders, by the general meeting of Shareholders. The general meeting of Shareholders may
however appoint a qualified auditor at any time.
The supervision of the Company has not to be entrusted to one or more statutory auditors if qualified auditor(s) are
appointed.
Title VI - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole Shareholder, or in case of plurality
of Shareholders, by a resolution of an extraordinary general meeting of Shareholders taken in the manner provided for
amendments of the Articles. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or
bankruptcy of any Shareholder.
Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by a
resolution of an extraordinary general meeting of Shareholders taken in the manner provided for amendments of the
Articles, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of
the Company will be allocated to the sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders, they will be allocated first
to the holders of Non-Voting MRPS for an amount equal to the Redemption Price and the surplus, if any, shall only be
paid to the holders of Ordinary Shares proportionally to the Shares they hold.
Should the aggregate Redemption Price to be paid to the holders of Non-Voting MRPS be insufficient to pay them all,
the available aggregate Redemption Price shall only be paid to the holders of Non-Voting MRPS proportionally to the
Non-Voting MRPS they hold.
<i>Subscription - Paymenti>
These Articles having been drawn up, the appearing parties, represented as stated above, have subscribed to the
following Shares and have paid in cash the following amounts:
- Xtreme (Luxembourg) has subscribed to 40,000 Ordinary Shares, and has fully paid-up those Shares by a contribution
in cash of USD 40,000; and
- Suhayl Abdul Mohsin Al Shoaibi & Sons Holding Company Limited has subscribed to 10,000 Ordinary Shares, and
has fully paid-up those Shares by a contribution in cash of USD 10,000.
The total amount of USD 50,000 is therefore available to the Company, proof of which has been duly given to the
notary by producing a blocked funds certificate, and as is expressly acknowledged by the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, that are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euros (1,500.-
EUR).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders, representing the entirety of the share capital,
passed the following resolutions:
41989
1. The following are appointed as Directors for a term commencing on today's date and expiring on the 4
th
March
2016:
- Rod Uchytil, born in Edmonton, Canada on the 17
th
December 1963, with a professional address of 16285 Park Ten
Place, Ste 650 Houston, TX 77084, USA;
- Elizabeth Wilkinson, born in Coral Gables, Florida, USA on the 24
th
November 1957, with a professional address
of Park Ten Place, Ste 650 Houston, TX 77084, USA;
- Tom Wood, born in Calgary, Alberta, Canada on the 17
th
December 1956, with a professional address of 1402 500
Fourth Avenue, SW Calgary, AB T2P 2V6, Canada;
- Brett Cole, born in Illinois, USA on the 14
th
January 1967, with a professional address of 16285 Park Ten Place, Ste
650, Houston, TX 77084, USA;
- Faisal Suhayl A Al Shoaibi, born in Basra, Iraq on the 23
rd
September 1968, with a professional address of P.O. Box
1280, Al Khobar 31952, Saudi Arabia;
- Dennis Bosje, born in Amsterdam, Netherlands, on the 20
th
November, 1965 with a professional address of 5,
avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg; and
- Valérie Fisson, born in Marche, Belgium, on the 11
th
November, 1975, with a professional address of 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
2. The following are appointed as Statutory Auditors for a term commencing on today's date and expiring on the 4th
March 2016:
- Interaudit, 119, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
3. The Registered Office is established at 5 avenue Gaston Diderich, Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, at the request of the above parties
appearing by powers of attorney, this act is worded in English followed by a French version. Also at the request of the
above parties, in the event of discrepancies between the English text and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in the city of Luxembourg, on the date set
out at the beginning of this document.
This document having been read to the attorney present, the said attorney signed with us, the notary, this original act.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le quinzième jour du mois de mars,
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparus:
1. Xtreme (Luxembourg), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5 avenue Gaston
Diderich, Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
BO121024; et
2. Suhayl Abdul Mohsin Al Shoaibi & Sons Holding Company Limited, une société de droit du Royaume d'Arabie
Saoudite, ayant son siege social à Shoaibi Building, King Abdul Aziz Street, Al-Khobar 31952, Royaume d'Arabie Saoudite,
et immatriculée sous le numéro CR 2050003487;
chacune d'elles ici représentée par Christophe Maillard, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing-privé.
Lesdites procurations, chacune paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante concernée, resteront
annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.
Lesdites parties comparantes, agissant es qualité et représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire ins-
trumentant de dresser les statuts (les "Statuts") d'une société anonyme qui est ainsi constituée:
STATUTS DE LA SOCIETE
Titre I
er
- Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Forme. La société est une société anonyme régie par le droit luxembourgeois (la "Société") ainsi que par
les présents statuts (les "Statuts").
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est "Xtreme Equipment Group".
Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères, et d'acquérir par des
participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et
41990
licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, déve-
lopper, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.
De plus, la Société peut également détenir des intérêts de quelque forme que ce soit dans tout bien mobilier ou
immobilier sis à Luxembourg ou à l'étranger de manière directe ou indirecte, acquérir, vendre, ou louer tout bien mobilier
ou immobilier sis à Luxembourg ou à l'étranger et réaliser toute opération liée à de tels biens, y compris investir, acquérir,
et prendre directement ou indirectement des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
formes de sociétés ou entités luxembourgeoises ou étrangères et acquérir par des participations, des apports, achats,
options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété
que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en
tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.
La Société peut également prendre part à toutes transactions, y compris financières ou commerciales, et accorder à
toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec
la Société, en ce inclues les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout
autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de
garantir les obligations des sociétés et/ou entités précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.
Enfin, la Société pourra prendre toute action et mener toute opération se rattachant directement ou indirectement à
son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration conformément
aux présents Statuts.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des Actionnaires (tels que définis ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II - Capital - Actions
Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à 50.000 USD (cinquante mille dollars américains) composé de
50.000 actions ordinaires (les "Actions Ordinaires").
Par ailleurs, la Société peut émettre des actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote (les "MRPS sans
Droit de Vote").
Les MRPS sans Droit de Vote et les Actions Ordinaires sont collectivement désignées ci-après par les "Actions", ou
chacune séparément une "Action", et les détenteurs d'Actions sont collectivement désignés ci-après comme les "Action-
naires").
Toutes les Actions ont une valeur nominale d'1 USD chacune et sont entièrement souscrites et libérées.
Toutes les Actions sont nominatives.
Un registre des Actionnaires est tenu par la Société à son siège social. Le registre des Actionnaires doit documenter
le nom et l'adresse de chaque Actionnaire tel que communiqués par ledit Actionnaire à la Société, le nombre d'Actions
qu'il détient, le montant libéré par Action et, le cas échéant, la date et les informations relatives à tout transfert ou toute
conversion d'Actions. Tout Actionnaire doit notifier par écrit à la Société son adresse et tout changement y relatif.
Le capital social et le capital social autorisé, le cas échéant, peuvent être augmentés ou réduits par résolution de
l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur ou toute autre personne autorisée le pouvoir de
constater les apports et de recevoir paiement des actions représentant tout ou partie de l'augmentation de capital dans
le cadre du capital autorisé.
Les primes d'émission payées en relation avec les Actions Ordinaires ou les MRPS sans Droit de Vote doivent être
comptabilisées dans des comptes de prime d'émission particuliers comme suit:
- Toute prime d'émission payée en relation avec des Actions Ordinaires doit être comptabilisée dans un compte de
prime d'émission des Actions Ordinaires (le "Compte de Prime d'Emission des Actions Ordinaires"), et une telle prime
d'émission doit demeurer attachée aux Actions Ordinaires pour lesquelles la prime d'émission a été payée;
- Toute prime d'émission payée en relation avec une MRPS sans Droit de Vote doit être comptabilisée dans un compte
de prime d'émission des MRPS sans Droit de Vote (le "Compte de Prime d'Emission des MRPS sans Droit de Vote"), une
telle prime d'émission doit demeurer attachée aux MRPS sans Droit de Vote pour lesquelles la prime d'émission a été
payée.
Art. 7. Capital Autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé à 10.000.000 USD (dix millions de dollars américains)
représenté par 10.000.000 (dix millions) d'Actions d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune.
De plus, conformément à l'article 32 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la "Loi"), le conseil d'administration est autorisé pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication des
41991
présents Statuts, à augmenter le capital social, dans les limites du montant du capital autorisé, et à modifier les Statuts en
conséquence. Une telle autorisation peut être renouvelée par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des
Actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour déterminer les conditions et modalités d'émission, de
souscription et de libération des nouvelles Actions, ainsi que pour déterminer si les Actions à émettre seront des Actions
Ordinaires ou des MRPS sans Droit de Vote, qui peuvent être émises en particulier avec ou sans prime d'émission, et
libérées par apport en nature ou en numéraire, ou de toute autre manière déterminée par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en limitant ou supprimant le
droit préférentiel de souscription des Actionnaires sur les Actions à émettre.
Art. 8. Droits de vote. Chaque Action Ordinaire confère un droit de vote identique et chaque détenteur d'Action(s)
Ordinaire(s) dispose de droits de vote proportionnels au nombre de Action(s) Ordinaire(s) qu'il détient.
Chaque MRPS sans Droit de Vote ne confère aucun droit de vote à son détenteur, sauf dans les cas visés aux articles
44 (2) et 46 de la Loi, c'est-à-dire:
- Les MRPS sans Droit de Vote confèrent un droit de vote dans toute assemblée générale convoquée pour délibérer
sur les questions suivantes:
- L'émission de nouvelles Actions conférant des droits privilégiés;
- La fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux MRPS sans Droit de Vote;
- La conversion de MRPS sans Droit de Vote en Actions Ordinaires;
- La réduction du capital social de la Société;
- Toute modification de l'objet social de la Société;
- L'émission d'obligations convertibles;
- La dissolution de la Société;
- La transformation de la Société en une société d'une autre forme juridique au sens de l'article 46(1) de la Loi; ou.
- Les MRPS sans Droit de Vote confèrent le même droit de vote que les Actions Ordinaires dans toute assemblée,
lorsque, les Dividendes Préférentiels (tels que définis à l'article 19) auxquels les détenteurs de MRPS sans Droit de Vote
ont droit, n'ont pas été entièrement mis en paiement malgré l'existence de bénéfices disponibles à cet effet, pendant deux
exercices successifs et ce jusqu'à ce que ces Dividendes Préférentiels aient été intégralement mis en paiement.
Hormis les hypothèses visées ci-dessus, les MRPS sans Droit de Vote ne sont pas prises en considération afin de
déterminer les règles de quorum et de majorité pour la tenue des assemblées générales.
Les détenteurs de MRPS sans Droit de Vote bénéficient des mêmes droits quant à la réception des convocations,
documents, rapports et informations sur la Société que les détenteurs d'Actions Ordinaires.
Art. 9. Indivisibilité des actions. Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul pro-
priétaire par Action. Si une Action est détenue conjointement ou si la détention d'une telle Action est revendiquée par
plusieurs personnes, un mandataire commun doit être désigné par les copropriétaires ou les personnes revendiquant un
droit sur cette Action comme s'ils étaient un seul et unique propriétaire de cette Action, faute de quoi tout droit attaché
à cette Action sera suspendu.
Art. 10. Transfert et Rachat des Actions. Les Actions sont librement cessibles.
Les Actions peuvent être rachetées selon les conditions prévues par la Loi.
Les MRPS sans Droit de Vote sont des actions rachetables au sens de l'article 49-8 de la Loi qui régit également leurs
conditions de rachat.
Les MRPS sans Droit de Vote émises doivent être rachetées par la Société:
- A tout moment, à sa demande et à sa seule discrétion;
- Au plus tard à la date du dixième anniversaire de la date d'émission des MRPS sans Droit de Vote (la "Date d'Echéan-
ce").
Le rachat des MRPS sans Droit de Vote est subordonné au respect des conditions suivantes:
1. le rachat n'est possible qu'en utilisant des fonds distribuables en vertu de la Loi ou le produit d'une nouvelle émission
réalisée en vue de procéder à un tel rachat;
2. sauf dans le cas d'une nouvelle émission réalisée en vue de procéder à un rachat, un montant égal à la valeur nominale
ou, à défaut, au pair comptable de toutes les MRPS sans Droit de Vote émises et devant être rachetées doit être affecté
à une réserve qui ne peut être distribuée aux Actionnaires, sauf cas de réduction du capital social de la Société. Sauf dans
ce cas particulier, la réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital social de la Société par incorporation de
cette réserve au capital social;
3. pour chaque MRPS sans Droit de Vote rachetée, le détenteur des MRPS sans Droit de Vote rachetées est en droit
de recevoir un paiement par MRPS sans Droit de Vote en espèces ou en nature (le "Prix de Rachat") égal à:
i. la valeur nominale ou, à défaut, le pair comptable de la MRPS sans Droit de Vote rachetée, plus
41992
ii. un montant correspondant à la portion du Compte de Prime d'Emission des MRPS sans Droit de Vote égal au solde
du Compte de Prime d'Emission des MRPS sans Droit de Vote divisé par le nombre de MRPS sans Droit de Vote émises
avant le rachat, plus
iii. tout Dividende Préférentiel échu mais non payé auquel donne droit la MRPS sans Droit de Vote rachetée au moment
du rachat, plus enfin
iv. un montant correspondant à la portion du Compte de Réserve des MRPS sans Droit de Vote égal au solde du
Compte de Réserve des MRPS sans Droit de Vote, divisé par le nombre de MRPS sans Droit de Vote émises avant le
rachat;
4. le paiement des sommes dues en vertu de 3.ii. à 3.iv. ci-dessus ne peut être opéré qu'au moyen de fonds distribuables
en vertu de l'article 72-1 de la Loi (les "Sommes Disponibles").
Toutefois, à la Date d'Echéance, si les Sommes Disponibles sont insuffisantes pour que la Société puisse racheter la
totalité des MRPS sans Droit de Vote, le rachat de toutes les MRPS sans Droit de Vote ne sera pas entravé, cette
insuffisance n'entraînant que le report du paiement du Prix de Rachat dû à la Date d'Echéance (le "Prix de Rachat à
l'Echéance"). Dans ce dernier cas, la Société devra seulement verser aux détenteurs des MRPS sans Droit de Vote ra-
chetées une partie seulement du Prix de Rachat à l'Echéance, jusqu'à concurrence du montant des Sommes Disponibles
à la Date d'Echéance, la partie restante du Prix de Rachat, sera versée, en un ou plusieurs versements dès que la Société
disposera de Sommes Disponibles suffisantes à cet effet.
Tant que le Prix de Rachat à l'Echéance n'aura pas été intégralement payé, aucun dividende ne sera payé aux Action-
naires.
Titre III - Administration
Art. 11. Nomination des administrateurs. La Société est administrée par un conseil d'administration qui est composé
d'au moins trois administrateurs.
Lorsque la Société a un actionnaire unique, elle peut être administrée par un administrateur unique qui exerce alors
seul les pouvoirs du conseil d'administration. Dans ce cas, toute référence faite ci-dessous au conseil d'administration
doit être lue comme désignant l'administrateur unique de la Société, si cette référence est appropriée.
La qualité d'Actionnaire n'est pas requise afin d'être administrateur. Les administrateurs sont nommés pour une pé-
riode de six années par résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par résolution des
actionnaires représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société prise durant une assemblée
générale. Le cas échéant, la rémunération des administrateurs est déterminée de la même manière.
Les administrateurs sont rééligibles pour des périodes successives de six ans, sans aucune restriction.
Cependant, en cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs en fonction peuvent coopter un autre
administrateur pour pourvoir au mandat vacant jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale conformément à la
Loi.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, elle est tenue de communiquer à la Société le
nom et les informations relatives à la personne physique qui sera son représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Un administrateur peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment, par une résolution des actionnaires
représentant plus de 50 % (cinquante pour cent) du capital social de la Société prise durant une assemblée générale.
Art. 12. Pouvoirs des administrateurs. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou les Statuts à l'actionnaire unique, ou, en cas de pluralité d'actionnaires, à l'assemblée générale des
actionnaires, sont de la compétence de l'administrateur unique ou du conseil d'administration, le cas échéant.
La Société est liée par la signature de son administrateur unique, ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la
signature conjointe de deux de ses administrateurs.
Le conseil d'administration peut déléguer pour une période déterminée son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques
à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société. Le conseil d'admi-
nistration déterminera les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.
La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette gestion
journalière peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants et/ou agents qui n'ont pas à être actionnaire
(s) de la Société.
Art. 13. Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit parmi les administrateurs un président qui présidera
toutes les réunions du conseil d'administration. En l'absence du président, le conseil d'administration sera présidé par un
administrateur présent et nommé à cet effet.
Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas à être administrateur ou actionnaire de la
Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs.
41993
Une convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l'ensemble des
administrateurs au moins 24 heures à l'avance, sauf quand il y est renoncé par chacun des administrateurs, ou lorsque
tous les administrateurs sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par tout
autre moyen de communication adéquat un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur peut représenter
plus d'un administrateur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des administrateurs participant à la réunion de
s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation phy-
sique.
Une réunion du conseil d'administration est dûment tenue quel qu'en soit l'objet si, au début de celle-ci, sont présents
en personne ou sont représentés au moins la moitié du nombre total des administrateurs.
Les décisions du conseil d'administration sont valablement prises par une résolution approuvée lors d'une réunion du
conseil d'administration de la Société dûment réunie par vote d'au moins la moitié des administrateurs présents et re-
présentés qui ont voté et ne se sont pas abstenus.
La voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux
administrateurs. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les résolutions du conseil d'administration peuvent êtres prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et
approuvées par écrit par tous les administrateurs afin de manifester leur accord unanime. Cette approbation peut résulter
d'un seul document ou de documents séparés, transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le
même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué.
Lorsqu'un administrateur unique est valablement désigné, les décisions sont prises à l'endroit et au moment déterminé
par lui comme étant le plus approprié et formalisé dans un document écrit signé par l'administrateur unique.
Art. 14. Responsabilité des administrateurs. Aucun administrateur n'engage sa responsabilité personnelle pour des
engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société conformément aux Statuts dans le cadre de ses fonctions
d'administrateur de la Société.
Titre IV - Assemblées d'actionnaires
Art. 15. Actionnaire unique. Un actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des ac-
tionnaires par la Loi. Dans ce cas, toute référence faite ci-dessous à l'assemblée générale des actionnaires de la Société,
doit être lue comme faisant référence à l'actionnaire unique de la Société.
Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par
écrit.
Art. 16. Assemblées générales. L'assemblée générale des Actionnaires peut être convoquée par le conseil d'adminis-
tration ou le(s) commissaire(s). Ils doivent la convoquer de manière à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois, lorsque
des Actionnaires représentant un dixième du capital social de la Société l'exigent, par demande écrite indiquant l'ordre
du jour de la réunion.
Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque actionnaire au
moins 8 (huit) jours avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout Actionnaire peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par
écrit un tiers qui n'a pas à être actionnaire de la Société.
Tout Actionnaire peut participer à toute assemblée générale par téléphone, visioconférence ou par tout autre moyen
de communication approprié permettant son identification et garantissant une participation effective à l'assemblée. Une
telle participation est réputée équivalente à une participation physique.
Les résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sont valablement adoptées à la majorité des voix
exprimées par un ou plusieurs actionnaires présents ou représentés et en droit de voter.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ne délibère valablement que si plus de 50% (cinquante pour cent)
du capital social de la Société est représenté. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les actionnaires
seront convoqués par lettre recommandée à une seconde assemblée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées quelle que soit la portion du capital
social représentée.
Néanmoins, les résolutions décidant de modifier les Statuts ne peuvent être adoptées que par une résolution prise en
assemblée générale extraordinaire par au moins les deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés et pour
autant qu'ils ne se soient pas abstenus ou n'aient pas voté blanc ou que le vote ne soit pas nul.
41994
Une assemblée générale des actionnaires devant statuer sur l'approbation des comptes du dernier exercice social clos
de la Société doit être tenue annuellement à Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de
mai à 15 heures ou le lendemain si ce jour est un jour férié.
Les minutes des assemblées générales d'actionnaires sont signées par le président, ou le cas échéant son remplaçant,
et les scrutateur(s) de l'assemblée et actionnaires qui le demandent.
Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit
Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un
décembre, à l'exception du premier exercice qui commence ce jour et se termine le 31 décembre 2010.
Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un bilan et un
compte de pertes et profits, conformément à la Loi, auxquels un inventaire sera annexé. Les comptes annuels seront
soumis à l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour approbation.
Quinze jours avant l'assemblée générale des Actionnaires, chaque Actionnaire peut prendre connaissance au siège
social de la Société, du bilan, du compte de pertes et profits ainsi que de tous les documents mentionnés par l'article 73
de la Loi.
Art. 19. Bénéfice. Le solde positif du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortisse-
ments, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'Actionnaires, par
l'assemblée générale des Actionnaires, représente le bénéfice net de la Société.
Le bénéfice net de la Société peut être distribué par l'assemblée générale des Actionnaires comme suit:
Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être reprise à tout moment jusqu'à
entière reconstitution si elle venait à redescendre sous le seuil de 10% du capital social.
Lors de chaque exercice social, sur les bénéfices restants après affectation à la réserve légale et calculés selon les
principes comptables généralement reconnus au Grand-Duché de Luxembourg (le "Bénéfice Disponible"), chaque dé-
tenteur de MRPS sans Droit de Vote a droit au dividende préférentiel tel que précisé au moment de l'émission des MRPS
sans Droit de Vote (le "Dividende Préférentiel").
Le Dividende Préférentiel est augmenté par le(s) montant(s) du(des) Dividende(s) Préférentiel(s) qui n'aurai(en)t pas
été distribué(s), que ce soit en totalité ou en partie, au cours des derniers exercices sociaux.
Si le Bénéfice Disponible est suffisant pour distribuer le Dividende Préférentiel, en tout ou en partie, et que l'Actionnaire
unique, ou en cas de pluralité d'Actionnaires, l'assemblée générale des Actionnaires, ne prend pas de décision de distri-
bution d'un tel Dividende Préférentiel, le montant du Dividende Préférentiel qui aurait dû être distribué aux détenteurs
de MRPS sans Droit de Vote, sera automatiquement affecté à une réserve distribuable comptabilisée dans un compte de
réserve de MRPS sans Droit de Vote (le "Compte de Réserve des MRPS sans Droit de Vote").
Après la distribution ou l'allocation du Dividende Préférentiel, le reliquat du Bénéfice Disponible pourra être distribué
aux détenteurs d'Actions Ordinaires.
Ce reliquat de bénéfices est alloué par l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'Actionnaires, par résolution prise
durant une assemblée générale par un ou plusieurs Actionnaires présents ou représentés et représentant plus de la moitié
du capital sociale de la Société, décidant soit de le distribuer proportionnellement au nombre d'Actions qu'il(s) détient
(détiennent), soit de l'allouer au report à nouveau, soit encore de l'affecter à une réserve distribuable.
Chaque détenteur d'Actions Ordinaires(s) a droit à une fraction du total des bénéfices distribués à toutes les Actions
Ordinaires proportionnellement au nombre d'Actions Ordinaire(s) qu'il détient dans la Société.
Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le conseil d'administration peut décider, conformément
à l'article 72-2 de la Loi et sous réserve du respect des conditions prévues par la Loi et les présents Statuts, de verser
des dividendes intérimaires payés en espèces ou en nature.
Art. 21. Audit. La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaire(s) ou non.
Chaque commissaire doit être nommé par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne devant
pas excéder 6 années.
Le mandat des commissaires peut être renouvelé sans restriction.
Un commissaire peut être révoqué, avec ou sans raison, à tout moment par résolution prise en assemblée générales
par des actionnaires représentant plus de 50%(cinquante pour cent) du capital social de la Société.
Lorsque les conditions de l'article 35 de la Loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre des Sociétés ainsi que les
comptes annuels seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises
agrées désigné(s) par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale des action-
naires. L'assemblée générale des actionnaires pourra cependant nommé un réviseur d'entreprises à tout moment.
La surveillance de la Société n'a pas à être confiée à un ou plusieurs commissaire(s) si un ou plusieurs réviseurs
d'entreprises est(sont) nommé(s).
41995
Titre VI - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'action-
naires, par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un actionnaire.
Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par résolution
d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts,
résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations éventuelles.
Au moment de la clôture de la liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'Actionnaire Unique, ou, en cas
de pluralité d'Actionnaires, aux Actionnaires, comme suit: ils seront attribués en priorité aux détenteurs de MRPS sans
Droit de Vote pour un montant égal au Prix de Rachat, et le surplus, le cas échéant, sera attribué aux détenteurs d'Actions
Ordinaires proportionnellement au nombre d'Actions Ordinaires qu'ils détiennent.
Dans l'hypothèse où le montant total du Prix de Rachat devant être versé aux détenteurs de MRPS sans Droit de Vote
s'avèrerait insuffisant pour payer intégralement chacun d'eux, le Prix de Rachat global disponible devra être attribué aux
détenteurs de MRPS sans Droit de Vote proportionnellement au nombre de MRPS sans Droit de Vote qu'ils détiennent.
<i>Souscription - Paiementi>
Une fois les Statuts établis, les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont souscrits aux Actions
et ont payé en l'espèce les montants comme suit:
- Xtreme (Luxembourg) a souscrit à 40.000 Actions Ordinaires, et a intégralement libéré ces Actions par un apport
en numéraire de 40.000 USD; et
- Suhayl Abdul Mohsin Al Shoaibi & Sons Holding Company Limited a souscrit à 10.000 Actions Ordinaires, et a
intégralement libéré ces Actions par un apport en numéraire de 10.000 USD
Le montant total de 50.000 USD est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant
par la production d'un certificat de blocage des fonds, ce qui est expressément reconnu par le notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont évalués à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les Associés, représentant la totalité du capital social, ont pris les
résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour un mandat débutant à la date de ce jour et s'achevant
le 4 mars 2016:
- Rod Uchytil, né à Edmonton, Canada le 17 décembre 1963, résidant professionnellement à 16285 Park Ten Place,
Ste 650 Houston, Texas 77084, Etats-Unis d'Amérique;
- Elizabeth Wilkinson, née à Coral Gables, Floride, Etats-Unis d'Amérique le 24 novembre 1957, résidant profession-
nellement à Park Ten Place, Ste 650 Houston, Texas 77084, Etats-Unis d'Amérique;
- Tom Wood, né à Calgary, Alberta, Canada, le 17 décembre 1956, résidant professionnellement à 1402 500 Fourth
Avenue, SW Calgary, AB T2P 2V6, Canada;
- Brett Cole, né dans l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique, le 14 janvier 1967, résidant professionnellement à 16285 Park
Ten Place, Ste 650, Houston, Texas 77084, USA;
- Faisal Suhayl A Al Shoaibi, né à Basra, Irak le 23 Septembre 1968, résidant professionnellement à P.O. Box 1280, Al
Khobar 31952, Arabie Saoudite
- Dennis Bosje, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 20 novembre 1965 résidant professionnellement au 5, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg; et
- Valérie Fisson, née à Marche, Belgique, le 11 novembre 1975, résidant professionnellement au 5, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée commissaire:
- Interaudit, 119, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 5, avenue Gaston Diderich, Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête des parties comparantes
agissant par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
41996
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. MAILLARD, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 mars 2010. Relation: LAC/2010/11754. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Référence de publication: 2010041309/718.
(100041165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Valmis S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 35.672.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1
er
mars 2010 documenté par Maître Joëlle
BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mars 2010, LAC / 2010 / 9698.
Que:
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans au L-1724 Luxembourg, 47,
boulevard du Prince Henri.
Luxembourg, le 18 mars 2010.
Pour extrait conforme
Joëlle BADEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2010041492/19.
(100041327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Coney S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 110.811.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 mars 2010i>
1. La démission de la société MANACOR (Luxembourg) S.A. en tant que gérant a été acceptée avec effet immédiat.
2. Mme Charlotte LAHAIJE-HULTMAN, née le 24 mars 1975 à Barnarp (Suède) domiciliée professionnellement à
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommée en tant que nouvelle gérante avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
3. Le siège social a été transféré de L-1855 Luxembourg, 46A, avenue JF Kennedy à L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CONEY S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010041493/19.
(100041604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Swiss & Global Multicash Advisory S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. Julius Baer Multicash Advisory).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 85.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041494/10.
(100041252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
41997
Russian Style Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 135.397.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 23 mars 2010.
Référence de publication: 2010041495/10.
(100041270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Genevrieres European Finance S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 125.329.
1. Le siège social de la société GENEVRIERES EUROPEAN FINANCE S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
2. Madame Luisella MORESCHI, Madame Frédérique VIGNERON et Madame Patricia JUPILLE ont démissionné avec
effet immédiat de leur poste d'administrateur au sein de la société.
3. La société GORDALE MARKETING LIMITED a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux
comptes.
4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société GENEVRIERES EUROPEAN FINANCE
S.A. et Luxembourg Management Company Group SA (LMC Group SA), est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 22 mars 2010.
L.M.C Group S.A
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2010041496/17.
(100041386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
R.E.W.-Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 123.623.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010041497/10.
(100041521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Promexis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 115.122.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041498/9.
(100041555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Progx S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 101.532.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PROGX S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2010041500/11.
(100041754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
41998
Magadom International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 125.336.
1. Le siège social de la société MAGADOM INTERNATIONAL S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
2. Madame Luisella MORESCHI, Madame Frédérique VIGNERON et Madame Patricia JUPILLE ont démissionné avec
effet immédiat de leur poste d'administrateur au sein de la société.
3. La société GORDALE MARKETING LIMITED a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux
comptes.
4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société MAGADOM INTERNATIONAL S.A. et
Luxembourg Management Company Group SA (LMC Group SA), est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 22 mars 2010.
L.M.C Group S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2010041499/17.
(100041387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Imperatriz Finance S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 125.330.
1. Le siège social de la société IMPERATRIZ FINANCE S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
2. Madame Luisella MORESCHI, Madame Frédérique VIGNERON et Madame Patricia JUPILLE ont démissionné avec
effet immédiat de leur poste d'administrateur au sein de la société.
3. La société GORDALE MARKETING LIMITED a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux
comptes.
4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société IMPERATRIZ FINANCE S.A. et Luxem-
bourg Management Company Group SA (LMC Group SA), est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 22 mars 2010.
L.M.C Group S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2010041501/17.
(100041391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Nosbusch-Kohnen s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9220 Diekirch, 44, rue Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 99.542.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010041502/10.
(100041519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
MusicEnterprise, Association sans but lucratif.
Siège social:
R.C.S. Luxembourg F 4.081.
DISSOLUTION
Lors de son assemblée générale, tenue ce jour, l'a.s.b.l. MusicEnterprise a décidé de cesser ses activités et de dissoudre
et de liquider l'association.
Elle ne dispose pas de biens à affecter.
La liquidation est donc clôturée.
Fait à Luxembourg, le 22 mars 2010.
Référence de publication: 2010041503/13.
(100041503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
41999
Manuel Silva Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 90.266.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010041504/9.
(100041553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Longevity Capital S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.095.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 février 2010i>
L'Assemblée décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.
L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans,
à partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des
Sociétés et Associations, Mémorial C, à l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Référence de publication: 2010041505/13.
(100041587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Wachsund Handelsgesellschaft A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 143.867.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 mars 2010 au siège de la
société que:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Joseph
HANSEN de sa fonction d'administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Olegario
RIVERO de sa fonction d'administrateur-délégué de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Guy Nicolas FRANKARD né le 18.05.1962 à Steinfort, administrateur de sociétés, demeurant profession-
nellement à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon
En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915, l'administrateur nommé Monsieur
Guy Nicolas FRANKARD, achève le mandat de celui qu'il remplace, Monsieur Joseph HANSEN.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de nommer comme administrateur-délégué, délégué à la
gestion journalière, Monsieur Guy Nicolas FRANKARD né le 18.05.1962 à Steinfort, administrateur de sociétés, demeu-
rant professionnellement à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon. Le mandat de l'administrateur-délégué nommé prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.
Luxembourg, le 22 mars 2010.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010041525/30.
(100041472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
42000
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Athic S.à r.l.
BCD Travel Luxembourg S.A.
cominvest Asset Management S.A.
Coney S.à r.l.
Deloitte S.A.
Dexia Quant
Dimocharous S.à r.l.
Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg
Genevrieres European Finance S.A.
Imperatriz Finance S.A.
IMY S.A., SPF
International Pension Administration S.à r.l.
Julius Baer Multicash Advisory
Julius Baer Multicooperation Advisory
Julius Baer Multiinvest Advisory
Julius Baer Multiopportunities Advisory
Julius Baer Multipartner Advisory
Julius Baer Multiselect Advisory
Julius Baer Multistock Advisory
Julius Baer Sicav II Advisory
Julius Baer Strategy Fund Advisory
Longevity Capital S.A.
Magadom International S.A.
Manuel Silva Immobilière S.à r.l.
Mare Foundation
MB CONSULT s.à r.l.
Michelangelo
MusicEnterprise
Nosbusch-Kohnen s.à.r.l.
PEME 09 - ITM S.C.A., SICAR
Piscadera Investments S.A.
Prestige 2001 Sàrl
Progx S.A.
Promexis S.A.
QS Geo Pep S.C.A., SICAR
R.E.W.-Immo S.A.
Ril Invest S.A.
Russian Style Investments S.à r.l.
Sewerin Schiltz S.à r.l.
Sicav Patrimoine Investissements
Space Liner S.A.
Sudring Holding S.A.
Swiss & Global Multicash Advisory S.A.H.
Swiss & Global Multicooperation Advisory S.A.H.
Swiss & Global Multiinvest Advisory S.A.H.
Swiss & Global Multiopportunities Advisory S.A.H.
Swiss & Global Multipartner Advisory S.A.H.
Swiss & Global Multiselect Advisory S.A.H.
Swiss & Global Multistock Advisory S.A.H.
Swiss & Global Sicav II Advisory S.A.H.
Swiss & Global Strategy Fund Advisory S.A.H.
Valengilux S.A.
Valmis S.A.
Valorinvest
Vista S.A.
Wachsund Handelsgesellschaft A.G.
WWK Rolling Protect
WWK Rolling Protect
Xtreme Equipment Group
Yaletipart S.A.
Zork S.A.