logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 630

24 mars 2010

SOMMAIRE

Antunite Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

30224

A.P. LUX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30205

ATC-MAT S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30232

Beta DB Lindsell Limited S.C.S.  . . . . . . . . .

30194

Bezalel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30231

Bifica Real Estate Investment S.A.  . . . . . . .

30240

BLRM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30222

C2NT Import Export S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

30205

Cellon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30205

Centower Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

30231

Chripas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30210

Citynet Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30205

ColMolitor (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30208

Company Invest Meat Industry S.A.  . . . . .

30206

Conseil Comptable S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30220

DiPiU Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30223

Dominis Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30224

Eaton Holding IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30206

Eaton Holding IX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30207

Eaton Holding VIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

30206

Eaton Holding X S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30206

Emerald First Layer " J " S.A.  . . . . . . . . . . .

30237

Entropie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30222

Fernbach Financial Software S.A. . . . . . . . .

30209

Fiduciaire Générale GROUP, s.à r.l.  . . . . .

30216

Finacor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30223

Financière Hôtelière Européenne S.A.  . . .

30221

Fintech Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

30239

Frozen Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30222

Granis Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30217

Graphite et Métaux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

30207

HAZ Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30218

HEBB S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30209

Hickory Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

30218

Howald Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30219

Hungaria Baukonzepte A.G.  . . . . . . . . . . . .

30217

IBR Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30220

IFF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30220

Imagine Cyber Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

30219

Immobilière Reiserbann S.A.  . . . . . . . . . . . .

30206

Immotourisme S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30219

Jero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30209

Lanchester S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30221

Meranti Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

30232

Metallum Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30223

Moeller Electric S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30207

Newtec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30209

Pierjet Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30209

PRB Luxembourg International S. à r.l.  . .

30232

Restaurant La Belle Africaine  . . . . . . . . . . .

30218

Scandinavian Company Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30208

Scandinavian Company Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30232

Scandinavian Company Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30232

SK Logistic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30217

Sword Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

30205

The Leading Travel Companies of the

World S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30224

Triul S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30207

Unitpool Asset Management Alpha S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30194

W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30208

Wasaby S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30221

Whitehall French RE 10 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

30208

Whitehall French RE 11 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

30207

30193

Beta DB Lindsell Limited S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 137.436.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. STEICHEN.

Référence de publication: 2010028511/10.
(100024914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Unitpool Asset Management Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.480,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 151.374.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the eleventh day of February.
Before MaTtre Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

UNITPOOL AG, a public limited company (Aktiengesellschaft) organized and existing under the laws of Switzerland,

with registered office at Steinackerstrasse 2, CH-8302 KLOTEN, Switzerland, registered with the Commercial Register
of the Canton of ZURICH, Switzerland, under file number CH-020.3.025.636-6 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Quentin HUBEAU, in his capacity as a proxy holder, residing professionally at 2a Boulevard Joseph

II,  L-1840  Luxembourg,  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  by  virtue  of  a  Limited  Power  of  Attorney  given  in  KLOTEN,
Switzerland, on 8 February 2010.

Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested that the undersigned notary enact the following

articles of association of a private limited liability company (société a responsabilité limitée), to be hereby incorporated:

Form - Name - Purpose - Registered office - Duration

Art. 1. Corporate Form. There is hereby formed a private limited liability company (société a responsabilité limitée)

governed by these Articles of Association (the "Articles") and by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in
particular the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law of 1915").

If and as long as one shareholder holds all the Shares (as defined below), the Company shall exist as a sole shareholder

company (société unipersonelle), pursuant to Article 179(2) of the Law of 1915, and be subject to the applicable legal
provisions.

At any time, the Sole Shareholder may join with one or several shareholders (the "Shareholders"). In the same manner,

the Shareholders may adopt the appropriate measures to restore the sole shareholder status of the Company.

Art. 2. Corporate Name. The Company is incorporated under the name Unitpool Asset Management Alpha S.à r.l.

Art. 3. Corporate Purpose.
3.1 The Company's purpose is to take participations in any form whatsoever in any Luxembourg or foreign companies

or enterprises, and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or
in any other way any securities, rights, patents and licenses, and any other property, rights and interest in property as
the Company shall deem fit (with or without consideration or benefit), and generally to hold, manage, develop, sell or
dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares
or securities of any company purchasing the same.

More particularly, the Company may purchase assets and lease such assets as part of an intra-group operation.
3.2 The Company may also give or grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise)

to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies
to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purpose (without these activities constituting a professional
activity of the financial sector subject to prior authorization from the "Commission de Surveillance du Secteur Financier"
or any activity that would be subject to a license or other prior regulatory authorization requirements).

30194

3.3 The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in as much as the Company shall be considered a "Société de
Participations Financières" according to the applicable provisions of the law.

3.4 The Company may borrow in any form and issue convertible bonds or other debt instruments or debentures,

without a public offer.

3.5 The Company may also give guarantees and grant security interests to any third party to secure its obligations or

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or to any other group company. The Company may further mortgage,
pledge, transfer and encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision

of the Shareholder(s), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The registered office may be
transferred within the municipality by decision of the Sole Manager (gérant), if only one Manager is appointed, or in case
of plurality of Managers by the Board of Managers (conseil de gérance).

4.3 In the event that the Sole Manager or the Board of Managers should determine that extraordinary political, eco-

nomic or social developments that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad have occurred or are imminent, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of the abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any inter-
ested parties by the Sole Manager or Board of Managers.

4.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The existence of the Company is not affected

by the death, suspension of civil rights, liquidation, bankruptcy or insolvency of any of its Shareholders.

Capital and Shares

Art. 6. Capital.
6.1 The subscribed and paid-in share capital is set at EUR 12,480.- (twelve thousand four hundred and eighty Euro),

represented by 1,248 (one thousand two hundred and forty-eight) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro)
each (collectively referred to as the "Shares" and each referred to as a "Share").

6.2 The share capital may be changed at any time by a decision of the Sole Shareholder or by decision of the General

Shareholder's Meeting in accordance with Article 12.3 of the Articles and within the limits provided for by the Law of
1915.

Art. 7. Shares.
7.1 Each Share entitles its holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of Shares in existence.

7.2 The Shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.
7.3 The Company may acquire its own Shares subject to the limits provided by the Law of 1915. The Company shall

not directly or indirectly by means of a loan, guarantee, provision of security or otherwise, give any financial assistance
for the purpose of any third party's actual or proposed acquisition of any Company shares, but nothing in these Articles
shall prohibit transactions permitted under the Law of 1915.

7.4 The Shareholder(s) can resolve to create different classes of Shares, referred to as Ordinary Shares and Preferred

Shares. The Ordinary Shares and Preferred Shares can be issued with or without a share premium, subject to legal
requirements and the provisions of the present Articles. Without prejudice to the legal requirements, the different classes
of Shares shall have the rights provided for in the present Articles and any new class of Shares which may be issued from
time to time will have such rights as may be determined in the resolutions approving the issue of such class of Shares.

7.5 Any amount of share premium paid in addition to the nominal value of the Shares shall be allocated to a share

premium reserve freely available to the Shareholders' General Meeting or Sole Shareholder. Any available share premium
shall be distributable.

Art. 8. Share Transfer.
8.1 The Shares are freely transferable among the Shareholders.
8.2 Shares may not be transferred inter vivos to non-Shareholders unless Shareholders representing at least seventy-

five percent (75%) of the share capital shall have agreed thereto in a General Meeting, as provided by the Law of 1915.

8.3 In case of plurality of Shareholders, no Shares may be transmitted by reason of death to non-Shareholders including

heirs compulsorily entitled to a portion of the deceased Shareholder's estate (héritiers réservataires) or the surviving
spouse, unless Shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the rights owned by the surviving Share-
holders approve of the transmittal. In these instances, the relevant provisions of the Law of 1915 shall apply.

30195

8.4 The creditors, representatives, rightful successors or heirs of any Shareholder are not allowed, for any reason

whatsoever, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. For the exercise of their rights, they must refer to the financial statements and to the
decisions of the Shareholders' General Meetings or Sole Shareholder.

8.5 All Share transfers must be recorded by notarised instrument or document under private seal.
8.6 No Share transfer shall be valid vis-à-vis the Company or third parties until they have been notified to the Company

or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Civil Code.

Management

Art. 9. Board of Managers.
9.1 The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will constitute

a Board of Managers (conseil de gérance) The Managers need not be shareholders. Where applicable, references to a
Manager, Board of Managers or Managers shall also be references to a Sole Manager (gérant unique). The Board of
Managers will elect a chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the first Shareholders'
General Meeting. If the Chairman is not present at a meeting, he will be temporarily replaced by a Manager elected for
this purpose from among the Managers present at the meeting. If no term of office is specified, the Manager(s) is/are
appointed for an undetermined period, and they may be reelected. The Manager(s) may be dismissed ad nutum (without
justification or indemnity) at any time.

9.2 The Managers are appointed by a simple majority decision of the Shareholders' General Meeting or the Sole

Shareholder which determines their powers and the term of their mandates.

In the event of a vacancy before the end of a Manager's term of office, the Manager appointed by the Shareholders'

General Meeting or the Sole Shareholder shall serve for the remainder of the term of office of the Manager being replaced.
If a Manager is removed from the Board of Managers under the provisions of these Articles, the Shareholders' General
Meeting or the Sole Shareholder may fill the vacancy at the meeting at which such Manager is removed. In the absence
of such election or appointment, the Board of Managers may fill the vacancy which must be ratified at the next Share-
holders' Meeting or by the Sole Shareholder.

9.3 The Board of Managers may sub-delegate part of their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The Board of Managers will determine such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of his agency.

9.4 In dealing with third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its Sole Manager and in case of

plurality of Managers, the Company shall be bound by the joint signature of any two Managers. Those Managers have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and carry out and approve all acts and operations consistent
with the corporate purpose, provided the terms of these Articles shall have been complied with. All powers not expressly
reserved by the Law of 1915 or these Articles to the Shareholders' General Meeting or the Sole Shareholder fall within
the competence of the Board of Managers or the Sole Manager. In any event the Company will be validly bound by the
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the Board of Managers
acting within the scope of the powers granted.

9.5 In carrying out his function, a Manager does not contract to any personal obligation with respect to the commit-

ments regularly made by him in the name of the Company; as an agent he is only responsible for the execution of his
mandate.

Art. 10. Board of Managers' Meetings.
10.1 The Board of Managers' Meetings are convened by the Chairman or by any Manager. The Board of Managers can

deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented at the Board of Managers'
Meetings.

10.2 The resolutions of the Board of Managers shall be validly adopted by a simple majority of votes cast by the Managers

present or represented.

10.3 For the calculation of quorum and majority, any and all Manager(s) may participate in any Board of Managers'

Meeting by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the Managers
taking part in the Meeting to be identified and effectively and continuously participate. Participation in, or the holding of
a Meeting by these means is equivalent to participation in person at such Meetings. A Meeting held using such means of
communication shall be deemed to have taken place at the registered office of the Company.

10.4 The Managers may cast their votes on the items on the agenda by letter, e-mail, telex, telefax, or other electronic

means of communication, with a confirmation sent by written letter.

10.5 Resolutions adopted in writing, approved and signed by all Managers, shall have the same effect as resolutions

passed at the Managers' Meeting. In those instances, resolutions or decisions shall be expressly taken in a single or several
separate documents, either in writing or by circular resolution, and transmitted by ordinary mail, electronic mail, facsimile
or other electronic means of communication.

30196

10.6 Any Manager may act at any Meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or e-mail or letter another Manager as his proxy. No Manager can represent more than one other Manager at the Board
of Managers' Meeting.

Shareholders

Art. 11. Shareholders' Meetings.
11.1 In case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder exercises the powers devolved to the Shareholders' Meeting

by the Law of 1915.

11.2 Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to Shareholders to their address ap-

pearing in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the Meeting. If
the entire share capital is represented at a Meeting, the Meeting may be held without prior notice.

11.3 A corporation which is a Shareholder shall, by written instrument, authorize a person to act as its representative

at any Shareholders' Meeting, and any person so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of
the corporation as that corporation could exercise if it were an individual Shareholder. That Shareholder shall be deemed
to be present at any such meeting attended by its authorized representative.

11.4 For the calculation of quorum and majority, any Shareholder may participate in any Shareholders' Meeting by

telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all Shareholders taking part
in the meeting to be identified and effectively and continuously participate. Participation in a meeting by these means is
equivalent to participation in person at such meetings, provided that at least one Shareholder or its representative is
physically present at the registered office of the Company. A meeting held using such means of communication shall be
deemed to have taken place at the Company's registered office.

11.5 In case and for as long as the Company has more than 25 Shareholders, the Annual General Meeting shall be held

on the third Friday in May of each year. If such day is not a business day, the Meeting shall be held on the immediately
following business day.

Art. 12. Shareholders' Resolutions.
12.1 Each Shareholder may take part in collective decisions and has a number of votes equal to the number of Shares

he owns and may validly act at any Shareholders' Meeting through a special proxy.

12.2 Decisions by Shareholders are taken in writing (to the extent permitted by law) or at Meetings, in such form and

by such majority(ies) as prescribed by the Law of 1915. Any regularly constituted Shareholders' Meeting or any valid
written resolution shall represent all Shareholders.

12.3 All decisions exceeding the powers of the Board Managers are taken by the Sole Shareholder or Shareholders.

Resolutions are validly adopted when taken by Shareholders representing more than half of the Company's share capital.
However, decisions to amend the Articles must be taken by a majority vote of Shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital. If this majority is not attained at a first Meeting, the Shareholders are convened
by registered mail to a second Meeting. At this second Meeting, decisions will be taken by a majority of Shareholder votes
whatever the percentage of share capital represented.

12.4 In case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the Shareholders at their addresses

inscribed in the register of Shareholders held at the Company's registered office at least eight (8) days before the proposed
effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon approval by the legally-required majority
for such collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein).
Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 13. The financial year begins on January 1 

st

 and closes on December 31 

st

 .

Art. 14. Each year, the Board of Managers shall establish an inventory, including an indication of the value of the

Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss accounts in which the necessary
depreciation charges must be made according to the accounting policies of the company.

Art. 15. Each Shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

accounts.

Art. 16. Distribution of Profits.
16.1 Every year, five percent (5%) of the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions shall

be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be mandatory when the legal reserve amounts to ten percent
(10%) of the share capital, but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any
reason, the legal reserve falls below 10 percent (10%) of the share capital.

16.2 The balance of the net profits may be distributed to the Shareholders commensurate to their share holding in

the Company. However, the Sole Shareholder or the Shareholders may decide, by the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of the legal reserve, be either carried forward or transferred to a freely
available extraordinary reserve.

30197

16.3 The Sole Shareholder or the Shareholders, upon recommendation of the Sole Manager or the Board of Managers,

may decide to make a distribution of interim dividends. A decision to distribute such dividends may only be taken on the
basis of interim accounts (balance sheet and profit and loss accounts) which evidence that the Company has sufficient
distributable reserves to fund the distribution. Should Luxembourg law provide that management can decide on the
distribution of interim dividends, these Articles herewith authorize the Manager or Board of Managers to decide on such
a distribution under the conditions provided for by the applicable law.

16.4 The amount capable of being distributed as an interim dividend shall not exceed the amount of net profits realized

since the close of the business year immediately preceding the distribution (provided the annual financial statements
pertaining to that year have been approved), increased by profits carried forward and amounts drawn from available
reserves, and reduced by losses carried forward and amounts to be allocated to the legal reserve.

16.5 The share premium account may be distributed to the Shareholders or the Sole Shareholder upon decision of

the Shareholders' General Meeting or the Sole Shareholder. The Shareholders' General Meeting or the Sole Shareholder
written resolutions may decide to allocate any amount of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 17. Winding-Up - Liquidation.
17.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the Sole Shareholder or of one of the Shareholders.

17.2 With the exception of a court-ordered dissolution, dissolution of the Company may only take place pursuant to

a resolution adopted by the Shareholders' General Meeting in accordance with the conditions set forth for amendments
to the Articles.

17.3 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who need not be Shareholders or Managers but are all physical or legal persons. The liquidators will be appointed by the
Shareholders' General Meeting or the Sole Shareholder which will also determine the powers and remuneration of the
liquidators. Unless decided otherwise, the liquidators will have the broadest powers to realize the assets and pay the
Company's liabilities. When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the
Shareholders proportionately to the shares they hold.

Art. 18. For all matters not provided for in these Articles, the Shareholders or the Sole Shareholder shall refer to the

laws in force, and in particular to the Law of 1915.

<i>Transitory Provision

In exception to Article 13 of these Articles, the first financial year shall begin today and end on December 31 

st

 , 2010.

<i>Subscription and Payment

All 1,248 (one thousand two forty-eight) Shares, representing the entirety of the Company's share capital have been

entirely subscribed as follows:

Subscriber

Number

of shares

Subscribed

amount

Percent age

of share

capital

1. UNITPOOL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,248

EUR12.480

100%

All subscribed Shares have been fully paid up in cash. Thus, the amount of EUR 12,480.- (twelve thousand four hundred

and eighty Euro) is as of now at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately one thousand one hundred Euro
(EUR 1,100.-).

<i>Sole Shareholder's decisions

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entirety of the subscribed

share capital, being itself regularly convened, and exercising the powers devolved to the Meeting, passed the following
decisions:

1) The Company shall have its registered office at 4, Rue Henri Schnadt L-2530 LUXEMBOURG
2) The number of Managers is set at three (3), and the following persons are appointed to the Company Board of

Managers for an unlimited period:

1. David Harman, Chief Executive Officer, residing professionally at Steinackerstr. 2 CH-8302 Kloten, Switzerland,
2. Andreas Ernst, Chief Financial Officer, residing professionally at Steinackerstr. 2 CH-8302 Kloten, Switzerland,.
3. Maria Cordoba Arranz, Commercial Director, residing professionally at Steinackerstr. 2 CH-8302 Kloten, Switzer-

land.

30198

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Declaration

In witness whereof, we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg on the day, month, year and

time given at the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the appearer's proxyholder, who signed together

with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above-appearing

party, this incorporation deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same party, and
in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.

Deutsche Fassung des vorhergehenden Textes

Im Jahre zweitausend und zehn, am elften Februar.
Vor  dem  Unterzeichneten  Maître  Martine  SCHAEFFER,  Notar  mit  Amtswohnsitz  in  Luxemburg,  Großherzogtum

Luxemburg, Ist erschienen:

UNITPOOL  AG,  eine  Aktiengesellschaft  schweizerischen  Rechts,  mit  eingetragenem  Sitz  in  Steinackerstrasse  2,

CH-8302 KLOTEN, Schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons ZÜRICH, Schweiz, unter der Aktennummer
CH-020.3.025.636-6 (die „Alleinige Gesellschafterin"),

hier vertreten durch Quentin HUBEAU, Jurist, in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter, jeweils geschäftsansässig in

2a, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, jeweils aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in KLOTEN,
Schweiz, am 8. Februar 2010.

Besagte Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeich-

neten Notar dieser Urkunde als Anlage dauerhaft beigefügt und zusammen mit dieser bei den Behörden zur Eintragung
eingereicht.

Die Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft

mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée)  (die  „Gesellschaft"),  die  sie  hiermit  gründet,  wie  folgt  zu
beurkunden.

Form - Name - Zweck - Sitz - Dauer

Art. 1. Gesellschaftsform. Es wird hiermit gegründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsa-

bilité limitée), gemäß dieser Gesellschaftssatzung (die „Satzung") und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 in seiner derzeit gültigen Fassung (das „Gesetz von 1915").

Wenn und solange ein Anteilseigner sämtliche Anteile (wie nachstehend bezeichnet) hält, soll die Gesellschaft als

Einpersonengesellschaft (société unipersonelle) gemäß Artikel 179(2) des Gesetzes von 1915 bestehen und den diesbe-
züglich anwendbaren gesetzlichen Vorschriften unterliegen. Zu jeder Zeit kann sich die Alleinige Gesellschafterin mit
einem oder mehreren weiteren Gesellschaftern zusammenschließen (die „Gesellschafter"). Ebenso kann durch die Ver-
einigung aller Anteile in der Hand eines einzigen Gesellschafters die Gesellschaft ihren Status als Einpersonengesellschaft
zurückerlangen.

Art. 2. Name der Gesellschaft. Die Gesellschaft wir unter dem Namen Unitpool Asset Management Alpha S.á r.l.

gegründet.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedweder Form an jedweden luxemburgischen oder ausländischen

Gesellschaften und Unternehmungen und der Erwerb, mittels Beteiligung, durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen,
Ausübung von Kaufoptionen, Verhandlung oder in sonstiger Art und Weise, von Wertpapieren, Rechten, Patenten und
Lizenzen sowie jedweden anderen Eigentums und Rechten an Eigentum, nach freiem Ermessen der Gesellschaft (mit oder
ohne Gegenleistung oder Gewinn), und ganz allgemein, diese zu halten, zu verwalten, zu entwickeln und durch Verkauf,
Abtretung, Tausch und insbesondere gegen Anteile oder Wertpapiere an Gesellschaften, die diese erwerben, oder in
sonstiger Art und Weise, zur Gänze oder in Teilen, nach dem Ermessen der Gesellschaft, zu verwerten oder abzutreten.

Insbesondere kann die Gesellschaft Anlagevermögenswerte erwerben und diese im Rahmen von konzerninternen

Geschäftstätigkeiten verpachten.

3.2 Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Un-

ternehmen,  die  zu  der  gleichen  Gruppe  von  Unternehmen  gehören  (indem  sie  diesen  Darlehen,  Vorschüsse  oder
Sicherheiten gewährt oder in jeder anderen Art und Weise) unterstützen, jedwede Kontroll- oder Aufsichtsmaßnahmen
oder jedwede sonstige Tätigkeit ausüben, die dem Erreichen ihres Gesellschaftszwecks dient (ohne insoweit Geschäfte
zu  tätigen,  die  Bankgeschäfte  oder  Geschäfte  des  Finanzsektors  sind,  die  einer  vorherigen  Genehmigung  seitens  der
"Commission de Surveillance du Secteur Financier" bedürfen, oder Aktivitäten auszuüben, die anderweitig Lizenzvor-
schriften oder anderen behördlichen Genehmigungsvoraussetzungen unterliegen).

30199

3.3 Ferner kann die Gesellschaft jegliche kommerzielle, technische und finanzielle Tätigkeit ausüben, die direkt oder

indirekt das Erreichen ihres Gesellschaftszwecks fördert, insofern als die Gesellschaft unter Beachtung der diesbezüglich
zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen als "Société de Participations Financières" anzusehen ist.

3.4 Die Gesellschaft kann in jedweder Form Darlehen aufnehmen und ohne öffentliches Angebot Wandelschuldver-

schreibungen oder andere Schuldtitel- oder Verschreibungen ausgeben.

3.5 Die Gesellschaft kann außerdem jedweder dritten Partei Garantien oder Sicherheiten gewähren, um ihre Schuld-

verschreibungen oder die ihrer Tochtergesellschaften oder Niederlassungen oder jeder anderen Konzerngesellschaft zu
besichern.

Die Gesellschaft kann außerdem ihre Anlagevermögenswerte in Teilen oder zur Gänze verpfänden, übertragen und

hypothekarisch oder anderweitig belasten.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
4.2  Durch  Beschluss  des  Alleinigen  Gesellschafterin  bzw.  der  Gesellschafter,  gefasst  nach  dem  Modus,  wie  er  für

Satzungsänderungen vorgesehen ist, kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der  Sitz  der  Gesellschaft  kann  innerhalb  der  Gemeinde  durch  Beschluss  des  Alleinigen  Geschäftsführers  (gérant)

verlegt werden, wenn nur ein Geschäftsführer ernannt ist, oder, wenn mehrere Geschäftsführer ernannt sind, durch
Beschluss des Geschäftsführerrats (conseil de gérance).

4.3 Sollte der Alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat befinden, dass die normale Geschäftstätigkeit am

Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außerge-
wöhnliche  Ereignisse  politischer,  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Art  gefährdet  werden,  so  kann  der  Gesellschaftssitz
vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einst-
weilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen
Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Solche zeitweiligen Maßnahmen werden seitens des Alleinigen
Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats ergriffen und allen betroffenen Parteien angezeigt.

4.4 Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland unterhalten.

Art. 5. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt

von Tod, Verlust der Bürgerrechte, Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit der Alleinigen Gesellschafterin bzw. der Gesell-
schafter.

Kapital und Anteile

Art. 6. Kapital der Gesellschaft.
6.1  Das  gezeichnete  und  einbezahlte Kapital  der Gesellschaft ist auf  12.480,-EUR (zwölftausendvierhundertachtzig

Euro) festgesetzt, eingeteilt in 1.248 (eintausendzweihundertachtundvierzig) Anteile mit einem Nennwert von 10,- EUR
(zehn Euro) (zusammen „die Anteile", einzeln jeweils „der Anteil").

6.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss der Alleinigen Gesellschafterin oder der Gesell-

schafterversammlung, der in Einklang mit den Artikel 12.3 dieser Satzung sowie gemäß den Vorschriften des Gesetzes
von 1915 gefasst wurde, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Anteile an der Gesellschaft.
7.1 Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile zur Beteiligung an den Aktiva und

an den Gewinnen der Gesellschaft.

7.2 Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft, die nur einen Inhaber pro Anteil anerkennt, unteilbar.
7.3 Die Gesellschaft kann, im Rahmen der Beschränkungen durch das Gesetz von 1915, eigene Anteile erwerben. Die

Gesellschaft wird in keiner Weise, direkt oder indirekt, mittels Darlehen, Garantie, Stellung von Sicherheiten oder an-
derweitig,  einer  dritten  Partei  finanzielle  Unterstützung  gewähren,  um  es  dieser  zu  ermöglichen,  tatsächlich  oder
vermeintlich Anteile an der Gesellschaft zu erwerben, jedoch soll keine der Bestimmungen dieser Satzung Geschäftsab-
schlüssen entgegenstehen, die im Einklang mit dem Gesetz von 1915 sind.

7.4 Die Alleinige Gesellschafterin bzw. die Gesellschafter können beschließen, verschiedene Klassen von Anteilen zu

schaffen, die als Stammanteile und Vorzugsanteile bezeichnet werden. Die Stamm- oder Vorzugsanteile können in Einklang
mit den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Bestimmungen der vorliegenden Satzung jeweils mit oder ohne Emissi-
onsagio ausgegeben werden. Unbeschadet der gesetzlichen Vorschriften, werden die verschiedenen Klassen mit den in
dieser Satzung festgelegten Rechten ausgestattet, und jede neue Klasse von Anteilen, die gegebenenfalls von Zeit zu Zeit
ausgegeben werden wird, wird mit solchen Rechten ausgestattet sein, wie sie dieser durch die Gesellschafterversammlung,
die die Ausgabe solcher neuer Anteile beschließt, zuerkannt werden.

7.5 Jegliches Emissionsagio, das über den Nominalwert der Anteile hinaus gezahlt wird, soll in eine Emissionsagio-

Reserve  fließen,  die  der  Gesellschafterversammlung  oder  der  Alleinigen  Anteilseignerin  zur  freien  Verfügung  steht.
Jegliches verfügbare Emissionsagio ist verteilbar.

30200

Art. 8. Übertragung von Anteilen.
8.1 Die Anteile sind zwischen den jeweiligen Gesellschafter frei übertragbar.
8.2 Anteile dürfen inter vivos nicht an Nicht-Anteilseigner übertragen werden, es sei denn, Gesellschafter, die min-

destens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals vertreten, beschließen dies anlässlich einer Gesellschaf-
terversammlung, wie nach dem Gesetz von 1915 vorgesehen.

8.3 Im Falle des Vorhandenseins von mehreren Gesellschaftern, dürfen Anteile im Todesfalle nicht an Nicht-Anteils-

eigner übertragen werden, auch nicht an Ehegatten oder Erben, wenn diese einen rechtlichen Pflichtanspruch auf einen
Anteil an den Gütern des verstorbenen Gesellschafters (héritiers réservataires) innehaben, es sei denn, dass Gesellschaf-
ter, die mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals der überlebenden Gesellschafter vertreten,
diese Übertragung gutheißen. In einem solchen Falle greifen die anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes von 1915.

8.4 Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßige Nachfolger oder Erben eines jeden Gesellschafters sind unter keinen Um-

ständen  berechtigt,  die  Sperrung  oder  Pfändung  des  Anlagevermögens  und  die  Versiegelung  der  Dokumente  der
Gesellschaft zu verlangen oder in irgendeiner Weise in die Verwaltung der Gesellschaft einzugreifen. Zur Ausübung ihrer
Rechte werden diese auf die Rechnungslegungen sowie die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bzw. der Alleinigen
Gesellschafterin verwiesen.

8.5 Sämtliche Anteilsübertragungen müssen notariell oder mittels privatschriftlichen Dokuments niedergelegt werden.
8.6 Anteilsübertragungen sind gegenüber der Gesellschaft oder Dritten erst dann gültig, wenn diese der Gesellschaft

angezeigt oder von dieser anerkannt wurden, gemäß den Bestimmungen des Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches.

Geschäftsführung

Art. 9. Geschäftsführerrat.
9.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführerrat geführt, die nicht Gesellschafter zu sein brau-

chen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so bilden diese gemeinsam den Geschäftsführerrat (conseil de gérance). Wo
anwendbar, beziehen sich alle Verweise auf den oder die Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat auch auf den
Alleinigen Geschäftsführer (gérant unique). Der Geschäftsführerrat wählt einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.

Der erste Vorsitzende kann von der ersten Gesellschafterversammlung ernannt werden. Ist es dem Vorsitzenden nicht

möglich, an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilzunehmen, wird er von einem der anwesenden Geschäftsführer, der
zu diesem Zwecke von den anwesenden Geschäftsführern gewählt wird, vertreten.

Ist keine Dauer des Mandats festgelegt, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt: Die Geschäftsführer

können ad nutum (ohne Angabe von Gründen und ohne Entschädigung) jederzeit abberufen oder ersetzt werden.

9.2 Die Geschäftsführer werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung, die die Dauer

ihres Mandats und ihre Befugnisse bestimmt, ernannt.

Im Falle der Freistellung eines Geschäftsführers vor Ende der Mandatslaufzeit, erfüllt ein Geschäftsführer, der zu diesem

Zwecke von der Gesellschafterversammlung oder der Alleinigen Gesellschafterin ernannt wird, dieses Mandat für die
restliche Laufzeit des Mandats des ersetzten Geschäftsführers.

Wird ein Geschäftsführer nach Maßgabe dieser Satzungsartikel aus dem Geschäftsführerrat abberufen, können die

Gesellschafterversammlung oder die Alleinige Gesellschafterin dieses Amt anlässlich der Versammlung, bei der die Ab-
berufung erfolgt, neu besetzen. Erfolgt eine solche Wahl oder Ernennung nicht, kann der Geschäftsführerrat einen neuen
Geschäftsführer benennen (kooptieren), der anlässlich der nächsten Gesellschafterversammlung oder durch die Alleinige
Anteilseignerin bestätigt werden muss.

9.3 Der Geschäftsführerrat kann Teile seiner Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere

Ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Der Geschäftsführerrat legt die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevoll-
mächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen
fest.

9.3 Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft verpflichtet durch Einzelunterschrift ihres Alleinigen Geschäftsführers

und im Falle von mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Geschäftsführern. Diese
Geschäftsführer haben umfassende Vollmacht, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle
Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, vorausgesetzt, dass die
Bestimmungen dieser Satzung erfüllt werden.

Der Geschäftsführerrat ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder

durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung oder der Alleinigen Gesellschafterin vorbehalten sind.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift einer oder mehrerer

Personen,  an  die  eine  solche  Unterschriftsvollmacht  seitens  des  Geschäftsführerrates  übertragen  wurde,  und  die  im
Rahmen dieser Bevollmächtigung handeln.

9.5 Ein Geschäftsführer übernimmt in Bezug auf sein Mandat keinerlei persönliche Haftung hinsichtlich Verbindlich-

keiten,  die  er  regelmäßig  im  Namen  der  Gesellschaft  eingeht;  als  Beauftragter  ist  er  lediglich  verantwortlich  für  die
Ausführung seines Mandats.

30201

Art. 10. Sitzungen des Geschäftsführerrats.
10.1 Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann vom Vorsitzenden sowie von jedem Geschäftsführer einzeln einbe-

rufen werden.

Der Geschäftsführerrat kann nur wirksam handeln und Beschlüsse fassen, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer

anwesend oder durch Vollmacht vertreten ist.

10.2  Die  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  werden  mit  der  einfachen  Mehrheit  der  abgegebenen  Stimmen  der

anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

10.3 Hinsichtlich der Berechnung von Beschlussfähigkeit und Mehrheit, kann jeder Geschäftsführer an einer Geschäfts-

führersitzung auch per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilneh-
men,  das  es  den  an  der  Sitzung  teilnehmenden  Geschäftsführern  erlaubt,  persönlich  ausgewiesen,  effizient  und
kontinuierlich an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der auf diese Weise an einer
Sitzung des Geschäftsführerrates teilnimmt, gilt als persönlich erschienen; Eine solche über Telekommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.

10.4 Die Geschäftsführer können ihre Stimmabgabe hinsichtlich der Punkte der Tagesordnung per Brief, E-Mail, Telex,

Telefax oder mittels jedweden anderen elektronischen Kommunikationsmittels ausüben; diese Form der Stimmabgabe
bedarf der nachträglichen schriftlichen Bestätigung per eingeschriebenen Brief.

10.5 Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern bestätigt und unterzeichnet werden, haben die gleiche

Wirkung wie anlässlich einer Sitzung des Geschäftführerrats gefasste Beschlüsse. In solchen Fällen sollen Beschlüsse oder
Entscheidungen in einem oder mehreren Dokumenten ausdrücklich, entweder schriftlich oder im Umlaufverfahren, über-
mittelt per Post, E-Mail, Faksimile oder mittels anderer elektronischer Kommunikationsmittel, gefasst werden.

10.6 Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse schriftlich per Brief, per Telegram, Telefax oder E-Mail an einen

anderen Geschäftsführer delegieren. Ein Geschäftsführer kann nur jeweils einen anderen Geschäftsführer anlässlich einer
Geschäftsführerratssitzung vertreten.

Gesellschafter

Art. 11. Gesellschafterversammlungen.
11.1  Solange  die  Gesellschaft  einen  einzelnen  Gesellschafter  hat,  übt  dieser  die  Befugnisse  der  Gesellschafterver-

sammlung gemäß dem Gesetz von 1915 aus.

11.2 Gesellschafterversammlungen werden einberufen, indem jedem der Gesellschafter mindestens acht (8) Tage im

Voraus eine entsprechende Benachrichtigung an dessen im Gesellschafterverzeichnis hinterlegte Adresse zugeht. Ist das
gesamte Gesellschaftskapital bei einer Versammlung vertreten, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufungsbe-
nachrichtigung abgehalten werden.

11.3 Eine Körperschaft, die Gesellschafterin ist, muss schriftlich eine Person benennen, die sie anlässlich einer Gesell-

schafterversammlung vertritt, und jede auf diese Weise bevollmächtigte Person übt im Auftrage der Körperschaft die
gleichen Befugnisse aus, die diese Körperschaft ausüben könnte, wäre sie ein Individualgesellschafter. Diese Gesellschaf-
terin gilt bei jeder Gesellschafterversammlung als anwesend, an der der von ihr bevollmächtigte Vertreter teilnimmt.

11.4 Hinsichtlich der Berechnung von Beschlussfähigkeit und Mehrheit, kann jeder Gesellschafter an einer Gesell-

schafterversammlung  per  Telefon-  oder  Videokonferenz  oder  durch  jedes  andere  ähnliche  Kommunikationsmittel
teilnehmen, das es den an der Sitzung teilnehmenden Gesellschaftern erlaubt, persönlich ausgewiesen, effizient und kon-
tinuierlich an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Gesellschafter, der auf diese Weise an einer Sitzung
der Gesellschafterversammlung teilnimmt, gilt als persönlich erschienen, vorausgesetzt dass wenigstens ein Gesellschafter
oder dessen Vertreter physisch am Sitz der Gesellschaft anwesend ist. Eine solche über Telekommunikationsmittel ab-
gehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.

11.5 Wenn und solange die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter hat, wird die jährliche Gesellschafterversammlung

am dritten Freitag des Monats Mai eines jeden Jahres, abgehalten. Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag in Luxemburg
ist, findet die Gesellschafterversammlung am nächsten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 12. Beschlüsse der Gesellschafter.
12.1 Jeder Gesellschafter ist anlässlich von gemeinsamen Beschlussfassungen stimmberechtigt und hat so viele Stimmen,

wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsgültig vertreten lassen.

12.2 Beschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich (nach gesetzlicher Maßgabe) oder anlässlich von Gesellschafter-

versammlungen hinsichtlich ihrer Form und durch Mehrheit(en) derart gefasst, wie vom Gesetz von 1915 vorgesehen.
Jede regulär konstituierte Gesellschafterversammlung oder jeder gültige Beschluss repräsentiert sämtliche Gesellschafter.

12.3 Jedwede Entscheidung, die die Befugnisse des Geschäftsführerrates übersteigt, wird durch die Alleinige Gesell-

schafterin oder die Gesellschafter getroffen. Beschlüsse sind dann gültig gefasst, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr
als die Hälfte der Anteile an der Gesellschaft repräsentieren, getroffen werden.

Beschlüsse zur Abänderung der Gesellschaftssatzung können nur von einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens

fünfundsiebzig Prozent (75%) aller Anteile der Gesellschaft repräsentiert, gefasst werden.

30202

Wird diese Mehrheit bei einer ersten Versammlung nicht erreicht, wird die Gesellschafterversammlung per Einschrei-

ben ein zweites Mal einberufen. Die Beschlüsse werden sodann mit einfacher Mehrheit gefasst, unabhängig davon, ob die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch die Mehrheit der Anteile repräsentiert.

12.4 Im Falle schriftlicher Beschlussfassung, wird der Wortlaut dieser Beschlüsse mindestens acht (8) Tage vor dem

vorgesehenen Inkrafttreten der Beschlüsse an die im Gesellschafterverzeichnis am Sitz der Gesellschaft hinterlegten Ad-
ressen der Gesellschafter gesandt. Die Beschlüsse treten mit Zustimmung durch die gesetzlich vorgeschriebene Mehrheit
für solche gemeinsamen Beschlussfassungen (oder gemäß der Erfüllung der Erfordernisse hinsichtlich der Mehrheitsver-
hältnisse, an dem darin benannten Datum) in Kraft.

Einstimmig schriftlich gefasste Beschlüsse können jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung gefasst werden.

Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 13. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 14. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres stellt der Geschäftsführerrat eine Bestandsaufnahme, die einen Befund

der Anlagevermögenswerte sowie der Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhaltet, sowie die Bilanz nebst Gewinn- und
Verlustrechnung, in der die notwendigen Abschreibungen gemäß der Buchhaltungspraxis der Gesellschaft vermerkt sein
müssen, zusammen.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Ver-

lustrechnung nehmen.

Art. 16. Gewinnverteilung.
16.1 Jedes Jahr sind in Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen aus dem Nettogewinn der Gesellschaft mindestens

fünf Prozent (5 %) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen. Diese Einbringung entfällt, sobald die gesetzliche
Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht, wird aber erneut verpflich-
tend,  sobald,  wann  und  aus  welchem  Grunde  auch  immer,  die  gesetzliche  Rücklage  unter  zehn  Prozent  (10%)  des
Gesellschaftskapitals sinktt.

16.2 Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft aus-

geschüttet werden. Die Alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafter können jedoch per Mehrheitsbeschluss gemäß
den gesetzlichen Bestimmungen entscheiden, dass der Nettogewinn, nach Abzug der gesetzlichen Rücklage, entweder auf
das nächste Geschäftsjahr vorgetragen oder in eine frei verfügbare außerordentliche Reserve übertragen wird.

16.3 Die Alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafter können auf Anraten des Geschäftsführerrats beschließen,

unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben eine Zwischendividende auszuschütten. Eine solche Entscheidung darf nur
auf Basis einer Zwischenbilanz (Bilanzbogen und Gewinn- und Verlustrechnung), die belegt, dass die Gesellschaft über
ausreichend verteilbare Reserven verfügt, um die Ausschüttung zu finanzieren, erfolgen.

Insoweit das luxemburgische Recht vorsieht, dass die Geschäftsführung über die Ausschüttung von Zwischendividen-

den befinden kann, wird der Geschäftsführerrat mittels dieser Satzung bevollmächtigt, unter Maßgabe der anwendbaren
gesetzlichen Vorschriften solche Ausschüttungen zu beschließen.

16.4 Der Betrag, der als Zwischendividende ausgeschüttet wird, darf den Betrag des Nettogewinns seit Ende desjenigen

Geschäftsjahres, das der Ausschüttung unmittelbar vorausging (vorausgesetzt, dass der Bilanzabschluss dieses betreffen-
den Jahres genehmigt wurde), zuzüglich vorgetragener Gewinne und Beträge, bezogen aus verfügbaren Reserven, und
abzüglich vorgetragener Verluste und Beträge, die gesetzlichen Rücklage zuzuführen sind, nicht überschreiten.

16.5 Das Guthaben auf dem Emissionsagio-Konto kann an die Alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafter gemäß

Beschluss der Gesellschafterversammlung oder der Alleinigen Gesellschafterin ausgeschüttet werden. Per Beschluss der
Gesellschafterhauptversammlung oder durch schriftlichen Beschluss der Alleinigen Gesellschafterin kann jedweder Anteil
des Guthabens auf dem Emissionsagio-Konto der gesetzlichen Reserve zugeführt werden.

Art. 17. Auflösung-Abwicklung.
17.1 Tod, Verlust der Bürgerrechte, Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit der Alleinigen Gesellschafterin oder der Ge-

sellschafter bedingen nicht die Auflösung der Gesellschaft.

17.2 Mit Ausnahme einer gerichtlich angeordneten Auflösung, kann die Gesellschaft nur durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung aufgelöst werden, wobei hierzu dieselbe Mehrheit der Stimmen notwendig ist, wie sie für eine
Abänderung dieser Gesellschaftssatzung erforderlich ist

17.3 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren durchge-

führt, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Die Liquidatoren werden durch die Gesellschafterversammlung unter
Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt. Insoweit nicht anders beschlossen, erhalten die Liquidatoren die
weitestgehenden Befugnisse, das Anlagevermögen zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu begleichen.
Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft, wird das übrige Anlagevermögen an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer
Beteiligung an der Gesellschaft zugemessen.

Art. 18. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und insbesondere die des Gesetzes von 1915 finden ihre Anwendung

überall dort, wo die gegenwärtige Satzung keine besondere Regelung oder Abweichung beinhaltet.

30203

<i>Übergangsbestimmungen

In Ausnahme zu Artikel 13 dieser Satzung, beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember

2010.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle 1.248 (eintausendzweihundertachtundvierzig) Anteile, darstellend das gesamte Gesellschaftskapital wurden wie

folgt gezeichnet:

Zeichner

Anzahl von

Anteilen

gezeichneter

Betrag

prozentualer

Anteil am

Gesellschaftkapital

1. UNITPOOL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.248

12.480,- EUR

100%

Alle gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die Summe von 12.480,- EUR (zwölftausend-

vierhundertachtzig  Euro)  ab  sofort  der  Gesellschaft  zur  Verfügung  steht;  ein  entsprechender  Nachweis  wurde  dem
unterzeichneten Notar gegenüber, der dies ausdrücklich bezeugt, erbracht.

<i>Bestätigung

Die Gesellschaft und ihre Satzung erfüllen nach Form und Inhalt die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen hin-

sichtlich der Handelsgesellschaften, insbesondere jene bezüglich der Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Gemäß den derzeit im Großherzogtum Luxemburg gültigen rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften und in Über-

einstimmung mit dem vertragsrechtlichen Prinzip, dass Verträge, die vor einem Notar geschlossen werden, unmittelbar
in Kraft treten, existiert die besagte Gesellschaft und erlangt ihre Rechtspersönlichkeit mit dem Datum der Unterzeich-
nung  dieses  notariellen  Gründungsaktes  als  Körperschaft  und  juristische  Person,  in  Abgrenzung  von  ihrer  Alleinigen
Gesellschafterin oder ihren Gesellschaftern, und zwar vor Erfüllung sämtlicher Registrierungs- und Veröffentlichungsfor-
malitäten bei dem Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburgs und dem Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations. Mithin ist die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung als Gesellschaft luxemburgischen rechtswirksam gegrün-
det.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-).

<i>Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin

Unmittelbar im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft, hat die oben genannte Alleinige Gesellschafterin, die das

gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, und die sich für rechtmäßig einberufen erklärt, alsdann folgende
Beschlüsse gefasst:

1. Als Sitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt 4, Rue Henri Schnadt L-2530 LUXEMBOURG
2. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festegesetzt, und zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden

folgende Personen auf unbestimmte Zeit ernannt:

1. David Harman, "Chief Executive Officer", mit Berufsanschrift in Steinackerstr. 2 CH-8302 Kloten, Schweiz,
2. Andreas Ernst, "Chief Financial Officer", mit Berufsanschrift in Steinackerstr. 2 CH-8302 Kloten, Schweiz,.
3. Maria Cordoba Arranz, "Commercial Director", mit Berufsanschrift in Steinackerstr. 2 CH-8302 Kloten, Switzerland.
Da keine weiteren Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung zu fassen waren, wurde diese daraufhin beendet.

<i>Erklärung

Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten

Datum unter diese Urkunde setzen.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der der erschie-

nenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass
im Falle einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der englische Text maßgebend ist.

Nach Vorlesen und Übersetzung alles Vorstehenden in deren Sprache, haben die Bevollmächtigten der Erschienenen

mit Uns, dem unterzeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: Q. Hubeau et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 février 2010. LAC/2010/7592. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30204

Luxembourg, le 22 février 2010.

Référence de publication: 2010029204/598.
(100026847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2010.

A.P. LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 37.485.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010028492/12.
(100025251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Cellon, Société Anonyme.

Siège social: L-7213 Bereldange, 29, Am Becheler.

R.C.S. Luxembourg B 25.789.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010028494/12.
(100025282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

C2NT Import Export S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 109.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010028520/10.
(100025204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Citynet Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 119.659.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010028522/10.
(100025203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Sword Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.238.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010028889/10.
(100025695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

30205

Eaton Holding IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 127.110.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.02.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010028890/10.
(100025883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Eaton Holding X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 137.019.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.02.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010028891/10.
(100025885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Eaton Holding VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 137.020.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.02.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010028892/10.
(100025895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Company Invest Meat Industry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 133.778.

Je soussigné, Philippe LEROY, représentant de la S.A. ABROAD Consulting, inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés sous le numéro B 107.654, démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes et d'administrateur avec
effet immédiat, dans la société Company Invest Meat Industry S.A, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 133 778.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Février 2010.

Philippe Leroy.

Référence de publication: 2010028840/13.
(100025625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Immobilière Reiserbann S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3396 Roeser, 10A, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 100.236.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN Sàrl
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature

Référence de publication: 2010028901/13.
(100025996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

30206

Eaton Holding IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 137.021.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.02.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010028893/10.
(100025898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Moeller Electric S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 9.145.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.02.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010028894/10.
(100025900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Graphite et Métaux S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.013.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2010.

Fernand CHOLHOT.

Référence de publication: 2010028895/10.
(100025902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Triul S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 96.678.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010028927/10.
(100025590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Whitehall French RE 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.785.783,96.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 138.807.

Constituée par-devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 avril 2008, acte publié au

Mémorial C no 1484 du 16 Juin 2008.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Whitehall French RE 11 S.à r.l.
Christophe Cahuzac
<i>Manager

Référence de publication: 2010028925/15.
(100025596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

30207

Whitehall French RE 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.785.783,96.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 138.796.

Constituée par-devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 avril 2008, acte publié au

Mémorial C no 1493 du 20 mai 2008.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Whitehall French RE 10 S.à r.l.
Christophe Cahuzac
<i>Manager

Référence de publication: 2010028926/15.
(100025593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 138.894.

Constituée par-devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai 2008, acte publié au

Mémorial C no 1520 du 19 Juin 2008.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l.
Christophe Cahuzac
<i>Manager

Référence de publication: 2010028930/14.
(100025611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Scandinavian Company Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 615, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 36.201.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010028932/10.
(100025699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

ColMolitor (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 130.451.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession sous seing privé intervenu en date du 30 septembre 2009, que la société Colony

Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.540, a cédé toutes
les parts sociales qu'elle détenait dans ColMolitor (Lux) S.à r.l. ("la Société") à:

Sisters Soparfi S.A., société anonyme ayant son siège social à 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, imma-

triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.387.

Suite à ce transfert, dûment accepté par la Société, les 504 parts sociales composant le capital social de la Société sont

détenues par Sisters Soparfi S.A.

Pour extrait conformedélivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30208

<i>Pour la Société
Signature
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2010028855/21.
(100026062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Jero S.A., Société Anonyme,

(anc. HEBB S.A.).

Siège social: L-4735 Pétange, 21, rue J.-B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 113.749.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010028884/11.
(100025764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Pierjet Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 104.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PIERJET INVESTMENTS S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010028864/12.
(100025966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Newtec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.152.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010028928/10.
(100025588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Fernbach Financial Software S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 385.200,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 70.830.

<i>Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2009

Am Donnerstag, den 17. Dezember 2009, sind die Aktionäre der FERNBACH FINANCIAL SOFTWARE S.A. in ihrem

Hauptsitz zur ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Bestimmungen ge-
troffen:

Dem Rücktritt des Mitglieds des Verwaltungsrats zum 17.12.2009, Herrn Stefan WEBER, Kirchweg 8, D-54308 Langsur,

wurde zugestimmt.

Herr Jean-Claude REYMOND, CFO, geboren am 09/07/1960 in Les Bayards, wohnhaft in Chalet Namaste, Les Es-

sertex-dessus, 1653 Crésuz, Schweiz, wird ab dem 18.12.2009 und für ein Jahr, an der Stelle von Herrn Stefan WEBER
zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

30209

Die Ernennung erfolgt mit sofortiger Wirkung.

Luxemburg, den 18. Februar 2010.

Unterschrift.

Référence de publication: 2010028193/19.
(100025287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Chripas, Société Anonyme.

Capital social: EUR 8.000.000,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 147.485.

In the year two thousand and ten, on the twelfth day of February.
Before, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), is held an extraordi-

nary general meeting (the Meeting) of the shareholders of CHRIPAS (the Company), a public limited liability company
(société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 147485, incorporated on July 14 

th

 , 2009 pursuant to a deed of the undersigned notary, published

in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 1652 of 27 August 2009. The articles of association of the
Company have not been amended since then.

The Meeting is chaired by Mr Eric LECLERC, employee, residing professionally in Luxembourg (the Chairman). The

Chairman appoints Mr Jos HEMMER, employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the
Secretary).

The Meeting elects Mrs Martine KAPP, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting

(the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau
of the Meeting.

The shareholders, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list

which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the shareholders and
the members of the Bureau.

The proxy from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes

and signed by the members of the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entire share

capital of the Company is duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items of its agenda hereafter reproduced.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Conversion of the existing one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euros (EUR 31.-) each into

thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-), so that the existing capital of thirty-one
thousand Euros (EUR 31,000) is represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one Euro (EUR
1.-).

2. Classification of the existing thirty-one thousand (31,000) shares, standard shares with voting right, to the shares'

category which will be designated as "Category A Shares".

3. Creation of a new shares' category to be known as "Category B Shares", shares that do not grant a voting right, but

giving right to a privileged dividend.

4. Share capital increase by a sum of seven million nine hundred sixty-nine thousand Euros (EUR 7,969,000) to bring

it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) to eight million Euros (EUR 8,000,000) by the
creation and issue of seven million nine hundred sixty-nine thousand (7,969,000) new shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1.-).

5. Subscription and payment by the current shareholders of the Company of the new shares in return for payment in

cash.

6. Subsequent modification of Article 5 of the statutes to bring it into alignment with the previous points.
7. Subsequent modification of Article 17 of the statutes to bring it into alignment with the previous points.
8. Subsequent modification of Article 19 of the statutes to bring it into alignment with the previous points.
9. Termination of the mandate of Mrs Martine KAPP as Category A Director ad appointment of new Category A

Directors

10. Miscellaneous
III. The Meeting has unanimously taken the following resolutions:

30210

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the  shareholders  represented  at  the  Meeting  considering  themselves  as  duly  convened  and  declaring  having  perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to convert the existing one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euros (EUR

31.-) each into thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-), so that the existing capital of
thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) is represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one
Euro (EUR 1.-), and resolves to exchange the existing one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euros
(EUR 31.-) each against thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to classify the thirty-one thousand (31,000) shares, ordinary shares with voting right, in a share

category which will be known as "Category A Shares".

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to create a new category of shares, to be known as "Category B Shares", shares that do not

grant a voting right, but granting the right to a privileged dividend. The "Category B shares" shall receive each year a
special dividend equal to three cent (EUR 0.03) per share. In case there are not enough results available for distribution,
the unpaid part of this dividend shall be accrued and paid as and when sufficient results are available. Both the "category
A shares" and the "Category B Shares" shall be equally entitled to any dividend, which the shareholders decide to pay out
of the distributable results remaining after payment of the above special dividend to the "Category B Shares".

The "Category A Shares" can be exchanged into "Category B Shares", and vice versa, with the restriction, that the

number of "Category B Shares" may at no time exceed the number of "Category A Shares".

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to increase the Company's share capital by a sum of seven million nine hundred sixty-nine

thousand Euros (EUR 7,969,000) to bring it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) to eight
million Euros (EUR 8,000,000) by the creation and issue of seven million nine hundred sixty-nine thousand (7,969,000)
new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), the total to be paid via contribution in cash.

The Meeting decides to permit the subscription to the new shares by the current shareholders as follows:
a) GADACO, a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the

Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 129811,

represented here by Eric LECLERC, private employee, with professional address at L-1734 Luxembourg, 2, Rue Carlo

Hemmer,

by way of proxy under private seal issued on February, 9 

th

 , 2010,

for five million nine hundred and eighty four thousand five hundred (5,984,500) new shares.
b) Carl Magnus EHRNROOTH, private investor, born in Helsinki on 26 November 1955, residing in 24, Guestrasse,

CH-8700 Kuesnacht ZH,

represented here by Eric LECLERC, private employee, with professional address at L-1734 Luxembourg, 2, Rue Carlo

Hemmer,

by way of proxy under private seal issued on February, 3 

rd

 , 2010,

for nine hundred ninety-two thousand two hundred and fifty (992,250) new shares.
c) Peter ERIKSSON, company director, born in Helsinki on 29 July 1966, residing in 14, rue d'Oradour, L-2266 Lu-

xembourg,

represented here by Eric LECLERC, private employee, with professional address at L-1734 Luxembourg, 2, Rue Carlo

Hemmer,

by way of proxy under private seal issued on February 11 

th

 , 2010,

for nine hundred ninety-two thousand two hundred and fifty (992,250) new shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The subscribers, represented as stated above, by way of proxies, under private seal as described above, which after

being signed "ne varietur" by the bureau members, the undersigned notary and the parties and / or their representatives,
will remain attached to the present document for submission together with it to the registration formalities,

declare and acknowledge that each of the shares purchased have also been paid by contribution in cash, and is forthwith

at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking

30211

certificate confirming the availability of the subscription amount on the Company's bank account and the notary expressly
acknowledges the availability.

As such, the Meeting decides to accept the contribution in cash by the subscribers,
and to pay, in return for this contribution in cash, three million nine hundred sixty-nine thousand (3,969,000) new

Category A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), fully subscribed and paid, for a total subscription price of
three million nine hundred sixty-nine thousand Euros (EUR 3,969,000),

and four million (4,000,000) new Category B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), fully subscribed and

paid, for a total subscription price of four million Euros (EUR 4,000,000),

shares which will be distributed as follows:
- GADACO: one million nine hundred eighty-four thousand five hundred (1,984,500) new Category A shares, and four

million (4,000,000) new Category B shares

- Carl Magnus EHRNROOTH: nine hundred ninety-two thousand two hundred and fifty (992,250) new Category A

shares

- Peter ERIKSSON: nine hundred ninety-two thousand two hundred and fifty (992,250) new Category A shares

<i>Sixth resolution

As a result of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend article 5 of the Articles, which will henceforth

read as follows:

"The subscribed capital of the company is fixed at EIGHT MILLION EURO (EUR 8,000,000) divided into four million

(4,000,000) Category A shares, ordinary shares with a voting right, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), and four
million (4,000,000) Category B shares, shares without a voting right, but granting the right to a special dividend each year,
equal to three cent (EUR 0.03) per share.

The "Category A Shares" can be exchanged into "Category B Shares", and vice versa, with the restriction, that the

number of "Category B Shares" may at no time exceed the number of "Category A Shares".

The  shares  may  be  registered  or  bearer  shares,  at  the  option  of  the  holder,  except  those  shares  for  which  Law

prescribes the registered form.

The company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares."

<i>Seventh resolution

As a result of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend article 17 of the Articles, which will henceforth

read as follows:

"Each Category A Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered

null and void.

The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the company.

In case one Category A Share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the

usufructuary."

<i>Eighth resolution

As a result of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend article 19 of the Articles, which will henceforth

read as follows:

"At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The "Category B shares" shall receive each year a special dividend to three cent (EUR 0.03) per share. In case there

are not enough results available for distribution, the unpaid part of this dividend shall be accrued and paid as and when
sufficient results are available. Both the "category A shares" and the "Category B Shares" shall be equally entitled to any
dividend, which the shareholders decide to pay out of the distributable results remaining after payment of the above
special dividend to the "Category B Shares".

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.".

<i>Nineth resolution

The Meeting resolves to accept the resignation of Martine KAPP as director of Category A and gives to full discharge

to her for the exercise of his mandate until today.

30212

The Meeting resolves to elect the following persons as directors of Category A, their mandate expiring at the general

meeting which will be held in the year 2015:

- Mr Paul EHRNROOTH, company director, born in Helsinki, on the 5 

th

 August 1965, residing in Seestantie 278,

FI-15460 Mâkelä

- Mr Peter ERIKSSON, company director, born in Helsinki, on the 29 July 1966, residing in 14, rue d'Oradour, L-2266

Luxembourg,

- Mr Carl Magnus EHRNROOTH, private investor, born in Helsinki on the 26th November 1955, residing in 24,

Guestrasse, CH-8700 Kuesnacht ZH.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed, is estimated to be approximately four thousand six hundred Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, and the members of the board, they signed

together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le douze février.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg, a été tenue une assemblée générale extraordinaire

(l'Assemblée) des actionnaires de CHRIPAS (la Société), une société anonyme, immatriculée et existant sous les lois du
Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Carlo Hemmer, à L-1734 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147485, constituée le 14 juillet 2009 suite
à un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 1652 du 27 août 2009.
Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par M. Eric LECLERC, employé, résidant professionnellement à Luxembourg (le Président).

Le président désigne M. Jos HEMMER, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de
l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée désigne Mme Martine KAPP, employée, résidant professionnellement à Luxembourg en tant que scruta-

teur  de  l'Assemblée  (le  Scrutateur).  Le  Président,  le  Secrétaire  et  le  Scrutateur  constituent  ensemble  le  Bureau  de
l'Assemblée.

Les actionnaires représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présences

qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le mandataire des Actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des Actionnaires représenté à la présente assemblée, resteront annexées aux présentes après avoir

été signées par le mandataire des Actionnaires et les membres du Bureau.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Il résulte de la liste des présences établie et certifiée par les membres du Bureau que le capital entier de la société

est représenté à l'Assemblée et en conséquence est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour reproduit
ci-après.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Conversion des mille (1.000) actions existantes avec une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune

en trente et un mille (31.000) actions avec une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), de façon à ce que le capital actuel
de trente et un mille euros (EUR 31.000) est représenté par trente et un mille (31.000) actions avec une valeur nominale
de un euro (EUR1,-).

2. Classification des trente et un mille (31.000) actions existantes, actions ordinaires avec droit de vote, en classe

d'actions qui sera désignée "Actions de Catégorie A".

3. Création d'une nouvelle classe d'actions qui sera désignée "Actions de Catégorie B", actions sans droit de vote

donnant droit à un dividende privilégié.

4. Augmentation du capital social d'un montant de sept millions neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 7.969.000)

afin de le porter de son montant actuel trente et un mille euros (EUR 31.000) à huit millions d'euros (EUR 8.000.000)
par la création et l'émission de sept millions neuf cent soixante-neuf mille (7.969.000) actions nouvelles avec une valeur
nominale de un euro (EUR 1,-).

5. Souscription et libération par les Actionnaires actuels de la Société des nouvelles Actions moyennant un apport en

numéraire.

6. Modification subséquente de l'Article 5 des statuts de la Société, afin de le mettre en concordance avec les points

précédents.

30213

7. Modification de l'Article 17 des statuts de la Société, afin de le mettre en concordance avec les points précédents.
8. Modification de l'Article 19 des statuts de la Société, afin de le mettre en concordance avec les points précédents.
9. Fin du mandat de Madame Martine KAPP en tant qu'administrateur de catégorie A et nomination de nouveaux

administrateurs de catégorie A

10. Divers
III. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités

de convocation, les actionnaires représentés s'estimant dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de convertir les mille (1.000) actions existantes avec une valeur nominale de trente et un euros

(EUR 31,-) chacune en trente et un mille (31.000) actions avec une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), de façon à ce
que le capital actuel de un trente et un mille euros (EUR 31.000) est représenté par trente et un mille (31.000) actions
avec une valeur nominale de un euro (EUR1,-) et décide d'échanger les mille (1.000) actions existantes avec une valeur
nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune contre trente et un mille (31.000) actions avec une valeur nominale
de un euro (EUR1,-).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de classifier les trente et une mille (31.000) actions existantes, actions ordinaires avec droit de

vote, en une classe d'actions qui sera désignée "Actions de Catégorie A".

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de créer une nouvelle classe d'actions qui sera désignée "Actions de Catégorie B", actions sans

droit de vote donnant droit à un dividende privilégié. Les "Actions de Catégorie B", recevront chaque année un dividende
particulier équivalant à trois cents (EUR 0,03) par action. Au cas où il n'y a pas suffisamment de résultats disponibles, le
partie impayée de ce dividende sera attribué et payé lorsqu'il y a suffisamment de résultats disponibles.

Aussi bien les "Actions de Catégorie A" et les "Actions de Catégorie B" auront droit à un dividende quelconque, que

les actionnaires décident de payer des résultats subsistants après paiement du dividende spécial aux "Actions de Catégorie
B" prénommé.

Les "Actions de Catégorie A" peuvent être échangées contre des "Actions de Catégorie B", et vice versa, avec la

limitation que le nombre des "Actions de Catégorie B" ne peut à aucun moment dépasser le nombre des "Actions de
Catégorie A".

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept millions neuf cent soixante-neuf

mille euros (EUR 7.969.000) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) à huit
millions d'euros (EUR 8.000.000) par la création et l'émission de sept millions neuf cent soixante-neuf mille (7.969.000)
actions nouvelles avec une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), le tout moyennant apport en numéraire.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des actions nouvelles, les Actionnaires actuels comme suit:
a) GADACO, une société anonyme, immatriculée et existant sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son

siège social au 2, rue Carlo Hemmer, à L-1734 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 129811,

ici représenté par Eric LECLERC, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1734 Luxembourg, 2, Rue Carlo

Hemmer,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 février 2010,
pour cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent (5.984.500) actions nouvelles.
b) Carl Magnus EHRNROOTH, investisseur privé, né à Helsinki le 26 novembre 1955, demeurant à 24, Guestrasse,

CH-8700 Kuesnacht ZH,

ici représenté par Eric LECLERC, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1734 Luxembourg, 2, Rue Carlo

Hemmer,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 11 février 2010,
pour neuf cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante (992.250) actions nouvelles.
b) Peter ERIKSSON, directeur de société, né à Helsinki le 29 juillet 1966, demeurant à 14, rue d'Oradour, L-2266

Luxembourg,

ici représenté par Eric LECLERC, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1734 Luxembourg, 2, Rue Carlo

Hemmer,

30214

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 11 février 2010,
pour neuf cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante (992.250) actions nouvelles.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Les souscripteurs, représentés aux présentes comme dit ci-avant, en vertu des procurations sous seing privé ci-avant

énoncées, lesquelles après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau, le notaire instrumentant et les
comparants et/ou leurs mandataires, resteront annexées aux présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
d'enregistrement,

déclarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites a été intégralement libérée par un apport en numéraire,

et est par conséquent à disposition de la Société, comme en atteste le certificat de blocage émis confirmant la disponibilité
du montant de souscription sur le compte bancaire de la Société. Le notaire instrumentaire constate expressément la
disponibilité des fonds ainsi versés.

A ce titre, l'Assemblée décide d'accepter l'apport en numéraire par les souscripteurs,
et d'émettre en contrepartie de cet apport trois millions neuf cent soixante neuf mille (3.969.000) actions nouvelles

de catégorie A avec une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), entièrement souscrites et libérées, pour un prix total de
souscription et d'émission de trois millions neuf cent soixante neuf mille euros (EUR 3.969.000),

et quatre millions (4.000.000) actions nouvelles de catégorie B avec une valeur nominale de un euro (EUR 1.-), entiè-

rement souscrites et libérées, pour un prix total de souscription et d'émission de quatre millions d'euros (EUR (4.000.000),

actions qui seront réparties comme suit:
- GADACO: un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent (1.984.500) actions nouvelles de catégorie A, et

quatre millions (4.000.000) actions nouvelles de catégorie B.

- Carl Magnus EHRNROOTH: neuf cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante (992.250) actions nouvelles de

catégorie A.

- Peter ERIKSSON: neuf cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante (992.250) actions nouvelles de catégorie

A.

<i>Sixième résolution

Conformément aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société, qui

aura désormais la teneur suivante:

"Le capital social souscrit est fixé à HUIT MILLIONS D'EUROS (8.000.000,- EUR) divisé en quatre millions (4.000.000)

d'actions de catégorie A, actions ordinaires avec droit de vote, avec une valeur nominale de un euro (EURI,-) et quatre
millions (4.000.000) actions de catégorie B, actions sans droit de vote ayant droit à un dividende particulier chaque année
équivalant à trois cents (EUR 0,03) par action.

Les "Actions de Catégorie A" peuvent être échangées contre des "Actions de Catégorie B", et vice versa, avec la

limitation que le nombre des "Actions de Catégorie B" ne peut à aucun moment dépasser le nombre des "Actions de
Catégorie A".

<i>Septième résolution

Conformément aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 17 des Statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

"Chaque Action de Catégorie A donne droit à une voix à chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en

blanc est nul et non avenu.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action de catégorie A est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute

hypothèse par l'usufruitier."

<i>Huiitième résolution

Conformément aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 19 des Statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

"Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

30215

Les "Actions de Catégorie B", recevront chaque année un dividende particulier équivalant à trois cents (EUR 0,03) par

action. Au cas où il n'y a pas suffisamment de résultats disponibles, le partie impayée de ce dividende sera attribué et payé
lorsqu'il y a suffisamment de résultats disponibles.

Aussi bien les "Actions de Catégorie A" et les "Actions de Catégorie B" auront droit à un dividende quelconque, que

les actionnaires décident de payer des résultats subsistants après paiement du dividende spécial aux "Actions de Catégorie
B" prénommé.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit."

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide de d'accepter la démission de Martine KAPP en tant qu'administrateur de catégorie A et lui donne

pleine décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de catégorie A, leur mandant expirant

à l'assemblée générale laquelle sera tenue en l'année 2015:

- M. Paul EHRNROOTH, directeur de société, né à Helsinki, le 5 août 1965, demeurant à Seestantie 278, FI-15460

Mâkelä

- M. Peter ERIKSSON, directeur de société, né à Helsinki, le 29 juillet 1966, demeurant à 14, rue d'Oradour, L-2266

Luxembourg,

- M. Carl Magnus EHRNROOTH, investisseur privé, né à Helsinki le 26 novembre 1955, demeurant à 24, Guestrasse,

CH-8700 Kuesnacht ZH.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à quatre mille six cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, et aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec

le notaire l'original du présent acte.

Signé: Eric LECLERC, Jos HEMMER, Martine KAPP, Carlo WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2010. LAC/2010/7390. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

- Pour copie conforme -

Luxembourg, le 22 février 2010.

Référence de publication: 2010029331/357.
(100026660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2010.

Fiduciaire Générale GROUP, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 53.433.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale ordinaire, tenue en date du 20 janvier 2010, que:
1. L'Assemblée accepte la démission de M. Philippe Bruneton de son mandat de gérant, avec effet au 7 décembre 2009;
2. L'assemblé décide de la nomination des trois nouveaux gérants suivants, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Vincent Gouverneur, né le 6 février 1968 à Longlier, Belgique, avec adresse professionnelle au 560, rue de

Neudorf, L-2220, Luxembourg;

- Monsieur Raymond Krawczykowski, né le 18 avril 1969 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle au 560, rue

de Neudorf, L-2220, Luxembourg;

- Madame Sophie Mitchell, née le 28 mars 1969 à Meulan, France, avec adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg.

3. Le mandat du commissaire a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 mai

2010:

- La société PKF Abax Audit.

30216

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010028351/25.
(100024803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

SK Logistic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 131.715.

1. Die Gesellschaft Lux-Fiduciaire Consulting Sàrl, mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe, legt sein Mandat

als Kommissar mit sofortiger Wirkung nieder.

Zwecks Änderungen im Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 18/02/2010.

Référence de publication: 2010028212/11.
(100025184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Hungaria Baukonzepte A.G., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 97.846.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société HUNGARIA BAUKONZEPTE A.G.:
Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BO-
DONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour HUNGARIA BAUKONZEPTE A.G.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028241/18.
(100025178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Granis Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 139.186.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société GRANIS INVESTMENTS S.A.: Madame
Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour GRANIS INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028245/17.
(100025174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

30217

HAZ Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 132.645.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société HAZ HOLDING S.A.: Madame Marie
BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour HAZ HOLDING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028250/17.
(100025160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Restaurant La Belle Africaine, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 439, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 140.100.

<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire de l'associée unique du 09 janvier 2010

Il est arrêté et convenu ce qui suit:
Le cédant, madame Jeannette BILO'O MBA, propriétaire de 50 parts sociales, cède ses 50 parts sociales de la société

Restaurant La Belle Africaine Sàrl à madame Martine MBALLA, cessionnaire, qui accepte suivant les modalités du contrat
de cession de parts passé d'entre elles. Ainsi, après cette cession, les 100 parts sociales de la société Restaurant La Belle
Africaine Sàrl sont toutes détenues par madame Martine MBALLA, qui est devenue, associée unique de la société Res-
taurant La Belle Africaine Sàrl.

L'associée unique, réunie en assemblée générale extraordinaire, a pris la décision d'accepter la démission de madame

Jeannette BILO'O MBA en tant que Gérante administrative;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Pour extrait sincère et conforme
Martine MBALLA

Référence de publication: 2010028345/20.
(100024892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Hickory Participations S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 98.127.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société HICKORY PARTICIPATIONS S.A.:
Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BO-
DONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour HICKORY PARTICIPATIONS S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028251/18.
(100024992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

30218

Howald Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 149.029.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, Président du Conseil

d'administration, R.C.S. Luxembourg B 63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant
permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société
HOWALD INVEST S.A. société anonyme: Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour HOWALD INVEST S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028252/18.
(100024990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Imagine Cyber Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 144.835.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société IMAGINE CYBER GROUP S.A.:
Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BO-
DONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour IMAGINE CYBER GROUP S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028254/18.
(100024984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Immotourisme S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 89.235.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société IMMOTOURISME S.A.: Madame Marie
BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour IMMOTOURISME S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028253/17.
(100024987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

30219

IFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 136.634.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société IFF S.A.: Madame Marie BOURLOND,
180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour IFF S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028255/17.
(100024981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Conseil Comptable S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 48.015.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 15 décembre 2009, que:
1. Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels arrêtés

au 31 mai 2010:

- Monsieur Maurice Lam
- Monsieur Franz Prost, Administrateur-délégué
- Madame Marie-José Steinborn
2. Est réélu Commissaire pour la même période:
- Monsieur Pierre SCHILL.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010028349/20.
(100024819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

IBR Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 132.140.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société IBR INVEST S.A.: Madame Marie
BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour IBR INVEST S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028256/17.
(100024974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

30220

Lanchester S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 123.746.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, VALON S.A., R.C.S. Luxembourg B 63.143, 283, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour son compte au conseil d'administration de la société LANCHESTER S.A.: Madame Marie BOURLOND, 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour LANCHESTER S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010028257/17.
(100024962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Financière Hôtelière Européenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 100.048.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 11 février 2010

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de la Société, Read S.à r.l. ayant

son adresse professionnelle au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe DAVEZAC, né le

14 février 1964 à Cahors, France, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet
immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010028370/20.
(100024907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Wasaby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 130.255.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, VALON S.A., Administrateur de Classe B, R.C.S. Luxem-

bourg B 63.143, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution
de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société WASABY S.A.: Madame Marie
BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour WASABY S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010028258/17.
(100024952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

30221

BLRM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 134.668.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de classe

A, R.C.S. Luxembourg B 63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société BLRM S.A.:
Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BO-
DONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour BLRM S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010028259/18.
(100024940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Entropie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 53.389.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 28 décembre 2009 que:
- Monsieur François WINANDY,
- Madame Mireille GEHLEN,
- Monsieur Thierry JACOB,
Ont démissionné avec effet immédiat.
Et que par lettre déposée au siège social de la société en date du 28 décembre 2009,
- H.R.T. Révision S.A,
a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes au sein de la société ENTROPIE S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 février 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010028313/19.
(100024961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Frozen Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 136.588.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société FROZEN HOLDING S.A.: Madame
Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour FROZEN HOLDING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010028260/17.
(100024933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

30222

Metallum Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.635.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, VALON S.A., Administrateur de classe A, R.C.S. Luxem-

bourg B 63.143, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution
de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société METALLUM HOLDING S.A.:
Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BO-
DONI.

Luxembourg, le 17 février 2010.

<i>Pour METALLUM HOLDING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010028261/18.
(100024927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Finacor Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 33.421.

<i>Extraits des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 22 décembre 2009

<i>3 

<i>ème

<i> Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Philippe DESPRIET, demeurant au 26/

C, Wolvendreef B-8500 Kortrijk, Belgique, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Il exercera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemble

Générale Statutaire de 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour FINACOR HOLDING S.A.
FIDALUX S.A.
Signature
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2010028365/19.
(100025083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

DiPiU Property S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 98.129.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B

63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société DiPiU Property S.A.: Madame Marie
BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 16 février 2010.

<i>Pour DiPiU Property S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028265/17.
(100025316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

30223

Dominis Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 145.239.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., société anonyme, Président du Conseil

d'administration, R.C.S. Luxembourg B 63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant
permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société
DOMINIS INVEST S.A.: Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement
de Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 16 février 2010.

<i>Pour DOMINIS INVEST S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010028267/18.
(100025312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Antunite Investments S.A., Société Anonyme,

(anc. The Leading Travel Companies of the World S.A).

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 118.615.

In the year two thousand and ten, on the fourth day of February.
Before Maître Marc LECUIT, notary public residing in Mersch.

Was  held  an  Extraordinary  General  Meeting  of  shareholders  of  THE  LEADING  TRAVEL  COMPANIES  OF  THE

WORLD S.A., a public limited liability company, having its registered office in 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Company Register number B118.615, constituted by a deed of Maître Henri
HELLINCKX, notary once residing in Mersch, on July 4th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1864 of October 5th, 2006.

The articles of Incorporation have been amended for the last time by a deed of Me Joseph ELVINGER, notary residing

in Luxembourg, on August 4th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2131
of November 15th, 2006.

The meeting was opened by Mrs Isabelle KOULOURIS, private employee, professionally residing in 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being in the chair and representing all the shareholders by means of
proxies.

Was appointed scrutineer of the meeting Mrs Stéphanie STACCHINI private employee, professionally residing in 67,

rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Change of the Company's name into "ANTUNITE INVESTMENTS S.A.";
2. Removal of the classes of directors;
3. Complete recast of the Articles of Incorporation taken into account the previous resolutions;
4. Resignations and Appointments of Directors;
5. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holder of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holder of the
represented shareholders, and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

30224

<i>First resolution

It has been resolved to change the Company's name into ANTUNITE INVESTMENTS S.A. with immediate effect.

<i>Second resolution:

It has been resolved to remove the classes of directors in order that the representation of the Company is valid

towards third parties only through the individual signature of the Sole Director or through the joint signatures of any
two directors, in case of plurality of directors.

<i>Third resolution

Further to the previous resolutions, it has been resolved to completely recast the articles of Incorporation of the

Company as follows:

"Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a "Société Anonyme" under the name of "ANTUNITE INVESTMENTS S.A.".

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the

board of directors or by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the
applicable provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of

participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of  investment,  subscription,  underwriting  or  option,  securities  and  patents,  to  realize  them  by  way  of  sale,  transfer,
exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant any assistance, loans, advances and guarantees
to companies where the Company may have any kind of interest.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire

and transfer any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage and
execute any operations which pertain directly or indirectly to the ownership of real estate.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital of the Company shall be thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into

one thousand (1,000) shares of thirty-one euro (EUR 31.-) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates re-

presenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The Company may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of the

Company, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10th August
1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may
determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received
by the Company as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by
the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the Company may redeem in accordance with
these Articles of In Corporation.

Shares redeemed by the Corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the Company or in any distribution paid upon the liquidation or winding up of
the Company.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7

of article 49 of the Law of 10th August 1915 on Commercial Companies.

30225

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at

least three members (each a "Director"), who need not be shareholders.

In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it

is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors
consisting of either one Director (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the Board
of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, the Board of Directors or the Sole Director
shall appoint or confirm the appointment of its legal representative in compliance with the law of 10 August 1915 as
amended. The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of
shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without
mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman

may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced
by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors

are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities. The Board of Directors can only
validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. Any Director may act at
any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint
another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage. All decisions by the Board of
Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote. The use of video-
conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director being able to hear
and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by telephone. Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved
in writing and signed by all the Directors in person (resolution circulaire). Such approval may be in a single or in several
separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted
at the Directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such

vote is confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts

shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

Art. 8. The Board of Directors or the Sole Director is invested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole

signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the joint signatures of any two directors or by the
single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors or the Sole
Director of the Company, but only within the limits of such power.

Art. 10. The Board of Directors may delegate with unanimous vote its powers to conduct the daily management of

the corporation to one director, who will be called managing director.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more directors,

and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not,
whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

30226

Title IV.- Supervision

Art. 12. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first

Monday of June at nine.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the Company. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve;
this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below 10% of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the Company is

dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto."

<i>Fourth resolution

It has been resolved to accept the resignations of Mr Alan DUNDON and Mr Daniel ADAM as B directors of the

Company with immediate effect and to grant them full discharge for the execution of their mandate up to today's date.

It has been resolved to accept the resignations of Mr Christophe DAVEZAC and Mrs Géraldine SCHMIT as A directors

of the Company with immediate effect and to grant them full discharge for the execution of their mandate up to today's
date.

It has been resolved to appoint the following as directors of the Company with immediate effect:
- Mr José CORREIA, born on October 4th, 1971 in Palmeira (Portugal), professionally residing in 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg,

- Mr Alain PEIGNEUX, born on February 27th, 1968 in Huy (Belgium), professionally residing in 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg,

- Mrs Géraldine SCHMIT, born on November 11th, 1969 in Messancy (Belgium), professionally residing in 67, rue

Ermesinde, L-1469 Luxembourg,

Their mandates will be ending at the end of the Ordinary General Meeting of Shareholders which will be held in 2015.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately One thousand five hundred euro
(1,500 EUR)

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing parties, the said parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le quatre février.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

30227

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE LEADING TRAVEL

COMPANIES OF THE WORLD S.A., avec siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, immatriculée au registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro 118.615, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors
notaire de résidence à Mersch, le 4 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1864
du 5 octobre 2006.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 04 août 2006 suivant acte reçu par Maître Joseph EL-

VINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2131
du 15 novembre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle KOULOURIS, employée privée, résident profession-

nellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentant tous les actionnaires
par procuration.

et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stéphanie STACCHINI employée privée, résident professionnelle-

ment au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

La Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société en «ANTUNITE INVESTMENTS S.A.»,
2. Suppression des catégories d'administrateurs;
3. Modification des statuts de la Société tenant compte des décisions ci-dessus;
4. Démissions et Nomination d'administrateurs;
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés ainsi que le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier la dénomination sociale de la Société en «ANTUNITE INVESTMENTS S.A.» avec effet im-

médiat.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de supprimer les catégories d'administrateurs. Par conséquent, la représentation de la société auprès des

tiers se fera seulement par la signature individuelle de l'administrateur unique ou par les signatures conjointes de deux
administrateurs quelconques, en cas de pluralité d'administrateurs.

<i>Troisième résolution

En accord avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de totalement remodeler les statuts de la société comme

suit:

«Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  II est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de «ANTUNITE INVESTMENTS

S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune par

simple décision du conseil d'administration ou par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, tel que requis
par les dispositions applicables de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

30228

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra

acquérir et transférer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra également engager
et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la propriété de tels biens immobiliers.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront

directement ou indirectement la réalisation de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de trente et un euros (EUR 31,-).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d'Administration considérera le rachat dans l'intérêt de la

société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par l'article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d'Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors
de l'émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d'Administration
en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l'article 49 de

la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Adminis-
tration consistant soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être
membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut

être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé
par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion. Le Conseil d'Administration se réunit sur
convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils

30229

pourront renoncer aux formalités de convocation. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer
que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration. Tout Administrateur est autorisé à se
faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier
soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Admi-
nistrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite. Toute décision du Conseil
d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit
en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les
autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être
prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs person-
nellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis
par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du
Conseil d'Administration, dûment convoquée. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou par

téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 8. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale

sont de la compétence du Conseil d'Administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts,
de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt,
étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le Conseil d'Administration
peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux
administrateurs quelconques ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer à l'unanimité des voix la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs

directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires,
qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités

au nom de la société par le Conseil d'Administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet
effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier

lundi de juin à neuf heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais
reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

30230

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures."

<i>Quatrième résolution

Il a été décidé d'accepter les démissions de Monsieur Daniel ADAM et Monsieur Alan DUNDON de leur poste

d'administrateur de catégorie B de la société avec effet immédiat et de leur donner décharge pour l'exécution de leur
mandat jusqu'à ce jour.

Il a été décidé d'accepter les démissions de Monsieur Christophe DAVEZAC et Madame Géraldine SCHMIT de leur

poste d'administrateur de catégorie A de la Société avec effet immédiat et de leur donnr décharge pour l'exécution de
leur mandat jusqu'à ce jour.

Il est décidé de nommer les personnes suivantes aux postes d'administrateurs de la société avec effet immédiat:
- Monsieur José CORREIA, né le 04 octobre 1971 à Palmeira (Portugal), résidant professionnellement au 67, rue

Ermesinde, L-1469 Luxembourg,

- Monsieur Alain PEIGNEUX, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg,

- Madame Géraldine SCHMIT, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), résidant professionnellement au 67,

rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de mille cinq cents Euros (1.500 EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. STACCHINI, I. KOULOURIS, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 10 février 2010. Relation: MER/2010/278. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A.MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 17 février 2010.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2010029244/394.
(100026287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2010.

Bezalel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 134.110.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010029126/9.
(100026112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Centower Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 85.280.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés, dans leur version abrégée, au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30231

Gheribi Fatia
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010028911/12.
(100026065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Meranti Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 85.333.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés, dans leur version abrégée, au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gheribi Fatia
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010028912/12.
(100026069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Scandinavian Company Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 615, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 36.201.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010028934/10.
(100025694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Scandinavian Company Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 615, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 36.201.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010028935/10.
(100025701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

ATC-MAT S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1232 Howald, 141, rue Ernest Beres.

R.C.S. Luxembourg B 138.589.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2010029127/10.
(100025418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

PRB Luxembourg International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 272.098.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 140.891.

In the year two thousand nine, the twenty-second day of December.
Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of PRB Luxembourg International

S.àr.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

30232

registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140.891 (the Company). The
Company has been incorporated on August 5, 2008 pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated September 5, 2008, N°- 2170. The
articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on November 25, 2009, pursuant
to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

There appeared:

PR Beverages Cyprus (Russia) Holding Limited, a company duly organized and incorporated under the laws of Cyprus,

having its registered office in Nicosia 1065, Cyprus, Capital Center, 2-4, Arch. Makarios III Avenue, 9th Floor, registered
with the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus under number 231182 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred US dollars (USD 100) in order to bring

the share capital from its present amount of two hundred seventy-two million ninety-seven thousand nine hundred US
dollars  (USD  272,097,900),  represented  by  five  million  four  hundred  forty-one  thousand  nine  hundred  fifty-eight
(5,441,958) shares having a nominal value of fifty US Dollars (USD 50) each to two hundred seventy-two million ninety-
eight thousand US dollars (USD 272,098,000), by way of the issue of two (2) new shares of the Company, having a par
value of fifty US Dollars (USD 50) each.

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted

under item 1.

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff (Luxembourg) and any
employee of Alter Domus to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the
register of shareholders of the Company.

5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of

one hundred US dollars (USD 100) in order to bring the share capital from its present amount of two hundred seventy-
two million ninety-seven thousand nine hundred US dollars (USD 272,097,900), represented by five million four hundred
forty-one thousand nine hundred fifty-eight (5,441,958) shares having a nominal value of fifty US Dollars (USD 50) each
to two hundred seventy-two million ninety-eight thousand US dollars (USD 272,098,000), by way of the issue of two (2)
new shares of the Company, having a par value of fifty US Dollars (USD 50) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to the increase

of the share capital of the Company in the amount of one hundred US dollars (USD 100) and it fully pays it up by a
contribution in kind consisting of (i) a claim in an amount of sixty-four thousand four hundred eighty-seven US dollars
(USD 64,487) (the Claim I) that the Sole Shareholder has against the Company and (ii) a claim in an amount of six million
three hundred eighty-four thousand two hundred twenty-three US dollars (USD 6,384,223) (the Claim II and together
with the Claim I, the Claims) that the Sole Shareholder has against Pepsi Bottling Group GmbH, a company existing and
organized under the laws of Germany, having its registered office in D-Neu-Isenburg, registered at the Local Court in
Offenbach am Main under number HRB 11548 (PBG).

The contribution in kind of the Claims, in an aggregate amount of six million four hundred forty-eight thousand seven

hundred ten US dollars (USD 6,448,710) is allocated as follows:

- One hundred US dollars (USD 100) to the nominal share capital account of the Company; and
- six million four hundred forty-eight thousand six hundred ten US dollars (USD 6,448,610) to the share premium

account of the Company.

30233

The valuation of the contribution in kind of the Claims to the Company is evidenced by, inter alia, a balance sheet of

the Sole Shareholder as at December 18, 2009 and signed for approval by a director of the Sole Shareholder, and a
certificate dated December 21, 2009 issued by the authorized representatives of the Company and the Sole Shareholder
stating that:

"1. the attached balance sheet as at December 18, 2009 shows (i) the Sole Shareholder's receivable in an amount of

sixty-four thousand four hundred eighty-seven US dollars (USD 64,487) is immediately due and payable by the Company
to the Sole Shareholder and (ii) the Sole Shareholder's receivable in an amount of six million three hundred eighty-four
thousand two hundred twenty-three US dollars (USD 6,384,223) is immediately due and payable by PBG to the Sole
Shareholder;

2. based on generally accepted accountancy principles (i) the worth of the Claim I contributed to the Company is of

sixty-four thousand four hundred eighty-seven US dollars (USD 64,487) (being the USD equivalent of EUR 43,000) and
(ii) the worth of the Claim II contributed to the Company is of six million three hundred eighty-four thousand two hundred
twenty-three US dollars (USD 6,384,223) (being the USD equivalent of EUR 4,257,000), per the attached balance sheet
and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made
to the Company;

3. the Claims contributed to the Company are freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and they

are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value;
and

4. all formalities to transfer the legal ownership of the Claims contributed to the Company have been or will be

accomplished."

A copy of the above documents after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the

appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share

capital, as follows:

PR Beverages Cyprus (Russia) Holding Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,441,960 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,441,960 shares

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it

reads henceforth as follows:

5.1. The Company's corporate capital is fixed at two hundred seventy-two million ninety-eight thousand US dollars

(USD 272.098,000) represented by five million four hundred forty-one thousand nine hundred sixty (5,441,960) shares
in registered form with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, all subscribed and fully paid-up."

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff (Lu-
xembourg) and any employee of Alter Domus to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly
issued shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 3,500,.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de PRB Luxembourg International

S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.891
(la Société). La Société a été constituée le 5 août 2008 suivant un acte de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 septembre 2008, N° 2170. Les
statuts de la société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 25 novembre 2009, suivant un acte notarié de

30234

Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

A comparu:

PR Beverages Cyprus (Russia) Holding Limited, une société dûment organisée et constituée selon les lois de Chypre,

ayant son siège social à Nicosia 1065, Chypre, Capital Center, 2-4, Arch. Makarios III Avenue, 9th Floor, immatriculée au
Registre des Sociétés de la République de Chypre sous le numéro 231182 (l'Associé Unique),

ici représentée par Vanessa Schmitt, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-

parante  et  le  notaire  instrumentant,  restera  annexée  au  présent  acte  pour  être  soumise  avec  lui  aux  formalités  de
l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent dollars américains (USD 100) afin de porter le

capital social de son montant actuel de deux cent soixante-douze millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cents dollars
américains (USD 272.097.900), représenté par cinq millions quatre cent quarante et un mille neuf cent cinquante-huit
(5.441.958) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50) chacune à deux cent
soixante-douze millions quatre-vingt-dix-huit mille dollars américains (USD 272.098.000), par l'émission de deux (2) nou-
velles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50) chacune.

2. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social indiquée au point 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point

1.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff (Luxembourg) et tout employé d'Alter
Domus pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société.

5. Divers
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de cent

dollars américains (USD 100) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent soixante-douze millions
quatre-vingt-dix-sept mille neuf cents dollars américains (USD 272.097.900), représenté par cinq millions quatre cent
quarante et un mille neuf cent cinquante-huit (5.441.958) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante dollars
américains (USD 50) chacune à deux cent soixante-douze millions quatre-vingt dix-huit mille dollars américains (USD
272.098.000), par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de cinquante
dollars américains (USD 50) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmen-

tation du capital social comme suit:

<i>Souscription - Libération

Sur ces faits, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à l'augmentation du

capital social de la Société d'un montant de cent dollars américains (USD 100) et il la libère intégralement par un apport
en nature composé (i) d'une créance d'un montant de soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-sept dollars amé-
ricains (USD 64.487) (la Créance I) que l'Associé Unique a contre la Société et (ii) d'une créance d'un montant de six
millions trois cent quatre-vingt-quatre mille deux cent vingt-trois dollars américains (USD 6.384.223) (la Créance II et
avec la Créance I, les Créances) que l'Associé Unique a contre Pepsi Bottling Group GmbH, une société existante et
organisée selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège social à D-Neu-lsenburg, immatriculée au Tribunal Cantonal (Local
Court) d'Offenbach am Main sous le numéro HRB 11548 (PBG).

L'apport en nature de la Créance, d'un montant total de six millions quatre cent quarante-huit mille sept cent dix

dollars américains (USD 6.448.710) est affecté comme suit:

- cent dollars américains (USD 100) au compte capital social nominal de la Société; et
- six millions quatre cent quarante-huit mille six cent dix dollars américains (USD 6.448.610) au compte de prime

d'émission de la Société.

30235

L'évaluation de l'apport en nature de la Créance à la Société est documentée entre autres, par un bilan de l'Associé

Unique au 18 décembre 2009 et signé pour accord par un administrateur de l'Associé Unique et un certificat daté du 21
décembre 2009 émis par les représentants habilités de la Société et de l'Associé Unique, stipulant que:

"1. le bilan annexé au 18 décembre 2009 indique (i) que la créance de l'Associé Unique d'un montant de soixante-

quatre mille quatre cent quatre-vingt-sept dollars américains (USD 64.487) est immédiatement due et exigible par la
Société à l'Associé Unique et (ii) que la créance de l'Associé Unique d'un montant de six millions trois cent quatre-vingt-
quatre mille deux cent vingt-trois dollars américains (USD 6.384.223) est immédiatement due et exigible par PBG à
l'Associé Unique.

2. sur base de principes comptables généralement acceptés, (i) la valeur de la Créance I apportée à la Société est de

soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt sept dollars américains (USD 64.487) (étant l'équivalent en USD de EUR
43.000) et (ii) la valeur de la Créance II apportée à la Société est de six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille deux
cent vingt-trois dollars américains (USD 6.384.223) (étant l'équivalent en USD de EUR 4.257.000), selon le bilan ci-joint
et depuis la date du bilan, aucun changement matériel n'est intervenu qui aurait déprécié l'apport fait à la Société;

3. les Créances apportées à la Société sont librement cessibles par l'Associé Unique à la Société et ne sont soumises

à aucune restriction ou grevée d'aucun gage ou autre droit limitant leur cessibilité ou réduisant leur valeur; et

4. toutes les formalités afin de transférer la propriété juridique des Créances apportées à la Société ont été ou seront

accomplies."

Une copie des documents ci-dessus, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de

la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement.

L'Associé Unique décide d'enregistrer que l'actionnariat dans la Société, suite à l'augmentation de capital, se présente

comme suit:

PR Beverages Cyprus (Russia) Holding Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.441.960 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.441.960 parts sociales

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus, de sorte qu'il aura

désormais la teneur suivante:

5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent soixante-douze millions quatre-vingt-dix-huit mille dollars

américains (USD 272.098.000) représenté par cinq millions quatre cent quarante et un mille neuf cent soixante (5.441.960)
parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus

et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff (Luxembourg) et
à tout employé d'Alter Domus pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement
émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la société en raison

du présent acte sont estimés à environ EUR 3.500.-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même partie comparante en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du document faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a

signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: V. SCHMITT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57597. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 janvier 2010.

Référence de publication: 2010029350/227.
(100026787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2010.

30236

Emerald First Layer " J " S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 118.091.

In the year two thousand nine, on the thirty-first day of December.
Before the undersigned, Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "Emerald First Layer "J" S.A.", a société anonyme, having

its principal office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, registered with the Trade and Companies' Register of
Luxembourg, section B, under the number 118091, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary
residing in Luxembourg, on July 18 

th

 , 2006, published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

number 1814 of September 28 

th

 , 2006

The meeting was opened by M. Armand BASTENDORFF, with professional address at 21, rue Colmar-Berg, L-7525

Mersch, being in the chair,

The meeting elected as scrutineer Mr Jorrit CROMPVOETS, with professional address at 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To dissolve the Company and to put it into liquidation.
2. To appoint Fairland Property Limited as liquidator and to determine its powers as liquidator.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares are present or represented at the present general meeting.
IV. As a consequence, more than half of the capital being present or represented, the present meeting is regularly

constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as of this day.

<i>Second resolution

The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator, Fairland Property Limited,

a company existing and organized under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at offices of Euro-
American  Trust  and  Management  Services  Limited,  Road  Town,  Tortola,  British  Virgin  Islands,  registered  with  the
Registrar of Companies of the British Virgin Islands under number 517295.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may

execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for

such period he may determine.

<i>Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven hundred fifty euro (750.-
EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Marc LECUIT notaire, résidant à Mersch.

30237

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Emerald First Layer "J" S.A.",

ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés,
section B, numéro 118091, constituée suivant acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 18 juillet 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1814 du 28 septembre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Armand BASTENDORFF, demeurant professionnellement

au 21, rue Colmar-Berg, L-7525 Mersch.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jorrit CROMPVOETS, demeurant professionnellement au 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Fairland Property Limited comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu'il ressort de la dite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente

assemblée générale.

IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement con-

stituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, Fairland Property Limited, une société existant sous les lois des

Iles Vierges Britanniques, avec siège social chez Euro-American Trust and Management Services Limited, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, enregistrée auprès du Registrar of Companies of the British Virgin Islands sous le n°517295.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à environ sept cent cinquante euros (750,-EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. BASTENDORFF, J. CROMPVOETS, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 08 janvier 2010. Relation: MER/2010/58. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

30238

Mersch, le 15 février 2010.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2010028615/109.
(100025549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Fintech Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 140.678.

L'an deux mil dix, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée  FINTECH  INVESTMENTS  S.A.,  avec  siège  social  à  BRIDEL,  inscrite  au  R.C.S.  Luxembourg  Section  B  n°
140.678

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 septembre 2008 publié au Mémorial C no. 2061 du

26 août 2008 page 98.917.

L'assemblée est présidée par M. Marco LAGONA, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire M. J.P. SADDI, demeurant professionnellement à Luxembourg,
et l'Assemblée choisit comme scrutateur Mme Sophie JACQUET, employée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

tous ici présents et acceptant.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, tous les actionnaires, représentant l'en-

tièreté du capital social souscrit, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement
délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Qu'il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée, et qu'en conséquence l'assemblée est

régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la société et modification subséquente de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la

teneur suivante:

"Le siège de la société est établi à Luxembourg,
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout,

selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder."

2. Divers.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé

l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Résolution Unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à L-2352 Luxembourg, 4, Rue

Jean-Pierre Probst, et ce avec effet au 1 

er

 janvier 2010,

Suite à la présente résolution, elle décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
"Le siège de la société est établi à Luxembourg,

30239

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout,

selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder."

<i>Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. LAGONA, J.P. SADDI, S. JACQUET, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 19 janvier 2010, LAC/2010/2731: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 20 février 2010.

Référence de publication: 2010029201/79.

(100026204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2010.

Bifica Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 122.724.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, VALON S.A., R.C.S. Luxembourg B 63.143, 283, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour son compte au conseil d'administration de la société BIFICA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.: Monsieur Guy
KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean BODONI.

Par décision du Conseil d'administration du 4 février 2010, LANNAGE S.A., Président du Conseil d'administration,

R.C.S. Luxembourg B 63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé
de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société BIFICA REAL ESTATE
INVESTMENT S.A.: Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de
Monsieur Jean BODONI.

Luxembourg, le 16 février 2010.

<i>Pour BIFICA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Liette Heck

Référence de publication: 2010029141/22.

(100025481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

30240


Document Outline

Antunite Investments S.A.

A.P. LUX S.à r.l.

ATC-MAT S.à.r.l.

Beta DB Lindsell Limited S.C.S.

Bezalel S.A.

Bifica Real Estate Investment S.A.

BLRM S.A.

C2NT Import Export S.A.

Cellon

Centower Investments S.à r.l.

Chripas

Citynet Trading S.A.

ColMolitor (Lux) S.à r.l.

Company Invest Meat Industry S.A.

Conseil Comptable S.A.

DiPiU Property S.A.

Dominis Invest S.A.

Eaton Holding IV S.à r.l.

Eaton Holding IX S.à r.l.

Eaton Holding VIII S.à r.l.

Eaton Holding X S.à r.l.

Emerald First Layer " J " S.A.

Entropie S.A.

Fernbach Financial Software S.A.

Fiduciaire Générale GROUP, s.à r.l.

Finacor Holding S.A.

Financière Hôtelière Européenne S.A.

Fintech Investments S.A.

Frozen Holding S.A.

Granis Investments S.A.

Graphite et Métaux S.àr.l.

HAZ Holding S.A.

HEBB S.A.

Hickory Participations S.A.

Howald Invest S.A.

Hungaria Baukonzepte A.G.

IBR Invest S.A.

IFF S.A.

Imagine Cyber Group S.A.

Immobilière Reiserbann S.A.

Immotourisme S.A.

Jero S.A.

Lanchester S.A.

Meranti Investments S.à r.l.

Metallum Holding S.A.

Moeller Electric S.à r.l.

Newtec S.A.

Pierjet Investments S.A.

PRB Luxembourg International S. à r.l.

Restaurant La Belle Africaine

Scandinavian Company Luxembourg S.A.

Scandinavian Company Luxembourg S.A.

Scandinavian Company Luxembourg S.A.

SK Logistic S.A.

Sword Technologies S.A.

The Leading Travel Companies of the World S.A

Triul S.A.

Unitpool Asset Management Alpha S.à r.l.

W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l.

Wasaby S.A.

Whitehall French RE 10 S.à r.l.

Whitehall French RE 11 S.à r.l.