logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 592

19 mars 2010

SOMMAIRE

Adapto SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28395

AdriaMedic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28408

Alleva Immobilière S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . .

28415

Applied Radio Technology S.A. Holding

Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28406

BAEK-IMMO HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

28374

BK Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28395

Brunel Properties S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28396

Brunel Properties S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28405

Cinquestrel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28384

Entreprise de constructions, de travaux de

voirie et de façade Alleva Frères s.e.n.c.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28415

European Truck Service Corporation S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28370

Gaai Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28385

Geocad s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28412

GSL Immobilière S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28413

Immo-Promotions Difa S.A. . . . . . . . . . . . . .

28416

JPMorgan Portfolio Strategies Funds . . . . .

28413

K200 Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28372

KNEIP ingénieurs-conseils, S.à r.l.  . . . . . . .

28413

LBREP III Immit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28409

Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . .

28385

LuxCo 109 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28410

Meribel Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28410

Merwood Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

28375

Merwood Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

28383

Mistral RE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28395

Opengate Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

28384

PRO Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28409

ProLogis Poland VIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

28411

ProLogis Poland VI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

28411

ProLogis Poland V S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

28411

ProLogis Poland XCIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

28412

ProLogis Poland XCI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

28412

ProLogis Poland X S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

28412

Rapier Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

28385

Rapier Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

28394

Sico S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28396

Socavia III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28374

Tarp International Holding S.A.  . . . . . . . . .

28385

Tarp International Holding S.A.  . . . . . . . . .

28385

TecniStyle Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28411

TKK 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28406

Tourbillon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28410

Vaunage Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28410

Xion 3000 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28370

28369

Xion 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 79.360.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010026210/9.
(100022105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

EUTRUSCO S.A., European Truck Service Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 59, rue Ernest Beres.

R.C.S. Luxembourg B 26.009.

L'an deux mille neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme European Truck Service Cor-

poration S.A. en abrégé EUTRUSCO S.A. avec siège social à L-1232 Howald, 59 rue Ernest Beres, inscrite au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro B 26009, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom METZLER, de
résidence à Luxembourg, en date du 25 mai 1987, publié au Mémorial Recueil Spécial C no 274 en date de l'année 1987.

L'Assemblée est ouverte à 12 heures sous la présidence de Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant

professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Soleuvre.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Julien DIOT, employé privé, demeurant professionnellement à Mamer.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de Leudelange à Mamer et modification du deuxième alinéa de l'article 2 des

statuts

2.- Fixation de l'adresse sociale de la société.
3.- Conversion du capital social, en EUROS.
4.- Modification de l'article cinq des statuts.
5.- Modification de l'article six (premier alinéa) des statuts
6.- Acceptation de la démission d'un administrateur
7.- Nomination de deux nouveaux administrateurs et d'un président du conseil d'administration.
8.- Engagement de la société vis à vis des tiers.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'

actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par
les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a

donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Howald à Contern et de modifier par conséquent le premier

alinéa de l'article deux des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Contern.
(Le reste sans changement.)

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-5324 Contern, 1a rue des Chaux.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide:
a) de convertir le capital social de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000-) en EUROS au taux de

conversion de 40,3399, soit CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS QUATRE-
VINGT-DEUX CENTS (EUR 198.314,82.-);

28370

b) de supprimer les cent soixante actions (160) existantes de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000.-flux)

chacune et de créer cent soixante actions nouvelles (160) sans valeur nominale

<i>Quatrième résolution

De ce qui précède, L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de modifier

l'article cinq, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS

QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (EUR 198.314,82.-) représenté par cent soixante actions (160) sans valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

Art. 6. (premier alinéa): Toutes les actions sont et resteront au porteur.
(Le reste sans changement. ).

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission d'un administrateur à savoir:
- Monsieur Jean-Pierre GRAEFFLY, fonctionnaire européen, demeurant à L- 5898 Syren, 36 rue Aloyse Ludovissy.
Et lui accorde décharge pour l'accomplissement de son mandat.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer à compter de ce jour pour une durée de six ans:
a) dans la fonction d'administrateurs:
- Monsieur Emile FERRO, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, 27 Letzebuerger Strooss.
- Monsieur Claude QUARING, demeurant à L-8366 Hagen, 13 Cité Pierre Braun.
b) dans la fonction de Président du Conseil d'Administration:
Monsieur Fernand CONRARDY, administrateur de société, demeurant à L-7432 Gosseldange, 138 rte de Mersch.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2014.

<i>Composition actuelle du conseil d'administration:

- Monsieur Alphonse CONRARDY, employé privé, demeurant à L-2168 Luxembourg, 55 rue de Muhlenbach.
- Monsieur Fernand CONRARDY, administrateur de société, demeurant à L-7432 Gosseldange, 138 rte de Mersch.
- Monsieur Emile FERRO, prédit.
- Monsieur Claude QUARING, prédit.

<i>Huitième résolution

Conformément à l'article 10 des statuts, la société est en toutes hypothèses valablement engagée par les signatures

conjointes du président et d'un autre membre du conseil d'administration.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du

présent acte, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.- Euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.
Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Paché; Muhovic; Diot, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2009. Relation: EAC/ 2009/ 15901. Reçu soixante-quinze euros 75.-€

<i>Le Receveur (signé): Kirchen.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

28371

Esch-sur-Alzette, le 2 février 2010.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2010025750/95.
(100022026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

K200 Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 139.415.

In the year two thousand nine, on the eighteenth of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Dart Holdings (Cayman) Limited, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered

office at 4 

th

 Floor, Queensgate House, 113 South Church Street, George Town - Grand Cayman N, registered with the

registrar of Companies Cayman Islands, under number 154000,

here represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I.- It is the sole shareholder of K200 Finance S.à.r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, on May 26, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C number 1668 of July 7,
2008.

- That the sole partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 25,- (twenty five

euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro)
to EUR 12.525.- (twelve thousand five hundred and twenty-five euro) by way of the issue of 1 (one) new share of the
Company with a nominal value of TWENTY FIVE EURO (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the
existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the sole shareholder, Dart Holdings (Cayman) Limited, prenamed, represented as thereabove mentioned,

declares to subscribe for the 1 (one) new share and to fully pay it up by contribution in kind of all the assets and liabilities
of the Company Woodford S.à r.l..

The ownership and the value of such assets and liabilities have been certified to the undersigned notary by a certificate

issued on December 18, 2009 by the management of Woodford S.à r.l. to which a contribution balance sheet as per 18
December 2009 is attached. According to the said certificate:

-all assets and liabilities of the Company are shown on the attached certified balance sheet as per 18 December 2009.
-based on generally accepted accountancy principles the net worth of the company per attached balance sheet is

estimated to be EUR 8,864,182.-

-all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to K200 Finance S.á r.l. will be accomplished

by the undersigned."

The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be transferred

to a share premium account.

Such certificate, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following

wording:

"The Company's Corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND AND TWENTY FIVE EURO (12,525.- EUR)

represented by FIVE HUNDRED AND ONE (501) shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.-EUR) each, all
subscribed and fully paid up.".

There being no further business, the meeting is terminated.

28372

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 4,000.- (four thousand
euro).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, he signed together with the notary the

present original deed.

Follows the French version:

L'an deux mil neuf, le dix-huit décembre.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Dart Holdings (Cayman) Limited, une société constituée selon les lois des îles Cayman, ayant son siège social au 4 

th

Floor, Queensgate House, 113 South Church Street, George Town - Grand Cayman N, immatriculée au Registre des
sociétés des îles Cayman, sous le numéro 145 000,

ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est le seul associé actuel de la société "K200 Finance S.à r.l.", société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 26 mai 2009, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1668 du 7 juillet 2009;

Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 25,- (vingt cinq euros) pour

porter son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 12.525,- (douze mille cinq cent vingt
cinq euros) par l'émission de 1 (une) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros), ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, l'associé unique Dart Holdings (Cayman) Limited, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare sou-

scrire une part sociale nouvelle et la libérer moyennant apport en nature de tous les actifs et passifs de la société Woodford
S.à r.l.

La propriété et la valeur de tels actifs et passifs a été certifiée au notaire soussigné au moyen d'un certificat émis en

date du 18 décembre 2009 par la gérance de Woodford S.à r.l., auquel est annexé un bilan en date du 18 décembre 2009.
Selon le dit certificat:

- tous les actifs et passifs de la société sont repris au bilan certifié ci-annexé, en date du 18 décembre 2009.
- sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de la société selon le bilan annexé est évaluée

à EUR 8.864.182,-

- toutes les formalités pour transférer la propriété juridique de tels actifs et passifs seront accomplies par le soussigné."
La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à un

compte de prime d'émission.

Le dit certificat, après signature "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:
"Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS (12.525,- EUR) représenté par CINQ

CENT ET UNE (501) parts d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, entièrement souscrites
et libérées."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

28373

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ EUR 4.000,- (quatre mille euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2009. Relation: LAC/2009/56915. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur

 (singé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 février 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010025773/121.
(100022442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Socavia III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 127.553.

<i>Rectificatif du document déposé le 25 mai 2009 au

<i>Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro de dépôt L090075066.05

<i>Transfert des parts sociales de Socavia III S .à r.l.

Il fallait lire qu'en date du 26 décembre 2008, l'associé Codan Trust Company Limited a transféré 6 parts sociales de

Socavia III S.à r.l. à Sunrise Junior Trust, trust de par sa forme juridique et ayant son siège social au 1100 N. King Street
à Wilmington, Etat du Delaware, Etats Unis d'Amérique et non pas à Jordan Ashley Charvillat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2010.

Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.
17, rue des Jardiniers
B.P. 2650 L-1026 Luxembourg
<i>Expert-Comptable
Signature

Référence de publication: 2010026662/20.
(100022889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

BAEK-IMMO HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.307.

En date du 18 novembre 2009, l'actionnaire unique de la société à responsabilité limité 'BAEK-IMMO HoldCo S. à r.l.'
a accepté les démissions de Michael Lipnik et Jean-Pierre Staelens de leur fonction d'administrateur avec effet au 18

novembre 2009

et élu Anne Keilholz, née 9 juillet 1966, et Marco Heim, né le 7 septembre 1974, demeurant professionnellement au

3, Wettinerstrasse, D-65189 Wiesbaden en tant qu'administrateurs de la société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 11 février 2010.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2010026669/15.
(100022970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

28374

Merwood Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 151.256.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of December.
Before the undersigned Maître Jacques DELVAUX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MERWOOD PROPERTIES LIMITED, a company

incorporated under the Law of Ile of Man, established and having its registered office at Millennium House, Victoria Road,
Douglas, Ile of Man, with the register number N. 061094C (the "Company").

The extraordinary general meeting is opened by Mr Xavier MANGIULLO, employee, residing in Luxembourg, as

Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Xavier MANGIULLO, prenamed.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the Dou-

glas, Ile of Man, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and fiscal
purposes, from the date January 1 

st

 , 2009, without the Company being dissolved and with full corporate and legal

continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with

the name "Merwood Properties S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the
registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;

3. Change of the purpose of the company as follows:
"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies

both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or
subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences
and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said
object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof. ".

4. Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxem-

bourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

5. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office,

principal establishment and central administration of the Company from the Douglas, Ile of Man to the city of Luxembourg
and further to the complete restatement of the Company's articles of association;

6. Change of the currency of express of the share capital from GBP into EUR, basing on the currency rate applicable

at January 1 

st

 ,2009, date of the opening of the present financial year, equal to 1 GBP=1.0385 EUR, so that the current

share capital of 4 GBP will be 4,15 EUR. The difference resulting from the application of the currency rate at January 1

st

 , 2009 and the currency rate at the date of the notary deed of conversion, if is negative, will be paid by the contribution

of the same amount equal to the difference between the amount of the share capital of 4,15 EUR and the amount obtained
by the conversion using the currency rate applicable at the date of the conversion, this amount will be down from the
profit brought forward and if it positive will be deposited in a special provision account that can be used only following
the provision for the modification of the share capital;

7. Increase of the capital subscribed of 12,495.85 Eur in order to bring it from its actual amount of 4,15 Eur up to

12,500.00 Eur by the increase of the nominal value of the present shares, with the same rights and advantages of the
existing shares

8. Allocation to shares of a par value of EUR 1.00 by replacement of the 4 existing shares with 12,500 shares of nominal

value of 1.00 Eur each to assign to the shareholders with the same "prorata" as per the existing owned shares.

9. Subsequent amendment of the Articles of association;

28375

10. Resignation and appointment of Mr. Robert Michael Churchill, born in Exeter at October 30 

th

 1944, residing in

Granville, La Grande Route De St Cleme, St Clement, Jersey JE2 6QP; Mrs. Julie Coward, born in Solihull at August 10

th

 , 1956, residing in Le Bocage House, Les Fond De Longueville, Grouville, Jersey, JE3 9AB; Mr Frank Stuart Gee, born

in Oldenburg at January 16 

th

 ,1952, residing in La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route des Petits Camps, St Helier, Jersey,

JE2 4JP and Ms Letitia Lorretta Cummins, born in Jersey at August 28 

th

 , 1966, residing in 3, La Croix, La Rue Becq,

Trinity, Jersey, JE 5FR, as managers of the Company , all of them for an unlimited period, acting individually or together
with another or others;

11. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

12. Fixing the financial year to run from 1 

st

 January to 31 

st

 December of each year;

13. Consequent amendment of The Article of incorporation of the statutes to adapt to the resolutions taken on the

basis of the agenda;

14. Miscellaneous
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of the Company are present

or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on
the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

The Chairman declares that the company will transfer its registered and official office to Luxembourg.
Pursuant to a written resolution of the Board of Directors of the Company given in Jersey on November 12, 2009,

the transfer of the registered office, the real management, the central administration and the principal office to Luxem-
bourg, in the forms required by Luxembourg law, all this without any change of the legal entity was decided. A copy of
such document, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

For the execution of this resolution, it is necessary to adjust the articles of incorporation of the company to the law

of the new country of the registered office.

Furthermore stays added to the present deed:
- a certificate of standing of the "Financial Supervisory Commission of Isle of Man", dated November 16, 2009;
- a certificate containing the transfer of domicile dated December 21 

st

 , 2009;

- a declaration of solvency given by a director of the Company dated November 24, 2009;
- an irrevocable undertaking of acceptance of services of legal process;
- a balance sheet on January 1 

st

 , 2009 and a valuation certificate;

- a legal opinion of POPE &amp; CO SOLICITORS
After deliberation, the meeting then adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office, principal establishment and central administration of

the Company from Douglas, Ile of Man, to the City of Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, Grand Duchy of Lu-
xembourg, and that starting, for the accounting and fiscal purposes, from the date January 1 

st

 , 2009, without the Company

being dissolved and with full corporate and legal continuance

<i>Second resolution

The General Meeting decides to adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité

limité) with the name "Merwood Properties S.à r.l.", and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the
transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to modify the purpose of the company as follows:
"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies

both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or
subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences

28376

and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said
object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform

them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as
specified in resolution 2 above,

and resolves to acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the

registered office, principal establishment and central administration of the Company from Douglas, Ile of Man, the city of
Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves to change the currency of expression of the share capital from GBP into EUR, based

on the currency rate applicable on January 1 

st

 , 2009, date of the opening of the present financial year, equal to 1 GBP

= 1,0385 EUR,

so that the current share capital of 4 GBP will be 4.15 EUR.
The difference resulting from the application of the currency rate at 1 

st

 January 2009 and the currency rate at the

date of the present deed, being 1.-GBP = 1,1128, making the amount of EUR 0,3012 will be deposited in a special provision
account that can be used only following the provision for the modification of the share capital

<i>Sixth resolution

After  the  change  of  currency,  the  General  Meeting  resolves  to  increase  the  share  capital  by  an  amount  of  EUR

12,495.85,

In order to bring it from its present amount of EUR 4.15 to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro),
without issuance of new shares but by the increase of the par value of the existing 4 shares to EUR 3,125,
entirely paid up in cash by the two actual shareholders, so that the amount of EUR 12,495.85 is at the free disposal of

the company from now on, so as this has been shown to the notary pursuant to a bank certificate

<i>Seventh resolution

The General Meeting resolves to replace the 4 existing shares by 12,500 shares with a par value of EUR 1 each, allocated

to the 2 actual shareholders as follows:

- BASEL ONE LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250 shares

First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier. Jersey, JE23QQ
- GOLDLAND UNIVERSAL LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250 shares

56 Administration Drive, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares

<i>Eighth resolution

The General Meeting accepts the resignation of the former managers of the company and appoints the same persons:
- Mr Robert Michael Churchill, born in Exeter at October 30 

th

 1944, residing in Granville, La Grande Route De St

Cleme, St Clement, Jersey JE2 6QP;

- Mrs Julie Coward, born in Solihull at August 10 

th

 , 1956, residing in Le Bocage House, Les Fond De Longueville,

Grouville, Jersey, JE3 9AB;

- Mr Frank Stuart Gee, born in Oldenburg at January 16 

th

 ,1952, residing in La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route

des Petits Camps, St Helier, Jersey, JE2 4JP

- Ms Letitia Lorretta Cummins, born in Jersey at August 28 

th

 , 1966, residing in 3, La Croix, La Rue Becq, Trinity,

Jersey, JE 5FR,

as managers of the Company, all of them for an unlimited period

<i>Ninth resolution

The General Meeting confirms the establishment of the registered office at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

28377

The Sole Shareholder confirms that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Ile of Man natio-

nality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to own
all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of Ile of Man
nationality.

<i>Tenth resolution

The General Meeting resolves to fix the financial year to run from the 1 

st

 of January to the 31 

st

 of December of each

year.

<i>Eleventh resolution

The General Meeting, in conformity with the above taken resolutions, resolves to amend the Articles of Association,

which after total update to conform them to the Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

ARTICLES OF INCORPORATION

Art. 1. The company has as denomination Merwood Properties S.à r.l..

Art. 2. The registered office is set in Luxembourg.

Art. 3. "The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other

companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contribu-
tions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents
and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked
to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. The corporate capital is set at Eur 12,500 (twelve thousand five hundred euro) divided into 12,500 (twelve

thousand five hundred) shares with a nominal value of Eur 1 (one euro) each, fully paid-up.

Art. 6. The shares are freely transferable among the existing shareholders. To non shareholders they can only be

transferred in the limits foreseen by law.

Art. 7. In case the company was to have only one single shareholder, the decisions are taken by this single shareholder

and will be put in writing and will be recorded under the form of minutes.

Art. 8. The company is managed by one or more Manager(s) (gérants), shareholders or not, designated by the meeting

of shareholders deciding at the simple majority of the shares as stipulated in article 12 for the meetings of shareholders
not modifying the articles of association.

The sole Manager may accomplish all acts of administration and disposition necessary or useful for the accomplishment

of the corporate object except for those reserved by law to the decision of the shareholders.

In case several Managers are appointed, their joint signature is necessary in order to validly bind the company, unless

special delegation.

The mandate of the Manager(s) may be granted for a limited or unlimited period.

Art. 9. The company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the

shareholders. In case of death of a shareholder, the company will continue to run among the heirs of the sole shareholder
who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away, all this
in the limits of article 189 of the company law.

The company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person

among themselves in order to represent them vis-à-vis of the company.

The heirs and creditors may not, under whatever argument whatsoever, ask to have seals put on the assets and

documents of the company nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the company.
With reference to the exercise of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the
shareholders.

Art. 10. The corporate years starts on the first of September of each year and finishes on August 31 of the next year.

Art. 11. The company will be dissolved pursuant to the legal prescriptions.

28378

Art. 12. The decisions not amending the articles of association are not taken validly unless they are approved by

shareholders representing more than half of the shares. If because of absence or abstention of shareholders, this figure
cannot be obtained in a first meeting or written consultation the shareholders are called or consulted a second time by
registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast under the condition that they concern only
matters examined in the first meeting or consultation.

The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the company. All other amendments

of the articles of association are decided at a majority of the shareholders representing the three quarters of the corporate
capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.

In case the company has only one shareholder, the authority of the meeting of shareholders is attributed to the sole

shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.

Art. 13. With reference to all other points not specifically regulated by the present articles of association, the share-

holders are subject to the existing legal regulations

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 3,000.-.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire, de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de MERWOOD PROPERTIES LIMITED, une société

existent sous les lois de "Ile of Man", établie et ayant son siège social au Millennium House, Victoria Road, Douglas, Ile of
Man, inscrite sous le numéro 061094C (la "Société").

L'assemblée est présidée par M. Xavier MANGIULLO, employé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire M. Gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur M. Xavier MANGIULLO, précité.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the Dou-

glas, Ile of Man, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and fiscal
purposes, from the date January 1 

st

 , 2009, without the Company being dissolved and with full corporate and legal

continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with

the name "Merwood Properties S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the
registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;

3. Change of the purpose of the company as follows:
"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies

both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or
subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences
and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said
object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof. ".

4. Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxem-

bourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

28379

5. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office,

principal establishment and central administration of the Company from the Douglas, Ile of Man to the city of Luxembourg
and further to the complete restatement of the Company's articles of association;

6. Change of the currency of express of the share capital from GBP into EUR, basing on the currency rate applicable

at January 1 

st

 ,2009, date of the opening of the present financial year, equal to 1 GBP=1.0385 EUR, so that the current

share capital of 4 GBP will be 4,15 EUR. The difference resulting from the application of the currency rate at January 1

st

 ,2009 and the currency rate at the date of the notary deed of conversion, if is negative, will be paid by the contribution

of the same amount equal to the difference between the amount of the share capital of 4,15 EUR and the amount obtained
by the conversion using the currency rate applicable at the date of the conversion, this amount will be down from the
profit brought forward and if it positive will be deposited in a special provision account that can be used only following
the provision for the modification of the share capital;

7. Increase of the capital subscribed of 12.495.85 Eur in order to bring it from its actual amount of 4,15 Eur up to

12.500,00 Eur by the increase of the nominal value of the present shares, with the same rights and advantages of the
existing shares.

8. Allocation to shares of a par value of EUR 1.00 by replacement of the 4 existing shares with 12.500 shares of nominal

value of 1.00 eur each to assign to the shareholders with the same "prorata" as per the existing owned shares.

9. Subsequent amendment of the Articles of association;
10. Resignation and appointment of Mr. Robert Michael Churchill, born in Exeter at October 30 

th

 1944, residing in

Granville, La Grande Route De St Cleme, St Clement, Jersey JE2 6QP; Mrs. Julie Coward, born in Solihull at August 10

th

 , 1956, residing in Le Bocage House, Les Fond De Longueville, Grouville, Jersey, JE3 9AB; Mr. Frank Stuart Gee, born

in Oldenburg at January 16 

th

 ,1952, residing in La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route des Petits Camps, St Helier, Jersey,

JE2 4JP and Ms Letitia Lorretta Cummins, born in Jersey at August 28 

th

 , 1966, residing in 3, La Croix, La Rue Becq,

Trinity, Jersey, JE 5FR, as managers of the Company , all of them for an unlimited period, acting individually or together
with another or others;

11. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

12. Fixing the financial year to run from 1 

st

 January to 31 

st

 December of each year;

13. Consequent amendment of The Article of incorporation of the statutes to adapt to the resolutions taken on the

basis of the agenda;

14. Miscellaneous
II. Que les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont

indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents,
les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront
annexés au présent acte
.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.
III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Monsieur le Président déclare que la société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxembourg.
Conformément à une décision écrite prise le conseil d'administration de la société à Jersey en date du 12 novembre

2009. il a décidé le transfert du siège statutaire, l'administration centrale, le siège de direction effectif et le principal
établissement de la société vers le Grand-Duché de Luxembourg, dans les formes et conditions prévues par la loi lu-
xembourgeoise, sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption. Une copie de cette
décision reste annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Pour l'exécution de la susdite décision, il est nécessaire d'adapter les statuts de la société à la loi du nouveau pays du

siège social.

De plus restent annexés au présent acte:
- un " certificat of standing " délivré par le " Financial Supervisory Commission of Isle of Man ", daté du 16 novembre

2009;

- un certificat renseignant le transfert de siège daté du 21 décembre 2009;
- une "declaration of solvency" délivrée par un administrateur de la société datée du 24 novembre 2009;
- un "irrevocable undertaking of acceptance of services of legal process";
- une situation comptable au 1 

er

 janvier 2009 ainsi qu'un certificat d'évaluation;

- un "legal opinion" délivré par POPE &amp; CO SOLICITORS
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

28380

<i>Première résolution

L'assemblée décide que le siège social statutaire, la direction effective, l'administration centrale et le principal établis-

sement de la société est transféré de Douglas, Ile of Man, à Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, Grand-Duché de
Luxembourg, le tout sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide que la société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous

la dénomination de "Merwood Properties S.à r.l." suite au transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de
l'administration centrale et du principal établissement de la société vers le Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de changer l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et

étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise
en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide ensuite de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation luxembourgeoise, pour leur donner la version coordonnée dont question ci-après.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier la devise du capital de GBP en EURO au taux de change du 1 

er

 janvier 2009, savoir:

1,- GBP = 1,0385 EUR,

de sorte que le capital sociale actuel de GBP 4, sera de EUR 4,15, représentée par 4 parts sociales sans désignation de

valeur nominale.

La différence résultant de l'application du cours de change au 1 

er

 janvier 2009 et le cours de change applicable à la

date du présent acte savoir 1,-GBP = EUR 1,1128, soit la somme de EUR 0,3012 est versée à un compte de réserve dont
il ne pourra être disposée qu'en observant les règles sur la modification du capital social

<i>Sixième résolution

Suite à la conversion de devise qui précède, l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR

12.495,85,

afin de le porter de son montant actuel de EUR 4,15 à EUR 12,500 (douze mille cinq cents Euros ),
sans émission de parts sociales nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 4 parts sociales actuelles

à EUR 3.125 par part sociale

entièrement libérée par un versement en numéraire par les actuels associés, de sorte que le montant de EUR 12.495,85

est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au Notaire par un certificat bancaire.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de remplacer les 4 actuelles parts sociales par 12.500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR

1 par part sociale, attribuées aux 2 actuels associés comme suit:

- BASEL ONE LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250 parts

First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier. Jersey, JE23QQ
- GOLDLAND UNIVERSAL LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250 parts

56 Administration Drive, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 parts

<i>Huitième résolution

L'assemblée accepte les démission des anciens gérants et décide de nommer les mêmes personnes, savoir
- Mr Robert Michael Churchill, né à Exeter le 30 octobre 1944, demeurant à Granville, La Grande Route De St Cleme,

St Clement, Jersey JE2 6QP;

28381

- Mme Julie Coward, née à Solihull le 10 août 1956, demeurant à Le Bocage House, Les Fond De Longueville, Grouville,

Jersey, JE3 9AB;

- Mr Frank Stuart Gee, né à Oldenburg le 16 janvier 1952, demeurant à La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route des

Petits Camps, St Helier, Jersey, JE2 4JP

- Mlle Letitia Lorretta Cummins, née à Jersey le 28 août 1966, demeurant au 3, La Croix, La Rue Becq, Trinity, Jersey,

JE 5FR,

comme nouveaux gérants de la société, tous pour une durée illimitée.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée confirme l'établissement du siège social de la société au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg.
L'Assemblée confirme que tous les actifs et passifs de la société précédemment de nationalité de Ile of Man restent

sans limitation et dans leur entièreté la propriété de la société luxembourgeoise, laquelle continuera à être propriétaire
de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment de nationalité de Ile
of Man.

<i>Dixième résolution

L'Assemblée décide que l'exercice social court du 1 

er

 janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.

<i>Onzième résolution

L'Assemblée, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier les statuts qui, après refonte totale pour les

mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, auront désormais la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination Merwood Properties S.à r.l..

Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg

Art. 3. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros), divisé en 12.500 (douze

mille cinq cents) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), chacune entièrement libérée.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les limites

prévues par la loi.

Art. 7. Au cas où la société ne devait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont

retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.

Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée

des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l'article 12 pour les assemblées non modi-
ficatives des statuts.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplis-

sement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.

En cas de nomination de plusieurs gérants, leur signature conjointe est exigée pour engager valablement la société,

sauf délégation spéciale.

Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l'associé décédé tout ceci dans les limites de l'article 189 de la loi sur les sociétés. La société
ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les
représenter au regard de la société.

28382

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens

et  documents  de  la  société,  ni  s'immiscer  en  aucune  manière  dans  les  actes  de  son  administration;  ils  doivent  pour
l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.

Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.

Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des

associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre
n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications

statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun
cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Lorsque la société n'a qu'un seul associé les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à

l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.

Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en

vigueur

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société en raison des présentes à EUR 3.000,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: X. MANGIULLO, G. SADDI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 30 décembre 2009, LAC/2009/57903: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 January 2010.

Référence de publication: 2010026964/458.
(100023166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Merwood Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 151.256.

RECTIFICATIF

L'an deux mil dix, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Xavier MANGIULLO, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Avenue Gaston

Diderich,

agissant en sa qualité de président et scrutateur, lors de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire sous-

signé en date du 24 décembre 2009 de la société, à cette date dénommée MERWOOD PROPERTIES LIMITED, une
société existent sous les lois de "Ile of Man", établie et ayant son siège social au Millennium House, Victoria Road, Douglas,
Ile of Man, inscrite sous le numéro 061094C

actuellement dénommée, suite audit acte du 24 décembre 2009, "MERWOOD PROPERTIES S.à.r.l ", ayant son siège

social à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich,

et en sa qualité de mandataire des deux seuls associés détenant l'intégralité du capital social de la prédite société, savoir

les sociétés BASEL ONE LIMITED, avec siège social à First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier. Jersey,

28383

JE23QQ, et GOLDLAND UNIVERSAL LIMITED, avec siege social au 56 Administration Drive, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands

en vertu de 2 procurations restées annexées au susdit acte du 24 décembre 2009 reçu par le notaire soussigné,
2) Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de secrétaire lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2009 de la susdite

société.

Lesquels comparants, agissant es-qualités, déclarent que dans ledit acte du 24 décembre 2009, à la onzième résolution

portant sur la refonte totale des statuts pour les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, l'article 10 (version
anglaise et traduction française) a été érronément indiqué comme suit:

Version anglaise

Art. 10. The corporate years starts on the first of September of each year and finishes on August 31 of the next year.

Traduction française

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante:

alors que cet article 10 aurait dû dire que l'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31

décembre de la même année.

En ces circonstances, il y a lieu de rectifier l'article 10 (version anglaise et traduction française) comme suit:

Version anglaise

Art. 10. The corporate years starts on the first of January of each year and ends on December 31 of the same year.

Traduction française

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Les comparants requièrent le notaire instrumentaire de faire les rectifications nécessaires partout ou cela s'impose.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: X. MANGIULLO, G. SADDI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 2 février 2010, LAC/2010/4952: Reçu douze Euros (EUR 12.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 13 février 2010.

Référence de publication: 2010026966/51.
(100023166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Opengate Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.449.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010026126/9.
(100022416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Cinquestrel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 147.825.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 12 février 2010.

Référence de publication: 2010026295/10.
(100022736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

28384

Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 91.796.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2010.

Référence de publication: 2010026289/10.
(100023075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Tarp International Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 15.602.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010026419/10.
(100023086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Tarp International Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 15.602.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010026420/10.
(100023083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Gaai Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.405.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 27-01-2010.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.
Represented by: / Represented by:
Mr H.H.J. Kemmerling / Mr H.H.J. Kemmerling
Mr F.H.R. Sonnenschein / Mr F.H.R. Sonnenschein

Référence de publication: 2010026217/14.
(100022342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Rapier Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 151.255.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the thirtieth of December.
Before the undersigned Maître Jacques DELVAUX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RAPIER INVESTMENTS LIMITED (hereinafter "the

Company"), a company incorporated under the Law of Grand Cayman, established and having its registered office in 4

th

 Floor Harbour Centre, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

The extraordinary general meeting is opened by Mr Xavier MANGIULLO, employee, residing in Luxembourg, as

Chairman.

28385

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Xavier MANGIULLO, prenamed.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the George

Town, Grand Cayman, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and
fiscal purposes, from the date January 1 

st

 , 2009, without the Company being dissolved and with full corporate and legal

continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with

the name "Rapier Investments S.àr.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the
registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;

3. Approve the interim balance sheet of the Company dated January 1 

st

 , 2009;

4. Change of the purpose of the company as follows:
"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies

both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or
subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences
and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said
object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.".

5. Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxem-

bourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

6. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office,

principal establishment and central administration of the Company from the Grand Cayman to the city of Luxembourg
and further to the complete restatement of the Company's articles of association;

7. Change of the currency of express of the share capital from USD into EUR, basing on the currency rate applicable

at January 1 

st

 ,2009, date of the opening of the present financial year, equal to 1 USD=0.7121 EUR, so that the current

share capital will be 82.606 EUR. The difference resulting from the application of the currency rate at January 1 

st

 , 2009

and the currency rate at the date of the notary deed of conversion, if is negative, will be paid by the contribution of the
same amount equal to the difference between the amount of the share capital of 82.606 EUR and the amount obtained
by the conversion using the currency rate applicable at the date of the conversion, this amount will be down from the
profit brought forward and if it positive will be deposited in a special provision account that can be used only following
the provision for the modification of the share capital;

8. Subsequent amendment of the Articles of association;
9. Allocation to shares of a par value of EUR 1.00;
10. To fix the authorised capital at 900.000,00 Eur (nine hubdred thousand Eur) represented by 900.000 (nine hundred

thousand) shares of a par value of 1,00Eur each.

11. Resignation and appointment of Mr. Robert Michael Churchill, born in Exeter at October 30 

th

 1944, residing in

Granville, La Grande Route De St Cleme, St Clement, Jersey JE2 6QP; Mrs. Julie Coward, born in Solihull at August 10

t

 

h

 , 1956, residing in Le Bocage House, Les Fond De Longueville, Grouville, Jersey, JE3 9AB; Mr. Frank Stuart Gee, born

in Oldenburg at January 16 

th

 ,1952, residing in La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route des Petits Camps, St Helier, Jersey,

JE2 4JP and Ms Letitia Lorretta Cummins, born in Jersey at August 28 

th

 , 1966, residing in 3, La Croix, La Rue Becq,

Trinity, Jersey, JE 5FR, as managers of the Company , all of them for an unlimited period, acting individually or together
with another or others;

12. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

13. Fixing the financial year to run from 1 

st

 January to 31 

st

 December of each year

14. Consequent amendment of The Article of incorporation of the statutes to adapt to the resolutions taken on the

basis of the agenda;

15. Miscellaneous

28386

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of the Company are present

or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on
the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

Furthermore stays added to the present deed:
- a written resolution of the shareholders containing the transfer of domicile dated December 22, 2009;

- a balance sheet on January 1 

st

 , 2009;

- a certificate of good standing dated December 2, 2009;
- an undertaking of notice of transfer dated December 22, 2009.
The Chairman declares that the company will transfer its registered and official office to Luxembourg.
Pursuant to a written resolution of the shareholders of the Company given on December 22, 2009, the transfer of

the registered office, the real management, the central administration and the principal office to Luxembourg, in the forms
required by Luxembourg law, all this without any change of the legal entity was decided. A copy of such document, after
having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

For the execution of this resolution, it is necessary to adjust the articles of incorporation of the company to the law

of the new country of the registered office.

After deliberation, the meeting then adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office, principal establishment and central administration of

the Company from Grand Cayman to the City of Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, Grand Duchy of Luxembourg,
and that starting, for the accounting and fiscal purposes, from the date January 1 

st

 , 2009, without the Company being

dissolved and with full corporate and legal continuance.

<i>Second resolution

The General Meeting decides to adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité

limité) with the name "RAPIER INVESTMENTS S.à r.l.", and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the
transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the interim balance sheet of the Company dated January 1, 2009.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to modify the purpose of the company as follows:
"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies

both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or
subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences
and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said
object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves to amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform

them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as
specified in resolution 2 above,

28387

and resolves to acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the

registered office, principal establishment and central administration of the Company from Road Town, British Virgin
Islands, the city of Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association

<i>Sixth resolution

The General Meeting resolves to change the currency of expression of the share capital from USD into EUR, based

on the currency rate applicable on January 1, 2009, equal to 1 USD = 0,7121 EUR,

so that the current share capital of USD 116,002 will be EUR 82,606.
The difference resulting from the application of the currency rate at January 1, 2009 and the currency rate at the date

of the present deed, being 1.-USD = 0,703 EUR, making the amount of EUR 1,369,80 will be paid by the debit of the same
amount from the account called "profit and loss account".

account that can be used only following the provision for the modification of the share capital.

<i>Seventh resolution

The General Meeting resolves to replace the 116,002 existing shares by 82,606 shares with a par value of EUR 1 each,

allocated to the 2 actual shareholders as follows:

- BASEL ONE LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier. Jersey, JE23QQ
- GOLDLAND UNIVERSAL LIMITED, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,605 shares
56 Administration Drive, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,606 shares

<i>Eighth resolution

The General Meeting accepts the resignation of the former managers of the company and appoints the same persons:
- Mr Robert Michael Churchill, born in Exeter at October 30 

th

 1944, residing in Granville, La Grande Route De St

Cleme, St Clement, Jersey JE2 6QP;

- Mrs Julie Coward, born in Solihull at August 10 

th

 , 1956, residing in Le Bocage House, Les Fond De Longueville,

Grouville, Jersey, JE3 9AB;

- Mr Frank Stuart Gee, born in Oldenburg at January 16 

th

 ,1952, residing in La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route

des Petits Camps, St Helier, Jersey, JE2 4JP

- Ms Letitia Lorretta Cummins, born in Jersey at August 28 

th

 , 1966, residing in 3, La Croix, La Rue Becq, Trinity,

Jersey, JE 5FR,

as managers of the Company, all of them for an unlimited period

<i>Ninth resolution

The General Meeting confirms the establishment of the registered office at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Sole Shareholder confirms that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Cayman Islands

nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to
own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of Cayman
Islands nationality.

<i>Tenth resolution

The General Meeting resolves to fix the financial year to run from the 1 

st

 of January to the 31 

st

 of December of each

year.

<i>Eleventh resolution

The General Meeting, in conformity with the above taken resolutions, resolves to amend the Articles of Association,

which after total update to conform them to the Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

ARTICLES OF INCORPORATION

Art. 1. The company has as denomination RAPIER INVESTMENTS S.à r.l..

Art. 2. The registered office is set in Luxembourg.

Art. 3. "The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other

companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contribu-
tions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents
and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked
to the said object.

28388

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. The corporate capital is set at Eur 82,606, divided into 82,606 shares with a nominal value of Eur 1 (one euro)

each, fully paid-up.

Art. 6. The shares are freely transferable among the existing shareholders. To non shareholders they can only be

transferred in the limits foreseen by law.

Art. 7. In case the company was to have only one single shareholder, the decisions are taken by this single shareholder

and will be put in writing and will be recorded under the form of minutes.

Art. 8. The company is managed by one or more Manager(s) (gérants), shareholders or not, designated by the meeting

of shareholders deciding at the simple majority of the shares as stipulated in article 12 for the meetings of shareholders
not modifying the articles of association.

The sole Manager may accomplish all acts of administration and disposition necessary or useful for the accomplishment

of the corporate object except for those reserved by law to the decision of the shareholders.

In case several Managers are appointed, their joint signature is necessary in order to validly bind the company, unless

special delegation.

The mandate of the Manager(s) may be granted for a limited or unlimited period.

Art. 9. The company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the

shareholders. In case of death of a shareholder, the company will continue to run among the heirs of the sole shareholder
who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away, all this
in the limits of article 189 of the company law.

The company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person

among themselves in order to represent them vis-à-vis of the company.

The heirs and creditors may not, under whatever argument whatsoever, ask to have seals put on the assets and

documents of the company nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the company.
With reference to the exercise of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the
shareholders.

Art. 10. The corporate years starts on the first of September of each year and finishes on August 31 of the next year.

Art. 11. The company will be dissolved pursuant to the legal prescriptions.

Art. 12. The decisions not amending the articles of association are not taken validly unless they are approved by

shareholders representing more than half of the shares. If because of absence or abstention of shareholders, this figure
cannot be obtained in a first meeting or written consultation the shareholders are called or consulted a second time by
registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast under the condition that they concern only
matters examined in the first meeting or consultation.

The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the company. All other amendments

of the articles of association are decided at a majority of the shareholders representing the three quarters of the corporate
capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.

In case the company has only one shareholder, the authority of the meeting of shareholders is attributed to the sole

shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.

Art. 13. With reference to all other points not specifically regulated by the present articles of association, the share-

holders are subject to the existing legal regulations

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 3,000.-.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

28389

The document having been read to the proxy holder, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire, de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de RAPIER INVESTMENTS LIMITED (ci-après la Société),

une société constituée sous les lois des Grand Cayman, établie et ayant son siège social au 4 

th

 Floor Harbour Centre,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

L'assemblée est présidée par M. Xavier MANGIULLO, employé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire M. Gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur M. Xavier MANGIULLO, précité.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the George

Town, Grand Cayman, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and
fiscal purposes, from the date January 1 

st

 , 2009, without the Company being dissolved and with full corporate and legal

continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with

the name "Rapier Investments S.àr.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the
registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;

3. Approve the interim balance sheet of the Company dated January 1 

st

 , 2009;

4. Change of the purpose of the company as follows:
"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies

both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or
subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences
and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said
object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.".

5. Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxem-

bourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

6. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office,

principal establishment and central administration of the Company from the Grand Cayman to the city of Luxembourg
and further to the complete restatement of the Company's articles of association;

7. Change of the currency of express of the share capital from USD into EUR, basing on the currency rate applicable

at January 1 

st

 ,2009, date of the opening of the present financial year, equal to 1 USD=0.7121 EUR, so that the current

share capital will be 82.606 EUR. The difference resulting from the application of the currency rate at January 1 

st

 ,2009

and the currency rate at the date of the notary deed of conversion, if is negative, will be paid by the contribution of the
same amount equal to the difference between the amount of the share capital of 82.606 EUR and the amount obtained
by the conversion using the currency rate applicable at the date of the conversion, this amount will be down from the
profit brought forward and if it positive will be deposited in a special provision account that can be used only following
the provision for the modification of the share capital;

8. Subsequent amendment of the Articles of association;
9. Allocation to shares of a par value of EUR 1.00;
10. To fix the authorised capital at 900.000,00 Eur (nine hundred thousand Eur) represented by 900.000 (nine hundred

thousand) shares of a par value of 1,00Eur each.

11. Resignation and appointment of Mr. Robert Michael Churchill, born in Exeter at October 30 

th

 1944, residing in

Granville, La Grande Route De St Cleme, St Clement, Jersey JE2 6QP; Mrs. Julie Coward, born in Solihull at August 10

th

 , 1956, residing in Le Bocage House, Les Fond De Longueville, Grouville, Jersey, JE3 9AB; Mr. Frank Stuart Gee, born

in Oldenburg at January 16 

th

 ,1952, residing in La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route des Petits Camps, St Helier, Jersey,

JE2 4JP and Ms Letitia Lorretta Cummins, born in Jersey at August 28 

th

 , 1966, residing in 3, La Croix, La Rue Becq,

28390

Trinity, Jersey, JE 5FR, as managers of the Company , all of them for an unlimited period, acting individually or together
with another or others;

12. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

13. Fixing the financial year to run from 1 

st

 January to 31 

st

 December of each year

14. Consequent amendment of The Article of incorporation of the statutes to adapt to the resolutions taken on the

basis of the agenda;

15. Miscellaneous
II. Que les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont

indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents,
les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront
annexés au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.
III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Monsieur le Président déclare que la société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxembourg.
Conformément à une décision écrite prise les associés en date du 22 décembre 2009, il a été décidé le transfert du

siège statutaire, l'administration centrale, le siège de direction effectif et le principal établissement de la société vers le
Grand-Duché de Luxembourg, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, sans changement de la
personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption. Une copie de cette décision reste annexée au présent acte
avec lequel elle sera formalisée.

Pour l'exécution de la susdite décision, il est nécessaire d'adapter les statuts de la société à la loi du nouveau pays du

siège social.

De plus restent annexés au present acte:
- une résolution écrite des associés renseignant le transfert de siège daté du 22 décembre 2009;
- une situation comptable au 1 

er

 janvier 2009;

- un certificat of "good standing" daté du 2 décembre 2009,
- un "undertaking of notice of transfer" daté du 22 décembre 2009
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide que le siège social statutaire, la direction effective, l'administration centrale et le principal établis-

sement de la société est transféré de George Town, Grand Cayman, à Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, Grand-
Duché de Luxembourg, le tout sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide que la société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous

la dénomination de "RAPIER INVESTMENTS S.à r.l." suite au transfert du siège social statutaire, de la direction effective,
de l'administration centrale et du principal établissement de la société vers le Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'approuver la situation intérimaire de la société arrêtée au 1 

er

 janvier 2009.

<i>Quatrième résolution

L'Associé  Unique  décide  ensuite  de  modifier  les  statuts  de  la  société  dans  la  mesure  nécessaire  pour  les  rendre

conformes à la législation luxembourgeoise,

et plus particulièrement à ce sujet décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
"La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises

et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise
en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation."

28391

<i>Cinquième résolution

L'Associé  Unique  décide  ensuite  de  modifier  les  statuts  de  la  société  dans  la  mesure  nécessaire  pour  les  rendre

conformes à la législation luxembourgeoise, pour leur donner la version coordonnée dont question ci-après.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier la devise du capital de USD en EURO au taux de change du 1 

er

 janvier 2009, savoir:

1,- USD = 0,7121 EUR,

de sorte que le capital sociale actuel de USD 116.002, sera de EUR 82.666,
La différence résultant de l'application du cours de change au 1 

er

 décembre 2009 et le cours de change applicable à

la date du présent acte savoir 1.-USD = EUR 0,703, soit la somme de EUR 1369,80 est à payer par le débit du même
montant du compte "résultats reportés".

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de remplacer les 116.002 actuelles parts sociales par 82.606 parts sociales d'une valeur nominale

de EUR 1 par part sociale, attribuées aux 2 actuels associés comme suit:

- BASEL ONE LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier. Jersey, JE23QQ
- GOLDLAND UNIVERSAL LIMITED., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.605 parts
56 Administration Drive, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.606 parts

<i>Huitième résolution

L'assemblée accepte les démission des anciens gérants et décide de nommer les mêmes personnes, savoir:
- M. Robert Michael Churchill, né à Exeter le 30 octobre 1944, demeurant à Granville, La Grande Route De St Cleme,

St Clement, Jersey JE2 6QP;

- Mme Julie Coward, née à Solihull le 10 août 1956, demeurant à Le Bocage House, Les Fond De Longueville, Grouville,

Jersey, JE3 9AB;

- M. Frank Stuart Gee, né à Oldenburg le 16 janvier 1952, demeurant à La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route des

Petits Camps, St Helier, Jersey, JE2 4JP

- Mlle Letitia Lorretta Cummins, née à Jersey le 28 août 1966, demeurant au 3, La Croix, La Rue Becq, Trinity, Jersey,

JE 5FR,

comme nouveaux gérants de la société, tous pour une durée illimitée.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée confirme l'établissement du siège social de la société au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg.
L'Assemblée confirme que tous les actifs et passifs de la société précédemment de nationalité des Cayman islands

restent  sans  limitation  et  dans  leur  entièreté  la  propriété  de  la  société  luxembourgeoise,  laquelle  continuera  à  être
propriétaire de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment de
nationalité de Cayman Islands.

<i>Dixième résolution

L'Assemblée décide que l'exercice social court du 1 

er

 janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.

<i>Onzième résolution

L'Assemblée, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier les statuts qui, après refonte totale pour les

mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, auront désormais la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination RAPIER INVESTMENTS S.àr.l. .

Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg

Art. 3. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

28392

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 82.606, divisé en 82.606 parts sociales, d'une valeur nominale de

EUR 1 (un Euro), chacune entièrement libérée.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les limites

prévues par la loi.

Art. 7. Au cas où la société ne devait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont

retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.

Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée

des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l'article 12 pour les assemblées non modi-
ficatives des statuts.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplis-

sement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.

En cas de nomination de plusieurs gérants, leur signature conjointe est exigée pour engager valablement la société,

sauf délégation spéciale.

Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l'associé décédé tout ceci dans les limites de l'article 189 de la loi sur les sociétés. La société
ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les
représenter au regard de la société.

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens

et  documents  de  la  société,  ni  s'immiscer  en  aucune  manière  dans  les  actes  de  son  administration;  ils  doivent  pour
l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.

Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.

Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des

associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre
n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications

statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun
cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Lorsque la société n'a qu'un seul associé les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à

l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.

Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en

vigueur

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société en raison des présentes à EUR 3.000,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: X. MANGIULLO, G. SADDI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 4 janvier 2010, LAC/2010/203: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

28393

- Pour expédition conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 9 February 2010.

Référence de publication: 2010026959/440.
(100023172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Rapier Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 151.255.

RECTIFICATIF

L'an deux mil dix, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Xavier MANGIULLO, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Avenue Gaston

Diderich,

agissant en sa qualité de président et scrutateur, lors de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire sous-

signé en date du 29 décembre 2009 de la société, à cette date dénommée RAPIER INVESTMENTS LIMITED (ci-après la
Société), une société constituée sous les lois des Grand Cayman, établie et ayant son siège social au 4 

th

 Floor Harbour

Centre, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

actuellement dénommée, suite audit acte du 29 décembre 2009, "RAPIER INVESTMENTS S.à.r.l", ayant son siège social

à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich,

et en sa qualité de mandataire des deux seuls associés détenant l'intégralité du capital social de la prédite société, savoir

les sociétés BASEL ONE LIMITED, avec siège social à First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier. Jersey,
JE23QQ, et GOLDLAND UNIVERSAL LIMITED, avec siege social au 56 Administration Drive, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands

en vertu de 2 procurations restées annexées au susdit acte du 29 décembre 2009 reçu par le notaire soussigné,
2) Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de secrétaire lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2009 de la susdite

société.

Lesquels comparants, agissant ès qualités, déclarent que dans ledit acte du 29 décembre 2009, à la onzième résolution

portant sur la refonte totale des statuts pour les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, l'article 10 (version
anglaise et traduction française) a été érronément indiqué comme suit:

Version anglaise

Art. 10. The corporate years starts on the first of September of each year and finishes on August 31 of the next year.

Traduction française

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante

alors que cet article 10 aurait du dire que l'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31

décembre de la même année.

En ces circonstances, il y a lieu de rectifier l'article 10 (version anglaise et traduction française) comme suit:

Version anglaise

Art. 10. The corporate years starts on the first of January of each year and ends on December 31 of the same year.

Traduction française

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Les comparants requièrent le notaire instrumentaire de faire les rectifications nécessaires partout ou cela s'impose.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: X. MANGIULLO, G. SADDI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 2 février 2010, LAC/2010/4951: Reçu douze Euros (EUR 12.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

28394

- Pour expédition conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 13 février 2010.

Référence de publication: 2010026962/51.
(100023172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Mistral RE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.303.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 31 décembre

2009, enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2010, LAC/2010/756, que l'assemblée a décidé de clôturer la liquidation
et a pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relatif aux sociétés commerciales et conformément
à l'article 9 de ladite loi.

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: c/o Citco

REIF Services (Luxembourg) S.A., 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

<i>Pour la société
Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010026663/20.
(100022771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

BK Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 76.781.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010026169/9.
(100022177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Adapto SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 114.598.

EXTRAIT

Monsieur Rudolf Kömen a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 31 décembre 2009.
Lors de la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue le 15 décembre 2009 il a été décidé de coopter Monsieur

Patrik Burnäs à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Rudolf Kömen. Le mandat de Monsieur Patrik
Burnäs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2010.

La nomination de Monsieur Patrik Burnäs sera ratifiée à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
De ce fait, le conseil d'administration se compose au 1 

er

 janvier 2010 comme suit:

Monsieur Per Mikael Lennart Guldstrand avec adresse professionnelle à S-11157 Stockholm, 4 Oxtorgsgatan, président

du conseil d'administration

Monsieur Carl Jesper Almkvist avec adresse professionnelle à S-11157 Stockholm, 4 Oxtorgsgatan, vice-président du

conseil d'administration

Madame Ann-Charlotte Lawyer avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Interna-

tionale

Monsieur Gavin Byrnes avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale.
Monsieur Patrik Burnäs avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale

28395

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010026680/24.
(100023005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Sico S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 53.786.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 11 février 2010

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. Management s.à r.l., ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Lu-

xembourg, représentée par Monsieur Edward Patteet, représentant permanent, résidant professionnellement au 16, rue
de Nassau, L-2213 Luxembourg; A.T.T.C. Directors s.à r.l. ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
représentée par Monsieur Jean Pierre Van Keymeulen, représentant permanent résidant professionnellement au 16, rue
de Nassau, L-2213 Luxembourg et A.T.T.C. Services s.à r.l. ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
représentée par Monsieur Edward Patteet, représentant permanent résidant professionnellement au 16, rue de Nassau,
L-2213 Luxembourg ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. Control s.a., étant venus à échéance, les ad-
ministrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. s.a / A.T.T.C. s.a.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010026674/24.
(100022741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Brunel Properties S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 151.252.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of December.
Before the undersigned Maître Jacques DELVAUX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BRUNEL PROPERTIES LIMITED, a company in-

corporated under the Law of Ile of Man, established and having its registered office at Millennium House, Victoria Road,
Douglas, Ile of Man, with the register number N. 057669C (the "Company").

The extraordinary general meeting is opened by Mr Xavier MANGIULLO, employee, residing in Luxembourg, as

Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Xavier MANGIULLO, prenamed.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the Dou-

glas, Ile of Man, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and fiscal
purposes, from the date January 1 

 

s

 t 

 , 2009, without the Company being dissolved and with full corporate and legal

continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with

the  name  "Brunel  Properties  S.à  r.l."  and  acceptance  of  the  Luxembourg  nationality  arising  from  the  transfer  of  the
registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;

3. Change of the purpose of the company as follows:
"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies

both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or

28396

subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences
and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said
object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.".

4. Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxem-

bourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

5. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office,

principal establishment and central administration of the Company from the Douglas, Ile of Man to the city of Luxembourg
and further to the complete restatement of the Company's articles of association;

6. Change of the currency of express of the share capital from GBP into EUR, basing on the currency rate applicable

at January 1 

st

 , 2009, date of the opening of the present financial year, equal to 1 GBP=1.0385 EUR, so that the current

share capital of 2 GBP will be 2,08 EUR. The difference resulting from the application of the currency rate at January 1

st

 , 2009 and the currency rate at the date of the notary deed of conversion, if is negative, will be paid by the contribution

of the same amount equal to the difference between the amount of the share capital of 2,08 EUR and the amount obtained
by the conversion using the currency rate applicable at the date of the conversion, this amount will be down from the
profit brought forward and if it positive will be deposited in a special provision account that can be used only following
the provision for the modification of the share capital;

7. Increase of the capital subscribed of 12.497.92 Eur in order to bring it from its actual amount of 2,08 Eur up to

12.500,00 Eur by the increase of the nominal value of the present shares, with the same rights and advantages of the
existing shares

8. Allocation to shares of a par value of EUR 1.00 by replacement of the 2 existing shares with 12.500 shares of nominal

value of 1,00 eur each to assign to the shareholders with the same "prorata" as per the existing owned shares.

9. Subsequent amendment of the Articles of association;
10. Confirmation of Mr. Robert Michael Churchill, born in Exeter at October 30 

th

 1944, residing in Granville, La

Grande Route De St Cleme, St Clement, Jersey JE2 6QP; Mrs Julie Coward, born in Solihull at August 10 

th

 , 1956, residing

in Le Bocage House, Les Fond De Longueville, Grouville, Jersey, JE3 9AB; Mr Frank Stuart Gee, born in Oldenburg at
January 16 

th

 ,1952, residing in La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route des Petits Camps, St Helier, Jersey, JE2 4JP and

Ms Letitia Lorretta Cummins, born in Jersey at August 28 

th

 , 1966, residing in 3, La Croix, La Rue Becq, Trinity, Jersey,

JE 5FR, as managers of the Company , all of them for an unlimited period, acting individually or together with another or
others;

11. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

12. Fixing the financial year to run from 1 

st

 January to 31 December of each year

13. Consequent amendment of The Article of incorporation of the statutes to adapt to the resolutions taken on the

basis of the agenda;

14. Miscellaneous
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of the Company are present

or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on
the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

Furthermore stays added to the present deed:
- a certificate of standing of the "Financial Supervisory Commission of Isle of Man", dated November 16, 2009;
- a certificate containing the transfer of domicile dated December 21 

st

 , 2009;

- a declaration of solvency given by a director of the Company dated November 24, 2009;
- an irrevocable undertaking of acceptance of services of legal process;
- a balance sheet on January 1 

st

 , 2009 and a valuation certificate;

28397

- a legal opinion of POPE &amp; CO SOLICITORS
The Chairman declares that the company will transfer its registered and official office to Luxembourg.
Pursuant to a written resolution of the Board of Directors of the Company given in Jersey on November 12, 2009,

the transfer of the registered office, the real management, the central administration and the principal office to Luxem-
bourg, in the forms required by Luxembourg law, all this without any change of the legal entity was decided. A copy of
such document, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

For the execution of this resolution, it is necessary to adjust the articles of incorporation of the company to the law

of the new country of the registered office.

After deliberation, the meeting then adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office, principal establishment and central administration of

the Company from Douglas, Ile of Man, to the City of Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, Grand Duchy of Lu-
xembourg, and that starting, for the accounting and fiscal purposes, from the date January 1 

st

 , 2009, without the Company

being dissolved and with full corporate and legal continuance

<i>Second resolution

The General Meeting decides to adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité

limité) with the name "Brunel Properties S.à r.l.", and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer
of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to modify the purpose of the company as follows:
"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies

both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or
subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences
and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said
object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform

them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as
specified in resolution 2 above,

and resolves to acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the

registered office, principal establishment and central administration of the Company from Douglas, Ile of Man, the city of
Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves to change the currency of expression of the share capital from GBP into EUR, based

on the currency rate applicable on January 1 

st

 , 2009, date of the opening of the present financial year, equal to 1 GBP

= 1.0385 EUR,

so that the current share capital of 2 GBP will be 2.08 EUR.
The difference resulting from the application of the currency rate at 1 

st

 January 2009 and the currency rate at the

date of the present deed, being 1.-GBP = 1.1128 EUR, making the amount of EUR 0,1456 will be deposited in a special
provision account that can be used only following the provision for the modification of the share capital

<i>Sixth resolution

After  the  change  of  currency,  the  General  Meeting  resolves  to  increase  the  share  capital  by  an  amount  of  EUR

12,497.92,

In order to bring it from its present amount of EUR 2.08 to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro),
without issuance of new shares but by the increase of the par value of the existing 2 shares to EUR 6,250,

28398

entirely paid up in cash by the two actual shareholders, so that the amount of EUR 12,497.92 is at the free disposal of

the company from now on, so as this has been shown to the notary pursuant to a bank certificate

<i>Seventh resolution

The General Meeting resolves to replace the 2 existing shares by 12,500 shares with a par value of EUR 1 each, allocated

to the 2 actual shareholders as follows:

- BASEL ONE LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250 shares

First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier. Jersey, JE23QQ
- GOLDLAND UNIVERSAL LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250 shares

56 Administration Drive, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares

<i>Eighth resolution

The General Meeting accepts the resignation of the former managers of the company and appoints the same persons:
- Mr Robert Michael Churchill, born in Exeter at October 30 

th

 1944, residing in Granville, La Grande Route De St

Cleme, St Clement, Jersey JE2 6QP;

- Mrs Julie Coward, born in Solihull at August 10 

th

 , 1956, residing in Le Bocage House, Les Fond De Longueville,

Grouville, Jersey, JE3 9AB;

- Mr Frank Stuart Gee, born in Oldenburg at January 16 

th

 ,1952, residing in La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route

des Petits Camps, St Helier, Jersey, JE2 4JP

- Ms Letitia Lorretta Cummins, born in Jersey at August 28 

th

 , 1966, residing in 3, La Croix, La Rue Becq, Trinity,

Jersey, JE 5FR,

as managers of the Company, all of them for an unlimited period

<i>Ninth resolution

The General Meeting confirms the establishment of the registered office at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Sole Shareholder confirms that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Ile of Man natio-

nality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to own
all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of Ile of Man
nationality.

<i>Tenth resolution

The General Meeting resolves to fix the financial year to run from the 1 

st

 of January to the 31 

st

 of December of each

year.

<i>Eleventh resolution

The General Meeting, in conformity with the above taken resolutions, resolves to amend the Articles of Association,

which after total update to conform them to the Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

ARTICLES OF INCORPORATION

Art. 1. The company has as denomination Brunel Properties S.àr.l..

Art. 2. The registered office is set in Luxembourg.

Art. 3. "The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other

companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contribu-
tions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents
and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked
to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. The corporate capital is set at Eur 12,500 (twelve thousand five hundred euro) divided into 12,500 (twelve

thousand five hundred) shares with a nominal value of Eur 1 (one euro) each, fully paid-up.

28399

Art. 6. The shares are freely transferable among the existing shareholders. To non shareholders they can only be

transferred in the limits foreseen by law.

Art. 7. In case the company was to have only one single shareholder, the decisions are taken by this single shareholder

and will be put in writing and will be recorded under the form of minutes.

Art. 8. The company is managed by one or more Manager(s) (gérants), shareholders or not, designated by the meeting

of shareholders deciding at the simple majority of the shares as stipulated in article 12 for the meetings of shareholders
not modifying the articles of association.

The sole Manager may accomplish all acts of administration and disposition necessary or useful for the accomplishment

of the corporate object except for those reserved by law to the decision of the shareholders.

In case several Managers are appointed, their joint signature is necessary in order to validly bind the company, unless

special delegation.

The mandate of the Manager(s) may be granted for a limited or unlimited period.

Art. 9. The company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the

shareholders. In case of death of a shareholder, the company will continue to run among the heirs of the sole shareholder
who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away, all this
in the limits of article 189 of the company law.

The company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person

among themselves in order to represent them vis-à-vis of the company.

The heirs and creditors may not, under whatever argument whatsoever, ask to have seals put on the assets and

documents of the company nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the company.
With reference to the exercise of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the
shareholders.

Art. 10. The corporate years starts on the first of September of each year and finishes on August 31 of the next year.

Art. 11. The company will be dissolved pursuant to the legal prescriptions.

Art. 12. The decisions not amending the articles of association are not taken validly unless they are approved by

shareholders representing more than half of the shares. If because of absence or abstention of shareholders, this figure
cannot be obtained in a first meeting or written consultation the shareholders are called or consulted a second time by
registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast under the condition that they concern only
matters examined in the first meeting or consultation.

The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the company. All other amendments

of the articles of association are decided at a majority of the shareholders representing the three quarters of the corporate
capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.

In case the company has only one shareholder, the authority of the meeting of shareholders is attributed to the sole

shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.

Art. 13. With reference to all other points not specifically regulated by the present articles of association, the share-

holders are subject to the existing legal regulations

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 3,000.-.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire, de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de BRUNEL PROPERTIES LIMITED, une société existent

sous les lois de "Ile of Man", établie et ayant son siège social au Millennium House, Victoria Road, Douglas, Ile of Man,
inscrite sous le numéro 057669C (la "Société").

L'assemblée est présidée par Mr Xavier MANGIULLO, employé, demeurant à Luxembourg,

28400

qui désigne comme secrétaire Mr Gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mr Xavier MANGIULLO, précité.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the Dou-

glas, Ile of Man, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and that starting, for the accounting and fiscal
purposes, from the date January 1 

st

 , 2009, without the Company being dissolved and with full corporate and legal

continuance;

2. Have the Company adopt the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with

the  name  "Brunel  Properties  S.à  r.l."  and  acceptance  of  the  Luxembourg  nationality  arising  from  the  transfer  of  the
registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;

3. Change of the purpose of the company as follows:
"The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies

both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or
subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences
and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said
object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.".

4. Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxem-

bourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

5. Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office,

principal establishment and central administration of the Company from the Douglas, Ile of Man to the city of Luxembourg
and further to the complete restatement of the Company's articles of association;

6. Change of the currency of express of the share capital from GBP into EUR, basing on the currency rate applicable

at January 1 

st

 , 2009, date of the opening of the present financial year, equal to 1 GBP=1.0385 EUR, so that the current

share capital of 2 GBP will be 2,08 EUR. The difference resulting from the application of the currency rate at January 1

st

 , 2009 and the currency rate at the date of the notary deed of conversion, if is negative, will be paid by the contribution

of the same amount equal to the difference between the amount of the share capital of 2,08 EUR and the amount obtained
by the conversion using the currency rate applicable at the date of the conversion, this amount will be down from the
profit brought forward and if it positive will be deposited in a special provision account that can be used only following
the provision for the modification of the share capital;

7. Increase of the capital subscribed of 12.497.92 Eur in order to bring it from its actual amount of 2,08 Eur up to

12.500,00 Eur by the increase of the nominal value of the present shares, with the same rights and advantages of the
existing shares

8. Allocation to shares of a par value of EUR 1.00 by replacement of the 2 existing shares with 12.500 shares of nominal

value of 1,00 eur each to assign to the shareholders with the same "prorata" as per the existing owned shares.

9. Subsequent amendment of the Articles of association;
10. Confirmation of Mr. Robert Michael Churchill, born in Exeter at October 30 

th

 1944, residing in Granville, La

Grande Route De St Cleme, St Clement, Jersey JE2 6QP; Mrs. Julie Coward, born in Solihull at August 10 

th

 , 1956, residing

in Le Bocage House, Les Fond De Longueville, Grouville, Jersey, JE3 9AB; Mr. Frank Stuart Gee, born in Oldenburg at
January 16 

th

 ,1952, residing in La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route des Petits Camps, St Helier, Jersey, JE2 4JP and

Ms Letitia Lorretta Cummins, born in Jersey at August 28 

th

 , 1966, residing in 3, La Croix, La Rue Becq, Trinity, Jersey,

JE 5FR, as managers of the Company , all of them for an unlimited period, acting individually or together with another or
others;

11. Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 5, Avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

12. Fixing the financial year to run from 1 

st

 January to 31 December of each year

13. Consequent amendment of The Article of incorporation of the statutes to adapt to the resolutions taken on the

basis of the agenda;

14. Miscellaneous

28401

II. Que les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont

indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents,
les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront
annexés au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.
III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Monsieur le Président déclare que la société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxembourg.
Conformément à une décision écrite prise le conseil d'administration de la société à Jersey en date du 12 novembre

2009. il a décidé le transfert du siège statutaire, l'administration centrale, le siège de direction effectif et le principal
établissement de la société vers le Grand-Duché de Luxembourg, dans les formes et conditions prévues par la loi lu-
xembourgeoise, sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption. Une copie de cette
décision reste annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Pour l'exécution de la susdite décision, il est nécessaire d'adapter les statuts de la société à la loi du nouveau pays du

siège social.

De plus restent annexés au present acte:
- un "Certificate of standing" délivré par le Financial Supervisory Commission of Isle of Man, daté du 16 novembre

2009;

- un certificat renseignant le transfert de siège daté du 21 décembre 2009;
- une "declaration of solvency" délivrée par un administrateur de la société datée du 24 novembre 2009;
- un "irrevocable undertaking of acceptance of services of legal process";
- une situation comptable au 1 

er

 janvier 2009 ainsi qu'un certificat d'évaluation;

- un "legal opinion" délivré par POPE &amp; CO SOLICITORS
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide que le siège social statutaire, la direction effective, l'administration centrale et le principal établis-

sement de la société est transféré de Douglas, Ile of Man, à Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, Grand-Duché de
Luxembourg, le tout sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide que la société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous

la dénomination de "Brunel Properties S.à r.l." suite au transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de
l'administration centrale et du principal établissement de la société vers le Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de changer l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et

étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise
en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide ensuite de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation luxembourgeoise, pour leur donner la version coordonnée dont question ci-après.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier la devise du capital de GBP en EURO au taux de change du 1 

er

 janvier 2009, savoir:

1,- GBP = 1,0385 EUR,

de sorte que le capital sociale actuel de GBP 2, sera de EUR 2,08, représentée par 2 parts sociales sans désignation de

valeur nominale.

28402

La différence résultant de l'application du cours de change au 1 

er

 janvier 2009 et le cours de change applicable à la

date du présent acte savoir 1.-GBP = EUR 1,1128, soit la somme de EUR 0,1456 est versée à un compte de réserve dont
il ne pourra être disposée qu'en observant les règles sur la modification du capital social

<i>Sixième résolution

Suite à la conversion de devise qui précède, l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR

12.497,92,

afin de le porter de son montant actuel de EUR 2,08 à EUR 12,500 (douze mille cinq cents Euros ),
sans émission de parts sociales nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 2 parts sociales actuelles

à EUR 6.250 par part sociale

entièrement libérée par un versement en numéraire par les actuels associés, de sorte que le montant de EUR 12.497,92

est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au Notaire par un certificat bancaire.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de remplacer les 2 actuelles parts sociales par 12.500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR

1 par part sociale, attribuées aux 2 actuels associés comme suit:

- BASEL ONE LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250 parts

First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier. Jersey, JE23QQ
- GOLDLAND UNIVERSAL LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250 parts

56 Administration Drive, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 parts

<i>Huitième résolution

L'assemblée accepte les démission des anciens gérants et décide de nommer les mêmes personnes, savoir
- M. Robert Michael Churchill, né à Exeter le 30 octobre 1944, demeurant à Granville, La Grande Route De St Cleme,

St Clement, Jersey JE2 6QP;

- Mme Julie Coward, née à Solihull le 10 août 1956, demeurant à Le Bocage House, Les Fond De Longueville, Grouville,

Jersey, JE3 9AB;

- M. Frank Stuart Gee, né à Oldenburg le 16 janvier 1952, demeurant à La Renaissance, 3 Bel Respiro, la Route des

Petits Camps, St Helier, Jersey, JE2 4JP

- Mlle Letitia Lorretta Cummins, née à Jersey le 28 août 1966, demeurant au 3, La Croix, La Rue Becq, Trinity, Jersey,

JE 5FR,

comme nouveaux gérants de la société, tous pour une durée illimitée.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée confirme l'établissement du siège social de la société au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg.
L'Assemblée confirme que tous les actifs et passifs de la société précédemment de nationalité de Ile of Man restent

sans limitation et dans leur entièreté la propriété de la société luxembourgeoise, laquelle continuera à être propriétaire
de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment de nationalité de Ile
of Man.

<i>Dixième résolution

L'Assemblée décide que l'exercice social court du 1 

er

 janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.

<i>Onzième résolution

L'Assemblée, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier les statuts qui, après refonte totale pour les

mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, auront désormais la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination Brunel Properties S.àr.l..

Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg

Art. 3. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

28403

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros), divisé en 12.500 (douze

mille cinq cents) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), chacune entièrement libérée.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les limites

prévues par la loi.

Art. 7. Au cas où la société ne devait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont

retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.

Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée

des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l'article 12 pour les assemblées non modi-
ficatives des statuts.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplis-

sement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.

En cas de nomination de plusieurs gérants, leur signature conjointe est exigée pour engager valablement la société,

sauf délégation spéciale.

Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l'associé décédé tout ceci dans les limites de l'article 189 de la loi sur les sociétés. La société
ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les
représenter au regard de la société.

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens

et  documents  de  la  société,  ni  s'immiscer  en  aucune  manière  dans  les  actes  de  son  administration;  ils  doivent  pour
l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.

Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.

Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des

associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre
n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications

statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun
cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Lorsque la société n'a qu'un seul associé les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à

l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.

Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en

vigueur

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société en raison des présentes à EUR 3.000,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: X. MANGIULLO, G. SADDI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 30 décembre 2009, LAC/2009/57899: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

28404

- Pour expédition conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 January 2010.

Référence de publication: 2010026953/457.
(100023162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Brunel Properties S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 151.252.

RECTIFICATIF

L'an deux mil dix, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Xavier MANGIULLO, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Avenue Gaston

Diderich,

agissant en sa qualité de président et scrutateur, lors de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire sous-

signé en date du 24 décembre 2009 de la société, à cette date dénommée BRUNEL PROPERTIES LIMITED, une société
existant sous les lois de "Ile of Man", établie et ayant son siège social au Millennium House, Victoria Road, Douglas, Ile of
Man, inscrite sous le numéro 057669C,

actuellement dénommée, suite audit acte du 24 décembre 2009, "BRUNEL PROPERTIES S. à.r.l", ayant son siège social

à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich,

et en sa qualité de mandataire des deux seuls associés détenant l'intégralité du capital social de la prédite société, savoir

les sociétés BASEL ONE LIMITED, avec siège social à First Floor, International House, 41 The Parade, St Helier. Jersey,
JE23QQ, et GOLDLAND UNIVERSAL LIMITED, avec siege social au 56 Administration Drive, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands

en vertu de 2 procurations restées annexées au susdit acte du 24 décembre 2009 reçu par le notaire soussigné,
2) Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de secrétaire lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2009 de la susdite

société.

Lesquels comparants, agissant es-qualités, déclarent que dans ledit acte du 24 décembre 2009, à la onzième résolution

portant sur la refonte totale des statuts pour les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, l'article 10 (version
anglaise et traduction française) a été érronément indiqué comme suit:

Version anglaise

Art. 10. The corporate years starts on the first of September of each year and finishes on August 31 of the next year.

Traduction française

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante

alors que cet article 10 aurait du dire que l'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et fint le 31

décembre de la même année.

En ces circonstances, il y a lieu de rectifier l'article 10 (version anglaise et traduction française) comme suit:

Version anglaise

Art. 10. The corporate years starts on the first of January of each year and ends on December 31 of the same year.

Traduction française

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Les comparants requièrent le notaire instrumentaire de faire les rectifications nécessaires partout ou cela s'impose.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: X. MANGIULLO, G. SADDI, J. DELVAUX
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 30 décembre 2009, LAC/2010/4958: Reçu douze Euros (EUR 12.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

28405

- Pour expédition conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 13 février 2010.

.

Référence de publication: 2010026954/51.
(100023162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Applied Radio Technology S.A. Holding Company, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 92.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010025672/10.
(100021232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

TKK 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 125.706.

In the year two thousand and nine, on the eight day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TKK SCA, a "Société en Commandite par Actions", incorporated under the laws of Luxembourg, with registered

address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

Being the sole shareholder of, and holding all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in TKK 2 S.à

r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on March 5, 2007, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1024 of May 31, 2007 registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxembourg under number B 125 706.

Duly represented by Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party, acting in the above stated capacity, considered the following agenda:
1) Approval of the interim financial statements of the Company as at October 8, 2009;
2) Decision to dissolve the Company and put it into liquidation;
3) Discharge given to the board of managers of the Company for the performance of their duties from January 1 

st

 ,

2009 until the date of putting the Company into liquidation;

4) Appointment of TKK Holdings, LLC, as liquidator of the Company, and determination of its power.
After having approved the above, the sole shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to approve the interim financial statements of the Company as at October 8, 2009.

<i>Second resolution

It was resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation (the Company subsisting for the

sole purpose of the liquidation).

<i>Third resolution

The meeting decides to grant full discharge to the board of managers of the Company for the performance of their

duties from January 1 

st

 , 2009 until the date of putting the Company into liquidation.

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to appoint as liquidator TKK Holdings, LLC, a company with registered office at 1209 Orange

Street, Wilmington, DE 19801 (New Castle County) State of Delaware (USA).

28406

The meeting resolved that, in performing his duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided by

Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, to carry out any act of
administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of August 10, 1915, on commercial

companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed

by a French translation; at the request of the appearing persons, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.

This document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by its name, first name, civil

status and residence, the said person signed together this original deed with us, the notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le huitième jour du mois d'octobre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TKK SCA, une "Société à Responsabilité Limitée", constituée et existant en vertu des lois de Luxembourg, ayant son

siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

En tant qu'associé unique de, et détenant toutes les douze mille cinq cent (12,500) parts sociales de TKK 2 S.àr.l. (la

"Société") ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée par acte notarié du notaire
instrumentant en date du 5 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"),
numéro 1024 du 31 mai 2007 et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 125 706.

Dûment représenté par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

lui-délivrée sous seing privé, laquelle procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le
notaire susnommé restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en sa capacité précitée, a considéré l'ordre du jour suivant:
1) Approbation des états financiers intérimaires de la société au 8 octobre 2009;
2) Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation;
3) Décharge donné aux membres du conseil de gérance de la société pour l'exercice de leur mandat du 1 

er

 janvier

2009 jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société;

4) Désignation de TKK Holdings,LLC, associé unique, en tant que liquidateur de la Société et octroi de ses pouvoirs.
Après avoir approuvé ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'approuver les états financiers intérimaires de la Société au 8 octobre 2009.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation (la Société subsistant pour les seuls besoins de la

liquidation).

<i>Troisième résolution

L'assemblée décidé de donner décharge aux membres du conseil de gérance pour l'exercice de leur mandat du 1 

er

janvier 2009 jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée a décidé de nommer comme liquidateur: TKK Holdings, LLC, avec siège

social à 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (New Castle County) State of Delaware (USA).

L'assemblée a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus

prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la "Loi") pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit
la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présents.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et

est suivi d'une version française; à la requête de la personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise fera foi.

28407

Après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et demeure, le

mandataire a signé, avec le notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 october 2009. Relation: LAC/2009/42666. Reçu douze euros (12.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010025735/100.
(100021944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

AdriaMedic S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 19, ZARE Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 108.893.

L'an deux mille dix, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AdriaMedic S.A." (numéro

d'identité 2009 22 22 978), avec siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 108.893, constituée sous la dénomination de "MENISTAN HOLDING S.A." suivant acte reçu par le notaire
Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 24 juin 2005, publié au Mémorial C, numéro 1137 du 3 novembre
2005 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Jean-Joseph WAGNER, en date du 9
novembre 2009, publié au Mémorial C, numéro 2316 du 26 novembre 2009, ledit acte contenant notamment changement
de la dénomination sociale en "AdriaMedic S.A.".

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Armand HAMLING, administrateur de sociétés, demeurant

à Soleuvre,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines à L-4384 Ehlerange, 19, ZARE Ouest et

modification subséquente du 2 

ème

 alinéa de l'article 1 

er

 des statuts et de l'article 8 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines à L-4384 Ehlerange,

19, ZARE Ouest.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts et l'article 8 des statuts

pour leur donner la teneur suivante:

A) Version anglaise:

Art. 1. par. 2. The registered office is established in Ehlerange."

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Ehlerange at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the first Monday of June at 11 AM. If said day is a public holiday, the meeting shall be held
the next following working day."

28408

B) Version française:

 Art. 1 

er

 . al. 2.  Le siège social est établi à Ehlerange."

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi de juin à 11.00 heures à Ehlerange au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à environ huit cents euros (€ 800.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: HAMLING, J.M.WEBER, RENTMEISTER, A.WEBER.
Enregistré à Capellen, le 27 janvier 2010. Relation: CAP/2010/302. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 05 février 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010026862/62.
(100023879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

PRO Investment, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 35.662.

En date du 2 décembre 2008, l'assemblée générale a nommé comme administrateur Monsieur Daniel Schaerer de-

meurant à F-88000 Chantraine, 3 allée des Sylphides, en remplacement de Monsieur Thierry de Pascal, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

En date du 1 

er

 décembre 2009, l'assemblée générale a nommé comme commissaire la société PricewaterhouseCoo-

pers SARL, sise à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch en remplacement de Fiduciaire Générale de Luxembourg SA.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Pro Investment
Signature

Référence de publication: 2010025801/16.
(100022349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

LBREP III Immit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.899.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales en date du 08 février 2010 que les dix mille (10,000) parts

sociales ordinaires de la Société ont été transférées de LBREP III Europe Holdings LP à LBREP III Europe S.à r.l, SICAR.

Dès lors, depuis le 08 février 2010, les dix mille (10,000) parts sociales ordinaires de la Société sont détenues par

LBREP III Europe S.à r.l, SICAR.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

28409

Luxembourg, le 10 février 2010.

Pour extrait conforme
LBREP III Immit S.à r.l.
Michael Denny
<i>Category A Manager

Référence de publication: 2010025929/19.
(100022097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

LuxCo 109 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 150.591.

Il résulte du contrat de vente du 26 janvier 2010 que toutes les parts sociales ordinaires de la Société détenues par

TMF Corporate Services S.A., ont été transférées à JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2 S.à r.l., ayant
son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Lu-
xembourg, sous le numéro B 110156, de sorte que JPMorgan European Propery Holding Luxembourg 2 S.à r.l. détient
désormais 500 parts sociales ordinaires de la Société représentant l'entièreté de son capital.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2010.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010025936/19.
(100022168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Vaunage Invest S.A., Société Anonyme,

(anc. Meribel Invest S.A.).

Siège social: L-2172 Luxembourg, 37, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 149.401.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n°57835 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010026109/13.
(100022213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Tourbillon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 66.985.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11.02.2010.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2010026112/12.
(100022074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

28410

TecniStyle Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8008 Strassen, 60, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.256.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11.02.2010.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2010026113/12.
(100021985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

ProLogis Poland VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 71.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010026139/14.
(100021896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

ProLogis Poland V S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 71.113.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010026138/14.
(100021895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

ProLogis Poland VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 71.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010026140/14.
(100021898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

28411

Geocad s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 96.681.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010026141/11.
(100022398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

ProLogis Poland X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010026142/14.
(100021900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

ProLogis Poland XCI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.998.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010026143/14.
(100021904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

ProLogis Poland XCIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.984.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représentée par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010026145/14.
(100021906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

28412

KNEIP ingénieurs-conseils, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 7.743.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010026144/11.
(100022400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

JPMorgan Portfolio Strategies Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 89.734.

Le bilan au 30 Septembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour JPMorgan Portfolio Strategies Funds
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010026146/13.
(100022408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

GSL Immobilière S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8281 Kehlen, 2B, Juddegaass.

R.C.S. Luxembourg E 4.231.

STATUTS

L'an deux mille dix, le 1 

er

 février.

1.- Monsieur Schmitt Luc, né le 12 septembre 1977, demeurant au 2B, Juddegaass à L-8281 Kehlen,
2.- Monsieur Schroeder Guy, né le 20 août 1968, demeurant au 29, rue Thomas Byrne à L-3761 Tétange.
Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination GSL Immobilière S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'exploitation d'immeubles à acquérir, ainsi

que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l'exercice social avec

effet au trente et un décembre de l'année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à
son ou ses coassociés.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Kehlen. Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision des gérants.

Titre II. - Apports, Capital social, Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de mille euros (1.000,- euros) divisé en cent (100) parts sociales de dix

euros (10,- euros) chacune.

Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Schmitt Luc, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

2.- Monsieur Schroeder Guy, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

28413

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de mille

euros (1.000,- euros) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le reconnaissent mu-
tuellement.

Art. 6. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par les autres associés.

Toutefois la transmission à cause de mort à des héritiers en ligne directe ou au conjoint est libre.

En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts à cause de mort à des personnes non

associées les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s'exercera de la façon
suivante:

L'associé qui se propose de céder tout ou partie de ses parts à une personne non associée doit préalablement informer

par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et des nom et adresse du
cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d'acquérir les parts offertes dans la proportion des parts qu'ils
possèdent, devront,  dans  le mois  et par  lettre  recommandée  à la poste,  informer le cédant  de leurs intentions  soit
d'acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur droit de
préemption.

Au cas où, endéans ce délai d'un mois, le droit de préemption n'est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une

assemblée générale doit être convoquée par les soins d'un ou des gérants endéans le délai d'un mois appelée à statuer
sur l'agrément du cessionnaire. En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s'exercera sur base d'un
prix de rachat calculé sur base d'un rapport d'expertise convenu entre parties ou ordonné en justice.

En cas de transmission à cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le conjoint

survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s'exercera sur base d'un prix de rachat calculé con-
formément à l'alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur auteur, requérir
des autres associés survivants s'ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants devront, dans le
mois de la réception de cette réquisition, à faire par lettre recommandée, informer également par lettre recommandée
à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d'exercer leur droit de préemption, soit d'y renoncer.

Au cas où le droit de préemption n'est pas exercé, ou n'est exercé qu'en partie, il est procédé conformément à l'alinéa

trois qui précède.

A défaut d'agréation par les autres associés de l'acheteur des parts proposé par le cédant ou ses héritiers ou ayant

droit, et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non agréés ou l'associé cédant peuvent
provoquer la dissolution anticipée de la société.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu'il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes dans la proportion
de leurs parts d'intérêts dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du Code civil.

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

Art. 11. Chaque part est indivisible à l'égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas

tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Titre III. - Administration de la société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S'il n'existe qu'un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par la seule signature du gérant. S'il y a plusieurs gérants, ils engagent
valablement la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d'achat, transformation
ou de vente immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement et en général les actes d'admi-
nistration ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, sans
que cette énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d'ouverture de crédit ou autres et hypothéquer les biens immo-
biliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

Art. 13. Chaque associé à un droit illimitée de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra en

particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.

28414

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du

ou des gérants et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit convenir l'ordre du jour de
l'assemblée.

Art. 15. Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires,

est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit
à une voix.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2010.

Art. 17. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. Tout associé peut

prendre au siège social communication de l'inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale
ordinaire.

Titre V. - Dissolution et Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par

les associés.

Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le où les liqui-

dateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment, vendre les immeubles à l'amiable
ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de
paiement, régler et acquitter le passif.

Titre VI. - Dispositions générales

Art. 19. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par

la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Assemblée générale

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis

en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l'unanimité, ont pris les résolutions
suivantes:

A) Sont nommés gérants:
Monsieur Schmitt Luc et Monsieur Schroeder Guy, prénommés.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
B) L'adresse de la société est fixée à L-8281 Kehlen, 2B, Juddegaass.

Fait à Kehlen, date qu'en tête des présentes.

Schmitt Luc / Schroeder Guy.

Référence de publication: 2010025898/117.
(100022338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Alleva Immobilière S.e.n.c., Société en nom collectif,

(anc. Entreprise de constructions, de travaux de voirie et de façade Alleva Frères s.e.n.c.).

Siège social: L-4711 Pétange, 97, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 6.699.

L'an deux mil dix, le sept janvier.
Par devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Antonio dit Antoine ALLEVA; entrepreneur, né à Fortaneto (I), le 1 

er

 janvier 1933 (1933 0101 116),

époux de Madame Josiane BOENTGES, demeurant à L- 4711 Pétange, 187, rue d'Athus,

2) Monsieur Enzio ALLEVA, architecte, né à Differdange, le 12 mai 1973 (1973 05 12 115), époux de Madame Sandy

GLODY, demeurant à L-4762 Pétange, 99 route de Niederkorn,

3) Monsieur Silvio ALLEVA, entrepreneur, époux de Madame Rita PRESCUTTI, né à Pétange, le 18 février 1969 (1969

02 18 111), demeurant à L- 4762 Pétange, 75, rue de Niedercorn,

agissant en leur qualité d'associés uniques de la société en nom collectif (Entreprise de constructions, de travaux de

voirie et de façade ALLEVA Frères s.e.n.c, avec siège à L-4711 Pétange, 97, rue d'Athus (RCS Luxembourg B No 6699)
constituée sous seing privé en date du 14 janvier 1964, publié au Mémorial C 8/1964.

28415

Lesquels  comparants  ont requis le  notaire  d'acter le  changement de  la  raison  sociale en  "ALLEVA  IMMOBILIERE

S.e.n.c", et de modifier l'article 3 alinéa 1 

er

 des statuts comme suit:

Art. 3. alinéa 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "ALLIEVA IMMOBILIERE S.e.n.c"

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent dix euro (€ 910,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: ALLEVA A., ALLEVA E., ALLEVA S., D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 14 janvier 2010. Relation: EAC/2010/592. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 19 janvier 2010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010026923/32.
(100023878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

Immo-Promotions Difa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 219, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 52.572.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2009

Le jour 30 décembre 2009, à 11.45 heures, s'est réunie l'assemblée ordinaire de la société pour délibérer sur l'ordre

du jour suivant:

1) Mandat Administrateurs
2) Démission commissaire aux comptes
3) Nomination commissaire aux comptes
Assume la présidence de la séance Monsieur FATONE Michel lequel, après avoir vérifié la présence de tous les ac-

tionnaires et après avoir invité Monsieur Roberto VASTA à la fonction de secrétaire, ouvre la séance.

<i>Deuxième résolution

Sur le deuxième point à l'ordre du jour l'assemblée, à l'unanimité, délibère de renouveler jusqu'à l'assemblée générale

qui se tiendra en l'année 2015 le mandat des administrateurs:

- Monsieur FATONE Giuseppe, ingénieur, né à Luxembourg le 15/01/1972 et domicilié à L-8082 Bertrange, 5, rue

Alphonse München - Administrateur

- Monsieur FATONE Michele, entrepreneur, né à Montemilone (I) le 09/02/1934 et domicilié à L-1941 Luxembourg,

219, route de Longwy - Administrateur

- Madame CARLONE Antonietta, gérante, née à Montemilone (I) le 09/07/1941 et domiciliée à L-1941 Luxembourg,

219, route de Longwy - Administrateur et Administrateur Délégué avec signature individuelle.

<i>Troisième et quatrième résolutions

Le président informe l'assemblée que le commissaire aux comptes mademoiselle FATONE Maria Gabriella a présenté

sa démission et qu'en conséquence il faut nommer un nouveau commissaire aux comptes.

L'assemblée, à l'unanimité, délibère d'accepter la démission du commissaire aux comptes, et de nommer commissaire

aux comptes monsieur VASTA Roberto, né à SPOLETO (I) le 13/11/1944 et domicilié à L-2734 Luxembourg - 39, rue
de Wiltz, et de fixer la durée de son mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.15 heures.

Michele FATONE / Roberto VASTA
<i>Le Président / Le Secrétaire

Référence de publication: 2010026733/33.
(100022975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

28416


Document Outline

Adapto SICAV

AdriaMedic S.A.

Alleva Immobilière S.e.n.c.

Applied Radio Technology S.A. Holding Company

BAEK-IMMO HoldCo S.à r.l.

BK Consulting S.A.

Brunel Properties S.àr.l.

Brunel Properties S.àr.l.

Cinquestrel S.A.

Entreprise de constructions, de travaux de voirie et de façade Alleva Frères s.e.n.c.

European Truck Service Corporation S.A.

Gaai Holding S.A.

Geocad s.à r.l.

GSL Immobilière S.C.I.

Immo-Promotions Difa S.A.

JPMorgan Portfolio Strategies Funds

K200 Finance S.à r.l.

KNEIP ingénieurs-conseils, S.à r.l.

LBREP III Immit S.à r.l.

Lone Star Capital Investments S.à r.l.

LuxCo 109 S.à r.l.

Meribel Invest S.A.

Merwood Properties S.à r.l.

Merwood Properties S.à r.l.

Mistral RE S.à r.l.

Opengate Properties S.A.

PRO Investment

ProLogis Poland VIII S.à r.l.

ProLogis Poland VI S.à r.l.

ProLogis Poland V S.àr.l.

ProLogis Poland XCIII S.à r.l.

ProLogis Poland XCI S.à r.l.

ProLogis Poland X S.à r.l.

Rapier Investments S.à r.l.

Rapier Investments S.à r.l.

Sico S.A.

Socavia III S.à r.l.

Tarp International Holding S.A.

Tarp International Holding S.A.

TecniStyle Sàrl

TKK 2

Tourbillon S.à r.l.

Vaunage Invest S.A.

Xion 3000 S.A.