logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 497

8 mars 2010

SOMMAIRE

Accuracy World Wide S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

23813

Accuracy Worldwide S.Coop.SA  . . . . . . . .

23813

Adergo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23812

Adergo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23812

All & All International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

23810

Anglo American Ferrous Investments  . . .

23838

Anglo Iron Ore Investments  . . . . . . . . . . . .

23849

Ausinium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23851

AZ Euro Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

23839

BtoBe Luxemburg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23811

Bulwell Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23838

Callista Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23813

Copagest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23838

Corporate Express Silver S.à r.l.  . . . . . . . . .

23837

Dominican Entertainment (Luxembourg)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23836

DPD (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

23838

DZ PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23838

Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23837

Financial Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

23813

Five Mounts Real Estate Investments S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23850

Garage Linden S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23854

Hess Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23837

Hubert Jacques Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23812

IIINNOVATION S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23811

Innova Financial Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

23851

Jet Support Services Europe Sàrl  . . . . . . . .

23837

JP Commercial I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23849

Kalea Investments SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23812

Kantec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23849

Kinabalu Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23854

LuxCo 102 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23849

LuxCo 105 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23849

Materials Technics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23810

Mère Nature S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23856

Mouflolux S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23810

M.T.H. Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23850

Nacre Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23856

NSH Ansembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

23849

NSH Hollenfels S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23849

OI-Games S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23850

Ralt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23812

Reech AiM Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23813

Roses Immobilier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23811

Solar Resources Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

23811

Tortoise Income & Growth Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23836

Tortoise US Energy Infrastructure Trust

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23836

Universal Display S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23811

Vision IT Group PSF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

23810

WPP Luxembourg Gamma Sàrl  . . . . . . . . .

23850

23809

Materials Technics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 52.042.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 549/2009 en date du 26 novembre

2009 pardevant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022688/13.
(100017606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

All &amp; All International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 40.791.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 décembre 2009, acte n°582 pardevant

Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022689/14.
(100017603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Vision IT Group PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 82.344.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 02 février 2010.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022703/12.
(100017811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Mouflolux S.A.H., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 38.594.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 décembre 2009, acte n°655 par-

devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022690/14.
(100017600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

23810

Roses Immobilier S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 137.414.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 février 2008, acte n°90 pardevant

Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Jacques DELVAUX
Boîte Postale 320
L-2013 Luxembourg
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022691/16.
(100017598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

IIINNOVATION S.A., Société Anonyme,

(anc. Universal Display S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 109.431.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 02 février 2010.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022704/13.
(100017807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Solar Resources Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 131.619.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 1 

er

 février 2010.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022705/12.
(100017804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

BtoBe Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 74.575.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 1 

er

 février 2010.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022706/12.
(100017802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

23811

Adergo S.A., Société Anonyme,

(anc. Adergo Holding S.A.).

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 63.868.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 1 

er

 février 2010.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022707/13.
(100017797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Ralt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 71.678.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 1 

er

 février 2010.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022708/12.
(100017795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Kalea Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 144.079.

RECTIFICATIF

Les statuts de la société anonyme KALEA INVESTMENTS SA annexés à la présente remplacent et annulent ceux

déposés au RCS en date du 5 février 2009, portant le numéro L090019921.05 et publiés au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations n° 257 du 5 février 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 9 décembre 2009.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010022709/16.
(100017829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Hubert Jacques Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 141.845.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57145 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022712/12.
(100017910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

23812

Callista Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 106.386.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57085 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022714/12.
(100017937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 82.355.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57354 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022715/12.
(100017952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Reech AiM Group, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.129.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57370 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022716/12.
(100017961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Accuracy Worldwide S.Coop.SA, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme,

(anc. Accuracy World Wide S.à r.l.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.110.

In the year two thousand and nine, on the eighth day of October.
Before Us, Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

There appeared:

1.- Mr. Frédéric DUPONCHEL, companies' director, residing in F-92200 Neuilly-sur-Seine, 19 bis, rue Pauline Bor-

ghèse,

represented by Mr. Grégory GUISSARD, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (the Pro-

xyholder),

by virtue of proxy given under private seal on 24 September 2009,
2.- Mr. Christophe SCHMIT, companies' director, residing in F-92100 Boulogne-Billancourt, 21, rue Emile Dunois,
represented by Mr. Grégory GUISSARD, previously named,
by virtue of proxy given under private seal on 24 September 2009,
3.- Mr. Nicolas BARSALOU, companies' director, residing in F-92100 Boulogne-Billancourt, 33, rue Anna Jacquin,
represented by Mr. Grégory GUISSARD, previously named,

23813

by virtue of proxy given under private seal on 24 September 2009,
4.- Mr. Damien GROS, companies' director, residing in F-92130 Issy-les-Moulineaux, 3, Villa Francisco Ferrer,
represented by Mr. Grégory GUISSARD, previously named,
by virtue of proxy given under private seal on 24 September 2009,
5.- Mr. Stéphane PERROTTO, companies' director, residing in F-75016 Paris, 10, rue Oswaldo Cruz,
represented by Mr. Grégory GUISSARD, previously named,
by virtue of proxy given under private seal on 24 September 2009,
6.- Mr. Arnaud LAMBERT, companies' director, residing in F-75015 Paris, 46, rue du Théâtre,
represented by Mr. Grégory GUISSARD, previously named,
by virtue of proxy given under private seal on 24 September 2009,
7.- Mrs. Elyse SALZMANN, companies' director, residing in F-92200 Neuilly-sur-Seine, 4, place de Bagatelle,
represented by Mr. Grégory GUISSARD, previously named,
by virtue of proxy given under private seal on 25 September 2009,
8.- Mr. Christophe LECLERC, companies' director, residing in F-92700 Colombes, 61, rue Denis Papin,
represented by Mr. Grégory GUISSARD, previously named,
by virtue of proxy given under private seal on 24 September 2009,
9.- "ACCURACY FOUNDATION", Société Civile, a civil partnership having its registered offices in L-2086 Luxem-

bourg, 412F, route d'Esch, and duly incorporated pursuant to a deed signed under private seal and registered with the
Trade and Companies' Register of Luxembourg under section E and number 4.110,

represented by Mr. Grégory GUISSARD, previously named,
by virtue of proxy given under private seal on 5 October 2009.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the Proxyholder and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in their capacity as partners of "ACCURACY WORLD WIDE S.àr.l. " (the Partners), a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered offices in L-2086 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 412F, route d'Esch, incorporated by
deed of the undersigned notary dated 23 September 2008, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C", number 2572 of 21 October 2008, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section
B and number 142.110 (the Company), have recognized that they have been fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the share capital by an amount of three thousand five hundred euro (EUR 3,500.00) so as to raise it

from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00) to sixteen thousand euro (EUR 16,000.00);

2. To issue two hundred eighty (280) new shares, with a nominal value of twelve euro and fifty cents (EUR 12.50) each,

to be fully paid up, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day
of the extraordinary general meeting of partners resolving on the proposed capital increase;

3. To accept the subscription of the two hundred eighty (280) new shares, with a nominal value of twelve euro and

fifty cents (EUR 12.50) each, by the current Partners pro rata of their shareholding in the Company;

4. To reduce the nominal value of the shares of the Company from twelve euro and fifty cents (EUR 12.50) to ten

Euro (EUR 10.00);

5. To re-qualify the existing one thousand two hundred eighty (1,280) shares with a nominal value of twelve euro and

fifty cents (EUR 12.50) each of the Company into one thousand six hundred (1,600) shares with a nominal value often
euro (EUR 10.00) each, the shares remaining allocated to the current Partners of the Company;

6. To transform the Company from its current form of a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) into a cooperative in the form of a public limited company (société cooperative sous la forme de société anonyme);

7. To divide the share capital of the Company into a fixed part and another variable part, the fixed part being repre-

sented by the issuance, from time to time, of Class A Ordinary Shares and C Founder Share, the variable part being
represented by the issuance, from time to time, of Class B Preferred Shares;

8. To convert and re-qualify the one thousand six hundred (1,600) existing shares in registered form with a nominal

value of ten Euro (EUR 10.00) each, all subscribed and fully paid-up, of the Company under the form of a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), into one thousand six hundred (1,600) Class A Ordinary Shares of the
Company under the form of cooperative under the form of a public limited company (cooperative sous la forme de
société anonyme), with a nominal value of ten euro (EUR 10.00) each and having the rights and privileges defined by the
Company's articles of association, and to allocate all these shares to the current shareholders of the Company pro rata
of their shareholding in the Company;

23814

9. To increase the fixed share capital by an amount of ten euro (EUR 10.00) so as to raise it from its present amount

of sixteen thousand euro (EUR 16,000) to sixteen thousand and ten euro (EUR 16,010.00), by issuing one (1) C Founder
Share;

10. To issue one (1) new share, as C Founder Share and being part of the fixed share capital, with a nominal value of

ten euro (EUR 10.00), to be fully paid up, having the rights and privileges defined by the Company's articles of association;

11. Waiver by the existing shareholders of their preferential subscription right and agreement by the existing share-

holders to the subscription of the C Founding Share, to be issued, by "ACCURACY FOUNDATION", Société Civile;

12. To change the name of the Company to "ACCURACY WORLDWIDE S.Coop.SA.";
13. To restate the corporate object of the Company;
14. To fully restate the articles of association in order to comply with the provisions of the law dated 10 August 1915

on commercial companies, as amended, governing the cooperative in the form of a public limited company (société
cooperative sous la forme de société anonyme) in order to reflect the transformation of the Company, the change of the
corporate name, the corporate object, and the change of the share capital divided into a fixed part and variable part and
the rights attached to the shares;

15. To acknowledge the termination of the mandate of the current manager of the Company under the legal form,

appointment of new directors of the Company having the rights and duties defined by the Company's articles of association
as restated and determine the duration of their mandate;

16. To appoint the statutory auditor of the Company and determine the duration of its mandate;
17. Miscellaneous.
and have requested the undersigned notary to record the following resolutions they have adopted unanimously:

<i>First resolution

The Partners resolve to increase the corporate capital by an amount of three thousand five hundred euro (EUR

3,500.00) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00) to sixteen
thousand euro (EUR 16,000.00).

<i>Second resolution

The Partners resolve to issue two hundred eighty (280) new shares, with a nominal value of twelve euro and fifty cents

(EUR 12.50) each, to be fully paid up, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends
as from the day of the extraordinary general meeting of partners resolving on the proposed capital increase.

<i>Third resolution

<i>Subscription and Payment

Thereupon appeared Mr. Grégory GUISSARD, aforementioned, acting in his capacity as duly authorized attorney by

virtue of proxies given as said herebefore.

The Proxyholder declares to subscribe in the name and on behalf of the current Partners, pro rata of their shareholding

in the Company, to the two hundred eighty (280) new shares, with a nominal value of twelve euro and fifty cents (EUR
12.50) each, and to make payment in full of the nominal value of each of such new shares by contribution in cash, so that
the amount of three thousand five hundred euro (EUR 3,500.00) is as of now available to the Company, as has been
justified to the undersigned notary.

Thereupon the Partners resolve to accept the said subscription and payment in cash and to allot the two hundred

eighty (280) new shares to the current Partners, prorata of their shareholding in the Company.

<i>Fourth resolution

The Partners resolve to convert the existing one thousand two hundred eighty (1,280) shares having a par value of

twelve euro fifty cents (EUR 12.50) each into one thousand six hundred (1,600) shares having a par value of ten euro
(EUR 10.00) each.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Partners resolve to re-qualify the existing one thousand two hundred

eighty (1,280) shares with a nominal value of twelve euro and fifty cents (EUR 12.50) each of the Company into one
thousand six hundred (1,600) shares with a nominal value of ten euro (EUR 10.00) each, the shares remaining allocated
to the current Partners of the Company.

<i>Sixth resolution

The Partners resolve to transform the Company from its current form of a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) into a cooperative in the form of a public limited liability company (société coopérative sous la
forme de société anonyme) with immediate effect and without creating a new legal entity or affecting the legal existence
or personality of the Company in any manner.

23815

The Partners resolve to continue the current business of the Company, with all its assets and liabilities as indicated in

an interim balance sheet dated on 7 September 2009, which shall remain attached to the present deed.

Thereupon, from now on, the Partners are referred hereinafter as shareholders (the Shareholders), and have the rights

as granted by the law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to divide the share capital of the Company into a fixed part and another variable part, the

fixed part being represented by the issuance, from time to time, of Class A Ordinary Shares and C Founder Share, the
variable part being represented by the issuance, from time to time, of Class B Preferred Shares.

<i>Eighth resolution

As a consequence of the foregoing resolution and the transformation of the Company into a cooperative in the form

of a public limited company, the Shareholders resolve to convert and re-qualify the one thousand six hundred (1.600)
existing shares in registered form with a nominal value of ten euro (EUR 10.00) each, all subscribed and fully paid-up, of
the Company under the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), into one thousand
six hundred (1,600) Class A Ordinary Shares of the Company, having the rights and privileges defined by the Company's
articles of association, with a nominal value of ten euro (EUR 10.00) each, and to allocate all these shares to the current
Shareholders of the Company in accordance with their shareholding in the Company.

<i>Ninth resolution

The Shareholders resolve to increase the corporate capital by an amount of ten euro (EUR 10.00) so as to raise it

from its present amount of sixteen thousand euro (EUR 16,000.00) to sixteen thousand and ten euro (EUR 16,010.00).

<i>Tenth resolution

The Shareholders resolve to issue one (1) new share, as C Founder Share and being part of the fixed share capital,

with a nominal value often euro (EUR 10.00), to be fully paid up, having the rights and privileges defined by the Company's
articles of association.

<i>Eleventh resolution

The existing Shareholders declare to waive their preferential subscription right.

<i>Subscription and Payment

Thereupon appeared Mr. Grégory GUISSARD, aforementioned, acting in his capacity as duly authorized attorney by

virtue of a proxy given on 5 October 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Proxyholder declares to subscribe to the new share to be issued in the name and on behalf of "ACCURACY

FOUNDATION", Société Civile, a civil partnership having its registered offices in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,
and duly incorporated pursuant to a deed signed under private seal and registered with the Trade and Companies' Register
of Luxembourg under section E and number 4.110, by contribution in cash, so that the amount of ten euro (EUR 10.00)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Thereupon the Shareholders resolve to accept the said subscription and payment in cash and to allot one (1) new

share, as C Founder Share, to "ACCURACY FOUNDATION", Société civile.

<i>Twelfth resolution

The Shareholders resolve to change the name of the Company in "ACCURACY WORLDWIDE S.Coop.SA".

<i>Thirteenth resolution

The Shareholders decide to restate the corporate object of the Company as follows:
"The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and intellectual property rights
of any kind through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way,
or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop and manage such
holding of interests.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, and more particularly the administration,
management, control and development of the companies of the Accuracy Group.

The Company can also take whatever action necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service

marks, licenses, know how and other industrial, commercial or intellectual property rights, sublicenses and similar rights
against infringement by third party.

The Company may also enter into the following transactions:

23816

(i) To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives
or otherwise;

(ii) To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits and credits, to its

Subsidiaries or companies in which the Company has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company
being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the Accuracy Group;

(iii)To render any assistance to the Subsidiaries, within the limits of any applicable law;
(iv) To enter into agreements, including, but not limited to any form of acquisition agreement, partnership agreements,

underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agree-
ments and other contracts for services, selling agreements, in relation to the Subsidiaries."

<i>Fourteenth resolution

As consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to fully restate the Articles of Incorporation

of the Company in order to comply with the provisions of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, governing the cooperative in the form of a public limited company (société cooperative sous la forme de société
anonyme) in order to reflect the transformation of the Company, the change of the corporate name, the corporate object,
and the change of the share capital divided into a fixed part and variable part and the rights attached to the shares, the
management of the Company.

The Articles of Incorporation of the Company shall forthwith read as follows:

"Chapter I. Definitions

"Accuracy Group" means, collectively, the Company, Accuracy SAS (a "société par actions simplifiée" incorporated

under the laws of France) and its Subsidiaries directly or indirectly owned by Accuracy SAS.

"Accuracy Partners' Chart" means the partners' chart signed by and between the Founding Partners and the Company,

as amended, restated or supplemented from time to time, and any deed of adherence pursuant to a new Shareholder
agrees and adheres to the terms and conditions of the Partners' Chart.

"Articles" means the articles of association of the Company, as amended from time to time.
"Board of Directors" means the board of directors of the Company appointed from time to time in accordance with

article 13.1, and Director shall be construed accordingly.

"Control" means, in relation to an entity, where a person (or persons acting in concert) has or acquires direct or

indirect control (i) of the affairs of that entity, or (ii) more than fifty (50) percent of the total voting rights conferred by
all the issued Shares in the capital of that entity which are ordinarily exercisable in a shareholders' general meeting of that
entity or (iii) of the composition of the main Board of Management of that entity. For these purposes "persons acting in
concert", in relation to an entity, are persons which actively co-operate pursuant to an agreement or understanding
(whether formal or informal) with a view to obtaining or consolidating Control of that entity.

"Company" means ACCURACY WORLDWIDE S.Coop.SA.
"Class A Dividend" has the meaning given in article 8.2 of these Articles.
"Class A Ordinary Shares" means, from time to time, all issued and outstanding ordinary voting shares in the share

capital of the Company of class A, having a nominal value of ten euro (EUR 10.00).

"Class B Preferred Dividend" has the meaning given in article 8.1 of these Articles.
"Class B Preferred Shares" means, from time to time, all issued and outstanding ordinary non voting shares in the share

capital of the Company of class B, having a nominal value of ten euro (EUR 10.00).

"C Founder Share" means the share subscribed by Accuracy Foundation, having a nominal value often euro (EUR 10.00).
"Departure" means for a Partner, the termination, on any grounds and for any reason, of all the Partner's employment

contract and/or office (as employee, as corporate office ("mandataire social")) or as board member.

"Founding Partners" mean the following persons: Mr. Nicolas BARSALOU, Mr. Frederic DUPONCHEL, Mr. Damien

GROS, Mr. Arnaud LAMBERT, Mr. Christophe LAMBERT, Mr. Stephane PERROTTO, Mrs. Elyse SALZMANN and Mr.
Christophe SCHMIT.

"Law" means the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
"Partners" means, collectively, any Founding Partner, any Partner of the Company, and any other person who has

agreed to adhere to the Partners' Chart.

"Permitted Transfer" shall have the meaning set out in article 7.1 of these Articles.
"Remaining Distribuable Net Profit" shall have the meaning set out in article 8.2 of these Articles.
"Shares" means from time to time, collectively, the Class A Ordinary Shares, the Class B Preferred Shares and the

Class C Founder Shares (or any of them if the context requires so) issued by the Company or to be issued in accordance
with article 5.

"Special Committee" means from time to time, the Presidential Candidacy Committee in accordance with Art. 22.

23817

"Subsidiary" means, with respect to the Accuracy Group, any other company of which securities or interest having

the power to elect a majority of that company the governing body or otherwise having the power to exercise a majority
of votes in a general meeting of shareholders are held by the Company, Accuracy SAS or one or more of its Subsidiaries.

"Supermajority Vote" shall have the meaning set out in article 12.4 of these Articles.
"Transfer" (including the terms "Transferred" or "Transferring") means a conveyance of the legal title and/or of the

beneficial interest by whatever means whether by sale (including in the context of a public offer), assignment, contribution,
distribution, gift or otherwise irrespective of the type of consideration, if any, receives therefore.

Chapter II. Form and Name - Registered office - Duration - Corporate object

Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a cooperative in the form of a public limited company (société cooperative sous la

forme de société anonyme) (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the Law), and by the present
articles of association (the Articles).

1.2 The Company will exist under the name of "ACCURACY WORLDWIDE S.Coop.SA.".

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of

directors of the Company (the Board of Directors).

2.3 Where the Board of Directors determines that extraordinary political or military developments or events have

occurred  or  are  imminent  and  that  these  developments  or  events  would  interfere  with  the  normal  activities  of  the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances.
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted

in the manner required for amendments of these Articles.

Art. 4. Corporate object.
4.1 The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and intellectual property rights
of any kind through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way,
or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop and manage such
holding of interests.

4.2 The Company can perform all commercial, technical and financial operation, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, and more particularly the administration,
management, control and development of the companies of the Accuracy Group.

4.3 The Company can also take whatever action necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service

marks, licenses, know how and other industrial, commercial or intellectual property rights, sublicenses and similar rights
against infringement by third party.

4.4 The Company may also enter into the following transactions:
(i) To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives
or otherwise;

(ii) To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits and credits, to its

Subsidiaries or companies in which the Company has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company
being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the Accuracy Group;

(iii) To render any assistance to the Subsidiaries, within the limits of any applicable law;
(iv) To enter into agreements, including, but not limited to any form of acquisition agreement, partnership agreements,

underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agree-
ments and other contracts for services, selling agreements, in relation to the Subsidiaries.

Chapter III. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is composed of a fixed part and another variable part.

23818

5.2 The fixed share capital is set at sixteen thousand and ten euro (EUR 16,010.00) consisting of one thousand six

hundred (1,600) Class A Ordinary Shares, and (ii) one (1) C Founder Share, with a par value often euro (EUR 10.00).

5.3 The variable share capital is unlimited and subscribed by the Partners divided in Class B Preferred Shares with a

par value of ten euro (EUR 10.00). Each one must be entirely subscribed and fully paid-up at the time of its subscription.

Subject to the provisions of article 12.4 (i) of these Articles, the Board of Directors is therefore authorised to issue

Class B Preferred Shares under the variable share capital.

5.4 Except where the context so requires, the Class A Ordinary Shares, the Class B Preferred Shares and the C

Founder Share are collectively referred to as the "Shares", and individually a "Share".

Except where the context so requires, the holders of the Class A Ordinary Shares, and/or the holders of Class B

Preferred  Shares,  and/or  the  holder  of  the  C  Founder  Share  are  collectively  referred  to  as  the  "Shareholders",  and
individually a "Shareholder".

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares of the Company shall be in registered form.
6.2 A register of Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder.

Ownership of Shares will be established by inscription in the said register.

6.3 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more Shares are jointly owned or if the title

of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.4 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 7. Restriction on transfers of Shares.
7.1 Each Shareholder agrees not to Transfer, directly or indirectly, any of his A and B Shares from the date of sub-

scription of his shares by the said Shareholder, except in the following limited circumstances and subject to the provisions
of the Partners' Chart: (i) upon the Departure and/or (ii) upon the Retirement and/or (iii) upon the agreement of the
Board of Directors (each such Transfer being a "Permitted Transfer").

7.2 Any purported Transfer other than those expressly permitted by article 7.1 above shall be null and void and shall

have no force and effect.

7.3 The Shares cannot be pledged. Any purported pledge shall be null and void and shall have no force and effect.

Art. 8. Right to distribution.
8.1 Each Class B Preferred Share carries at all times, prior to any other distribution, the right to a preferential and

cumulative  dividend  to  be  declared  and  paid  in  cash  according  to  the  provisions  of  Article  24.2  corresponding  to  a
maximum amount of ninety-nine percent (99%) of the distributed annual profit (the Class B Preferred Dividend). The
Class B Preferred Dividend may however not be declared to the extent that such distribution would exceed sums which
are generally available for distribution in accordance with the Law. To the extent, the distribution of the Class B Preferred
Dividend shall be made in accordance with the Accuracy Partners' Chart.

8.2 After the holders of Class B Shares have received the Class B Preferred Dividend, then the holders of Class A

Shares will receive a dividend equal, for each financial year, to the difference between the total amount of the distributable
net profits of the Company and the Class B Preferred Dividend (the Remaining Distributable Net Profits) and this dis-
tribution will be made on pro rata basis among the holders of the Class A Shares on the basis of the number of Class A
shares held by each holder (the Class A Dividend).

8.3 To the extent that, after the allocation to the legal reserve, funds are available at the level of the Company for

distribution to the Shareholders and to the extend permitted by the Law and by the Articles of Association as well as in
consideration of the Accuracy Partners' Chart as from time to time in effect, the General meeting of Shareholders shall:

(i) firstly allocate, pari passu, the Class B Preferred Dividend to the holders of the Class B Preferred Shares;
(ii) secondly, allocate the Remaining Distributable Net Profits (if any) pro rata to the holders of Class A Ordinary

Shares.

8.4 The C Founder Share shall confer no right to participate in the assets, profits, liquidation profit or surpluses of, or

generated by, the Company.

8.5 Subject to the provisions of these articles, the resigning or excluded holder of Class B Preferred Shares is entitled

to receive only the par value of his shares. In no circumstances can any part of the balance sheet which represents the
assets of the Company be distributed to him.

Art. 9. Voting right.
9.1 Class A Ordinary Shares and C Founder Share have one vote each.
9.2 Class B Preferred Shares are non-voting Shares but shall be entitled to vote in the following situations:
9.2.1 In the following matters as defined in article 46 (1) of the Law:

23819

(i) the issue of new Shares carrying preferential rights;
(ii) the determination of the preferential cumulative dividend attaching to the non-voting Shares;
(iii) the conversion of Preference Shares into Ordinary Shares;
(iv) any change to the Company's corporate object;
(v) the issue of convertible bonds;
(vi) the dissolution of the Company before its term;
(vii) the transformation of the Company into a Company of another legal form.
9.2.2 According to article 44 of the Law, Preference Shares shall also be given the right to vote on all matters:
(i) if the right to a preferential and cumulative dividend as provided for in article 44 (1) 2) of the Law, should no longer

be granted or be removed;

(ii) if the preferential right on liquidation as provided for in article 44 (1) 3) of the Law, should not be granted or

removed.

Art. 10. Liability of the Shareholders. The Shareholders shall only be liable for payment to the Company of the par

value and issue premium on each Share they subscribe for. In particular, Shareholders shall not be obligated for the debts,
liabilities and obligations of the Company or of any other Shareholder.

Chapter IV. General Meeting of the Shareholders

Art. 11. Meetings of the Shareholders of the Company.
11.1 Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting) shall represent the

entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to all the operations of the Company.

11.2 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of

the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the third Friday of the month of June, at 10.00 a.m. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

11.3 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional

circumstances so require.

11.4 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

11.5 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partici-
pating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

Art. 12. Notice, Quorum, Powers of Attorney and Convening Notices.
12.1 Any General Meeting of the Company shall be convened by the Board of Directors or by the holder(s) of Class

C Founder Share.

In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.
The notice periods provided for by Law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless

otherwise provided herein. The quorum shall be calculated as follows:

- Upon first convening, (i) fifty percent (50%) of the voting rights of those A Shareholders present or represented and

(ii) the C Shareholder shall be present or represented;

- Upon second convening, no quorum shall be applicable but the C Shareholder shall be present and represented.
12.2 Each Class A Ordinary Shares and the Class C Founder Share is entitled to one vote.
12.3 Except as otherwise required by Law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will

be passed by (i) a simple majority of the voting rights of those A Shareholders present or represented and voting and (ii)
a favorable vote of the C Shareholder.

12.4 Without prejudice to the provision of article 12.3 of these Articles, the following decisions shall be taken by (i)

a 3/4 majority of the voting rights of the A Shareholders present or represented and voting and (ii) a favorable vote of
the C Shareholder (a Supermajority Vote):

(i) Appointment of new Partners;
(ii) Appointment and/or dismissal of the members of the Board of Directors (except for the C Directors as defined

below);

(iii) Ratification of the President's appointment;
(iv) Modification of these Articles;
(v) Modification of the Accuracy Partners' Chart;

23820

(vi) Decision not to renew the Accuracy Partners' Chart on its normal expiry date;
(vii) Modification of the share capital of the Company;
(viii) Acquisitions or dispositions of securities, businesses or other assets (whether by way of stock purchase, merger,

consolidation or otherwise) by the Company or by any Subsidiary;

(ix) Any purchase of or merger with a company for an equity amount in excess of five million euro (EUR 5,000,000.00).
12.5 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in

original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

12.6 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves

as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Chapter V. Management - Supervision

Art. 13. Management.
13.1  The  Company  shall  be  managed  by  a  Board  of  Directors  composed  of  a  maximum  of  fifteen  (15)  members

(collectively referred to as the "Directors", or individually referred to as a "Director"), divided into two (2) categories of
Directors (B Directors and C Directors), and chosen by the General Meeting as follows: (i) a minimum of one (1) and a
maximum of four (4) C Directors, representing the Founding partners and appointed by the C shareholder, and (ii) a
maximum of eleven (11) B Directors, representing the Subsidiaries, on the basis of a ratio set out in the Accuracy Partners'
Chart, and proposed by the relevant Subsidiaries and appointed by the B shareholders.

13.2 The Directors shall be appointed for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected,

provided, however, that any Director may be removed at any time by a resolution taken by the General Meeting. The
Directors shall be eligible for one reappointment only, unless the Board of Directors decides that a third term would be
necessary and the General Meeting approves such decision.

13.3 At the end of the six-year term of the first Board of Directors, half of the members of the Board of Directors

shall be appointed or reappointed for three (3) years only (excluding the President who will be reappointed for a period
of six years only).

13.4 In the event of vacancy in the office of a Director because of death, resignation or otherwise, the remaining

directors elected by the General Meeting may meet and elect a Director of the same category (C Director or B Director)
to fill such vacancy until the next General Meeting or the next decision of the C Shareholder.

Art. 14. The President.
14.1 The Board of Directors shall choose from among its members a President (the President), and may choose among

its members one or more vice-president(s). The first President shall be Mr. Frédéric DUPONCHEL.

14.2 The candidates for the office of President shall be chosen by the Presidential Candidacy Committee, which shall

designate one or more candidates for the office of President to the Board of Directors. Subject to the ratification of its
decision by the General Meeting, the Board of Directors decides to appoint the President among the candidates designated
by the Presidential Candidacy Committee.

14.3 The President shall be appointed for a period which may not exceed six (6) years and until his successor is elected.

The President shall be eligible for reappointment, under the conditions set out in the Accuracy Partners' Chart. The
President can be dismissed at any time by the Board under the conditions set out in the Accuracy Partners' Chart, it
being understood that in such an instance, the President will not be allowed to vote.

14.4 The President shall preside over all meetings of the Board of Directors, but in his absence, the members of the

Board of Directors may appoint another Director as President pro tempore by vote of a majority of the Directors present
or represented at any such meeting.

14.5 Subject to the provisions set out in article 17.2, the President shall also act as Managing Director (Administrateur-

délégué). In this respect the President shall be granted all necessary powers and authority to manage the Company in
accordance with the powers granted to him by the Board of Directors, and in accordance with the Articles and the terms
of the Accuracy Partners' Chart.

Art. 15. Meeting of the Board of Directors.
15.1 The Board of Directors may choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep

the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as
directed from time to time by the Board of Directors.

15.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the President or any five (5) Directors or by any person

delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight (8) calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of
urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or
telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described
in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

23821

15.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,

or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

15.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented

at a meeting of the Board of Directors.

15.5 Decisions shall be taken by a 3/4 majority vote of the Directors present or represented at such meeting including

a favorable vote of a 3/4 majority vote of the C Directors. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
However, as regards any decision concerning the Class B Preferred Shares or the B Shareholders, the Directors who do
not hold Class B Preferred Shares shall not have the right to vote and shall not be taken into account for the calculation
of the quorum and of the majority.

15.6 Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

15.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent

in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 16. Powers of the Board of Directors.
16.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of

disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles
to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

16.2 More precisely, the role of the Board of Directors is to define the commercial, financial and development strategies

as well as the operating policies and procedures of the Accuracy Group and to manage the appointment and the departure
of the Partners.

16.3 The Board of Directors shall be also competent to: (i) appoint the President of the Board of Directors of the

Company, among the candidates designated by the Presidential Candidacy Committee and subject to the further ratifi-
cation of the General Meeting, (ii) to dismiss the President, (iii) to propose to the general meetings or boards of the
directors (in respect of the applicable legislation) of the Subsidiary the candidates(s) to the office of legal representatives
of the Subsidiaries, among the candidates designated by the Subsidiaries' President Candidacy Committee, (iv) to dismiss
the legal representatives of the Subsidiaries, subject to further ratification by the board of directors or the general meeting
of the relevant Subsidiary, (v) to set in detail Partners remuneration rules and criteria, (vi) to determine annually the
amount which can be distributed to Class A Ordinary Shares and Class B Preferred Shares, upon the proposition of the
Allocation Committee (in respect of the principles set out in the Accuracy Partners' Chart), before the vote of the General
Meeting, (vii) to appoint the members of the Specials Committees, and (viii) to exclude a Partner.

Art. 17. Delegation of powers.
17.1  The  Board  of  Directors  is  also  authorized  to  appoint  a  person,  either  director  or  not,  for  the  purposes  of

performing specific functions at every level within the Company.

17.2 Especially, the Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily

management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided
for by article 60 of the Law to an executive or other committee or committees whether formed from among its own
members or not, or to one or more directors, managers or other agent who may act individually or jointly. The Board
of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to
these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

Art. 18. Binding signatures.
18.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any C Director

together with any B Directors, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such
signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 19. Conflict of interests.
19.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

19.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

19.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of

the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company or which are entered into on arm's length terms.

23822

Art. 20. Confidentiality. Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as

well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the
Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required
(i) by a legal or regulatory provision applicable to "sociétés anonymes" or (ii) for the public benefit.

Art. 21. Statutory Auditor(s).
21.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,

where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

21.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their

remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.

Chapter VI. Special Committees

Art. 22. Presidential Candidacy Committee.
22.1 A Presidential Candidacy Committee shall be put in place six (6) months before the date of expiration of the

President's term of office.

22.2 The members of the Presidential Candidacy Committee shall be serving members of the Board of Directors at

the  date  on  which  the  Presidential  Candidacy  Committee  is  put in place and  shall  be appointed as  follows: four  (4)
Directors (whether C or B), designated by the Board of Directors.

22.3 In the instance of a reappointment (i.e. at the end of the first term), the role of the Presidential Candidacy

Committee is only, in the light of all feedbacks on the President's performance, to ensure that no significant doubts exist
which should trigger a vote of non confidence with a 3/4 majority of Board members. If no such triggering event is
identified, the Board of Directors shall reappoint the President for a second term.

22.4 In all other instances, the Presidential Candidacy Committee's role is to take down and/or to incite candidacies

for the office of President, to discuss with the candidates their motivation and program and to ensure that such candidates
are liable to be appointed by a large majority of the votes.

22.5 The name(s) of the selected candidate(s) shall be submitted by the Presidential Candidacy Committee to the

Board of Directors, which will retain the most appropriate candidacy and submit it for ratification to the General Meeting.

22.6 No one may be appointed President if this procedure has not been complied with.

Chapter VII. Financial year - Financial statement - Dissolution and Liquidation

Art. 23. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall

terminate on the thirty-first day of December of the same year.

Art. 24. Allocation of profits.
24.1 From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

24.2 Subject to the provisions of the Accuracy Partners' Chart and to the guidelines set out by the Board of Directors,

the General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of.

24.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and they may be

paid at such places and times as may be determined by the Board. Subject to the conditions fixed by the Law and in
compliance with the forgoing provisions and notably article 8.1 of the Articles, the Board may decide to pay interim
dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

Art. 25. Dissolution and Liquidation.
25.1 The resigning or excluded Shareholders may not cause the company to be liquidated.
25.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner

required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried
out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding
such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

25.3 After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall, subject to the conditions fixed by the Law, be distributed to the Shareholders, as follows:

(i) first, to each holder of Class B Preferred Shares until the nominal and share premium (if any) amounts paid up on

the Class B Preferred Shares has been repaid in full;

(ii) second and to the extend that the proceeds exceed the amounts payable under article 25.3 (i), to each holder of

Class A Ordinary Shares until the nominal and share premium (if any) amounts paid up on the Class A Ordinary Shares
has been repaid in full; and

23823

(iii) thereafter and to the extend that the proceeds exceed the amounts payable under article 25.3 (i) and 25.3 (ii)

inclusive, following the order of priority of payments and the amount of distribution set out in article 8.

Chapter VIII. General Provision

Art. 26. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an Extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in article 12.4 (iii).

Art. 27. Applicable Law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Law."

<i>Fifteenth resolution

The Shareholders resolve to acknowledge the end of the mandate of the Company's current manager and to appoint

the following persons with immediate effect and for a period ending at the Annual General Meeting of the Company to
be held in 2010:

- Mr. Frédéric DUPONCHEL, previously named;
- Mr. Nicolas BARSALOU, previously named;
- Mr. Christophe LECLERC, previously named.

<i>Sixteenth resolution

The Shareholders resolve to appoint "FIN-CONTROLE S.A.", with registered offices in L-1882 Luxembourg, 12F, rue

Guillaume Kroll, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B and number 42.230
as new auditor of the Company for a period ending at the Annual General Meeting of the Company to be held in 2010.

<i>Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at three thousand two hundred

euro (EUR 3,200.00).

<i>Declaration

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English texts, the English text will be prevailing.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by his surname, name,

civil status and residence, he signed with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille neuf, le huit octobre.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.-  Monsieur  Frédéric  DUPONCHEL,  dirigeant  d'entreprises,  demeurant  à  F-92200  Neuilly-sur-Seine,  19  bis,  rue

Pauline Borghèse,

représenté par Monsieur Grégory GUISSARD, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Mandataire),
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 24 septembre 2009,
2. - Monsieur Christophe SCHMIT, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-92100 Boulogne-Billancourt, 21, rue Emile

Dunois,

représenté par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 24 septembre 2009,
3. - Monsieur Nicolas BARSALOU, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-92100 Boulogne-Billancourt, 33, rue Anna

Jacquin,

représenté par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 24 septembre 2009,
4. - Monsieur Damien GROS, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-92130 Issy-les-Moulineaux, 3, Villa Fransisco

Ferrer,

représenté par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 24 septembre 2009,
5. - Monsieur Stéphane PERROTTO, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-75016 Paris, 10, rue Oswaldo Cruz,

23824

représenté par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 24 septembre 2009,
6. - Monsieur Arnaud LAMBERT, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-75015 Paris, 46, rue du Théâtre,
représenté par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 24 septembre 2009,
7. - Madame Elyse SALZMANN, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 4, place de Bagatelle,
représentée par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 25 septembre 2009,
8. - Monsieur Christophe LECLERC, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-92700 Colombes, 61, rue Denis Papin,
représenté par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 24 septembre 2009,
9.- "ACCURACY FOUNDATION ", société civile, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch et

dûment constituée suivant un acte sous seing privé et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section E et le numéro 4.110,

représentée par Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 5 octobre 2009.
Les procurations mentionnées ci-dessus, signées "ne varietur " par le Mandataire et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants, agissant en qualité d'associés de "ACCURACY WORLD WIDE S.à r.l. " (les Associés), une société à

responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 412F, route d'Esch, constituée par acte reçu par le notaire soussigné le 23 septembre 2008, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2572 du 21 octobre 2008, inscrite au Registre du Commerce
et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  la  section  B  et  le  numéro  142.110  (la  Société),  reconnaissent  être  pleinement
informés des résolutions à adopter sur la base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,00) de manière à le porter

de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) à seize mille euros (EUR 16.000,00);

2. Emission de deux cent quatre-vingts (280) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de douze

euros et cinquante cents (EUR 12,50) entièrement libérées, disposant des mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes et donnant droit aux dividendes à partir de la date de l'assemblée générale décidant de la présente augmentation
de capital;

3. Acceptation de la souscription des deux cent quatre-vingts (280) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur

nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50), par les Associés actuels de la Société au prorata de leur
participation;

4. Réduction de la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société de douze euros et cinquante cents (EUR

12,50) à dix euros (EUR 10,00);

5. Requalification des mille deux cent quatre-vingts (1.280) parts sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale

de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50) en mille six cents (1.600) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale
de dix euros (EUR 10,00), les parts sociales restant détenues par les Associés actuels de la Société;

6. Transformation de la Société de sa forme juridique actuelle de société à responsabilité limitée en société coopérative

sous la forme de société anonyme;

7. Division du capital social de la Société en une partie fixe et une autre partie variable, la partie fixe étant représentée

par l'émission, à tout moment, d'Actions Ordinaires de Classe A et Part de Fondateur C, la part variable étant représentée
par l'émission, à tout moment, d'Actions Préférentielles de Classe B;

8. Conversion et requalification des mille six cents (1.600) parts sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale

de dix euros (EUR 10,00), toutes souscrites et intégralement libérées de la Société sous son ancienne forme de société
à responsabilité limitée en mille six cents (1.600) Actions Ordinaires de Classe A de la Société sous la forme de coopérative
sous la forme de société anonyme, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,00) chacune, ayant les droits et
privilèges tels que définis dans les statuts de la Société; toutes les actions restant détenues par les Actionnaires actuels
de la Société au prorata de leur participation;

9. Augmentation de la partie fixe du capital social d'un montant de dix euros (EUR 10,00) de manière à le porter de

son montant actuel de seize mille euros (EUR 16.000,00) à seize mille dix euros (EUR 16.010), par l'émission d'une (1)
Part de Fondateur C;

10. Emission d'une (1) nouvelle action, en tant que Part de Fondateur C composant le capital fixe, ayant une valeur

nominale de dix euros (EUR 10,00), entièrement libérée, ayant les droits et privilèges tels que définis dans les statuts de
la Société;

23825

11. Renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription et acceptation par les action-

naires existants de la souscription de la Part de Fondateur C, à émettre, par "ACCURACY FOUNDATION", Société
Civile;

12. Changement de la dénomination de la Société en "ACCURACY WORLDWIDE S.Coop.SA.";
13. Reformulation de l'objet social de la Société;
14. Reformulation intégrale des statuts de la Société afin de les conformer aux dispositions de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, gouvernant la société coopérative sous la forme de société
anonyme, de manière à refléter la transformation de la Société, le changement de l'objet social, le changement du capital
social dorénavant divisé en une partie fixe et une autre partie variable ainsi que les droits attachés à ces actions;

15. Constatation de la fin du mandat du gérant de la Société sous l'ancienne forme de société à responsabilité limitée

et nomination des nouveaux administrateurs de la Société sous sa forme actuelle, ayant les prérogatives telles que dé-
terminées dans les Statuts de la Société et détermination de la durée de leur mandat;

16. Nomination du Commissaire et détermination de la durée de son mandat;
17. Divers.
et demandent au notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,00) de

manière à le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) à seize mille euros (EUR
16.000,00).

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d'émettre deux cent quatre-vingts (280) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur

nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50) entièrement libérées, disposant des mêmes droits et privilèges
que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir de la date de l'assemblée générale décidant de
la présente augmentation de capital.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription et Paiement

Est alors intervenu Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé

en vertu de procurations comme dit ci-avant.

Le Mandataire déclare souscrire au nom et pour le compte des Associés, au prorata de leur participation, aux deux

cent quatre-vingts (280) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50)
chacune, et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en espèces, de sorte que le montant de trois
mille cinq cents euros (EUR 3.500,00) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.

Les Associés décident d'accepter la dite souscription et le paiement en espèces et d'allouer les deux cent quatre-vingts

(280) nouvelles parts sociales aux Associés, au prorata de leur participation dans la Société.

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de convertir les mille deux cent quatre-vingts (1.280) parts sociales ayant une valeur nominale

de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50) chacune en mille six cents (1.600) parts sociales d'une valeur nominale
de dix euros (EUR 10,00) chacune.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de requalifier les mille deux cent quatre-vingts

(1.280) parts sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50) en
mille six cents (1.600) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (EUR 10,00), les parts sociales
restant détenues par les Associés de la Société.

<i>Sixième résolution

Les Associés décident de transformer la Société de sa forme juridique actuelle de société à responsabilité limitée en

société coopérative sous la forme de société anonyme avec effet immédiat et sans création d'une nouvelle entité juridique
et/ou sans affecter l'existence ou la personnalité juridique de la Société d'aucune manière.

Les Associés décident de continuer les affaires actuelles de la Société, avec ses actifs et passifs tels qu'indiqués dans

une situation intérimaire datée du 7 septembre 2009, laquelle restera attachée au présent acte.

En conséquence, à partir de maintenant, les Associés sont qualifiés d'actionnaires (les Actionnaires), et ont les droits

consentis par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

23826

<i>Septième résolution

Les Actionnaires décident la division du capital social de la Société en une partie fixe et une autre partie variable, la

partie fixe étant représentée par l'émission, à tout moment, d'Actions Ordinaires de Classe A et Part de Fondateur C,
la part variable étant représentée par l'émission, à tout moment, d'Actions Préférentielles de Classe B.

<i>Huitième résolution

Conséquemment à la résolution précédente et à la transformation de la Société en coopérative sous la forme de

société anonyme, les Actionnaires décident la conversion et requalification des mille six cents (1.600) parts sociales
existantes, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (EUR 10,00), toutes souscrites et intégralement libérées de
la Société sous son ancienne forme de société à responsabilité limitée en mille six cents (1.600) Actions Ordinaires de
Classe A de la Société sous la forme de coopérative sous la forme de société anonyme, ayant une valeur nominale de dix
euros (EUR 10,00) chacune, ayant les droits et privilèges tels que définis dans les statuts de la Société, toutes les actions
restant détenues par les actionnaires actuels de la Société au prorata de leur participation dans la Société.

<i>Neuvième résolution

Les Actionnaires décident d'augmenter la partie fixe du capital social d'un montant de dix euros (EUR 10,00) de manière

à le porter de son montant actuel de seize mille euros (EUR 16.000,00) à seize mille dix euros (EUR 16.010,00), par
l'émission d'une (1) Part de Fondateur C.

<i>Dixième résolution

Les Actionnaires décident d'émettre une (1) nouvelle action, en tant que Part de Fondateur C composant le capital

fixe, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,00), entièrement libérée, ayant les droits et privilèges tels que définis
dans les statuts de la Société.

<i>Onzième résolution

Les Actionnaires existants déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et Paiement

Est alors intervenu Monsieur Grégory GUISSARD, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé

en vertu d'une procuration datée du 5 octobre 2009.

La procuration mentionnée ci-avant, signée par le comparant et le notaire soussigné, restera attachée au présent acte

pour les besoins de l'enregistrement.

Le Mandataire déclare souscrire au nom et pour le compte d'"ACCURACY FOUNDATION ", une société civile ayant

son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch et dûment constituée suivant un acte sous seing privé et
enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section E et le numéro 4.110, et la
libérer par apport en espèces, de sorte que le montant de dix euros (EUR 10,00) est dès maintenant à la disposition de
la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Les Actionnaires décident d'accepter ladite souscription et le paiement en espèces et d'allouer une (1) nouvelle part

sociale, en tant que Part de Fondateur C, à "ACCURACY FOUNDATION " Société Civile.

<i>Douzième résolution

Les Actionnaires décident de changer la dénomination de la Société en "ACCURACY WORLDWIDE S.Coop.SA ".

<i>Treizième résolution

Les Actionnaires décident de reformuler l'objet social de la Société comme suit:
"L'objet de la Société est de détenir, directement ou indirectement, des participations, sous quelque forme que ce

soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir au moyen d'achat, de souscription,
d'acquisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou
d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers, sous quelque forme
que ce soit, et de posséder, d'administrer, de développer et de gérer cette détention de participations.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs décrits ci-dessus et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet, et plus particulièrement l'ad-
ministration, la gestion, le contrôle et le développement des sociétés du Groupe Accuracy.

La Société pourra prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférent aux brevets, marques, licences,

marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, sous-licences
et droits similaires contre toute violation par les tiers.

La Société peut également réaliser les opérations suivantes:
(i) L'emprunt d'argent, sous quelque forme que ce soit, ou l'obtention de crédit, sous quelque forme que ce soit, et

la levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans limitation, l'émission d'obligations, de billets à ordre, de recon-
naissances de dettes et d'autres instruments obligataires, l'utilisation de produits dérivés ou autres.

23827

(ii) L'assistance, sous quelque forme que ce soit, comprenant mais sans limitation, par avances, prêts, dépôts monétaires

et crédits, à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, même non substantiel, ou
à des sociétés qui sont actionnaires directs ou indirects de la Société ou à des sociétés appartenant au Groupe Accuracy.

(iii) L'assistance aux Filiales dans les limites des lois applicables.
(iv) La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes formes de contrat d'acquisition, de pro-

messe de vente, de contrats d'association, de contrats de prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion
et de mise à disposition, de contrats d'administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en
relation avec les Filiales."

<i>Quatorzième résolution

Les Actionnaires décident de reformuler intégralement les statuts de la Société afin de les conformer avec les dispo-

sitions  de  la  loi  du  10  août  1915  concernant  les  sociétés  commerciales,  telle  qu'amendée,  gouvernant  la  société
coopérative sous la forme de société anonyme, de manière à refléter la transformation de la Société, le changement de
l'objet social, le changement du capital social dorénavant divisé en une partie fixe et une autre partie variable ainsi que
les droits attachés à ces actions, le mode de fonctionnement de la Société.

Les Statuts de la Société devront être lus dorénavant comme suit:

«Chapitre I 

er

 . Définitions

"Groupe Accuracy" signifie, conjointement, la Société, Accuracy SAS (une société par actions simplifiée constituée

conformément aux lois de France) et ses Filiales, directement ou indirectement détenues par Accuracy SAS.

"Charte des Associés Accuracy" signifie la charte des associés signée par les Associés Fondateurs avec la Société, telle

qu'amendée, reformulée ou complétée le cas échéant, ainsi que toute déclaration d'adhésion par lequel un nouvel Ac-
tionnaire s'engage et adhère aux termes et conditions de la charte des associés.

"Statuts" signifie les statuts de la Société, telle qu'amendés périodiquement.
"Conseil d'Administration" signifie le conseil d'administration de la Société, élu périodiquement en conformité avec

l'article 13.1, et, Administrateur sera interprété en conséquence.

"Contrôle" signifie, par rapport à une entité, lorsque une personne (ou des personnes agissant de concert) détient ou

acquiert le contrôle direct ou indirect (i) des activités de cette entité, ou (ii) de plus de cinquante pourcent (50%) du total
des droits de vote conférés par toutes les actions émises dans le capital de cette entité et qui peuvent être exercés aux
assemblées générales de cette entité ou (iii) de la composition du principal conseil d'administration de cette entité. Dans
cette optique, "les personnes agissant de concert" par rapport à une entité sont les personnes qui coopèrent activement
en  application  d'un  accord  ou  de  ce  qui  a  été  communément  admis  (formellement  ou  non)  en  vue  d'obtenir  ou  de
consolider le Contrôle de cette entité.

"Société" signifie ACCURACY WORLDWIDE S.Coop.SA.
"Dividende de Classe A" a la signification telle que donnée à l'article 8.2 des Statuts.
"Actions Ordinaires de Classe A" désigne l'ensemble des actions ordinaires de classe A émises et en circulation dans

le capital social de la Société ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,00).

"Dividende Préférentiel de Classe B" a la signification telle que donnée à l'article 8.1 des Statuts.
"Action de Préférence de Classe B" désigne l'ensemble des actions ordinaires sans droit de vote de classe B émises et

en circulation dans le capital de la Société, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,00).

"Part de Fondateur C" signifie l'Action souscrite par Accuracy Foundation, ayant une valeur nominale de dix euros

(EUR 10,00).

"Départ" signifie pour un Associé la résiliation, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de ses obligations

contractuelles et/ou de son office (en qualité d'employé, mandataire social) ou de ses fonctions de membre du conseil
d'administration.

"Associés Fondateurs" signifie les personnes suivantes: Monsieur Nicolas BARSALOU, Monsieur Frédéric DUPON-

CHEL,  Monsieur  Damien  GROS,  Monsieur  Arnaud  LAMBERT,  Monsieur  Christophe  LAMBERT,  Monsieur  Stéphane
PERROTTO, Madame Elyse SALZMANN et Monsieur Christophe SCHMIT.

"Loi" signifie la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
"Associés" signifie, conjointement, tout Associé Fondateur, tout Associé de la Société et toute autre personne qui a

adhéré à la charte des Associés.

"Transfert Permis" a la signification telle que prévue à l'article 7.1 des Statuts.
"Profit Net Restant Distribuable" aura la signification donnée à l'article 8.2 des Statuts.
"Actions" signifie à tout moment, conjointement, les Actions Ordinaires de Classe A, les Actions Préférentielles de

Classe B, la Part de Fondateur C (ou n'importe laquelle lorsque le contexte le requiert) émises par la Société ou à émettre
conformément à l'article 5.

"Comité Spécial" signifie à tout moment, le Comité de Candidature du Président conformément à l'article 22.

23828

"Filiales" signifie, dans le cadre du Groupe Accuracy, toute société dont les titres ou intérêts permettant d'élire la

majorité des organes de représentation de la Société ou le pouvoir d'exercer la majorité des droits de vote en assemblée
générale sont détenu par la Société, Accuracy SAS ou l'une ou plusieurs de ses Filiales.

"Vote de Supermajorité" a la signification telle que donnée à l'article 12.4 des Statuts.
"Transfert" (incluant les termes "Transféré" ou "Transférant") signifie le transfert d'un titre juridique et/ou d'un intérêt

économique par n'importe quel moyen, que ce soit par vente (incluant une offre publique), cession, contribution, distri-
bution, donation ou autrement, indépendamment du type de considération donnée.

Chapitre II. Forme et Dénomination - Siège social - Durée - Objet social

Art. 1 

er.

 Forme et Dénomination.

1.1 Il est formé par les présentes une société coopérative sous la forme de société anonyme (la Société) laquelle sera

régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales telle qu'amendée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de "ACCURACY WORLDWIDE S.Coop.SA.".

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le Conseil d'Administration).

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet social.
4.1 L'objet de la Société est de détenir, directement ou indirectement, des participations, sous quelque forme que ce

soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir au moyen d'achat, de souscription,
d'acquisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou
d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers, sous quelque forme
que ce soit, et de posséder, d'administrer, de développer et de gérer cette détention de participations.

4.2 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs décrits ci-dessus et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet, et plus particulièrement l'ad-
ministration, la gestion, le contrôle et le développement des sociétés du Groupe Accuracy.

4.3 La Société pourra prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférent aux brevets, marques, licences,

marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, sous-licences
et droits similaires contre toute violation par les tiers.

4.4 La Société peut également réaliser les opérations suivantes:
(i) L'emprunt d'argent, sous quelque forme que ce soit, ou l'obtention de crédit, sous quelque forme que ce soit, et

la levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans limitation, l'émission d'obligations, de billets à ordre, de recon-
naissances de dettes et d'autres instruments obligataires, l'utilisation de produits dérivés ou autres.

(ii) L'assistance, sous quelque forme que ce soit, comprenant mais sans limitation, par avances, prêts, dépôts monétaires

et crédits, à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, même non substantiel, ou
à des sociétés qui sont actionnaires directs ou indirects de la Société ou à des sociétés appartenant au Groupe Accuracy.

(iii) L'assistance aux Filiales dans les limites des lois applicables.
(iv) La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes formes de contrat d'acquisition, de pro-

messe de vente, de contrats d'association, de contrats de prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion
et de mise à disposition, de contrats d'administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en
relation avec les Filiales.

Chapitre III. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social.
5.1 Le Capital social est composé d'une part fixe et d'une autre part variable.

23829

5.2 La partie fixe du capital social s'élève à seize mille dix euros (EUR 16.010,00) consistant en mille six cents (1.600)

Actions Ordinaires de Classe A, et (ii) une (1) Part de Fondateur C, chacune ayant une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,00).

5.3 La partie variable du capital est illimitée et souscrite par les Associés et divisée en Actions de Préférence de Classe

B ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,00). Chacune devra être intégralement souscrite et libérée intégrale-
ment à l'occasion de la souscription.

Sous réserve des dispositions de l'article 12.4 (i) des présents Statuts, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre

des Actions de Préférence de Classe B au niveau du capital variable.

5.4 Sauf lorsque le contexte le requiert, les Actions Ordinaires de Classe A, les Actions de Préférence de Classe B et

la Part de Fondateur C seront dénommées collectivement les "Actions", et individuellement une "Action". Sauf lorsque
le contexte le requiert, les détenteurs d'Actions Ordinaires de Classe A, les détenteurs d'Actions de Préférence de Classe
B et/ou le détenteur de la Part de Fondateur C seront collectivement appelés les "Actionnaires", et individuellement un
"Actionnaire".

Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions de la Société seront émises sous la forme nominative.
6.2 Un registre des Actionnaires sera tenu au siège social de la Société, où il pourra être consulté par tout Actionnaire.

La détention des Actions sera établie par l'inscription dans le registre des actionnaires.

6.3 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces Actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les Action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les Action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux Actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

6.4 La Société peut racheter ses propres actions dans les limites déterminées par la Loi.

Art. 7. Restrictions au transfert d'Actions.
7.1 Chaque Actionnaire s'engage à ne pas Transférer, directement ou indirectement, ses Actions Ordinaires de Classe

A et Actions de Préférence de Classe B depuis la date de souscription de ces actions par l'Actionnaire en question, excepté
dans les conditions limitées suivantes, sous réserve des dispositions prévues par la Charte des Associés: (i) en cas de
Départ et/ou (ii) en cas de retraite et/ou (iii) suite à un accord conclu avec le Conseil d'Administration (chacun de ces
transferts étant un "Transfert Autorisé").

7.2 Tout prétendu transfert autre que ceux prévus à l'article 7.1 ci-avant sera considéré comme nul et inopposable et

n'aura aucun effet contraignant.

7.3 Les Actions ne peuvent être mises en gage. Tout prétendu gage sera considéré comme nul et inopposable et n'aura

aucun effet contraignant.

Art. 8. Droit aux dividendes.
8.1 Chaque Action de Préférence de Classe B emporte à tout moment droit à un dividende préférentiel et cumulatif

devant être déclaré et payé en numéraire conformément aux dispositions de l'article 24.2 correspondant à un montant
maximum de quatre-vingt dix-neuf pourcent (99%) du profit annuel distribuable (le Dividende Préférentiel de Classe B).
Le Dividende Préférentiel de Classe B peut cependant ne pas être déclaré dans le cas où une telle distribution dépasserait
les montants généralement disponibles pour les distributions conformément à la Loi. Pour autant que de besoin, la dis-
tribution du Dividende Préférentiel de Classe B devra être faite en conformité avec la Charte des Associés.

8.2 Après que les détenteurs d'Actions de Préférence de Classe B aient reçu le Dividende Préférentiel de Classe B,

les détenteurs d'Actions Ordinaires de Classe A recevront un dividende égale, pour chaque exercice social, à la différence
entre le montant total du bénéfice net distribuable de la Société et le Dividende Préférentiel de Classe B (le Profit Net
Restant Distribuable) et cette distribution sera faite au prorata parmi les détenteurs d'Actions Ordinaires de Classe A
en fonction du nombre d'Action de Classe A détenues par ces détenteurs (le Dividende de Classe A).

8.3 Dans l'hypothèse où, après affectation à la réserve légale, des fonds sont disponibles au niveau de la Société pour

distribution aux Actionnaires et dans la mesure autorisée par la Lois et par les Statuts, ainsi qu'en tenant compte de la
Charte des Associés qui pourrait de temps à autre être en vigueur, l'assemblée générale des Actionnaires doit:

(i) premièrement, attribuer, pari passu, le Dividende Préférentiel de Catégorie B aux titulaires d'Actions de Préférence

de Classe B;

(ii) deuxièmement, attribuer le Profit Net Restant Distribuable (le cas échéant) au prorata aux titulaires d'Actions

Ordinaires de Catégorie A.

8.4 La Part de Fondateur C ne confère aucun droit sur les actifs, bénéfices, boni de liquidation ou surplus, ou généré,

par la Société.

23830

8.5 Sous réserve des dispositions de ces articles, le détenteur d' Actions de Préférence de Classe B exclu ou démis

est en droit de recevoir uniquement le montant de la valeur nominale de ses Actions. Dans aucunes circonstances,
n'importe quel élément du bilan représentant les avoirs de la Société ne pourra lui être distribué.

Art. 9. Droit de Vote.
9.1 Les Actions Ordinaires de Classe A et la Part de Fondateur C ont chacune un vote.
9.2 Les Actions de Préférence de Classe B sont des Actions sans droit de vote, toutefois elles seront habilitées à voter

dans les situations suivantes:

9.2.1 Dans les matières suivantes telles que définies à l'article 46 (1) de la Loi:
(i) l'émission de nouvelles actions portant des droits préférentiels;
(ii) la détermination du dividende préférentiel cumulé attaché aux Actions Préférentielles;
(iii) la conversion d'actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires;
(iv) tout changement dans l'objet de la Société,
(v) l'émission d'obligations convertibles;
(vi) la dissolution de la Société avant son terme;
(vii) la transformation de la Société sous une autre forme légale.
9.2.2 Conformément à l'article 46 de la Loi, les Actions Préférentielles auront les mêmes droits de vote lors de toutes

assemblées si:

(i) le droit à un dividende préférentiel et cumulatif comme prévu par les articles 44 (1) 2) de la Loi ne devait plus être

attribué ou enlevé;

(ii) le droit préférentiel sur la liquidation tel que prévu à l'article 44 (1) 3) de la Loi et établi dans les Statuts ne devait

plus être attribué ou enlevé.

Art. 10. Responsabilité des Actionnaires. Les Actionnaires ne seront tenus du paiement à la Société que du montant

de la valeur nominale et de la prime d'émission de chaque action qu'ils auront souscrite. En particulier, les Actionnaires
ne seront pas tenus des dettes, responsabilités et engagements de la Société ou de tout autre Actionnaire.

Chapitre IV. Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 11. Assemblée des Actionnaires de la Société.
11.1 Chaque assemblée des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale), régulièrement constituée, représente

l'intégralité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes
relatifs aux opérations de la Société.

11.2 L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social

de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième vendredi du
mois de juin de chaque année à 10.00 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg,
l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

11.3 L'Assemblée Générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Admi-

nistration de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

11.4 Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans

les avis de convocation.

11.5 Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que (i) toutes les personnes participant
à la réunion peuvent être identifiées, (ii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent entendre et parler avec
les autres participants, (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la
participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une partici-
pation en personne à une telle réunion.

Art. 12. Délais de Convocation, Quorum, Procuration et Avis de Convocation.
12.1 Toute assemblée générale sera convoquée par le Conseil d'Administration ou par le détenteur de la Part de

Fondateur de Classe C. En tel cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l'agenda de la réunion.

Les délais de convocation prévus par le Loi gouvernent les convocations, et la tenue des assemblées générales, sauf

dispositions contraires ci-après. Le quorum sera calculé comme suit:

- Lors de la première convocation, (i) cinquante pourcent (50%) des droits de vote des Actionnaires de Classe A

présents ou représentés et (ii) l'Actionnaire de Classe C présent ou représenté;

-  Lors  de  la  seconde  convocation,  aucun  quorum  de  sera  applicable,  hormis  la  présence  ou  la  représentation  de

l'actionnaire de Classe C.

12.2 Chaque Action Ordinaire de Classe A et la Part de Fondateur de Classe C donne droit à un vote.

23831

12.3 Hormis lorsque requis par la Loi ou par les présents Statuts, les résolutions de toute assemblée régulièrement

convoquée sera adoptée par (i) une majorité simple des droits de vote des Actionnaires de Classe A présents ou repré-
sentés et (ii) un vote favorable de l'Actionnaire de Classe C.

12.4 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12.3 des Statuts, les résolutions suivantes seront prises par (i)

une majorité de trois-quarts (3/4) des droits de vote des Actionnaires de Classe A présents ou représentés et (ii) le vote
favorable de l'Actionnaire de Classe C (la Supermajorité):

(iii) Nomination de nouveaux Associés;
(iv) Nomination et/ou révocation des membres du Conseil d'Administration (à l'exception des Administrateurs de

catégorie C tells que définis ci-avant);

(v) Ratification de la nomination du Président;
(vi) Modification des Statuts;
(vii) Modification de la Charte des Associés;
(viii) Décision de ne pas reconduire la Charte des Associé à l'expiration de son terme;
(ix) Modification du capital social de la Société;
(x) Acquisitions ou cessions de valeurs mobilières, fond de commerce ou autres actifs (soit par voie d'acquisition

d'actions, de fusion, de consolidation ou autre) par la Société ou par l'une de ses Filiales;

(xi) Toute acquisition ou fusion avec une société pour une valeur d'acquisition excédant cinq millions d'euros (EUR

5.000.000,00).

12.5 Chaque Actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électro-
nique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

12.6 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Chapitre V. Gestion - Supervision

Art. 13. Gestion.
13.1 La Société est gérée par un Conseil d'Administration composé de maximum quinze (15) membres (collectivement

dénommés les Administrateurs, ou individuellement un Administrateur), divisé en deux catégories d'Administrateurs
(Administrateurs B et Administrateurs C), et choisi par l'Assemblée Générale comme suit: (i) au minimum un (1) et
maximum quatre (4) Administrateurs de Catégorie C, représentant les Associés fondateurs et nommés par l'Actionnaire
de Classe C, et (ii) un maximum de onze (11) Administrateurs de Classe B, représentant les Filiales, sur la base d'un ratio
déterminés dans la Charte des Associés, et proposés par les Filiales respectives et nommés par les Actionnaires de Classe
B.

13.2 Les Administrateurs sont élus pour une période n'excédant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs

soient élus, étant entendu que chaque Administrateur peut être révoqué à tout moment par une résolution prise en
Assemblée Générale. Les Administrateurs sont rééligibles une seule fois, sauf si le Conseil d'Administration décide qu'un
troisième mandat est nécessaire et que l'Assemblée Générale approuve cette décision.

13.3 A l'échéance du terme de six (6) ans du premier Conseil d'Administration, la première moitié des membres du

Conseil d'Administration sera nommée ou réélue pour une période de trois années seulement (à l'exclusion du Président
qui sera réélu pour une période de six années seulement).

13.4 En cas de vacance d'un Administrateur pour cause de décès, révocation ou autre, les Administrateurs restants,

nommés par l'Assemblée Générale, peuvent se réunir et coopter un nouvel Administrateur de la même catégorie (Ad-
ministrateur de Catégorie B ou Administrateur de catégorie C) pour reprendre la vacance jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale ou la prochaine décision de l'Actionnaire de Catégorie C.

Art. 14. Le Président.
14.1 Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président (le Président), et peut choisir parmi ses

membres un ou plusieurs vice-présidents. Le premier président sera Monsieur Frédéric DUPONCHEL.

14.2 Les candidats pour la charge de Président seront choisis par le Comité de Candidature du Président, qui proposera

un ou plusieurs candidats pour la charge de président du Conseil d'Administration. Sous la condition de ratification de sa
décision par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration décide de nommer le Président parmi les candidats pro-
posés par le Comité de Candidature du Président.

14.3 Le Président est nommé pour une période qui ne peut excéder six (6) ans, et jusqu'à ce que son successeur soit

élu. Le Président peut être réélu, conformément aux conditions reprises dans la Charte des Associés. Le Président peut
être révoqué à tout moment par le Conseil conformément aux conditions reprises dans la Charte des Associés étant
entendu qu'en telle circonstance, le Président ne pourra prendre part au vote.

14.4 Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence, les membres du

Conseil d'Administration peuvent nommer un Administrateur en qualité de Président ad-intérim par vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à une telle réunion.

23832

14.5 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 17.2, le Président agira également en tant qu'Administrateur-

Délégué. Dans ce contexte, le Président sera investi de tous les pouvoirs et autorités nécessaires pour la gestion de la
Société en conformité avec les pouvoirs conférés par le Conseil d'Administration, les Statuts et la Charte des Associés.

Art. 15. Réunion du Conseil d'Administration.
15.1 Le Conseil d'Administration pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Administrateur et

qui  pourra  être  responsable  de  la  tenue  des  procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil  d'Administration  ainsi  que  de
l'exécution de telle fonction administrative ou autre lui conférée de temps en temps par le Conseil d'Administration.

15.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de cinq (5) Administrateurs ou par toute

autre personne déléguée à cet effet par les Administrateurs au lieu et à l'heure indiqués dans la convocation à l'assemblée,
la/les personne(s) convoquant l'assemblée fixant également l'ordre du jour. Chaque Administrateur sera convoqué par
écrit à toute réunion du Conseil d'Administration au moins huit (8) jours civils à l'avance par rapport à l'horaire fixé pour
ces réunions, excepté dans des circonstances d'urgence, dans lequel cas une convocation donnée vingt-quatre (24) heures
à l'avance et mentionnant dûment les raisons de l'urgence sera suffisante. Il pourra être passé outre à cette convocation,
pour l'avenir ou rétroactivement, à la suite de l'assentiment par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur de
chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

15.3 Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit

ou par télégramme, par télécopieur ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne
peut représenter plus d'un de ses collègues.

15.4 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administra-

teurs est présente ou représentée à la réunion du Conseil d'Administration.

15.5 Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des Administrateurs présents ou représentés à une telle

réunion, incluant le vote favorable des Administrateurs C. En cas d'égalité de voix, la proposition est considérée comme
rejetée. Cependant, concernant toute décision en rapport avec les Actions de Préférence de Classe B ou les Actionnaires
de Classe B, les Administrateurs qui ne détiennent pas d'Actions de Préférence de Classe B n'auront pas le droit de voter
et ne seront pas pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

15.6 Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou

par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant à s'entendre mutuel-
lement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

15.7 Nonobstant ce qui précède, une résolution du Conseil d'Administration peut également être adoptée par con-

sentement unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés par
chaque Administrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.

Art. 16. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
16.1 Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition

et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts
à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

16.2 Plus particulièrement, le rôle du Conseil d'Administration est de définir la stratégie commerciale, financière et de

développement, les principes et procédures gouvernant le Groupe Accuracy, ainsi que la gestion de la nomination et la
démission des Associés.

16.3 Le Conseil d'Administration est également compétent pour: (i) la nomination du Président du Conseil d'Admi-

nistration de la Société, parmi les candidats proposés par le Comité de Candidature du Président, et soumis à la ratification
de l'Assemblée Générale, (ii) la révocation du Président, (iii) proposer à l'assemblée générale ou le conseil d'administration
(conformément à la législation applicable) des Filiales le(s) candidat(s) pour la représentation légale des Filiales, parmi les
candidats proposés par le Comité de Candidature des Président de Filiales, (iv) la révocation du représentant légal des
Filiales, sous la condition suspensive d'une ratification par l'assemblée générale et/ou le conseil d'administration de la
Filiale concernée, (v) déterminer le détail de la rémunération des Associés, (vi) déterminer le montant annuel pouvant
être distribué aux détenteurs d'Actions Ordinaires de Classe A et les détenteurs d'Actions de Préférence de Classe B,
sur proposition du Comité d'Allocation (dans le respect des principes établis dans la Charte des Associés), avant le vote
en Assemblée Générale, (vii) la nomination des membres des Comités Spéciaux, et (viii) l'exclusion d'un Associé.

Art. 17. Délégation de pouvoirs.
17.1 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, Administrateur ou non, pour l'exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

17.2 Particulièrement, le Conseil d'Administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion

journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à
l'article 60 de la Loi, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou
non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le
Conseil d'Administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces
délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

23833

Art. 18. Signatures autorisées.
18.1 La Société est engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers seulement par (i) la signature conjointe d'un

Administrateur de catégorie C et d'un Administrateur B, ou (ii) la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique
signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et
ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 19. Conflit d'intérêts.
19.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont Administrateur, Actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société
ou entité.

19.2 Tout Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

19.3 Au cas où un Administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet Administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne participera pas aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être
fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux
paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations
réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 20. Confidentialité.
20.1 Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil d'Administration, de même que

toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d'Administration, ne devra pas dévoiler des informations
sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation
ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou (ii) l'intérêt du public.

Art. 21. Commissaire(s).
21.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la loi,

par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six ans et
il est rééligible.

21.2 Le commissaire est nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée

de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée
Générale.

Chapitre VI. Comité Spécial

Art. 22. Comité de Candidature du Président.
22.1 Un Comité de Candidature du Président sera mis en place six mois avant l'échéance du terme du mandat de

président.

22.2 Les membres du Comité de Candidature du Président seront membres du Conseil d'Administration à la date à

laquelle le Comité de Candidature du Président sera mis en place et seront nommés comme suit: quatre (4) Adminis-
trateurs (soit de catégorie C ou B), désignés par le Conseil d'Administration.

22.3 Dans la situation d'une réélection (c'est à dire à la fin du premier terme), le rôle du Comité de Candidature du

Président est seulement, à la lumière de l'ensemble des performances du Président, de s'assurer qu'il n'existe aucun doute
significatif qui pourrait entraîner un vote de défiance par une majorité des trois quarts du Conseil d'Administration. Si
une telle situation n'est pas déclenchée, le Conseil d'Administration élira le Président pour un second terme.

22.4 Dans tous les autres cas, le rôle du Comité de Candidature du Président est de prendre et/ou inciter les candi-

datures pour le mandat de Président, de discuter avec les candidats sur leurs motivations et programme et de s'assurer
que de tels candidats sont susceptibles d'être élus par une large majorité des voix.

22.5 Le(s) nom(s) des candidats retenus sera(ont) soumis par le Comité de Candidature du Président au Conseil

d'Administration, lequel retiendra le candidat le plus approprié et le soumettra pour ratification à l'Assemblée Générale.

22.6 Personne ne pourra être nommé Président si toute cette procédure n'a pas été respectée.

Chapitre VII. Exercice social - Comptes annuels - Dissolution et Liquidation

Art. 23. Exercice social.
L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et s'achève le trente et un

décembre de la même année.

23834

Art. 24. Affectation des bénéfices.
24.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pourcent (5%) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pourcent (10%) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 ci-
avant.

24.2 Sous réserve des dispositions de la Charte des Associés et des directives établies par le Conseil d'Administration,

l'Assemblée Générale déterminera le montant du profit annuel pouvant être distribué.

24.3 Les dividendes peuvent être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

peuvent être payés aux lieu et heure choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider
de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi et en conformité avec les
dispositions précédentes, notamment l'article 8.1 des Statuts.

Art. 25. Dissolution et Liquidation.
25.1 La démission ou l'exclusion d'un Actionnaire ne peut provoquer la liquidation de la Société.
25.2 La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale, statuant comme en matière

de modification des statuts. En cas de dissolution de la Société, la liquidation est opérée par un ou plusieurs liquidateurs
(lesquels peuvent être des personnes physiques ou des entités légales) et sont nommées par l'Assemblée Générale qui
décide de cette liquidation. Cette Assemblée Générale détermine également leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

25.3 Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, en ce compris les dépenses de liquidation, le boni

de liquidation sera, sous réserve des conditions prévues par la Loi, distribué aux Actionnaires de la manière suivante:

(i) d'abord à chaque détenteur d'Action Préférentielle de Classe B jusqu'à ce que les montants en nominal et en prime

d'émission (s'il y en a) de ces Actions de Préférence de Classe B aient été remboursés intégralement;

(ii) ensuite, et pour autant que le boni excède les montants payables conformément à l'article 25.3(i), à chaque dé-

tenteur d'Actions Ordinaires de Classe A jusqu'à ce que les montants en nominal et en prime d'émission (s'il y en a) de
ces Actions Ordinaires de Classe A aient été remboursés intégralement; et

(iii) finalement, et dans la mesure où le boni de liquidation excède les montants payables sous les articles 25.3(i) et

25.3(ii) inclus, suivant l'ordre de priorité de paiement et les montants de distribution prévus à l'article 8.

Chapitre VIII. Dispositions générales

Art. 26. Amendements. Les présents statuts pourront être modifiés, à tout moment, par une assemblée générale

extraordinaire, sous réserve du quorum et de la majorité requis à l'article 12.4 (iii).

Art. 27. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas expressément régies par les Statuts seront réglées con-

formément à la Loi.»

<i>Quinzième résolution

Les Actionnaires constatent la fin du mandat du gérant de la Société sous l'ancienne forme de société à responsabilité

limitée et décident la nomination des personnes suivantes en tant qu'Administrateurs, avec effet immédiat et pour une
période échéant lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société à tenir en 2010:

- Monsieur Frédéric DUPONCHEL, prénommé;
- Monsieur Nicolas BARSALOU, prénommé;
- Monsieur Christophe LECLERC, prénommé.

<i>Seizième résolution

Les Actionnaires décident de nommer "FIN-CONTROLE S.A. ", ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12F, rue

Guillaume Kroll, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 42.230 en tant que Commissaire de la Société pour une période échéant lors de l'Assemblée Générale Annuelle
de la Société à tenir en 2010.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à la somme de trois mille deux cents euros (EUR 3.200,00).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec le notaire la présente minute.

23835

Signé: G. Guissard, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 octobre 2009. Relation: LAC/2009/41911. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 16 octobre 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009133412/1226.
(090160959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Dominican Entertainment (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 105.934.

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 4 janvier 2010 qu'il a été décidé

à l'unanimité:

- De révoquer Monsieur Marc Rahola Matutes en tant que Gérant de Classe B de la Société avec effet immédiat au 4

janvier 2010;

- De renommer Monsieur Marc Rahola Matutes, né le 22 janvier 1974 à Barcelona (Espagne), demeurant au 18, Avenida

Bartolome Rosello, Ibiza 07800 (Espagne), en tant que Gérant de Classe A de la Société, pour une durée illimitée et avec
effet immédiat au 4 janvier 2010;

- De nommer Madame Carmen Matutes Prats, née le 31 août 1969 à Ibiza (Espagne), demeurant au 17, Avenida Santa

Eulalia, Ibiza 07800 (Espagne), en tant que Gérant de Classe B de la Société, pour une durée illimitée et avec effet immédiat
au 4 janvier 2010;

- De nommer Monsieur Antonio Serra Tur, né le 15 septembre 1961 à Santa Eulalia del Rio (Iles Baléares / Espagne),

demeurant au 1, c/Joan Castello Guasch, Ibiza 07800 (Espagne), en tant que Gérant de Classe A de la Société, pour une
durée illimitée et avec effet immédiat au 4 janvier 2010;

- De confirmer que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:

<i>Gérants A

Mademoiselle Xenia Kotoula
Monsieur Jorge Pérez Lozano
Monsieur Marc Rahola Matutes
Monsieur Pere Vidal
Monsieur Antonio Serra Tur

<i>Gérants B

Madame Carmen Matutes Prats
Monsieur José Bonet Ribas
Monsieur Abel Matutes Prats
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

<i>Pour la société
Xenia Kotoula
<i>Gérant de Classe A

Référence de publication: 2010022672/37.
(100017944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Tortoise Income &amp; Growth Company S.A., Société Anonyme de Titrisation,

(anc. Tortoise US Energy Infrastructure Trust S.A.).

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 147.785.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

23836

Luxembourg, le 03 février 2010.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010022725/14.
(100018197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Jet Support Services Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 74.037.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2010.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010022726/13.
(100018210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Corporate Express Silver S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 75.881.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57510 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022727/12.
(100018237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Hess Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.332.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

C. WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022728/13.
(100017947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 111.773.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2010.

Référence de publication: 2010022730/10.
(100017596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

23837

DPD (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3290 Bettembourg, 6, Z.A.E. Krakelshaff.

R.C.S. Luxembourg B 42.850.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de

résidence à Luxembourg en date du 8 janvier 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2010.

C. WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022731/13.
(100017553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

DZ PB, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 133.555.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022732/10.
(100018243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Copagest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 35.687.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022733/10.
(100017980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Bulwell Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.276.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022736/10.
(100017618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Anglo American Ferrous Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 122.501.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022737/10.
(100017731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

23838

AZ Euro Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 817.000.000,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 117.806.

Im Jahre zweitausendzehn, den sechsundzwanzigsten Januar, um 11.00 Uhr,
vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Capellen,
hat sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung), die
1) Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in

19, Reinsburgstraße in D-70178 Stuttgart, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter Nummer
HRB 20231,

in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter (der Alleinige Gesellschafter oder Allianz Lebensversicherungs-AG)

der AZ Euro Investments S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 14,
Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 117.806,
gegründet gemäß Urkunde vom 4. Juli 2006, aufgenommen durch Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1719 vom 14. September 2006, zum letzten Mal
abgeändert gemäß Urkunde vom 25. Februar 2009, ebenfalls aufgenommen durch Notar Camille Mines, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 762 vom 8. April 2009 (die Gesellschaft), eingefunden,

sowie, zum Zwecke der Zeichnung der neu herauszugebenden Anteile an der Gesellschaft (die Neuen Gesellschafter)
2) die Allianz Versicherungs - Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in

D-80802 München, Königinstrasse 28, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer
HRB 75727 (die Allianz Versicherungs-AG),

3) die AZ Euro Investments II S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Ge-

sellschaftssitz in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, eingetragen ipm Handelsregister Luxemburg unter
Nummer B 150.633 (die AZ Euro Investments II),

4) die Allianz Vie, eine Gesellschaft französischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in, F-75113 Paris Cedex 02, 87, rue de

Richelieu, eingetragen im Handelsregister Paris unter der Nummer 340 234 962 (die Allianz Vie),

5) die Allianz Insurance plc, eine Gesellschaft englischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 57 Ladymead, Guildford, Surrey

GU1 1DB, England, eingetragen im Handelregister Großbritannien (UK Registrar of Companies) unter der Nummer
84638 (die Allianz plc),

alle vertreten durch Herrn Christian Jungers, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Voll-

machten, ausgestellt in Stuttgart, München, Luxemburg, Paris und Guildford.

Die Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch den Notar und den Vertreter der Erschienenen, ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Alleinige Gesellschafter, namens handelnd wie eingangs erwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachs-

tehende Erklärungen zu beurkunden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass der Alleinige Gesellschafter in gegenwärtiger Generalversammlung

zugegen oder rechtlich vertreten ist; demzufolge ist die Generalversammlung regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig
über  alle  Punkte  der  Tagesordnung  beschließen.  Die  Anwesenheitsliste,  nach  ne  varietur  Unterzeichnung  durch  den
unterzeichneten Notar und die Bevollmächtigten, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregis-
triert zu werden.

II. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Verzicht auf Formalitätsregelungen der Einberufung;
2. Abänderung des Unternehmensgegenstandes und demzufolge Abänderung des zweiten Artikels der Gesellschafts-

satzung gemäß Punkt 9. der Tagesordnung;

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von EUR817.000.000 auf insgesamt EUR2.117.763.200, zu zahlen gemeinsam mit

einer Emissionsprämie in Höhe von EUR204.065.015, durch die Begebung 13.007.632 gleichwertiger Gesellschaftsanteile
mit einem Nennwert von je EUR100, und demzufolge Abänderung des fünften Artikels der Gesellschaftssatzung gemäß
Punkt 9. der Tagesordnung;

4.  Zeichnung  der  unter  3.  erwähnten  13.007.632  gleichwertigen  Gesellschaftsanteile  mit  einem  Nennwert  von  je

EUR100 durch die Allianz-Lebensversicherungs - AG, die Allianz Versicherungs-AG, die AZ Euro Investments II, die Allianz
Vie und die Allianz plc und Einzahlung der Gesellschaftskapitalerhöhung und der Emissionsprämie;

5. Jährliche Ausschüttung des Gewinns der Gesellschaft an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung,

nach Bildung der gesetzlichen Rücklage, und demzufolge Abänderung des sechzehnten Artikels der Gesellschaftssatzung
gemäß Punkt 9. der Tagesordnung;

23839

6. Einführung eines Vorkaufsrechts erstrangig zu Gunsten der Gesellschafter sowie zweitrangig zu Gunsten der Ge-

sellschaft und demzufolge Abänderung von Artikel dreizehn der Satzung der Gesellschaft gemäß Punkt 9. der Tagesord-
nung;

7. Einführung der Einstimmigkeit zur rechtskräftigen Beschlussfassung betreffend Abänderungen der Satzung der Ge-

sellschaft und demzufolge Abänderung von Artikel dreizehn der Satzung der Gesellschaft gemäß Punkt 9. der Tagesord-
nung;

8. Übersetzung der Satzung in die englische Sprache, wobei die deutsche Version maßgebend ist;
9. Neufassung der Satzung der Gesellschaft aufgrund der vorgenannten Beschlüsse.
Sodann trifft die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Gesellschaftskapital anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung

rechtmäßig vertreten ist, beschließt die Generalversammlung auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten;
der Alleinige Gesellschafter betrachtet sich als rechtmäßig geladen und bestätigt volle Kenntnis der Tagesordnung zu
haben, welche ihm vorher mitgeteilt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, den Unternehmensgegenstand gemäß Artikel zwei der Gesellschaftssatzung

abzuändern.

Aufgrund des oben gefassten Beschlusses, beschließt der Alleinige Gesellschafter die Abänderung des zweiten Artikels

der Satzung der Gesellschaft, gemäß Punkt 9. der Tagesordnung.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Gesamtbetrag von EUR1.300.763.200 (eine

Milliarde dreihundert Millionen siebenhundertdreiundsechzigtausend zweihundert Euro) zu erhöhen, zu zahlen gemein-
sam  mit  einer  Emissionsprämie  in  Höhe  von  EUR204.065.015  (zweihundertvier  Millionen  fünfundsechzigtausend  und
fünfzehn Euro), um es von EUR817.000.000 (achthundertsiebzehn Millionen Euro) auf insgesamt EUR2.117.763.200 (zwei
Milliarden einhundertsiebzehn Millionen siebenhundertdreiundsechzigtausend zweihundert Euro) zu erhöhen und zu die-
sem Zwecke insgesamt 13.007.632 (dreizehn Millionen siebentausend sechshundertzweiunddreißig) gleichwertige Ge-
sellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR100 (einhundert Euro) auszugeben.

Aufgrund des oben gefassten Beschlusses, beschließt der Alleinige Gesellschafter die Abänderung des fünften Artikels

der Satzung der Gesellschaft, gemäß Punkt 9. der Tagesordnung.

<i>Vierter Beschluss

Weiterführend zu Punkt 3 der gegenwärtigen Tagesordnung beschließt der Alleinige Gesellschafter sodann, welcher

auf  sein  Vorzugsrecht  hinsichtlich  der  Zeichnung  von  13.007.632  (dreizehn  Millionen  siebentausend
sechshundertzweiunddreißig) Anteilen verzichtet, folgende Zeichnung durch die Neuen Gesellschafter anzunehmen:

<i>Zeichnung - Einzahlung

Der Alleinige Gesellschafter und die Neuen Gesellschafter beschließen (i) die 13.007.632 (dreizehn Millionen sieben-

tausend sechshundertzweiunddreißig) neu ausgegebenen Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) diese mittels
einer Bareinzahlung, in Höhe von EUR1.504.828.215 (eine Milliarde fünfhundertvier Millionen achthundertachtundzwan-
zigtausend zweihundertfünfzehn Euro) voll einzuzahlen. Die Anteile an der Gesellschaft wurden zum 25. Januar 2010
bewertet. Die Berechnung des Wertes der Gesellschaft liegen dieser Urkunde als Anlage 1 bei.

Diese Bareinlage in Höhe von EUR1.504.828.215 (eine Milliarde fünfhundertvier Millionen achthundertachtundzwan-

zigtausend zweihundertfünfzehn Euro) wird folgendermaßen in die Gesellschaft eingezahlt:

(i) ein Betrag von EUR1.300.763.200 (eine Milliarde dreihundert Millionen siebenhundertdreiundsechzigtausend zwei-

hundert Euro) wird in das Gesellschaftskapital eingezahlt; und

(ii) der restliche Betrag von EUR204.065.015 (zweihundertvier Millionen fünfundsechzigtausend und fünfzehn Euro),

wird als Emissionsprämie eingezahlt, wobei insgesamt EUR130.076.320 (einhundertdreißig Millionen sechsundsiebzigtau-
send  dreihundertzwanzig  Euro)  zur  Bildung  der  gesetzlichen  Rücklage  der  Gesellschaft,  die  damit  von  gegenwärtig
EUR81.700.000 (einundachtzig Millionen siebenhunderttausend Euro) auf EUR211.776.320 (zweihundertelf Millionen sie-
benhundertsechsundsiebzigtausend dreihundertzwanzig Euro) erhöht wird, verwendet werden soll, während der restliche
Betrag in Höhe von EUR73.988.695 (dreiundsiebzig Millionen neunhundertachtundachtzigtausend sechshundertfünfund-
neunzig Euro) zur Bildung der freien Rücklage verwendet wird.

Der amtierende Notar stellt fest, aufgrund einer Bankbestätigung vom 25. Januar 2010, dass die Summe in Höhe von

EUR1.504.828.215  (eine  Milliarde  fünfhundertvier  Millionen  achthundertachtundzwanzigtausend  zweihundertfünfzehn
Euro) auf das Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt wurde, und der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht.

Die Aufteilung der neu ausgegebenen Anteile unter dem Alleinigen Gesellschafter und den Neuen Gesellschaftern

erfolgt folgendermaßen:

23840

Gesellschafter

Neue Anteile

Eingezahlter Betrag

Allianz Lebensversicherungs-AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.239.989

EUR374.828.215

Allianz Versicherungs-AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.321.966

EUR500.000.000

AZ Euro Investments II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.555.908

EUR180.000.000

Allianz Vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.457.572

EUR400.000.000

Allianz plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

432.197

EUR50.000.000

Daraus ergeben sich für die Gesellschaft nunmehr folgende Anteilsverhältnisse:

Anteilsinhaber

Anzahl der
gehaltenen

Anteile

Allianz Lebensversicherungs-AG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.409.989

Allianz Versicherungs-AG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.321.966

AZ Euro Investments II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.555.908

Allianz Vie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.457.572

Allianz plc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

432.197

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.177.632

<i>Fünfter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die jährliche Vollausschüttung des Gewinns der Gesellschaft an die Gesell-

schafter,  entsprechend  der  Anzahl  ihrer  gehaltenen  Anteile,  nach  Bildung  der  gesetzlichen  Rücklage,  es  sei  denn  die
Generalversammlung der Gesellschafter würde einstimmig einen anders lautenden Beschluss fassen. Die Neuen Gesell-
schafter haben ein Anrecht auf den Gewinn des gesamten Jahres 2009.

Aufgrund des oben gefassten Beschlusses, beschließt der Alleinige Gesellschafter die Abänderung des sechzehnten

Artikels der Satzung der Gesellschaft, gemäß Punkt 9. der Tagesordnung.

<i>Sechster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, im Falle mehrerer Gesellschafter ein Vorkaufsrecht für diese im Verhältnis

ihrer Beteiligung an der Gesellschaft einzuführen, sofern die Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht wahrnehmen, fällt
dieses der Gesellschaft zu, insofern das Vorkaufsrecht weder durch die Gesellschafter noch durch die Gesellschaft wahr-
genommen  wurde,  so  können  die  Anteile  im  Rahmen  von  Artikel  189  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über
Handelsgesellschaften veräußert werden und ansonsten auf die Bestimmungen von zuvor genanntem Artikel 189 zu ver-
weisen.

Aufgrund des oben gefassten Beschlusses, beschließt der Alleinige Gesellschafter die Abänderung des dreizehnten

Artikels der Satzung der Gesellschaft, gemäß Punkt 9. der Tagesordnung.

<i>Siebter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Einstimmigkeit zur rechtskräftigen Beschlussfassung in Bezug auf Abände-

rungen der Satzung der Gesellschaft einzuführen.

Aufgrund des oben gefassten Beschlusses, beschließt der Alleinige Gesellschafter die Abänderung des dreizehnten

Artikels der Satzung der Gesellschaft, gemäß Punkt 9. der Tagesordnung.

<i>Achter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Satzung der Gesellschaft in die englische Sprache zu übersetzen, wobei die

deutsche Version maßgebend ist.

<i>Neunter Beschluss

Der Wortlaut der Satzung der Gesellschaft ist demnach folgender:

Art. 1.  Es  besteht  zwischen  den  Erschienenen  und  jeder  natürlichen  oder  juristischen  Person,  die  in  der  Zukunft

Gesellschafter  der  Gesellschaft  werden  könnte,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité
limitée) mit der Firmenbezeichnung "AZ Euro Investments S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögenswerten, zur eigenen Vermö-

gensanlage. Die Gesellschaft darf, mit Ausnahme des Aufnehmens von Fremdmitteln, alle Geschäfte betreiben, die mit
dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängen und diesem unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des

einzigen Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden.

23841

Die Gesellschaft darf Büros und Zweigniederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen und unterhalten.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR2.117.763.200 (zwei Milliarden einhundertsiebzehn Millionen

siebenhundertdreiundsechzigtausend zweihundert Euro), eingeteilt in 21.177.632 (einundzwanzig Millionen einhundert-
siebenundsiebzigtausend sechshundertzweiunddreißig) gleichwertige Anteile mit einem Nennwert von je EUR100 (ein-
hundert Euro), welche voll eingezahlt sind.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem einzigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß

Artikel 13 dieser Satzung abgeändert werden.

Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Vermögenswerte und der Gewinne der Gesellschaft, der im direkten

proportionalen Verhältnis zur Zahl der bestehenden Anteile steht.

Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen.

Teileigentümer müssen eine einzelne Person bestimmen, die sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Der Übertragung von Anteilen durch einen Gesellschafter, der dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz

unterliegt, kann, sofern diese Anteile dem Sicherungsvermögen zugeführt sind, nur mit vorheriger Zustimmung des bes-
tellten Treuhänders oder eines seiner Stellvertreter nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz erfolgen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehr Geschäftsführer geleitet. Die Geschäftsführer bilden einen Ge-

schäftsführerrat. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der
Generalversammlung der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, ernannt, abberufen,
und ersetzt (ohne dass es hierbei der Angabe von Gründen bedarf).

Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, unter jeden Umständen im Namen der Gesellschaft zu

handeln, alle Handlungen und Geschäfte übereinstimmend mit dem Gesellschaftszweck der Gesellschaft durchzuführen
und zu bestätigen, insofern Artikel 11 dieser Satzung berücksichtig wurde.

Die Geschäftsführer sind befugt, alle Handlungen und Geschäfte vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz oder durch

diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Die Generalversammlung der Gesellschafter oder der Geschäftsführerrat kann ihre, bzw. seine Befugnisse für spezifische
Aufgaben einem oder mehreren ad hoc Bevollmächtigten übertragen.

Die Generalversammlung der Gesellschafter oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse und gegebenenfalls

das Gehalt dieser Bevollmächtigten, die Dauer deren Auftrages und jede relevante Bedingung deren Mandats bestimmen.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder ver-

tretenen Geschäftsführer gefasst.

Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax oder E-Mail wenigstens 24 (vierundzwan-

zig) Stunden im Voraus über die Abhaltung einer Sitzung des Geschäftsführerrats informiert, außer in Dringlichkeitsfällen.
Auf diese schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und
bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine separate Einberufung ist
nicht nötig für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des
Geschäftsführerrates festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per
Brief, Telefax oder E-Mail zu seiner Vertretung anlässlich einer Sitzung des Geschäftsführerrates bevollmächtigen. Die
Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen, müssen den entsprechenden Beschluss jedoch schriftlich bestätigen.
Beschlüsse können nur dann gefasst werden, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbes-

chluss  gefasst  werden.  Ein  Umlaufbeschluss  gilt  dann  als  gefasst,  wenn  eines  oder  mehrere  Dokumente,  welche  den
Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als
Datum des Beschlusses.

Art. 12. Die Geschäftsführer, aufgrund deren Stellung, können nicht persönlich haftbar gemacht werden in Bezug auf

die Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft und im Rahmen ihrer Befugnisse eingegangen sind.

Art. 13. Der alleinige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Generalversammlung der Gesellschafter vorbe-

halten sind. Falls es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen
teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemein-
same Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
halten, angenommen werden.

Im Falle mehrerer Gesellschafter müssen zum Verkauf stehende Gesellschaftsanteile zunächst den Mitgesellschaftern

angeboten werden. Zu diesem Zwecke informiert der Gesellschafter, welcher seine Anteile zum Verkauf anbietet, den
Geschäftführerrat schriftlich über sein Vorhaben. Der Geschäftsführerrat informiert sodann die übrigen Gesellschafter
schriftlich über das Verkaufsangebot. Jeder Gesellschafter hat ein Vorkaufsrecht hinsichtlich der zum Verkauf stehenden

23842

Anteile verhältnismäßig zu seiner Beteiligung an der Gesellschaft. Tritt ein Gesellschafter vollumfänglich oder teilweise
von seinem Vorkaufsrecht zurück, so geht dessen Anspruch verhältnismäßig auf die übrigen Gesellschafter über. Jeder
Gesellschafter informiert den Geschäftsführerrat über seine Entscheidung hinsichtlich der Ausübung seines Vorkaufsrecht
und die Anzahl der zu erwerbenden Anteile. Der Geschäftsführerrat teilt daraufhin den Gesellschaftern schriftlich mit,
welche Gesellschafter von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht haben sowie die Anzahl der erworbenen Anteile.

Sofern die Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht, beziehungsweise nicht vollständig ausüben, geht dieses an die Ge-

sellschaft über. Der Geschäftsführerrat entscheidet frei über den Rückkauf der zum Verkauf stehenden Anteile, voraus-
gesetzt die Gesellschaft verfügt über ausreichende freie Rücklagen, sodass das Gesellschaftskapital unangetastet bleibt.
Falls die freien Rücklagen nicht für den Rückkauf der zum Verkauf stehenden Anteile ausreichen und der Geschäftsfüh-
rerrat  dennoch  vom  Vorkaufsrecht  der  Gesellschaft  Gebrauch  machen  will,  so  muss  dieser  eine  außerordentliche
Generalversammlung der Gesellschafter einberufen welche über eine Herabsetzung des Gesellschaftskapitals im Rahmen
der Ausübung des Vorkaufsrecht der Gesellschaft entscheidet.

Insofern von den Vorkaufsrechten weder durch die Gesellschafter, noch durch die Gesellschaft Gebrauch gemacht

wird, können die Gesellschaftsanteile im Rahmen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften (das Gesetz über die Handelsgesellschaften) veräußert werden. Der Kaufpreis zu dem die Gesellschafter
ihr Vorkaufsrecht an den zu veräußernden Gesellschaftsanteilen ausüben können, ergibt sich aus dem Nettowert der
Vermögenswerte der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Vermögenswerte der Gesellschaft zum Zeitpunkt
des Verkaufs der Gesellschaftsanteile. Ansonsten ist Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften anwendbar.

Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Einstimmigkeit aller Gesellschafter.

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 15. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und die

Geschäftsführer erstellen die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich eines Inventars der Aktiva und Passiva
der Gesellschaft.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich des Inventars stehen jedem Gesellschafter am Gesell-

schaftssitz zur Einsicht zur Verfügung.

Zwecks Aufsicht und Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft können ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer benannt

werden.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt den oder die möglichen Wirtschaftsprüfer

und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann den oder die Wirtschaftsprüfer jederzeit ab-

berufen. Der bzw. die Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

Art. 16. Die Brutto-Einkünfte der Gesellschaft wie sie aus der Jahresbilanz hervorgehen, minus die allgemeinen Kosten

und Abschreibungen, bilden den Reingewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die
Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschafts-
kapital erreicht hat. Der verbleibende Reingewinn wird jährlich, an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteili-
gung zum Tag der Ausschüttung ausgeschüttet, es sei denn die Gesellschafter treffen einstimmig einen anders lautenden
Beschluss. Der Geschäftsführerrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuschütten.

Art. 17. Die Abwicklung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liquida-

toren können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von den Gesellschaftern ernannt, die deren Rechte
und Gehalt festlegen.

Art. 18. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes über die

Handelsgesellschaften verwiesen.

Es folgt die Übersetzung In die Englische Sprache des vorausgegangenen Textes:

Art. 1. There exists between the appeared persons and every natural or legal person, which could become shareholder

of the Company in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "AZ
Euro Investments S.à r.l." (the Company).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition and the management of assets for its own investment. The

Company is entitled to carry out all transactions pertaining, and directly or indirectly beneficial, to the Company's object
with the exception of borrowings.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an ordinary resolution of its

sole shareholder or its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

23843

Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR2,117,763,200 (two billion one hundred seventeen

million seven hundred sixty-three thousand two hundred euro), represented by 21,177,632 (twenty-one Million one
hundred seventy-seven thousand six hundred thirty-two) shares having a nominal value of EUR100 (one hundred Euro)
per share each, which are fully paid-up.

Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the

shareholders, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. The transfer of shares held by any shareholder which is subject to the German Insurance Supervision Act must

be authorised, prior to the transfer, by the appointed trustee or one of its agents in accordance with § 70 of the German
Insurance Supervision Act, provided that these shares are affected to the guarantee assets.

Art. 10.  The  death,  suspension  of  civil  rights,  insolvency  or  bankruptcy  of  the  sole  shareholder  or  of  one  of  the

shareholders will not terminate the Company.

Art. 11. The Company is managed by two or more managers. The managers will constitute a board of managers. The

managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general
meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital (without having to
indicate any reasons).

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf

of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 11 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-

holders fall within the power of the managers.

The Company shall be bound by the joint signature of two members of the board of managers. The general meeting

of the shareholders or the board of managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc
agents.

The general meeting of the shareholders or the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or

electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circum-
stances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that
they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held
at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager
may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another
manager as his proxy. The managers may also vote by telephone, however, the managers need to confirm such a resolution
in writing. Resolutions may only be adopted if the majority of the managers is present or represented.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed by circular resolutions. A

circular resolution is adopted when one or several documents containing the resolutions have been signed by each and
every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 12. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders. In case of a

plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares,
which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

In the event of several shareholders, the shares in the Company to be sold must be offered primarily to the other

shareholders of the Company. For this purpose, the shareholder willing to sell his shares in the Company informs the
board of managers in writing about his intention to sell his shares. The board of managers then informs the other share-
holders in writing about the offer to sell. Every shareholder benefits from a preemption right regarding the shares in the
Company in proportion to the shares he holds in the Company. If a shareholder renounces to his preemption right, in
whole or in part, his pre-emption right passes on a pro rate basis to the remaining shareholders. Every shareholder
informs the board of managers about his decision to exercise his pre-emption right and the amount of shares he wishes
to acquire. The board of managers then communicates in writing to the shareholders the identity of the shareholders
exercising their pre-emption right as well as the amount of shares acquired.

23844

Insofar as the shareholders do not exercise their pre-emption right, in whole or in part, the pre-emption right passes

to the Company. The board of managers freely decides on the redemption of the shares being for sale, provided that the
Company has allocated sufficient funds to the free reserve so that the share capital of the Company is not affected by the
redemption of shares. In case the board of managers wishes to proceed with the redemption of shares despite of the
Company's free reserve not being sufficient for this purpose, the board of managers shall convene an extraordinary
meeting of shareholders in order to decide on the reduction of the Company's share capital in relation to the redemption
of the shares.

Insofar as neither the shareholders nor the Company use their preemption right, the shares may be sold in accordance

with the provisions of article 189 of the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies
Act). The purchase price of the shares in the Company, applicable when the shareholders use their pre-emption right, is
calculated on the net asset value of the assets of the Company, based on the assets of the Company at the moment of
sale of the shares in the Company. Over and beyond article 189 of the Companies Act is applicable.

Resolutions modifying the articles of association of the Company are adopted unanimously by all the shareholders of

the Company.

Art. 14. The Company's year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the managers prepare

the balance sheet, the profit and loss statements and an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above profit and loss statements and balance sheet at the Company's registered

office.

For auditing and supervisory purposes of the activities of the Company, one or more independent external auditors

may be appointed.

The sole shareholder or the general meeting of the shareholders appoint the external auditor(s) and determine the

term of their office, which may not exceed six years.

The sole shareholder or the general meeting of the shareholders may revoke the independent external auditor(s) at

any time. They shall be eligible for re-appointment.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits on the day of distribution will be distributed every year to the shareholders com-
mensurate to their share holding in the Company, unless a contrary but unanimous decision is taken by the shareholders.
The board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Gebührenschätzung

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und Kosten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte auf ca. EUR 6.800,-geschätzt und fallen zu Lasten
der Gesellschaft.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen und keine weiteren Ersuchen gestellt wurden, wurde die

Generalversammlung um 11.30 Uhr geschlossen.

Der unterzeichnende Notar, der englischen Sprache mächtig, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der erschienenen

Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ver-
langen der erschienenen Parteien, im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist
die deutsche Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem, hat die Erschienene zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben.

Folgt die englische Übersetzung des Vorausgegangenen:

In the year two thousand and ten, on the twenty-sixth January, at 11.00 a.m.,
before us, Maître Camille Mines, notary, residing in Capellen, was held an extraordinary general meeting of the share-

holders (the Meeting) of AZ Euro Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at 14, Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies register under number B 117.806, incorporated pursuant to a notarial deed dated 4 July 2006 and recorded

23845

by Maître Camille Mines, notary residing in Capellen, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché
de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C), under number 1719 dated 14 September 2006,
amended for the last time pursuant to a notarial deed of Maître Camille Mines, dated 25 February 2009, published in the
Official Gazette under number 762 dated 8 April 2009 (the Company),

there appeared,
1) Allianz Lebensversicherungs - Aktiengesellschaft, a company incorporated under German law, having its registered

office at D-70178 Stuttgart, Reinsburgstraße 19, registered with the trade register of the local court of Stuttgart under
number HRB 20231,

in its capacity as sole shareholder (the Sole Shareholder or Allianz Lebensversicherungs-AG) of AZ Euro Investments

S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at L-2450
Luxembourg, 14 Boulevard F.D. Roosevelt, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B. 117.806 (the Company),

as well as for the subscription of the newly issued shares in the Company (the New Shareholders),
2) Allianz Versicherungs - Aktiengesellschaft, a company incorporated under German law, having its registered office

at D-80802 München, Königinstrasse 28, registered with the trade register of the local court of Munich under number
HRB 75727 (hereinafter referred to as Allianz Versicherungs-AG);

3) AZ Euro Investments II S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with

registered office at L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under the number B 150.633 (hereinafter referred to as AZ Euro Investments II);

4) Allianz Vie, a company incorporated under French law, with registered office at F-75113 Paris Cedex 02, 87, rue

de Richelieu, registered with the Trade and Companies Register of Paris under the number 340 234 962 (hereinafter
referred to as Allianz Vie);

5) Allianz Insurance plc, a company incorporated under English law, having its registered office at 57 Ladymead, Guild-

ford, Surrey GU1 1DB, England, registered with the UK Registrar of Companies under the number 84638 (hereinafter
referred to as Allianz plc),

hereby represented by Maître Christian Jungers, attorney at law, having his professional address in Luxembourg, by

virtue of powers of attorney under private seal, given in Stuttgart, Munich, Luxembourg, Paris and Guildford on 21 January
2010.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder, shall remain annexed

to the present minutes.

The Sole Shareholder, acting as stated above, has requested the undersigned notary to record the following statements:
I. that it results from the presence list, that the Sole Shareholder is duly present or represented at the Meeting. The

Meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate upon all the items of the agenda. The presence list, after
having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder, shall remain annexed to the present
minutes.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

<i>Agenda

1. Waiver of the convening notices;
2. Modification of the company object and subsequent amendment of article two of the articles of association of the

Company in accordance with point 9 of the present agenda;

3. Increase of the share capital of the Company from EUR817,000,000 to EUR2,117,763,200, together with a premium

payment of EUR204,065,015, further to the issuance of 13,007,632 shares having a nominal value of EUR100 per share
each, and subsequent amendment of article five of the articles of association of the Company in accordance with point 9
of the present agenda;

4. Subscription to the 13,007,632 shares mentioned under point 3 and having a nominal value of EUR100 per share

each by Allianz Lebensversicherungs-AG, Allianz Versicherungs-AG, AZ Euro Investments II, Allianz Vie and Allianz plc
and payment of the share capital increase and of the premium;

5. Annual payment of the profit of the Company to the shareholders in proportion to the number of shares they hold,

after constitution of the legal reserve, and subsequent amendment of article sixteen of the articles of association of the
Company in accordance with point 9 of the present agenda;

6. Introduction of a pre-emption right, primarily for the shareholders of the Company, secondarily for the Company,

for Company shares and subsequent amendment of article thirteen of the articles of association of the Company in
accordance with point 9 of the present agenda;

7. Introduction of a unanimity vote regarding modification of the articles of association of the Company and subsequent

amendment of article thirteen of the articles of association of the Company in accordance with point 9 of the present
agenda;

23846

8. Translation of the articles of association into the English language, whereby the German version of the articles of

association prevails;

9. Re-drafting of the articles of association of the Company further to the previous resolutions.
Thereafter, the Meeting passes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

As the entirety of the corporate share capital is regularly represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notices, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to change the object of the Company as mentioned in article two of the articles of

association of the Company.

As a consequence of the above, the Sole Shareholder resolves to amend article two of the articles of association of

the Company, in accordance with point 9 of the agenda.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the company by a total amount of EUR1,300,763,200

(one billion three hundred million seven hundred sixty-three thousand two hundred euro), to be paid together with the
premium payment of EUR204,065,015 (two hundred four million sixty-five thousand and fifteen euro), in order to bring
the share capital from currently EUR 817,000,000 (eight hundred and seventeen million euro) to EUR2,117,763,200 (two
billion one hundred seventeen million seven hundred sixty-three thousand two hundred euro), by way of issuance of
13,007,632  (thirteen  Million  seven  thousand  six  hundred  thirty-two)  shares  having  a  nominal  value  of  EUR100  (one
hundred Euro) per share each.

Further to this capital increase, the Sole Shareholder resolves to subsequently amend article five of the articles of

association of the Company, in accordance with point 9 of the present agenda.

<i>Fourth resolution

Further to point 3 of the present agenda, the Sole Shareholder waives its preferential subscription right with respect

to 13,007,632 (thirteen Million seven thousand six hundred thirty-two) newly issued shares, and accepts the following
subscription of the shares by the New Shareholders:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder and the New Shareholders resolve (i) to subscribe to the 13,007,632 (thirteen Million seven

thousand six hundred thirty-two) newly issued shares in the Company and (ii) to proceed to a cash payment of these
shares in a total amount of EUR1,504,828,215 (one billion five hundred four million eight hundred twenty-eight thousand
two hundred fifteen euro). The shares in the Company were evaluated as of 25 January 2010. This calculation of the value
of the Company are enclosed to the present deed (appendix 1).

This cash payment in a total amount of EUR1,504,828,215 (one billion five hundred four million eight hundred twenty-

eight thousand two hundred fifteen euro) will be executed as follows:

(i) a total amount of EUR1,300,763,200 (one billion three hundred million seven hundred sixty-three thousand two

hundred euro) will be paid into the share capital of the Company;

(ii) the remaining amount of EUR204,065,015 (two hundred four million sixty-five thousand and fifteen euro) will be

paid as a premium, whereby EUR130,076,320 (one hundred thirty million seventy-six thousand three hundred twenty
euro) will be transferred into the legal reserve of the Company, which will be increased from currently EUR81,700,000
(eighty-one million seven hundred thousand euro) to EUR211,776,320 (two hundred eleven million seven hundred sev-
enty-six thousand three hundred twenty euro), whereas EUR73,988,695 (seventy-three million nine hundred eighty-eight
thousand six hundred ninety-five euro) will be used to create the free reserve.

The  undersigned  notary  declares  that,  according  to  a  bank  confirmation  dated  25  January  2010,  the  amount  of

EUR1,504,828,215 (one billion five hundred four million eight hundred twenty-eight thousand two hundred fifteen euro)
has been transferred to the bank account of the Company, and that this amount is at the disposal of the Company as of
today.

The newly issued shares are distributed between the Sole and the New Shareholders as follows:

Shareholders

New shares

Amount paid

Allianz Lebensversicherungs-AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,239,989

EUR374,828,215

Allianz Versicherungs-AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,321,966

EUR500,000,000

AZ Euro Investments II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,555,908

EUR180,000,000

Allianz Vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,457,572

EUR400,000,000

Allianz plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

432,197

EUR50,000,000

23847

As a result of the issuance of new shares in the Company, the shareholding is constituted as follows:

Shareholder

Number of

shares

Allianz Lebensversicherungs-AG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,409,989

Allianz Versicherungs-AG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,321,966

AZ Euro Investments II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,555,908

Allianz Vie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,457,572

Allianz plc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

432,197

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,177,632

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to proceed to an annual payment of the entire profit of the Company to the shareholders

in proportion to the number of shares they hold, after constitution of the legal reserve, except if the general meeting of
the shareholders unanimously takes a different resolution. The New Shareholders are entitled to the profit for the entire
year 2009.

The Sole Shareholder subsequently resolves to amend article sixteen of the articles of association of the Company in

accordance with point 9 of the present agenda.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves, in the event of several shareholders, a pre-emption right for these shareholders, in

proportion to the number of shares they hold in the Company, if the shareholders do not use their preemption right,
the pre-emption right passes to the Company, if the preemption right is neither used by the shareholders, nor by the
Company, the shares may be sold in accordance with article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial com-
panies, as modified and to refer in other respects to the provisions of said article 189.

The Sole Shareholder subsequently resolves to amend article thirteen of the articles of association of the Company

in accordance with point 9 of the present agenda.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to introduce a unanimity vote regarding modifications to the articles of association of

the Company.

The Sole Shareholder subsequently resolves to amend article thirteen of the articles of association of the Company

in accordance with point 9 of the present agenda.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to proceed to the translation of the articles of association of the Company into the

English language, whereby the German version of the articles of association prevails.

<i>Ninth resolution

The wording of the articles of association is as follows:
Please see resolution 9 of the German version above.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated, with reservation of all rights, to be approximately EUR 6,800.- and will be at
charge of the Company.

Nothing else being on the agenda and no further requests raised, the Meeting was closed at 11.30 a.m..
The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing

person, this notarial deed is worded in English, followed by a German translation. At the request of the same appearing
person, and in the case of discrepancy between the English and the German versions, the German version shall prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Gezeichnet: C. JUNGERS, C. MINES
Enregistré à Capellen, le 27 janvier 2010. Relation: CAP/2010/308. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Folgt Abschrift der beigefügten Anlagen, für gleichlautende Abschrift.

23848

Capellen, den 29. Januar 2010.

Référence de publication: 2010021682/548.
(100017143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

Anglo Iron Ore Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 122.492.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022738/10.
(100017732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

NSH Hollenfels S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LuxCo 105 S.à r.l.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 149.007.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022739/11.
(100017808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

NSH Ansembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LuxCo 102 S.à r.l.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 149.005.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022741/11.
(100018246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Kantec, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 118.316.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022742/10.
(100017733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

JP Commercial I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 110.833.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022743/11.
(100017984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

23849

WPP Luxembourg Gamma Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.018.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Référence de publication: 2010022744/10.
(100017877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Five Mounts Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 93.862.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010022752/11.
(100018005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

OI-Games S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 147.203.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2010.

C. WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022749/13.
(100017556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

M.T.H. Finances S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 74.231.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2009 documenté par Maître Joëlle

BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2010, LAC / 2010 / 835.

Que:
- la Société a été mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat,
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-2227 Luxembourg, 23 avenue

de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Pour extrait conforme
Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2010022532/20.
(100018227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

23850

Ausinium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 115.337.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/02/2010.

Référence de publication: 2010022260/10.
(100016991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

Innova Financial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.243.000,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 128.343.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth of January.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

INNOVA/4 L.P., a foreign limited partnership registered under laws of England and Wales, whose principal place of

business is at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, registered under the number LP 11130, here represented by Mr. Raymond THILL, by virtue of a power of attorney
dated January 15, 2010.

GESDORAS INVESTMENTS Limited, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, having its

registered office at 20, Spyrou Kyprianou Avenue, Chapo Central, 3 

rd

 Floor, CY-1075 Nicosia, Cyprus, registered under

the number 190674, here represented by Mr. Raymond THILL, by virtue of a power of attorney dated January 15, 2010.

FRIENDS OF INNOVA L.P., having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, PO Box 908GT George

Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under the number WK-21369, here represented by Mr. Raymond
THILL, by virtue of a power of attorney dated January 15, 2010.

Mr. Slawomir LUKASIEWICZ residing at ul. Kasztanowa 8, 55-010 Zerniki Wroclawskie, Poland, here represented by

Mr. Raymond THILL, by virtue of a power of attorney dated January 15, 2010.

Which powers of attorney, after being signed by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to enact the following:
- That the 'société à responsabilité limitée' INNOVA FINANCIAL HOLDING S. à r. l, is a private limited liability

company, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître
Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on May 16 

th

 , 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations number 1436, dated July 12 

th

 , 2007 (the Company).

- The articles of incorporation of the Company have been amended last by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary

residing in Luxembourg, on the 11 

th

 of December 2009, in process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

- That the share capital of the Company amounts to thirty-five million five hundred and six thousand one hundred and

twenty-five euro (35,506,125.00 EUR), represented by two hundred and eighty-four thousand and forty-nine (284,049)
shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.00) each.

- That the appearing parties represent 100 % of the share capital.
- That the appearing parties fixed the agenda as follows:

<i>Agenda

1. Increase of the Company's subscribed share capital in EUR currency up to the amount of 7,000,000 PLN (seven

million Polish zlotys) (value in EUR corresponding to the exchange rate communicated by Société Générale Bank &amp; Trust
Luxembourg, as of actual date of the extraordinary general meeting of the Company) through the issue of a - round
number of - new shares of a par value of EUR 125 each. The increase in the capital will be carried out through a contribution
in kind as follows:

- Payment in kind by Innova /4 L.P. by conversion of loan between Innova/4 L.P. and the Company of the Euro equivalent

up to the amount of 7,000,000 PLN (seven million Polish zlotys) (value in EUR corresponding to the exchange rate
communicated by Société Générale Bank &amp; Trust Luxembourg, the date of the extraordinary general meeting of the

23851

Company) provided that the capital increase will result in creation for Innova/4 LP of the highest amount of new shares
with nominal value of 125 EUR each that will be possible with the applicable exchange rate.

2. Subscription;
3. Waiving to the preferential subscription right by the other shareholders;
4. Amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association further to the aforementioned resolutions;
5. Miscellaneous.
Considering the above agenda, the Shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution:

It is decided to increase the Company's subscribed share capital by the Euro equivalent of 7,000,000 PLN (seven million

Polish zlotys) using the exchange rate communicated by Société Générale Bank &amp; Trust Luxembourg, as of today's date,
which is EUR 1.00 for PLN 4.0300, so as to raise it from its present amount of EUR 35,506,125.00 (thirty-five million five
hundred and six thousand one hundred and twenty-five Euro) to EUR 37,243,000 (thirty-seven million two hundred and
forty-three thousand Euro) through the issue of a - round number of - new shares (13,895) with a nominal value of 125.00
EUR each.

<i>Second resolution

<i>Subscription - Payment

INNOVA/4 L.P., a foreign limited partnership registered under laws of England and Wales, whose principal place of

business is at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, registered under the number LP 11130, here represented by proxy by Mr. Raymond THILL declared to subscribe
to 13,895 (thirteen thousand eight hundred and ninety five) new shares with a nominal value 125.00 EUR each and to pay
them up by irrevocable waiver of its claim against the company, the claim being waived up to PLN 6,999,606.25 (six million
nine  hundred  ninety-nine  thousand  six  hundred  and  six  point  twenty-  five  Polish  zlotys)  which  value  in  Euro  (EUR
1,736,875.00 (one million seven hundred and thirty six thousand eight hundred and seventy-five euros)) corresponds to
the exchange rate communicated by Société Générale Bank &amp; Trust Luxembourg, as of today's date.

<i>Third resolution

The meeting states the waiver of their preferential subscription right by the following shareholders: Gesdoras Invest-

ments Limited, Friends of Innova L.P. and Mr. Slawomir LUKASIEWICZ,

<i>Fourth resolution

The meeting further decides to modify Article 6 of the Company's Articles of Association taking into account the

aforementioned resolutions:

Art. 6. "The Company's capital is set at EUR 37,243,000 (thirty-seven million two hundred and forty-three thousand

Euro) represented by 297,944 (two hundred and ninety-seven thousand nine hundred and forty-four) shares with a par
value of one hundred and twenty-five euro (125.00 EUR) each."

<i>Fifth resolution

The remaining PLN 393.75 (three hundred and ninety-three point seventy five Polish zlotys) of the loan between

Innova/4 LP and the Company that has not been used as payment towards the capital in accordance with the Second
Resolution given above shall remain in the Company as the ordinary shareholders loans.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately two thousand seven hundred euro (EUR 2,700.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le quinze janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

ONT COMPARU:

23852

INNOVA/4 L.P., société enregistrée sous la loi d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Walkers SPV

Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée sous le
numéro LP 11130, ici représentée par Monsieur Raymond THILL, en vertu d'une procuration sous seing privé datée le
15 janvier 2010.

GESDORAS INVESTMENTS Limited, société de droit de le République de Chypre, ayant son siège social à 20, Spyrou

Kyprianou Avenue, Chapo Central, 3 

rd

 Floor, CY-1075 Nicosia, Cyprus, enregistrée sous le numéro 190674, ici repré-

sentée par Monsieur Raymond THILL, en vertu d'une procuration sous seing privé datée le 15 janvier 2010.

FRIENDS OF INNOVA L.P., société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street,

PO Box 908GT George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée sous le numéro WK-21369, ici représentée par
Monsieur Raymond THILL, en vertu d'une procuration sous seing privé datée le 15 janvier 2010.

Monsieur Slawomir LUKASIEWICZ résidant à ul. Kasztanowa 8, 55-010 Zerniki Wroclawskie, Pologne, ici représenté

par Monsieur Raymond THILL, en vertu d'une procuration sous seing privé datée le 15 janvier 2010.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée INNOVA FINANCIAL HOLDING S. à r. l., société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1436 du 12 juillet 2007 (la Société).

- Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié reçu par Maître Martine Schaeffer,

notaire de résidence à Luxembourg, daté du 11 décembre 2009, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

-  Que  le  capital  social  de  la  Société  s'élève  à  trente  cinq  millions  cinq  cent  et  six  mille  cent  vingt-cinq  euros

(35.506.125,00 EUR), représenté par deux cent quatre-vingt-quatre mille quarante-neuf (284.049) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,00 EUR) chacune.

- Que les comparantes représentent 100 % du capital.
- Que les comparantes ont fixé l'ordre du jour comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social en euros d'un montant de PLN 7.000.000,00 (sept millions de zlotys polonaises)

correspondant au taux de change communiqué par la Société Générale Bank &amp; Trust Luxembourg aujourd'hui par l'émis-
sion d'un nombre -entier- de nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 125,00 (cent vingt-cinq euros)
par apport en nature comme suit:

- Conversion du prêt entre INNOVA/4 L.P. et la Société de l'équivalent en euros de PLN 7.000.000,00 (sept million

de zlotys polonaises), valeur en euros correspondant au taux de change communiqué par la Société Générale Bank &amp;
Trust Luxembourg à la date d'aujourd'hui, étant entendu que l'augmentation de capital produira un montant maximum
de nouvelles parts sociales de valeur nominale EUR 125,00 (cent vingt-cinq euros) qu'il sera possible d'émettre avec le
taux de change qui sera appliqué et au prorata du pourcentage de détention de INNOVA/4 L.P. comme indiqué ci-dessous;

2. Souscription;
3. Renonciation au droit préférentiel de souscription;
4. Modification de l'article 6 des statuts pour prendre en compte les résolutions prises ci-dessus;
5. Divers.
Sur base de l'ordre du jour précité, les associés prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de l'équivalent en euros d'un montant de PLN 7.000.000,00

(sept millions de zlotys polonaises) au taux de change communiqué par la Société Générale Bank &amp; Trust Luxembourg
aujourd'hui, qui est de EUR 1,00 pour PLN 4,0300 pour le porter de son montant actuel de EUR 35.506.125,00 à EUR
37,243,000 par l'émission d'un nombre -entier- de nouvelles parts sociales (13.895) avec une valeur nominale de EUR
125,00 (cent vingt-cinq euros).

<i>Deuxième résolution

<i>Souscription Paiement

INNOVA/4 L.P., société enregistrée sous la loi d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Walkers SPV

Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée sous le
numéro LP 11130, représentée en vertu d'une procuration sous seing privé par Monsieur Raymond THILL a déclaré
souscrire à 13.895 (treize mille huit cent quatre-vingt-quinze) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 125,00
(cent vingt-cinq euros) et a déclaré les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance
certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société et en annulation de cette même créance à

23853

concurrence de PLN 6.899.606,25 (six millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent six virgule vingt-cinq zlotys
polonaises) dont la valeur en euros (EUR 1.736.875,00 (un million sept cent trente-six mille huit cent soixante-quinze
euros)) correspond au taux de change communiqué par la Société Générale Bank &amp; Trust Luxembourg aujourd'hui.

<i>Troisième résolution

L'assemblée constate la renonciation de leur droit préférentiel de souscription par les actionnaires suivants: Gesdoras

Investments Limited, Friends of Innova L.P. et Mr. Slawomir LUKASIEWICZ

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 6 des statuts de la société pour y refléter les décisions prises

ci-avant:

Art. 6. "Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 37,243,000 (trente-sept millions deux cent quarante-

trois mille euros) représenté par 297.944 (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante-quatre) parts sociales
avec une valeur nominale de EUR 125,00 (cent vingt-cinq euros)"

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide que le reliquat de PLN 393,75 (trois cent quatre-vingt-treize virgule soixante-quinze zlotys polo-

naises) du prêt entre INNOVA/4 L.P. et la Société qui n'auront pas été utilisés pour la conversion en capital conformément
à la deuxième résolution ci-dessous, sera conservée dans la Société en comptes courants actionnaires.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille sept cents euros (EUR 2.700,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparantes le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite au mandataire des comparants, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2916. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2010.

Référence de publication: 2010021653/187.
(100017062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

Garage Linden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9390 Reisdorf, 44, route de la Sûre.

R.C.S. Luxembourg B 97.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GARAGE LINDEN SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2010022750/12.
(100017930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Kinabalu Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 40.379.

L'an deux mille neuf. Le vingt-neuf décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

23854

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "KINABALU FINANCE S.A." ayant son siège

social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 40379,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxem-
bourg), et maintenant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 mai 1992, publié au Mémorial C
numéro 454 du 9 octobre 1992, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître Jean
SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 décembre 2008, publié au
Mémorial C numéro 290 du 10 février 2009.

Le capital social s'élève à quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-onze Euros et quatre-vingt-six Cents (EUR 99.091,86)

représenté par six cent cinquante (650) actions sans désignation de valeur nominale

L'assemblée est présidée par Madame Valérie BERNS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Amélie BRICE, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Laetitia LENTZ, maître en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par les actionnaires présents les mandataires de ceux
représentés, et par le notaire instrumentant, sera conservée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire

instrumentant, demeureront annexées au présent acte lequel elles seront enregistrées.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu
comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
2. Nomination de Monsieur André WILWERT, né le 24 février 1951 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

demeurant  professionnellement  à  L-1143  Luxembourg,  24,  rue  Astrid,  comme  liquidateur  avec  les  pouvoirs  les  plus
étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats.
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société: Monsieur André WILWERT, né le 24 février 1951 à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par

les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société, à savoir Monsieur Eric MAGRINI,

président du conseil d'administration et administrateur-délégué, Monsieur Philippe TOUSSAINT et Monsieur Vincent
TUCCI et au commissaire aux comptes de la société, à savoir la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l.,
pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à huit cent cinquante Euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: BERNS - BRICE - LENTZ - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 07 janvier 2010. Relation GRE/2010/108. Reçu soixante-quinze euros 75€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

23855

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Junglinster, le 2 février 2010.

Référence de publication: 2010021617/65.
(100017541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

Nacre Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.374.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2009 de la société NACRE HOLDING S.A., avec

siège social à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, enregistré à Diekirch, le 19 janvier 2010,
Relation: DIE/2010/457,

constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre

2003,

publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 17 février 2004, numéro 195,
que:
1) le siège social de la société a été transféré vers L-1330 Luxembourg, 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
2) il a été constaté la démission des administrateurs
3) de nouveaux administrateurs ont été nommés avec effet au 20 octobre 2009, et ce pour une durée indéterminée,

à savoir:

- Maître Roy REDING, né le 17 juillet 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 40,

boulevard G.D.Charlotte,

- Monsieur Marco WOLFF, né le 20 février 1963 à Luxembourg, demeurant à L-4170 Esch/Alzette, 40, boulevard J.F.

Kennedy, et

- Madame Josette LENERTZ, née le 9 janvier 1941 à Bech, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 40,

boulevard G.D. Charlotte

4) le commissaire aux comptes a été révoqué
5) un nouveau commissaire au comptes a été nommé avec effet au 20 octobre 2009 et pour une durée indéterminée,

à savoir:

La société PENTLAND CORP., établie et ayant son siège social à PANAMA, calle Aquilino de la Guardia n°8.

Redange/Attert, le 28 janvier 2010.

Pour extrait conforme
Karine REUTER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010022685/33.
(100017617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Mère Nature S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 55, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 20.198.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2010.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010022824/15.
(100017810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

23856


Document Outline

Accuracy World Wide S.à r.l.

Accuracy Worldwide S.Coop.SA

Adergo Holding S.A.

Adergo S.A.

All &amp; All International S.A.

Anglo American Ferrous Investments

Anglo Iron Ore Investments

Ausinium S.A.

AZ Euro Investments S.à r.l.

BtoBe Luxemburg S.A.

Bulwell Holding Sàrl

Callista Holding

Copagest S.A.

Corporate Express Silver S.à r.l.

Dominican Entertainment (Luxembourg)

DPD (Luxembourg) S.à r.l.

DZ PB

Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à r.l.

Financial Services S.à r.l.

Five Mounts Real Estate Investments S.à r.l.

Garage Linden S.à r.l.

Hess Holding S.A.

Hubert Jacques Sàrl

IIINNOVATION S.A.

Innova Financial Holding S.à r.l.

Jet Support Services Europe Sàrl

JP Commercial I S.à r.l.

Kalea Investments SA

Kantec

Kinabalu Finance S.A.

LuxCo 102 S.à r.l.

LuxCo 105 S.à r.l.

Materials Technics S.A.

Mère Nature S.àr.l.

Mouflolux S.A.H.

M.T.H. Finances S.A.

Nacre Holding S.A.

NSH Ansembourg S.à r.l.

NSH Hollenfels S.à r.l.

OI-Games S.A.

Ralt S.A.

Reech AiM Group

Roses Immobilier S.A.

Solar Resources Holding S.à r.l.

Tortoise Income &amp; Growth Company S.A.

Tortoise US Energy Infrastructure Trust S.A.

Universal Display S.A.

Vision IT Group PSF S.A.

WPP Luxembourg Gamma Sàrl