This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 492
6 mars 2010
SOMMAIRE
Allianz Finance V Luxembourg S.à r.l. . . .
23589
Ascocentrum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23597
BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23585
Callatay et Wouters, Association d'Ingé-
nieurs-Conseils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23608
Cebi-Aviation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23570
CIS Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23593
ComLux Furniture S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
23570
Complete Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23570
DG-Immo-Invest GmbH . . . . . . . . . . . . . . . .
23609
Fandl B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23612
Gandi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23587
Genus Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23583
Green Electricity Master Invest . . . . . . . . .
23581
Green Partners S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23582
GSC European Credit Fund . . . . . . . . . . . . .
23579
GTH Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23577
Invesco Aberdeen Hotel Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23616
IPN Unternehmensberatung S.A. . . . . . . . .
23577
Köner + Keutz Finanz AG . . . . . . . . . . . . . . .
23605
KVIST Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23607
La Rigoutière S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23586
Lexinvest S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23615
Libra Assur S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23595
Libra Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23596
Media Consulting S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
23596
Miranda Consulting S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .
23595
Mohone S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23615
OPF Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23586
Pordano Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23612
Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l. . . . .
23615
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l. . . .
23616
Stocknet Investments Holding Sàrl . . . . . .
23616
Straumen Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23604
23569
Complete Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 72.379.
<i>Changement de siège sociali>
<i>Décision des liquidateurs du 8 octobre 2009.i>
Le siège social de la société a été transféré au L-1461 Luxembourg, rue d'Eich 27 avec effet au 8 octobre 2009.
Luxembourg, le 8 octobre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Les liquidateursi>
Référence de publication: 2009131128/14.
(090158058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2009.
Cebi-Aviation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 59.172.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2009.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2009134544/12.
(090162443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.
ComLux Furniture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.985.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twenty-first of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
"Entreprise Vert 4 S.à r.l.", a company incorporated under the laws of Luxembourg, registered in the trade register
under B 133998 and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll. L-1882 Luxembourg, Luxembourg
The founder is here all represented by Flora Gibert, jurist, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", private limited liability company, governed by the
present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, of September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended,
and the present articles of incorporation.
Art. 2. The Company's name is "ComLux Furniture S.à r.l.".
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and particular
23570
for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, to acquire (in Luxembourg and elsewhere),
whether directly or indirectly, any real estate (including but not limited to industrial, commercial, financial and residential
real estate), to finance such acquisitions, and also to create, acquire, finance and/or manage any other companies or other
legal entities necessary to carry out the objects and also to manage and/or develop any real estate so acquired and finally
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31
st
, 1929, on Holding Companies.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12 500 (twelve
thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
23571
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of
shareholders representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
Art. 17. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
23572
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2010.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows
and fully paid up in cash:
Entreprise Vert 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
12,500
Therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company
ComLux Furniture S.a r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which arc to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration
- Mr Frank Przygodda, manager, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mrs Daniela Weber, manager, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
In accordance with article eleven of the by-laws, the Company shall be bound by the single signature of its manager.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
person and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahr zwei tausend neun, am einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sind erschienen:
"Entreprise Vert 4 S.à r.l.", Gesellschaft gegründet unter der luxemburgischen Gesetzgebung, eingetragen im Handels-
register unter B 133998 und mit Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Luxemburg.
Die Gründer sind allesamt hier vertreten durch Flora Gibert, Juristin, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht.
Besagte Vollmachten, welche nachdem sie „ne varietur" von dem Bevollmächtigten der erschienenen Personen und
dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurden, im Anhang dieser Akte bleiben, um mit dieser zusammen eingetragen
zu werden.
23573
Diese erschienenen Parteien, wie oben angegeben vertreten, haben den unterzeichneten Notar beauftragt, die Satzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzunehmen:
Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dieser Satzung und den derzeitigen luxem-
burgischen Gesetzen unterliegt und insbesondere den abgeänderten Gesetzen vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften, vom 18. September 1933 und vom 28. Dezember 1992 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie
die vorliegende Satzung.
Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist „ComLux Furniture S.à r.l.".
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, indust-
riellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Kauf von jeglichen Wertpa-
pieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art
sowie der Kauf von
Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft als angemessen
erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teilweise für den Zweck
den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von Unternehmen die diese
kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen Transaktionen, und jeder
Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse hat, jegliche Un-
terstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen, gleich in welcher Art und
die Rückzahlung von dem geliehen Geld zu sichern, in Luxemburg oder im Ausland, direkt oder indirekt, jegliche unbe-
weglichen Güter zu kaufen, diese Käufe zu finanzieren und andere Unternehmen oder Rechtspersonen zu gründen, kaufen,
finanzieren und/oder zu verwalten und ebenfalls die so gekauften unbeweglichen Güter zu verwalten und/oder zu ent-
wickeln und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser Zweckerfüllung beitragen
jedoch ohne das Gesetz vom 31. Juli 1929 über Holding-Gesellschaften zu nutzen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt Großherzogtum Luxemburg.
Er kann an jeglichen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einen Beschluss der außer-
ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die wie für die Änderung der Satzung beschließt.
Auf Beschluss der Geschäftsführer, kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche Ereignisse eintreten oder bevorstehen, ob politischer,
wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art, die den normalen Tätigkeitsverlauf am Gesellschaftssitz oder die Kommuni-
kation mit dem Gesellschaftssitz oder zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen, kann die
Geschäftsführung den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen und dies bis zum Ende dieser anormalen Umstände.
Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese
bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer gegründet.
Art. 6. Das Leben der Gesellschaft ist nicht beendet durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs
oder Insolvenz eines der Gesellschafter.
Art. 7. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber und Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen,
weder die Beschlagnahme des Eigentums und der Dokumente der Gesellschaft veranlassen, noch können sie in irgendeiner
Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanz-
berichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.
Kapital - Aktien
Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf € 12.500 (zwölf tausend fünf hundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölf
tausend fünf hundert) Anteile von jeweils € 1 (ein Euro).
Art. 9. Alle Anteile haben die gleichen Rechte zum Zeitpunkt der Beschlussnahme.
Art. 10. Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Anteile dürfen nicht „inter vivos" an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von
wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt.
Weiterhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an.
Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern
bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Gesellschafter widerrufen werden.
23574
In dem Umgang mit Dritten werden die Geschäftsführer alle Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Operationen in Einklang mit dem Gesellschaftszweck und unter Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung
durchzuführen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung der Gesell-
schafter vorbehalten sind, unterliegen der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.
Die Gesellschaft ist durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, bei mehreren Geschäftsführern,
durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers gebunden.
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann seine) können
ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Beauftrage übertragen.
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann) können die
Zuständigkeiten und Entlohnung (falls zutreffend) dieses Beauftragten bestimmen, sowie die Dauer seines Mandats oder
sonstige zutreffenden Bedingungen davon.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Sitzungen der Geschäftsführung gültig abgehalten, wenn eine
Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.
In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer angenommen.
Die Benutzung von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen sind zugelassen, wenn jeder teilnehmende
Geschäftsführer in der Lage ist, alle teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden, gleich
ob sie diese Technologie benutzen oder nicht und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist dazu
ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.
Die Befugnisse und Entlohnungen der Geschäftsführer, die an einem späteren Datum zusätzlich oder an Stelle der
ersten Geschäftsführer ernannt werden, werden in der Ernennungsurkunde bestimmt.
Art. 12. Keiner der Geschäftsführer übernimmt in seiner Funktion eine persönliche Haftung betreffend seine Ver-
pflichtungen im Namen der Gesellschaft. Als Beauftragter ist er lediglich zuständig für die Ausübung seines Mandats.
Die Gesellschaft wird alle Geschäftsführer und ihre Erben, Beauftragten unbeschädigt halten von allen Ausgaben, Schä-
den, Ausgleichen und Kosten, die auf vernünftige Weise in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren entstehen,
in denen sie eine Partei sein können aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Anfrage der
Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft in der die Gesellschaft Aktien hält oder Gläubiger ist und durch die er keine
Entschädigung erhält außer in Verbindung mit Angelegenheiten in denen er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit oder
schwerwiegendem Verfehlen verurteilt wird. Im Falle einer Regelung erfolgt die Entschädigung lediglich, wenn die Ge-
sellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person ihre Verpflichtungen
nicht verletzt hat. Das vorliegende Recht auf Entschädigung schließt die anderen Anrechte dieser Person nicht aus.
Art. 13. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in dessen Sitzungen gefasst.
Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten sein durch einen von ihm per Fax, Tele-
gramm oder Telex bezeichnetes anderes Mitglied.
Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist richtig und gültig als wäre er bei der
Sitzung der Geschäftsführung angenommen worden. Ein solcher Beschluss wird ausdrücklich per Rundschreiben, per
Brief, elektronische Post, Telefon, Telekonferenz oder Telekommunikationsmittel getroffen.
Beschlüsse der Gesellschafter
Art. 14. Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen.
Die Einberufung dieser Versammlung ist nicht erforderlich solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.
In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, jedem Gesellschafter den vollständigen Text der Beschlüsse
zuzuschicken, dies in schriftlicher Form und per Brief, elektronischer Post oder Telefax.
Art. 15. Beschlüsse werden gültig angenommen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten,
dafür gestimmt haben.
Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht ist, werden die Gesellschafter sofort per Einschreiben
zu einer zweiten Versammlung einberufen.
Auf dieser zweiten Versammlung werden die Beschlüsse durch die Mehrheit des vertretenen Kapitals gefasst.
Beschlüsse für die Änderung der Satzung müssen durch eine Mehrheitsabstimmung der Gesellschafter getroffen wer-
den, die wenigstens drei Viertel des Kapitals darstellen.
Jede Versammlung findet in Luxemburg statt oder an einem Ort, der von den Geschäftsführern beschlossen wird.
Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
23575
Art. 17. Jedes Jahr, am 31. Dezember, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz mit der Angabe der Wirtschaftsgüter
der Gesellschaft sowie der Guthaben und Schulden zusammen mit einer Zusammenfassung der Verpflichtungen und der
Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft.
Gleichzeitig erstellt die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Generalversammlung zusammen
mit der Bilanz zur Zustimmung unterbreitet wird.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann dieses Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 19. Die Erträge eines Geschäftsjahres, nach Abzug der Allgemein- und Betriebskosten, Aufwendungen und Ab-
schreibungen, stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für dieses Geschäftsjahr dar.
Von dem so berechneten Nettogewinn werden jedes Jahr fünf Prozent abgezogen und der gesetzlichen Rücklage
zugeführt.
Dieser Abzug ist nicht mehr erforderlich, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals
der Gesellschaft erreicht hat. Die Rücklage muss wieder aufgenommen werden, wenn dies nicht mehr der Fall ist, gleich
aus welchem Grunde.
Der Saldo steht der Gesellschaft frei zur Verfügung.
Die Geschäftsführer können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit der geltenden Gesetzgebung,
beschließen, diesen Saldo vorzutragen oder einer außerordentlichen Rücklage zuzuführen.
Auflösung
Art. 20. Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche nicht Gesellschafter zu
sein brauchen, die von den Gesellschaftern ernannt sind, die auch deren Befugnisse und Entlohnung bestimmen.
Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft wird das Guthaben der Gesellschaft an die Gesellschafter, im Verhältnis
ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft, verteilt.
Geltende Gesetzgebung
Art. 21. Es wird Bezug genommen auf die im ersten Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen sofern diese nicht
ausdrücklich durch diese Satzung aufgehoben sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Alle Anteile wurden vollständig und wie folgt eingezahlt:
Entreprise Vert 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
12.500
Der Betrag von € 12.500 (zwölf tausend fünfhundert Euro) entsprechend dem Gesellschaftskapital steht der Gesell-
schaft ComLux Furniture S.à r.l. ab sofort zur Verfügung, wie dies dem Notar belegt wurde.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die die Gesellschaft in Verbindung mit ihrer Gründung
tragen oder bezahlen muss, wurden auf ein tausend drei hundert Euro geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft, haben die oben bezeichneten Personen, die die Gesamtheit des gezeich-
neten Kapitals darstellen und die der Sitzung erteilten Befugnisse ausübend, folgende Beschlüsse getroffen:
1) Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer wurden ernannt:
- Herr Frank Przygodda, Manager, mit beruflicher Adresse 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg,
- Frau Daniela Weber, Manager, mit beruflicher Adresse 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.
In Einklang mit Artikel 11 dieser Satzung, ist die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers ge-
bunden.
2) Die Gesellschaft wird ihren Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg haben.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit dass auf Anfrage der oben erschienenen
Partei, dieser Akt auf Englisch verfasst wurde und von der deutschen Übersetzung gefolgt ist. Auf Anfrage der gleichen
Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
maßgebend.
Vorüber Urkunde, zur Beurkundung dessen, dieser Akt aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie Eingangs.
Nach Vorlesung dieses Dokuments, hat die erschienene Person dieses zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Unterzeichnet: F. GIBERT, J. ELVINGER.
23576
Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2009. Relation: LAC/2009/56402. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (unterzeichnet): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg le 18 janvier 2010.
J. ELVINGER.
Référence de publication: 2010020836/350.
(100015653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2010.
IPN Unternehmensberatung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Waïstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 105.033.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Karine REUTER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2010022694/11.
(100017651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.
GTH Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.187.
DISSOLUTION
In the year two thousand nine,
on the thirtieth day of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),
there appeared the following:
Mr Bragi Pálsson, company director, residing at Langholti 7, IS-230 Keflavik (Iceland),
hereafter referred to as "the principal",
represented by:
Mrs Doriane ROSSIGNOL, bank employee, with professional address at 35a avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
hereafter referred to as "the proxy holder";
by virtue of a proxy under private seal given to her, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy
holder of the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this deed.
The proxy-holder declared and requested the notary to act:
- that the company "GTH HOLDING S.A.", (the "Company"), established and having its registered office at 35a avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B
80187, has been incorporated pursuant to a notarial deed by the undersigned notary on 18 December 2000, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 681 of 27 August 2001, page 32664.
The articles of association have never been amended since its incorporation date.
- that the corporate capital of the Company is set at TWENTY-FIVE MILLION SIX HUNDRED AND FIVE THOU-
SAND ICELANDIC KRONA (ISK 25.605.000,-) divided into two hundred fifty-six thousand fifty (256.050) shares with a
par value of ONE HUNDRED ICELANDIC KRONA (100.- ISK) each, all fully paid up in cash;
- that the principal is as of today the sole shareholder of the Company;
- that in his capacity as sole shareholder of the Company, he resolved to proceed to the anticipatory and immediate
dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in his capacity as liquidator of the Company, declares that all the liabilities of the Company,
including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;
- that the Company's activities have ceased;
- that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of
the terminated Company;
- that, following the above resolutions, the company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- that the company's directors and auditor are given full discharge for their respective duties;
- that there should be proceeded to the cancellation of all issued shares;
23577
- that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's
former registered office;
- to declare that the principal commits himself to pay the costs of the notarial deed.
The undersigned notary, who has personal and perfect knowledge of the English language, states that at the request
of the above appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall
prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and interpreted in the language of the soil to the appearing proxy holder, known to
the notary her surname, Christian name, civil status and residence, said proxy holder appearing signed together with us,
the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf,
le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Monsieur Bragi Pálsson, directeur de société, demeurant à Langholti 7, IS-230 Keflavik (Islande),
ci-après dénommé "le mandant";
dûment représenté par:
Madame Doriane ROSSIGNOL, employée de banque, avec adresse professionnelle au 35a avenue J.F. Kennedy,
ci-après dénommée: "le mandataire",
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par
le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise
en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société "GTH HOLDING S.A." (la "Société"), établie et ayant son siège social au 35a avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80187, a
été constituée suivant acte du notaire soussigné daté du 18 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C (le "Mémorial") numéro 681 du 27 août 2001, page 32664. Les statuts de la Société ne furent jamais
modifiés depuis que la Société fut constituée.
- que le capital social de la Société est fixé à VINGT-CINQ MILLIONS SIX CENT CINQ MILLE DE COURONNES
ISLANDAISES (25.605.000.- ISK) divisé en deux cent soixante-cinq mille cinquante (265.050) actions d'une valeur nominale
de CENT COURONNES ISLANDAISES (100.- ISK) chacune, toutes se trouvant intégralement libérées en numéraire;
- que le mandant est, depuis aujourd'hui, l'actionnaire unique de la Société;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, il a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de
la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, a déclaré que tout le passif de la Société, y compris
le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
- que l'activité de la Société a cessé;
- que l'actionnaire unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout le passif éventuel de la
Société dissoute;
- que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la Société;
- qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions émises;
- que les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège
social de la Société;
- que le mandant s'engage à régler personnellement les frais des présentes.
Le soussigné notaire, qui connaît parfaitement la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue de la mandataire, connue du notaire instru-
mentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. ROSSIGNOL, J.J. WAGNER.
23578
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2010. Relation: EAC/2010/181. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2010021663/94.
(100017544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
GSC European Credit Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 130.753.
In the year two thousand and nine,
on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "GSC EUROPEAN CREDIT FUND" a société ano-
nyme qualifying as a société d'investissement à capital variable, established and having its registered office at 5 Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company register under section B number
130 753, incorporated pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 14 August 2007, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1864 on 03 September 2007; the Articles of Incorporation
of which have not been amended since.
The meeting was declared open at 9.00 a.m. and was presided by Mrs Olga Zlobinska, bank employee, professionally
residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mrs Laetitia Boeuf, bank employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Katja Kieffer, bank employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the AGENDA of the meeting is the following:
1. to approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation with immediate effect;
2. to approve the appointment of KPMG Advisory Sàrl represented by Eric Collard and Sandrine Periot as the liquidator
of the Company and to determine the powers of the liquidator;
3. to transact any other business.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on a attendance-list, which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders,
the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the members of the board and the undersigned
notary, will also remain annexed to the present deed.
III. That the shareholders were convened to the Meeting by way of registered letters sent to them on 14 December
2009.
IV. It appears from said attendance-list that out of seventy-five million sixty-eight thousand (75,068,000) shares in issue,
fifty-two million five hundred twenty-two thousand (52,522,000) shares are duly represented at this meeting which is
therefore regularly constituted and can validly decide on the items of the agenda, the quorum of shareholders present
or represented imposed by law and by the Articles of Incorporation being reached.
After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting pro-
ceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions, each time at a majority vote of more than two-thirds as detailed in the attendance list:
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVES to dissolve and to put the Company into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVES to appoint KPMG Advisory S.à r.l. , a société à responsabilité limitée, with registered office
at 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (RCS. Luxembourg, section B number 50 597) represented by Eric Collard and
Sandrine Periot as the liquidator of the Company and to confer upon the liquidator the broadest powers to carry out
the liquidation of the Company in accordance with articles 144 and following of the law of 10th August, 1915, as amended
(the "Law").
The liquidator is authorised under his responsibility to delegate to one or several attorneys-in-fact such of his powers,
as he deems necessary and appropriate. All acts carried out by the liquidator validly bind the Company by the sole signature
of the liquidator.
23579
There being no further item on the agenda, the meeting was then closed and these minutes signed by the members
of the Board and by the notary.
The undersigned notary who knows English states herewith that on request of the above appearing persons, the present
deed worded in the English language is followed by a French translation, it being understood that the English version shall
prevail in case of divergences between the English and French text.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mil neuf,
le trente décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "GSC EUROPEAN CREDIT FUND" une société
anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, établie et ayant son siège social au 5 Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous section
B numéro 130 753, constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 14 août 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1864 du 03 septembre 2007; les statuts de la prédite société
n'ont jamais été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Olga Zlobinska, employée bancaire, résidant
professionnellement à Luxembourg.
Le Président à nommé Madame Laetitia Boeuf, employée bancaire, résidant professionnellement à Luxembourg comme
secrétaire.
L'Assemblée élit Madame Katja Kieffer, employée bancaire, résidant professionnellement à Luxembourg, comme scru-
tateur.
Le Bureau de l'Assemblée ainsi constituée, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat;
2. d'approuver la nomination de KPMG Advisory Sàrl représentée par Eric Collard et Sandrine Periot comme liqui-
dateur de la Société et de déterminer les pouvoirs du liquidateur;
3. divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Restent pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
"ne varietur" par les comparants.
III. Les actionnaires ont été convoqués au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 14 décembre 2009.
IV. Il résulte de ladite liste de présence que des soixante-quinze millions soixante-huit mille (75.068.000) actions émises
et en circulation, cinquante-deux millions cinq cent vingt-deux mille (52.522.000) actions sont représentées à l'assemblée,
de sorte que celle-ci est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, le quorum des
actionnaires présents ou représentés imposé par la Loi et les Statuts étant atteint.
Qu'après que ceci ait été communiqué par le Président et ait été constaté par les membres de l'Assemblée, celle-ci
aborde l'ordre du jour:
L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, le Président soumet au vote de ses membres les résolutions suivantes à
une majorité de plus de deux tiers comme détaillé dans la liste de présence:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation avec effet immédiat.
<i>Seconde résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer "KPMG Advisory S.à r.l." une société à responsabilité limitée avec siège
social au 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (RCS. Luxembourg, section B numéro 50 597) représentée par Eric Collard
et Sandrine Periot comme liquidateur de la Société et confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour mettre
en œuvre la liquidation de la Société conformément aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée
(la "Loi").
Le liquidateur est autorisé sous sa seule responsabilité à déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoir autant de
pouvoirs qu'il l'estime nécessaire et approprié. Tous les actes dressés par le liquidateur engageront valablement la Société
par la seule signature du liquidateur.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal est signé par les membres du bureau
et par le notaire.
23580
Le soussigné notaire qui connaît la langue anglaise confirme par la présente que sur demande des personnes ci-dessus
apparues, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française, sachant que la version anglaise
prédomine en cas de divergences entre les textes français et anglais.
Dont acte, fait et passé à la date stipulée en tête de ce document.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénoms, état civil et
domicile, lesdites personnes présentes ont signé avec nous, le notaire le présent acte en original.
Signé: O. ZLOBINSKA, L. BŒUF, K. KIEFFER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2010. Relation: EAC/2010/47. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): M.-N. KIRCHEN.
Référence de publication: 2010021664/117.
(100017125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Green Electricity Master Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 143.337.
L'an deux mille neuf, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
"Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg", société anonyme ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant au nom et pour le compte de "Degroof Green Fund", un
fonds d'investissement spécialisé luxembourgeois constitué sous la forme d'un fonds commun de placement conformé-
ment à la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissements spécialisés,
ici représentée par Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être déposée en même temps auprès des autorités d'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'actionnaire unique de la société anonyme "Green Electricity Master Invest", ayant son
siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 143337), constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 3000 du 22 décembre 2008.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de six millions sept
cent mille euros (EUR 6.700.000.-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille Euros (EUR 35.000.-) à six
millions sept cent trente-cinq mille euros (EUR 6.735.000-) par l'émission de six mille sept cents (6.700) Actions de classe
A de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par "Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg", agissant
au nom et pour le compte de "Degroof Green Fund" ici représenté par Madame Frédérique MIGNON, prénommée.
Toutes les Nouvelles Actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de six millions sept
cent mille euros (EUR 6.700.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
Art. 5. (Premier alinéa). "Le capital souscrit est fixé à six millions sept cent trente-cinq mille euros (EUR 6.735.000.-)
représenté par des actions de classe A, B et C (les "Actions de Classe A, B et C") étant émises en faveur du Compartiment
Renewable Energy Fund (le "Compartiment"), un Compartiment faisant partie de Degroof Green Fund, un Fonds commun
de placement - Fonds d'investissement spécialisé ("le Fonds") établi à Luxembourg;
(i) six mille sept cents (6.700) Actions de classe A de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune (les "Actions de Classe A");
(ii) sept (7) Actions de classe B de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune (les "Actions de Classe B");
(iii) vingt-huit (28) Actions de classe C de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune (les "Actions de Classe C").
23581
Les détenteurs d'actions dans la Société, sans distinction de classe ou sous-classe, sont repris comme étant les "Ac-
tionnaires".
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à cinq mille euros.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2010. Relation: EAC/2010/34. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff. i>
(signé): M.-N. KIRCHEN.
Référence de publication: 2010021666/56.
(100017345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Green Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 128.577.
L'an deux mille neuf, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
A COMPARU:
Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Gérant-Commandité de la société en com-
mandite par actions "GREEN PARTNERS S.C.A.", ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 128577 (la "Société"), à savoir la société anonyme de droit luxem-
bourgeois Green Partners Investment Management S.A., ayant son siège social à Luxembourg, en vertu d'un pouvoir qui
lui a été conféré par le Gérant-Commandité de ladite société par résolutions du 25 juin 2009, 29 juillet 2009 et 11
novembre 2009.
Le procès-verbal de cette résolution restera, après avoir été paraphé "ne varietur" par le comparant et le notaire,
annexé à la présente pour être soumis avec elle à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme
suit:
1) La société a été constituée suivant acte notarié en date du 23 mai 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 1528 du 23 juillet 2007. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 30 janvier 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 458 du 3 mars 2009.
2) Le capital social de la Société est actuellement fixé à soixante et onze mille vingt euros (EUR 71.020,-) divisé en
soixante trois mille neuf cent dix huit (63.918) actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A") qui seront détenues
par les associés commanditaires (les "Actionnaires de Catégorie A") en représentation de leur participation limitée dans
la Société et sept mille cent deux (7.102) actions de catégorie B (les "Actions de Catégorie B") qui seront détenues par
l'Associé Commandité (l'"Actionnaire de Catégorie B"), en représentation de sa participation illimitée dans la Société, les
actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ces actions étant entièrement libérées.
Conformément à l'Article 5 des Statuts, le capital autorisé de la Société est fixé à cent quarante-huit mille euros (EUR
148.000,-), divisé en cent trente-trois mille deux cents (133.200) Actions de Catégorie A et quatorze mille huit cents
(14.800) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Ce capital autorisé a pour seul objectif, et nonobstant toute suppression du droit préférentiel de souscription, de
permettre la création d'Actions de Catégorie A et d'Actions de Catégorie B en contrepartie d'apports en numéraire
effectués par les actionnaires de la Société en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant aura procédé confor-
mément aux arrangements contractuels pouvant exister de temps à autre entre la Société et ses actionnaires.
Le Gérant est autorisé et mandaté, jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmentation
de capital social en une ou plusieurs fois par l'émission de nouvelles Actions de Catégorie A et Actions de Catégorie B,
avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire, (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions
successives, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles et (iii) retirer ou limiter le droit
préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société dans le cas d'une émission d'actions contre paiement
en espèces.
Les droits attachés aux actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions déjà existantes de même classe.
23582
3) Par décision du 25 juin 2009, 29 juillet 2009 et 11 novembre 2009 le Gérant de la Société a décidé d'émettre dix
huit mille cent trente huit (18.138) actions nouvelles de catégorie A et deux mille trente six (2.036) actions nouvelles de
catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune. Le capital social est ainsi augmenté à concurrence de
EUR 20.174,- (vingt mille cent soixante quatorze euros) pour être porté de son montant actuel de EUR 71.020.- (soixante
et onze mille vingt euros) à EUR 91.194.- (quatre vingt onze mille cent quatre vingt quatorze euros).
Les droits attachés aux actions nouvelles sont identiques à ceux attachés aux actions déjà existantes de même classe.
Les actions nouvelles sont souscrites par les actionnaires actuels ici représentés par Madame Arlette Siebenaler, prén-
ommée, en vertu de trois procurations sous seing privé, comme suit:
- 9.069 (neuf mille soixante neuf) actions de catégorie A par C8 Land S.à r.l.
- 9.069 (neuf mille soixante neuf) actions de catégorie A par Cz2 Land S.à r.l.
- 2.036 (deux mille trente six) actions de catégorie B par Green Partners Investment Management S.A.
Les actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme EUR 20.174,- (vingt mille cent
soixante quatorze euros) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le
constate expressément.
4) A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
"Le capital social de la Société est fixé à EUR 91.194.- (quatre vingt onze mille cent quatre vingt quatorze euros) divisé
en quatre vingt deux mille cinquante six (82.056) actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A") qui seront détenues
par les associés commanditaires (les "Actionnaires de Catégorie A") en représentation de leur participation limitée dans
la Société et neuf mille cent trente huit (9.138) actions de catégorie B (les "Actions de Catégorie B") qui seront détenues
par l'Associé Commandité (l'"Actionnaire de Catégorie B"), en représentation de sa participation illimitée dans la Société,
les actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ces actions étant entièrement libérées"
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué à environ EUR 2.000.-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2010. Relation: LAC/2010/237. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff. i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 février 2010.
Référence de publication: 2010021667/76.
(100017027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Genus Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 74.685.
DISSOLUTION
In the year two thousand nine,
on the thirtieth day of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),
there appeared the following:
Mr Gunnar Jónsson, company director, residing at Hólahjalla 12, IS-200 Kópavogur (Iceland),
hereafter referred to as "the principal",
represented by:
Mrs Doriane ROSSIGNOL, bank employee, with professional address at 35a avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
hereafter referred to as "the proxy holder";
by virtue of a proxy under private seal given to her, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy
holder of the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this deed.
The proxy-holder declared and requested the notary to act:
- that the company "GENUS HOLDINGS S.A.", (the "Company"), established and having its registered office at 35a
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
23583
number B 74 685, has been incorporated pursuant to a notarial deed by the undersigned notary on 3 March 2000, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 449 of 26 June 2000, page 21539. The
articles of association have never been amended since its incorporation date.
- that the corporate capital of the Company is set at THIRTY-SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY-FOUR
EUROS AND THREE CENTS (EUR 37.184,03) divided into fifteen thousand (15.000) shares with a par value of TWO
EUROS AND FORTY-SEVEN CENTS (2,47 EUR) each, all fully paid up in cash;
- that the principal is as of today the sole shareholder of the Company;
- that in his capacity as sole shareholder of the Company, he resolved to proceed to the anticipatory and immediate
dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in his capacity as liquidator of the Company, declares that all the liabilities of the Company,
including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;
- that the Company's activities have ceased;
- that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of
the terminated Company;
- that, following the above resolutions, the company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- that the company's directors and auditor are given full discharge for their respective duties;
- that there should be proceeded to the cancellation of all issued shares;
- that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's
former registered office;
- to declare that the principal commits himself to pay the costs of the notarial deed.
The undersigned notary, who has personal and perfect knowledge of the English language, states that at the request
of the above appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall
prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and interpreted in the language of the soil to the appearing proxy holder, known to
the notary her surname, Christian name, civil status and residence, said proxy holder appearing signed together with us,
the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf,
le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Monsieur Gunnar Jónsson, directeur de société, demeurant à Hólahjalla 12, IS-200 Kópavogur (Islande),
ci-après dénommé "le mandant";
dûment représenté par:
Madame Doriane ROSSIGNOL, employée de banque, avec adresse professionnelle au 35a avenue J.F. Kennedy,
ci-après dénommée: "le mandataire",
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par
le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise
en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société "GENUS HOLDINGS S.A." (la "Société"), établie et ayant son siège social au 35a avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74 685, a
été constituée suivant acte du notaire soussigné daté du 3 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C (le "Mémorial") numéro 449 du 26 juin 2000, page 21539. Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés
depuis que la Société fut constituée.
- que le capital social de la Société est fixé à TRENTE-SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et
TROIS CENTS (37.184,03 EUR) divisé en quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de DEUX EUROS et
QUARANTE-SEPT CENTS (2,47 EUR) chacune, toutes se trouvant intégralement libérées en numéraire;
- que le mandant est, depuis aujourd'hui, l'actionnaire unique de la Société;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, il a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de
la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, a déclaré que tout le passif de la Société, y compris
le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
23584
- que l'activité de la Société a cessé;
- que l'actionnaire unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout le passif éventuel de la
Société dissoute;
- que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la Société;
- qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions émises;
- que les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège
social de la Société;
- que le mandant s'engage à régler personnellement les frais des présentes.
Le soussigné notaire, qui connaît parfaitement la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue de la mandataire, connue du notaire instru-
mentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. ROSSIGNOL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2010. Relation: EAC/2010/190. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2010021668/94.
(100017542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
BM SIDERURGIE Luxembourg, BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck II, route de Dudelange.
R.C.S. Luxembourg B 72.801.
L'an deux mille neuf, le vingt et un décembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,
A COMPARU:
La société par actions simplifiée de droit français "BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE", en abrégé "BM SIDERUR-
GIE", établie et ayant son siège social à F-73420 Mery, Hexapôle BP 80135 (France), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 511 515 165,
ici représentée par Monsieur Sébastien FEVE, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1528 Luxem-
bourg, 8, boulevard de la Foire, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir
été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enre-
gistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle est le
seul actionnaire (l'"Actionnaire Unique"), de la société anonyme "GIRAUD LUXEMBOURG S.A.", (ci-après la "Société"),
établie et ayant son siège social à L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 72801, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 7 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 978 du 20 décembre 1999,
et qu'elle a pris, par son mandataire, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de changer la dénomination sociale en "BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxem-
bourg", en abrégé "BM SIDERURGIE Luxembourg" et de modifier en conséquence l'article 1
er
des statuts afin de lui
donner la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxem-
bourg", en abrégé "BM SIDERURGIE Luxembourg", régie par les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus
particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à huit cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par son nom, prénom, état civil et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
23585
Signé: FEVE - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2009. Relation GRE/2009/5066. Reçu soixante-quinze euros 75 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Junglinster, le 29 janvier 2010.
Référence de publication: 2010021669/42.
(100017219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
OPF Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Koerich, 3-5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 108.415.
Le bilan (version abrégée des comptes annuels) au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010021638/11.
(100016310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2010.
La Rigoutière S.C.I., Société Civile Immobilière.
Capital social: EUR 76.215,00.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 8, rue Alfred de Musset.
R.C.S. Luxembourg E 2.346.
<i>Cession de parts socialesi>
Entre les Soussignés
LIFE INTERNATIONAL SARL, société à responsabilité limitée au capital de 31.250 €uros dont le siège social est situé:
8, Rue Alfred De Musset - L-2175 Luxembourg, représentée par sa gérante, Madame Ailette PIETROTTI, Ci-après dé-
nommée le cédant d'une part,
Et
Monsieur Claude Nathan GUEDJ, de profession urbaniste, de nationalité française, né à Lyon (Fiance) le 3 octobre
1937, demeurant au Luxembourg, L-2175, 8, Rue Alfred De Musset,
Ci-après dénommée le cessionnaire d'autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
LA RIGOUTIERE SCI, au capital de 76.215 €Euros composé de 5001 parts sociales de 15,24 €uros chacune, a pour
objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu'elle pourrait détenir ou acquérir.
<i>Origine de la propriétéi>
Le cédant possède dans cette société 5 000 parts sociales portant les numéros 2 à 5001 inclus, acquise le 11 février
2000 pour une valeur de 76 209 € auprès de Monsieur Claude Nathan GUEDJ, actuel cessionnaire du présent acte.
La société Life International S.a r l. reconnaît d'une part n'avoir jamais payé à Monsieur Claude Nathan GUEDJ le prix
d'acquisition des parts sociales acquises le 11 février 2000, d'autre part que pour éviter toute procédure judiciaire que
Monsieur GUEDJ souhaitait intenter à son rencontre, elle accepte de lui transférer la propriété de ces dites parts sociales
sans contrepartie financière, l'opération conduisant à une annulation de la vente initiale en date de février 2000
CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
<i>Déclarationsi>
Le cédant déclare:
- disposer de la pleine capacité juridique d'aliéner,
- que les parts sociales cédées sont libre de tout nantissement et de tous droits quelconques,
Le cessionnaire déclare disposer de la pleine capacité juridique afin d'acquérir librement ces parts sociales.
<i>Cessionsi>
Par les présentes, le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui
accepte 5000 (cinq mille) parts sociales, portant les numéros 2 à 5001 inclus qui lui appartiennent, telles que ci-dessus
désignées, avec tous les droits et obligations y attachés.
23586
Le cessionnaire sera propriétaire de ces parts cédées à compter de ce jour, et aura seul le droit à la fraction des
bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribué aux dites parts.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter de ce jour.
La part cédée n'est représentée par aucun titre et sa propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu
les modifier
<i>Prixi>
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de 76 209 (soixante mille deux cent neuf)
€uros, qui ne seront pas réglés au cessionnaire, cette opération conduisant à l'annulation de la cession initiale du 11
février 2000.
<i>Significationi>
La présente cession sera signifiée à la société à la société contre remise par la gérance d'une attestation de dépôt.
<i>Déclarations Fiscalesi>
Le cédant déclare également que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.
<i>Formalités Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'original des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités
légales de publicité et d'enregistrement.
<i>Agrémenti>
En tant que besoin, et si les cessionnaires ne sont pas associés de la société, la présente cession est consentie avec
l'agrément en qualité de nouvel associé par l'Assemblée Générale de la LA RIGOUTIERE SCI en date de ce jour.
<i>Fraisi>
Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront
supportés par Monsieur Claude Nathan GUEDJ qui s'y oblige.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2009.
En 5 exemplaires originaux
LIFE INTERNATIONAL S.A.R.L / -
Signature / CLAUDE NATHAN GUEDJ
Référence de publication: 2010021629/63.
(100016773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Gandi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 77.772.
DISSOLUTION
In the year two thousand nine,
on the thirtieth day of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),
there appeared the following:
Mrs Kristin Elin Gisladottir, company director, residing at Litlageroi 19, IS 900 Vestmannaeyjar (Iceland),
hereafter referred to as "the principal",
represented by:
Mrs Doriane ROSSIGNOL, bank employee, with professional address at 35a avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
hereafter referred to as "the proxy holder";
by virtue of a proxy under private seal given to her, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy
holder of the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this deed.
The proxy-holder declared and requested the notary to act:
- that the company "GANDI HOLDING S.A.", (the "Company"), established and having its registered office at 35a
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
number B 77 772, has been incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, on 16 August 2000,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 137 of 22 February 2001,
page 6553. The articles of association have never been amended since its incorporation date.
23587
- that the corporate capital of the Company is set at TEN MILLION ICELANDIC KRONA (ISK 10.000.000,-) divided
into one hundred thousand (100.000) shares with a par value of ONE HUNDRED ICELANDIC KRONA (100.- ISK) each,
all fully paid up in cash;
- that the principal is as of today the sole shareholder of the Company;
- that in his capacity as sole shareholder of the Company, he resolved to proceed to the anticipatory and immediate
dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in his capacity as liquidator of the Company, declares that all the liabilities of the Company,
including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;
- that the Company's activities have ceased;
- that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of
the terminated Company;
- that, following the above resolutions, the company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- that the company's directors and auditor are given full discharge for their respective duties;
- that there should be proceeded to the cancellation of all issued shares;
- that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's
former registered office;
- to declare that the principal commits himself to pay the costs of the notarial deed.
The undersigned notary, who has personal and perfect knowledge of the English language, states that at the request
of the above appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall
prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and interpreted in the language of the soil to the appearing proxy holder, known to
the notary her surname, Christian name, civil status and residence, said proxy holder appearing signed together with us,
the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf,
le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Madame Kristin Elin Gisladottir, directeur de société, demeurant à Litlageroi 19, IS 900 Vestmannaeyjar (Islande),
ci-après dénommée "le mandant"; dûment représentée par:
Madame Doriane ROSSIGNOL, employée de banque, avec adresse professionnelle au 35a avenue J.F. Kennedy,
ci-après dénommée: "le mandataire",
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par
le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise
en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société "GANDI HOLDING S.A." (la "Société"), établie et ayant son siège social au 35a avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77772, a
été constituée suivant acte du notaire soussigné daté du 16 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C (le "Mémorial") numéro 137 du 22 février 2001, page 6553. Les statuts de la Société ne furent jamais
modifiés depuis que la Société fut constituée.
- que le capital social de la Société est fixé à DIX MILLIONS DE COURONNES ISLANDAISES (10.000.000.- ISK) divisé
en cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de CENT COURONNES ISLANDAISES (100.- ISK) chacune, toutes
se trouvant intégralement libérées en numéraire;
- que le mandant est, depuis aujourd'hui, l'actionnaire unique de la Société;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, il a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de
la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, a déclaré que tout le passif de la Société, y compris
le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
- que l'activité de la Société a cessé;
- que l'actionnaire unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout le passif éventuel de la
Société dissoute;
- que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
23588
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la Société;
- qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions émises;
- que les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège
social de la Société;
- que le mandant s'engage à régler personnellement les frais des présentes.
Le soussigné notaire, qui connaît parfaitement la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue de la mandataire, connue du notaire instru-
mentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. ROSSIGNOL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-AIzette A.C., le 6 janvier 2010. Relation: EAC/2010/188. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2010021625/93.
(100017539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Allianz Finance V Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 151.057.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzehn, am sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Maître Camille Mines, Notar, mit Amtswohnsitz in Capellen.
IST ERSCHIENEN:
Allianz Finance II Luxembourg S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxembourg,
14, boulevard F.D. Roosevelt, eingetragen im eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der
Sektion B Nummer 128.975,
vertreten durch Christian Jungers, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in L-1855 Luxembourg, 33 avenue J.F. Kennedy,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 22. Januar 2010.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und dem amtie-
renden Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben wird.
Diese Erschienene, vertreten wie angegeben, erklärt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche
der folgenden Satzung unterliegt.
Art. 1. Es besteht zwischen den Erschienenen und jeder natürlichen oder juristischen Person, die in der Zukunft
Gesellschafter der Gesellschaft werden könnte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit der Firmenbezeichnung "Allianz Finance V Luxembourg S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögen, insbesondere von Anteilen
an Kapital-, sowie Immobiliengesellschaften, zur eigenen Vermögensanlage. Die Gesellschaft darf, mit Ausnahme der Auf-
nahme von Fremdmitteln, alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und
ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des
einzigen Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 5.000.000 (fünf Millionen) Anteile
mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (einem Cent) pro Anteil.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem einzigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß
Artikel 13 dieser Satzung abgeändert werden.
Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen
Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.
Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen.
Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.
23589
Art. 9. Der Übertragung von Anteilen durch einen Gesellschafter, der dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz
unterliegt, kann, sofern diese Anteile dem Sicherungsvermögen zugeführt sind, nur mit vorheriger Zustimmung des bes-
tellten Treuhänders oder eines seiner Stellvertreter nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz erfolgen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs
oder die Zahlungsunfähigkeit des einzigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls es mehrere Geschäftsführer
gibt, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer
werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen,
ernannt, widerrufen, und ersetzt (ohne dass es hierbei der Angabe von Gründen bedarf).
Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, unter jeden Umständen im Namen der Gesellschaft zu
handeln, die im Gesellschaftszweck vorgesehenen Geschäfte durchzuführen und zu beschließen, insofern Artikel 11 dieser
Satzung berücksichtig wurde.
Die Geschäftsführer sind befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung
ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat können ihre Befugnisse für spezifische Geschäfte einem oder
mehreren ad hoc Agenten übertragen.
Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse und das Gehalt (wenn es ein Gehalt
gibt) der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats bestimmen.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder ver-
tretenen Geschäftsführer gefasst.
Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax, Telegramm oder Telex von jedem Ge-
schäftsführerrat wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im voraus informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine
schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestätigen,
dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für Si-
tzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates
festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax, Tele-
gramm oder Telex zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen,
müssen dies jedoch schriftlich bestätigen. Beschlüsse können nur dann gefasst werden, wenn die Mehrheit der Geschäfts-
führer anwesend oder vertreten ist.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbes-
chluss gefasst werden. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst, wenn eines oder mehrere Dokumente, welche den
Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als
Datum des Beschlusses.
Art. 12. Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie im
Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.
Art. 13. Der einzige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls
es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen,
unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse
sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen
werden.
Ungeachtet Artikel 11 dieser Satzung kann der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, während
der ersten Gesellschafterversammlung, die direkt nach Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, eine dritte Person
dazu bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.
Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des
Gesellschaftskapitals besitzen, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 15. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der
oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft auf.
Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes
Gesellschafters zur Verfügung.
Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft kann ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer betraut
werden.
Der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt den oder die möglichen Wirtschaftsprüfer und
legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
23590
Der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann den oder die möglichen Wirtschaftsprüfer je-
derzeit abberufen. Der bzw. die möglichen Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.
Art. 16. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Re-
ingewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds
zurückzustellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapital erreicht hat. Der ver-
bleibende Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder
die Gesellschafter können Zwischendividenden ausschütten.
Art. 17. Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liquida-
toren können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die
ihre Rechte und ihr Gehalt festlegt.
Art. 18. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, verwiesen.
Es folgt die Übersetzung in die Englische Sprache des vorausgegangenen Textes:
Art. 1. There exists between the appeared persons and every natural or legal person, which could become shareholder
of the Company in the future, a private limited liability company (société a responsabilité limitée) by the name of "Allianz
Finance V Luxembourg S.à r.l." (the Company).
Art. 2. The object of the Company is the acquisition and the management of assets, especially shares in investment
companies and real estate companies, for its own investment. The Company is entitled to carry out all transactions
pertaining, and directly or indirectly beneficial, to the Company's object with the exception of borrowings.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an ordinary resolution of its
sole shareholder or its shareholders.
The Company may have branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company's share capital is fixed at EUR 50.000 (fifty thousand Euro), represented by 5.000.000 (five million)
shares having a nominal value of EUR 0,01 (one Cent) per share each.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the
shareholders, in accordance with article 13 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. The transfer of shares held by any shareholder which is subject to the German Insurance Supervision Act must
be authorised, prior to the transfer, by the appointed trustee or one of its agents in accordance with § 70 of the German
Insurance Supervision Act, provided that these shares are affected to the guarantee assets.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the
shareholders will not terminate the Company.
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. In case of more than one manager, the managers will
constitute a board of managers. The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and
replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the
share capital (without having to indicate any reasons).
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all operations consistent with the Company's objects and provided the
terms of this article 11 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-
holders fall within the power of the managers.
The Company shall be bound by the joint signature of two members of the board of managers. The general meeting
of the shareholders or the board of managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc
agents.
The general meeting of the shareholders or the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
23591
Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or
telegram or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances
of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act
at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another manager as his
proxy. The managers may also vote by telephone, however, the managers need to confirm such a resolution in writing.
Resolutions may only be adopted if the majority of the managers is present or represented.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed by circular resolutions. A
circular resolution is adopted when one or several documents containing the resolutions have been signed by each and
every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature.
Art. 12. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company and within the framework of their powers.
Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders. In case of a
plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares,
which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
Notwithstanding article 11 of the articles of association, the sole shareholder or the general meeting of the share-
holders may, at the first meeting of the shareholders immediately following the incorporation of the Company, authorize
a third person to acquire shares in one or more existing companies.
Resolutions modifying the articles of association of the Company are adopted by the majority of the shareholders of
the Company representing three quarters of the share capital of the Company, under reserve of the act dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).
Art. 14. The Company's year starts on 1
st
January and ends on 31
st
December of each year.
Art. 15. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and the managers
prepare the balance sheet, the profit and loss statements and an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above profit and loss statements and balance sheet at the Company's registered
office.
For auditing and supervisory purposes of the activities of the Company, one or more independent external auditors
may be appointed.
The sole shareholder or the general meeting of the shareholders appoint the external auditor(s) and determine the
term of their office, which may not exceed six years.
The sole shareholder or the general meeting of the shareholders may revoke the independent external auditor(s) at
any time. They shall be eligible for re-appointment.
Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to their share holding in the
Company. The sole shareholder or the general meeting of the shareholders may decide to pay interim dividends.
Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is
made in these articles of association.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle 5.000.000 Gesellschaftsanteile werden von der Allianz Finance II Luxembourg S.à r.l., vorbenannt, gezeichnet und
ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 50.000 der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden
Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis erbracht wurde. Vorübergehende Bestimmungen
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft, und wird am 31. Dezember 2010 enden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer
Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise EUR 1.200,-.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
23592
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 3 festgelegt. Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Hero Dirk Albert Wentzel, geboren am 29. August 1950 in Nieuwer-Amstel (NL), geschäftsansässig in 484,
Keizersgracht, NL-1017 Amsterdam;
- Herr Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen, geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg,
14, Boulevard F.D. Roosevelt; und
- Herr Johannes Christian Maria Zarnitz, geboren am 21. April 1959 in Augsburg (Deutschland), geschäftsansässig in
NL-1017 Amsterdam (Niederlande), 484, Keizersgracht.
Die Gesellschafter beschließen weiterhin, dass die Geschäftsführer fortan den Geschäftsführerrat der Gesellschaft
bilden.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
3) Die Gesellschafter beschließen schlussendlich, den gesetzlichen Reservefonds vorab und vollständig in bar einzu-
zahlen, so dass dieser bereits 10% des Gesellschaftskapitals erreicht. Dem Notar wurde der Nachweis erbracht, dass
EUR 5.000 auf ein Konto der Gesellschaft überwiesen wurden.
Der unterzeichnende Notar, der englischen Sprache mächtig, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der erschienenen
Parteien, die Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; auf
Verlangen der erschienenen Parteien, im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung,
ist die deutsche Fassung maßgebend.
Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. JUNGERS, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 27 janvier 2010. Relation: CAP/2010/307. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. Neu.
Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, den 29. Januar 2010.
Référence de publication: 2010021794/228.
(100017092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
CIS Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 104.282.
In the year two thousand and ten, on the nineteenth day of January.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
Mr Philipp Turowski, director, with professional address in Eschborn, Germany acting in his capacity as special attorney-
in-fact of the board of directors of CIS Luxembourg S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having
its registered office at 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Léon Thomas
known as Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg, on 22 November 2004, published in Mémorial C number 106
on 4 February 2005, entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number
104.282, the articles of incorporation of which have been amended for the last time following a deed received by the
undersigned notary on 30 October 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2835 of 26 November 2008 (the "Company"),
by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the board of directors dated 19 January 2010, a copy of
which resolutions, signed "ne varietur" by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed.
The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I. The issued share capital of the Company is presently set at one million one hundred thirty thousand US Dollars
(USD 1,130,000.-) divided into one thousand one hundred thirty (1,130) redeemable shares, each of a nominal value of
one thousand US Dollars (USD 1,000.-) and each with the rights and privileges as defined herein.
II. Pursuant to article 6 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has been set
at two million US Dollars (USD 2,000,000.-) to be divided into two thousand (2,000) shares, each with a nominal value
of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) and pursuant to the same article 6, the board of directors of the Company
has been authorised to increase the issued share capital of the Company, such article of the articles of association then
to be amended so as to reflect the increase of capital.
23593
III. In view of the redemption by the Company of some of its shares and in accordance with the Luxembourg law on
commercial companies (the "Law"), the directors of the Company, by resolutions adopted at the meeting of the board
of directors held on 19 January 2010, a copy of which shall remain attached to the present deed and in accordance with
the authority which they were conferred pursuant to article 6 of the Company's articles of association, have decided to
increase the Company's issued share capital by an amount of eighty thousand US Dollars (USD 80,000.-) in order to raise
the issued share capital to the amount of one million two hundred ten thousand US Dollars (USD 1,210,000.-) by the
creation of eighty (80) new redeemable shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) having the
same rights and privileges as the already existing redeemable shares.
IV. The directors of the Company, by resolutions adopted at the meeting of the board of directors held on 19 January
2010, have decided to issue eighty (80) new redeemable shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-)
having the same rights and privileges as the already existing redeemable shares and to cancel the preferential subscription
rights of the existing shareholders.
V. The directors of the Company, by resolutions adopted at the meeting of the board of directors held on 19 January
2010, have confirmed, that these new redeemable shares have been entirely subscribed and fully paid up by contribution
in cash to the Company, so that the total amount of eighty thousand US Dollars (USD 80,000.-) representing the aggregate
amount of the above mentioned capital increase has been on 19 January 2010 at the disposal of the Company for the
contemplated redemption of shares, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting
documents for the relevant payments and that the issue and allotment of the new redeemable shares have become effective
on 19 January 2010.
VI. As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital paragraph one of article 6 of the
Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:
" Art. 6. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at one million two hundred ten thousand US
Dollars (USD 1,210,000.-) divided into one thousand two hundred and ten (1,210) redeemable shares. Each issued share
has a nominal value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) and is fully paid up."
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately 1,300.- EUR
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le dix-neuf janvier,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg,
A comparu:
M. Philipp Turowski, administrateur, domicilié professionnellement à Eschborn, Allemagne, agissant en qualité de man-
dataire spécial du conseil d'administration de CIS Luxembourg S.A., une société anonyme régie par le droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, constituée le 22 novembre 2004 suivant acte
de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire, de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 106 le 6
février 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 104.282, dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné, le 30 octobre 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°2835 du 26 novembre 2008 (la "Société"),
en vertu d'une procuration lui conférée par les résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en
date du 19 janvier 2010, une copie desdites résolutions, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et
constatations suivantes:
I. La Société a actuellement un capital social de cent trente mille US Dollars (USD 130.000,-) représenté par mille cent
trente (1.130) actions rachetables, les actions ayant une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000,-) chacune, ces
actions étant entièrement libérées.
II. En vertu de l'article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à deux millions de US
Dollars (USD 2.000.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions, ayant chacune une valeur nominale de mille US
Dollars (USD 1.000,-) et qu'en vertu du même article 6, le conseil d'administration de la Société a été autorisé à procéder
à une augmentation de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter l'augmentation de
capital ainsi réalisée.
23594
III. En vue du rachat par la Société de quelques unes de ses actions et en conformité avec la loi luxembourgeoise sur
les sociétés commerciales (la "Loi"), les administrateurs de la Société, par résolutions adoptées lors de la réunion du
conseil d'administration en date du 19 janvier 2010, dont une copie restera annexée au présent acte, et en conformité
avec les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'article 6 des statuts de la Société, ont décidé d'augmenter le capital
social souscrit à concurrence de quatre-vingt mille US Dollars (USD 80.000,-) afin de porter le capital social souscrit à
un million deux cent dix mille US Dollars (USD 1.210.000,-) par la création de quatre-vingts (80) nouvelles actions ra-
chetables d'une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions rachetables existantes.
IV. Les administrateurs de la Société, par résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration en date
du 19 janvier 2010, ont décidé d'émettre quatre-vingts (80) nouvelles actions rachetables d'une valeur nominale de mille
US Dollars (USD 1.000,-) chacune et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions rachetables existantes et
d'annuler les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants.
V. Les administrateurs de la Société, par résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration en date
du 19 janvier 2010, ont confirmé, que toutes ces nouvelles actions rachetables ont été entièrement souscrites et libérées
intégralement, par apport en numéraire à la Société, de sorte que la somme de quatre-vingt mille US Dollars (USD
80.000,-) correspondant au montant total de la susdite augmentation du capital social se trouvait le janvier 2010 à la
disposition de la Société pour le rachat d'actions envisagé, tel que démontré au notaire instrumentant par la présentation
des pièces justificatives de libération et que l'allocation et l'émission de ces nouvelles actions ont pris effet le 19 janvier
2010. vi. Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article 6 des statuts
est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à un million deux cent dix mille US Dollars (USD
1.210.000,-) représenté par mille deux cent dix (1.210) actions rachetables. Chaque action émise a une valeur nominale
de mille US Dollars (USD 1.000,-) et est entièrement libérée.".
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme
de 1.300,- EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. TUROWSKI, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2010. Relation: LAC/2010/3966. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2010.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2010021808/126.
(100017254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Libra Assur S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Miranda Consulting S. à r.l.).
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.263.
L'an deux mil dix, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
L'associé/gérant
Monsieur Norberto de Azevedo Miranda, agent d'assurance, né à Luxembourg, le 20 octobre 1974, demeurant ac-
tuellement à L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon
Lequel comparant a déclaré être le seul et unique associé, représentant l'intégralité du capital social de la société à
responsabilité limitée "MIRANDA CONSULTING, S.à r.l." établie et ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 83, rue
de Hollerich
23595
constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 22 février
2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 649 du 5 juillet 2005
que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro
106.263
L'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de changer le nom de la société en LIBRA ASSUR S.à r.l. et en conséquence de ce qui précède
de modifier l'article 1
er
des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée existe sous la dénomination de LIBRA ASSUR S.à r.l.".
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social vers L-8211 Marner, 113, route d'Arlon et en conséquence de ce
qui précède de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 3. (1
er
paragraphe). Le siège social est établi à Mamer."
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 850,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: N. DE AZEVEDO MIRANDA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2010. Relation: LAC/2010/3961. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2010.
P. DECKER.
Référence de publication: 2010021805/43.
(100017146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Libra Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Media Consulting S. à r.l.).
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 146.120.
L'an deux mil dix, le dix-neuf janvier.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société à responsabilité limitée LIBRA ASSUR S.à r.l. (anc: MIRANDA CONSULTING, S.à r.l.) établie et ayant son
siège social actuellement à L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg section B sous le numéro 106.263
ici représentée par son gérant technique Monsieur Norberto de Azevedo Miranda, agent d'assurance, né à Luxem-
bourg, le 20 octobre 1974, demeurant actuellement à L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a déclaré être le seul et unique associé, représentant l'intégralité
du capital social de la société à responsabilité limitée "MEDIA CONSULTING, S.à r.l." établie et ayant son siège social à
L-8069 Bertrange, 26, rue de l'Industrie
constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 20 avril
2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1108 du 4 juin 2008
que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro
146.120
L'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
23596
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de changer le nom de la société en LIBRA IMMO S.à r.l. et en conséquence de ce qui précède
de modifier l'article 1
er
des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée existe sous la dénomination de LIBRA IMMO S.à r.l."
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social vers L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon et en conséquence de ce
qui précède de modifier l'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 3. Le siège social est établi à Mamer."
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. La société a pour objets:
- l'achat, la vente, la mise en valeur et la gérance d'immeubles, la gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers
propres ou pour compte de tiers;
- l'exploitation d'une agence immobilière, de promotion, d'administration immobilière et de syndic de copropriété, de
conciergerie avec toutes activités accessoires,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera,
l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à approximativement 900,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: N. DE AZEVEDO MIRANDA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2010. Relation: LAC/2010/3960. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2010.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2010021804/64.
(100017167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Ascocentrum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 151.088.
STATUTES
In the year two thousand and ten.
On the seventh day of January.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
23597
The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, with its registered office in L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by two of its directors, Mr Raphaël ROZANSKI and
Ms Laetitia LENTZ, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company
("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "ASCOCENTRUM S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by two
hundred and fifty (250) sharequotas of fifty Euro (50.- EUR) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota.
If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has
been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of share-
quotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders'
meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to
the surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
23598
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
23599
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 21. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2010.
<i>Subscription and Paymenti>
The two hundred and fifty (250) sharequotas are all subscribed by the public limited company ECOREAL S.A., pren-
amed.
The subscriber, through its directors, states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so
that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the
corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at nine hundred and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as managers of the category A and managers of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mr Christian HEINEN, company director, born in Malmedy (Belgium), on February 1, 1976, residing professionally
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Manager of the category B:i>
- Mr David SANA, company director, born in Forbach (France), on April 10, 1974, residing professionally in L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the directors of the appearing party, known to the notary by their name, first name,
civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix.
Le sept janvier.
23600
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, dûment représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Raphaël ROZANSKI et
Mademoiselle Laetitia LENTZ, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
La comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "ASCOCENTRUM S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales de cinquante Euros (50,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
23601
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
23602
Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2010.
<i>Souscription et Paiementi>
Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique, la société anonyme ECOREAL
S.A., prénommée.
La souscriptrice comparante déclare, par ses administrateurs, et reconnaît que chacune des parts sociales a été inté-
gralement libérée en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de neuf cent cinquante
Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Monsieur Christian HEINEN, administrateur de sociétés, né à Malmedy (Belgique), le 1
er
février 1976, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Monsieur David SANA, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 10 avril 1974, demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux administrateurs de la comparante, connus au notaire par leurs nom,
prénom, état civil et domicile, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: ROZANSKI - LENTZ - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2010. Relation GRE/2010/233. Reçu soixante-quinze euros 75€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Junglinster, le 4 février 2010.
Référence de publication: 2010022387/328.
(100018291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.
23603
Straumen Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.319.
DISSOLUTION
In the year two thousand nine,
on the thirtieth day of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared the following:
Mr Ragnar Kristinn Kristjánsson, company director, residing at Ljónastig 10, IS-845 FLÚĐIR (Iceland),
hereafter referred to as "the principal",
represented by:
Mrs Doriane ROSSIGNOL, bank employee, with professional address at 35a avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
hereafter referred to as "the proxy holder";
by virtue of a proxy under private seal given to her in Luxembourg, on 18 November 2009, which proxy, after having
been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will be registered with
this deed.
The proxy-holder declared and requested the notary to act:
- that the company "STRAUMEN HOLDING S.A.", (the "Company"), established and having its registered office at 35a
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
number B 80 319, has been incorporated pursuant under the denomination "FLUDIR HOLDINGS S.A." to a notarial deed
by the undersigned notary on 29 December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial"), number 708 of 31 August 2001, page 33953. The denomination of the company has been changed by a
notarial deed by the undersigned notary, on 31 March 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (the "Mémorial"), number 663 of 29 June 2004, page 31786.
- that the corporate capital of the Company is set at SIX MILLION ONE HUNDRED AND FIFTY THOUSAND
ICELANDIC KRONA (ISK 6,150,000.-) divided into sixty-one thousand five hundred (61,500) shares with a par value of
ONE HUNDRED ICELANDIC KRONA (100.- ISK) each, all fully paid up in cash;
- that the principal is as of today the sole shareholder of the Company;
- that in his capacity as sole shareholder of the Company, he resolved to proceed to the anticipatory and immediate
dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in his capacity as liquidator of the Company, declares that all the liabilities of the Company,
including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;
- that the Company's activities have ceased;
- that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of
the terminated Company;
- that, following the above resolutions, the company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- that the company's directors and auditor are given full discharge for their respective duties;
- that there should be proceeded to the cancellation of all issued shares;
- that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's
former registered office;
- to declare that the principal commits himself to pay the costs of the notarial deed.
The undersigned notary, who has personal and perfect knowledge of the English language, states that at the request
of the above appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall
prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and interpreted in the language of the soil to the appearing proxy holder, known to
the notary her surname, Christian name, civil status and residence, said proxy holder appearing signed together with us,
the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
23604
Monsieur Ragnar Kristinn Kristjánsson, directeur de société, demeurant à Ljónastig 10, IS-845 FLÚĐIR (Islande),
ci-après dénommé "le mandant";
dûment représenté par:
Madame Doriane ROSSIGNOL, employée de banque, avec adresse professionnelle au 35a avenue J.F. Kennedy,
ci-après dénommée: "le mandataire",
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 18 novembre 2009, laquelle procuration,
après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société "STRAUMEN HOLDING S.A." (la "Société"), établie et ayant son siège social au 35a avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80 319, a
été constituée sous la dénomination de "FLUDIR HOLDINGS S.A." suivant acte du notaire soussigné daté du 29 décembre
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (le "Mémorial") numéro 708 du 31 août 2001, page
33953. La dénomination de la Société fut modifiée suivant acte du notaire soussigné daté du 31 mars 2004, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (le "Mémorial") numéro 663 du 29 juin 2004, page 31786.
- que le capital social de la Société est fixé à SIX MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE COURONNES ISLANDAISES
(6.150.000,- ISK) divisé en soixante et un mille cinq cents (61.500) actions d'une valeur nominale de CENT COURONNES
ISLANDAISES (100,- ISK) chacune, toutes se trouvant intégralement libérées en numéraire;
- que le mandant est, depuis aujourd'hui, l'actionnaire unique de la Société;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, il a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de
la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, a déclaré que tout le passif de la Société, y compris
le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
- que l'activité de la Société a cessé;
- que l'actionnaire unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout le passif éventuel de la
Société dissoute;
- que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la Société;
- qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions émises;
- que les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège
social de la Société;
- que le mandant s'engage à régler personnellement les frais des présentes.
Le soussigné notaire, qui connaît parfaitement la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue de la mandataire, connue du notaire instru-
mentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. ROSSIGNOL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2010. Relation: EAC/2010/200. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2010022351/97.
(100017567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.
Köner + Keutz Finanz AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 53.993.
L'an deux mille neuf.
Le vingt neuf décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "KÖNER + KEUTZ FINANZ AG" ayant son
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro
53993, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-
Duché de Luxembourg), et maintenant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 9 février 1996, publié
au Mémorial C n° 238 du 11 mai 1996, et dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing-privé lors de la conversion
du capital social en Euros, en date du 12 novembre 2001, extrait publié au Mémorial C n° 740 du 15 mai 2002.
23605
Le capital social s'élève à cent mille Euros (EUR 100.000,-) représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur
nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
L'assemblée est présidée par Monsieur Paul MARX, docteur en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Laetitia LENTZ, maître en droit, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David SANA, maître en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre
d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par les
actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par le notaire instrumentant, sera conservée à l'étude de
celui-ci.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire
instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1 Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
2. Nomination de la société anonyme holding PHITEX S.A., R.C.S. Luxembourg B 32990, avec siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus
par les articles 144 à 148 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs.
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:
La société anonyme holding PHITEX S.A., R.C.S. Luxembourg B 32990, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par
les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société, à savoir Monsieur Gérard BIRCHEN,
président du conseil d'administration, Monsieur Hugo FROMENT et Monsieur Jacques CLAEYS, et au commissaire aux
comptes de la société, à savoir la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., pour l'exécution de leurs mandats
respectifs.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à huit cent cinquante Euros.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: MARX - LENTZ - SANA - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 07 janvier 2010. Relation GRE/2010/106. Reçu soixante-quinze euros 75€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Junglinster, le 3 février 2010.
Référence de publication: 2010022345/66.
(100017886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.
23606
KVIST Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.199.
DISSOLUTION
In the year two thousand nine,
on the thirtieth day of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared the following:
Mr Bergur Thórisson, company director, residing at Kvisthaga 5, IS 107 Reykjavik (Iceland),
hereafter referred to as "the principal",
represented by:
Mrs Doriane ROSSIGNOL, bank employee, with professional address at 35a avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
hereafter referred to as "the proxy holder";
by virtue of a proxy under private seal given to her in Luxembourg, 15 December 2009, which proxy, after having
been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will be registered with
this deed.
The proxy-holder declared and requested the notary to act:
- that the company "KVIST HOLDING S.A.", (the "Company"), established and having its registered office at 35a avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B
80 199, has been incorporated pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary on 18 December 2000,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 675 of 25 August 2001, page
32366. The articles of association have never been amended since its incorporation date.
- that the corporate capital of the Company is set at TWENTY-THREE MILLION EIGHT HUNDRED SIXTY-NINE
THOUSAND TWO HUNDRED ICELANDIC KRONA (ISK 23,869,200.-) divided into two hundred thirty-eight thousand
six hundred and ninety-two (238.692) shares with a par value of ONE HUNDRED ICELANDIC KRONA (100.-ISK) each,
all fully paid up in cash;
- that the principal is as of today the sole shareholder of the Company;
- that in his capacity as sole shareholder of the Company, he resolved to proceed to the anticipatory and immediate
dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in his capacity as liquidator of the Company, declares that all the liabilities of the Company,
including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;
- that the Company's activities have ceased;
- that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of
the terminated Company;
- that, following the above resolutions, the company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- that the company's directors and auditor are given full discharge for their respective duties;
- that there should be proceeded to the cancellation of all issued shares;
- that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's
former registered office;
- to declare that the principal commits himself to pay the costs of the notarial deed.
The undersigned notary, who has personal and perfect knowledge of the English language, states that at the request
of the above appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall
prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and interpreted in the language of the soil to the appearing proxy holder, known to
the notary her surname, Christian name, civil status and residence, said proxy holder appearing signed together with us,
the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf,
le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
23607
Monsieur Bergur Thórisson, directeur de société, demeurant à Kvisthaga 5, IS 107 Reykjavik (Islande),
ci-après dénommé "le mandant";
dûment représenté par:
Madame Doriane ROSSIGNOL, employée de banque, avec adresse professionnelle au 35a avenue J.F. Kennedy,
ci-après dénommée: "le mandataire",
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 15 décembre 2009, laquelle procuration,
après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société "KVIST HOLDING S.A." (la "Société"), établie et ayant son siège social au 35a avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80 199, a
été constituée suivant acte du notaire soussigné daté du 18 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C (le "Mémorial") numéro 675 du 25 août 2001, page 32366.
Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis que la Société fut constituée.
- que le capital social de la Société est fixé à VINGT-TROIS MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-NEUF MILLE DEUX
CENTS COURONNES ISLANDAISES (23.869.200,- ISK) divisé en deux cent trente-huit mille six cent quatre-vingt-douze
(238.692) actions d'une valeur nominale de CENT COURONNES ISLANDAISES (100,- ISK) chacune, toutes se trouvant
intégralement libérées en numéraire;
- que le mandant est, depuis aujourd'hui, l'actionnaire unique de la Société;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, il a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de
la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, a déclaré que tout le passif de la Société, y compris
le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
- que l'activité de la Société a cessé;
- que l'actionnaire unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout le passif éventuel de la
Société dissoute;
- que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la Société;
- qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions émises;
- que les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège
social de la Société;
- que le mandant s'engage à régler personnellement les frais des présentes.
Le soussigné notaire, qui connaît parfaitement la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue de la mandataire, connue du notaire instru-
mentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. ROSSIGNOL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2010. Relation: EAC/2010/187. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2010022344/97.
(100017559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.
Callatay & Wouters PSF, Callatay et Wouters, Association d'Ingénieurs-Conseils S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89F, rue Pafebruch, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 38.811.
Le siège social de l'administrateur et administrateur délégué, la société S.A. FINANCIERE STEVIN, représentée par
Monsieur Didier de CALLATAY, demeurant à B-1150 Bruxelles, avenue de Tervuren, 226, est désormais le suivant:
B-1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervuren, 226,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009130563/12.
(090157062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2009.
23608
DG-Immo-Invest GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6688 Mertert, 1, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 151.061.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzehn, den 26. Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Hans Dieter GOEBEL, Kauffmann, geboren am 1. Januar 1957 in Kelberg/Hünerbach (Deutschland), wohnhaft in
D-56767 Kolverath, Elztalstrasse, 11,
welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem
Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die
Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.
Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf von Immobilienbesitz in Luxemburg
oder im Ausland, sowie alle Vorgänge im Zusammenhang mit Immobilienbesitz, einschließlich (i) des direkten oder indi-
rekten Besitzes von Beteiligungen an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Gründung, der Verkauf, die Verwaltung
und/oder die Vermietung von Immobilienbesitz ist und (ii) die Gewährung von Darlehen, Bürgschaften oder jede andere
Art von Sicherheiten im Zusammenhang mit den oben aufgelisteten Aktivitäten.
Die Gesellschaft kann Kredite in jeglicher Form aufnehmen und Privatplazierung im Rahmen von Schuldverschreibungen
tätigen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft (durch Kredite, Zuschüsse, Garantien, Sicherheiten oder auf andere Weise)
anderen Gesellschaften und Unternehmen, an denen die Gesellschaft ein Interesse hat oder die Teil der Gesellschafts-
gruppe sind, zu der die Gesellschaft gehört, Unterstützung gewährleisten, jegliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen
vornehmen und jegliche Geschäfte tätigen, welche sie für die Erfüllung und Entwicklung ihres Gegenstandes als nützlich
erachtet.
Letztendlich kann die Gesellschaft alle kaufmännischen, technischen und finanziellen oder anderen Geschäfte, welche
unmittelbar oder mittelbar mit allen Bereichen in Verbindung stehen, tätigen, um die Erfüllung ihres Gegenstandes zu
erreichen.
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet "DG-IMMO-INVEST GMBH".
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen
Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend vierhundert Euro (12.400,- €) und
ist eingeteilt in einhundert und vierundzwanzig (124) Anteile zu je einhundert Euro (100,- €). Jeder Anteil berechtigt zur
proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegen-
wärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt einen Antrag auf Pfändung
des Firmeneigentums oder von Firmenstücken zu stellen, Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder ein
gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Ge-
sellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die
nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
23609
Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber
abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.
Wenn die Nutznießung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.
Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Eins-
timmigkeit aller Gesellschafter erfordert; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die
Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erfordert.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht
diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile,
das innerhalb von dreißig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird,
berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren
und sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder zwei
letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die
Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten
Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche von der Gesell-
schafterversammlung ernannt werden, geleitet und verwaltet.
Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
Falls die Gesellschafterversammlung, nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die ausgedehntesten
Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht
die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,
sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder
der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandats fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer
beschließen.
Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen
des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter
oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-
schafter oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer bei der Ausübung ihres Amtes keine persönlichen
Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung
ihres Mandats verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das
Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch
eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
23610
2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur
rechtswirksam wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter die Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertreten, ange-
nommen werden, es sei denn die gegenwärtige Satzung oder das Gesetz würden anders bestimmen.
3. Beschlüsse betreffend die Abänderung der Statuten sind nur rechtswirksam wenn sie von allen Gesellschaftern
angenommen werden.
4. Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht
an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 17. Inventar-Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Jeder Gesellschafter kann
am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals
erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren,
von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der
alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf
die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2010.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle einhundert und vierundzwanzig (124) Anteile wurden gezeichnet von Herrn Hans Dieter GOEBEL, vorgenannt.
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausend vierhundert Euro (12.400,- €)
der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September
1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzungen der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien
auf neunhundert Euro geschätzt.
<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung,
folgende Beschlüsse zu nehmen:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6688 Mertert, 1, route du Vin, festgesetzt.
2) Als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "DG-IMMO-INVEST GMBH" für eine unbestimmte
Dauer wird ernannt:
- Herr Hans Dieter GOEBEL, Kauffmann, geboren am 1. Januar 1957 in Kelberg /Hünerbach (Deutschland), wohnhaft
in D-56767 Kolverath, Elztalstrasse, 11.
Der Geschäftsführer hat die Befugnisse wie in Artikel 12 der Satzung erwähnt.
Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet, durch die Unterschrift des alleinigen Geschäfts-
führers.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparent, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Goebel, C. Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 janvier 2010. LAC/2010/4407. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
23611
Luxemburg, den 3. Februar 2010.
Référence de publication: 2010021784/162.
(100017343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Pordano Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 79.860.
EXTRAIT
<i>- Extrait devant être déposé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en vertu de la loi du 19 décembrei>
<i>2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises eti>
<i>modifiant certaines autres dispositions légalesi>
Il résulte de la résolution prise à Luxembourg le 6 octobre 2009 par l'associé unique de la société PORDANO FI-
NANCE S.à r.l., ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au RCS sous le n° B 79860,
que la société nomme avec effet immédiat à durée indéterminée comme nouveau gérant Mme Magalie HILCHER, em-
ployée privée, née le 5 janvier 1978 à Algrange (France), domiciliée à F-57280 Maizières-les-Metz (France), 21 Voie
Romaine.
Luxembourg, le 6 octobre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009130640/20.
(090157462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2009.
Fandl B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 22.700,00.
Siège de direction effectif: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 146.027.
In the year two thousand nine, the twenty-second day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Fandl B.V./ S.àr.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), organized under Dutch and Luxembourg laws, having its official seat
in Hoofddorp, the Netherlands, and its principal establishment and place of effective management at 68-70 Boulevard de
la Pétrussee, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Dutch Trade Register of Amsterdam
under no. 16036625 and the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 146.027 (the Com-
pany). The Company has been incorporated on April 21, 2009 pursuant to a deed of Maitre Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N° - 1046 of May 20, 2009.
There appeared:
IRR K Limited, a company under the laws of the Cayman Islands, having its office address at Ugland House, South
Church Street, the Cayman Islands (the Sole Shareholder),
hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of Mr. Alain Andrey as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company
(the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration,
all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
5. Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation;
23612
6. Decision to grant full and complete discharge to the managers of the Company for the performance of their res-
pective mandates; and
7. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr. Alain Andrey, administrator, born on May 29, 1953, at Estavayer le Lac,
Switzerland, with professional address at IRR SA, 4 Quai de la Poste, 1204 Geneva, Switzerland, as liquidator (the Liqui-
dator) in relation to the voluntary liquidation of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is
required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for
the performance of his duties.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg
act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible
consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the managers of the Company for the perfor-
mance of their respective mandates.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,200.-
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Fandl B.V. /S.àr.l., une société
à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg et des Pays-Bas, avec siège officiel à Hoofdorp, les Pays-
Bas, et son établissement principal et lieu de gestion effective au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L- 2320 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 146.027 (la Société). La Société a été constituée le 21 avril 2009, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
° - 1046 du 20 mai 2009.
A comparu:
IRR K Limited, une société organisée selon les lois des Iles Cayman, avec siège social à Ugland House, South Church
Street, les Iles Cayman (l'Associé Unique),
23613
représentée par M
e
Vanessa Schmitt, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de M. Alain Andrey comme liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le
Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions,
tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
5. Décision que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique;
6. Décision d'accorder décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs;
et
7. Divers.
Ces faits exposés, les parties comparantes, représentées comme décrit ci avant, prient le notaire instrumentaire d'acter
ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer M. Alain Andrey, administrateur, ne lé 29 mai 1953 à Estavayer le Lac, Suisse,
avec adresse professionnelle IRR SA, 4 Quai de la Poste, 1204 Genève, Suisse, comme liquidateur (le Liquidateur) dans
le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la
liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus
à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule
responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs per-
sonnes physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article
148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures
conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accorder décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs
mandats respectifs.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ EUR 1.200,-
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
23614
Signé: V. Schmitt, H. Hellinckx
Enregistré à Luxembourg A.C, le 30 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57826. Reçu douze euros EUR 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 3 février 2010.
Référence de publication: 2010021672/142.
(100017291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Mohone S.C.I., Société Civile.
Siège social: L-9514 Wiltz, 43, rue des Charretiers.
R.C.S. Luxembourg E 3.012.
Le siège social de la MOHONE SCI situé
13 rue Grande-Duchesse Charlotte - L-9515 WILTZ
est modifié et déplacé à l'adresse suivante:
43 rue des Charretiers - L-9514 WILTZ
Signature.
Référence de publication: 2009130744/12.
(090158128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2009.
Lexinvest S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.720,00.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 115.542.
Les nouvelles adresses des associés sont les suivantes:
1. WORKHAM EUROPEAN PROPERTY LTD
Hill Farm Barn - Bruern Road, Milton-Under-Wychwood, Oxfordshire OX7 6HB, UK
2. NPK HOLDINGS LTD
37, Cambridge Place, Cambridge, CBS 1NS, UK
3. AVERLEY WOOD PROPERTIES LTD
Kettlebury, Thursley Road, Churt, Farnham, Surrey GU10 2LQ, UK
4. QUINN Lochlann G.
Fitzwilliam Suite, The Merrion Hotel, 21-24 Upper Merrion Street, Dublin 2, IRL
5. MARKS John Graham
New Hall, 14 Sheering Drive, Old Harlow, Essex, CM17 OJJ, UK
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2010022433/21.
(100017439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 109.812.
Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2010022779/11.
(100018108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.
23615
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 112.219.
Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2010022780/11.
(100018103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2010.
Stocknet Investments Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.760.450,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 92.486.
Il est porté à la connaissance de tiers qu'en date du 06/03/2003, les associés ont décidé d'augmenter le capital social
de la Société à concurrence de 9.760.425,- EUR par la création et l'émission de 390.417 parts sociales d'une valeur
nominale de 25,- EUR chacune.
Toutes les 390.417 parts sociales ont été entièrement souscrites par FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVEST-
MENTS S.A., avec siège social au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 67.214.
A la même date, les associés ont décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 24.975,- EUR par
l'annulation de 999 parts sociales détenues par FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A.
Partant, la répartition des parts entre les associés est désormais la suivante:
FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390.417 parts sociales
FT HOLDING 2 S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2009.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009134689/23.
(090162183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.
Invesco Aberdeen Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: GBP 229.870,25.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.687.
<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 29. Januar 2010i>
Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 29. Januar 2010 beschlossen, dass Herr Andrew Rofe sowie Herr
Mark Weeden ihr Amt als Geschäftsführer niederlegen. Die folgenden Personen werden mit sofortiger Wirkung auf
unbestimmte Zeit als Geschäftsführer neu ernannt:
- Frau Juliette Henry, geboren am 30. April 1973 in West Bromwich, Vereinigtes Königreich, beruflich ansässig in 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg sowie
- Herr Chris Curtis, geboren am 19. September 1979 in Reading, Vereinigtes Königreich, beruflich ansässig in 43-45
Portman Square, W1H6LY London.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 29. Januar 2010.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Geschäftsführer / Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2010022429/20.
(100016903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
23616
Allianz Finance V Luxembourg S.à r.l.
Ascocentrum S.à r.l.
BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg
Callatay et Wouters, Association d'Ingénieurs-Conseils S.A.
Cebi-Aviation S.A.
CIS Luxembourg S.A.
ComLux Furniture S.à r.l.
Complete Holding S.A.
DG-Immo-Invest GmbH
Fandl B.V.
Gandi Holding S.A.
Genus Holdings S.A.
Green Electricity Master Invest
Green Partners S.C.A.
GSC European Credit Fund
GTH Holding S.A.
Invesco Aberdeen Hotel Investment S.à r.l.
IPN Unternehmensberatung S.A.
Köner + Keutz Finanz AG
KVIST Holding S.A.
La Rigoutière S.C.I.
Lexinvest S.àr.l.
Libra Assur S.à r.l.
Libra Immo S.à r.l.
Media Consulting S. à r.l.
Miranda Consulting S. à r.l.
Mohone S.C.I.
OPF Immo S.A.
Pordano Finance S.à r.l.
Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l.
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l.
Stocknet Investments Holding Sàrl
Straumen Holding S.A.