logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 377

20 février 2010

SOMMAIRE

352 Investors S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18072

ABN AMRO Multi-Manager Funds  . . . . . . .

18051

Agaka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18070

Atlantis Investments Holding S.A.  . . . . . . .

18074

BEBAU Swiss Holding S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

18076

Blatteus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18070

Business Management Group Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18068

Café Number 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18073

Cinemotion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18086

Coljon Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18096

COREAL Construction S.à r.l. . . . . . . . . . . .

18081

Defibresil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18068

Deutsche Finanz A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18074

DISA-Distribution Investments S.A.  . . . . .

18050

Dorsol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18073

Drayton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18050

Dresdner Portfolio Management  . . . . . . . .

18052

DZ PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18070

DZ Private Wealth Managementgesell-

schaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18070

EGL Holding Luxembourg AG  . . . . . . . . . .

18081

eOffice Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18050

Facility S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18085

Fairchild Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .

18054

Febex Technique S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18053

Ford Export Services, Luxembourg  . . . . . .

18055

Frank Kienel S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18075

Galli S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18054

Georue 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18077

H + A Montage S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18075

Immobilière et Commerciale Graas S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18073

Lindner Isoliertechnik GmbH, Niederlas-

sung Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18074

Lotoise Gourmande S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

18085

Lotoise Gourmande S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

18085

Lotoise Gourmande S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

18085

Luxriviera S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18072

Luxriviera S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18096

Madras Investments Holding S.A. . . . . . . . .

18074

Malux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18075

Matsip Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18072

Mondeltone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18053

Nomura U.S. High Yield Bond Income  . . .

18055

Nomura U.S. High Yield Bond Income  . . .

18068

Optima Consulting Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

18096

Outre-Mer Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18054

Peinture Baranowsky S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

18075

Petrus International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

18067

PO Invest 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18068

ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l.  . . . .

18076

ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l.  . . . .

18075

ProLogis Czech Republic XVI S.à r.l. . . . . .

18076

ProLogis Czech Republic XV S.à r.l.  . . . . .

18076

ProLogis Czech Republic XXI S.à r.l.  . . . .

18073

ProLogis Czech Republic XX S.à r.l.  . . . . .

18074

Racine Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

18067

Star Group S.A., société de gestion de pa-

trimoine familial, "SPF"  . . . . . . . . . . . . . . .

18067

Stenton Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

18089

Tabiadasc Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

18051

Tempura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18055

Tollamen SPF, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18055

TransArdenna S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18072

Trustcapital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18072

Uniker Investments Holding S.A.  . . . . . . . .

18073

18049

DISA-Distribution Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.158.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>March 12, 2010 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2009
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg

law on commercial companies of August 10, 1915

5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2010019359/795/17.

eOffice Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 90.728.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement jeudi, le <i>11 mars 2010 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Eric MAGRINI de son mandat d'administrateur et décharge.
2. Nomination de Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre

1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme
administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

3. Démission de la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA de son mandat de commissaire aux comptes

et décharge.

4. Nomination de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège

social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme commissaire aux comptes jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

5. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010019363/29/21.

Drayton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 41.520.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mars 2010 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations Statutaires
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010019374/795/16.

18050

Tabiadasc Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.240.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held extraordinarily on <i>March 11, 2010 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Resignation of the public limited company FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA as statutory auditor and discharge.
2. Appointment of the private limited company COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 58545, with registered

office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as statutory auditor until the end of the
statutory general shareholders' meeting of 2013.

3. Resignation of Mr. Eric MAGRINI as A director and chairman of the board of directors and discharge.
4. Appointment of Mr. Philippe TOUSSAINT, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975,

residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as A director until the
end of the statutory general shareholders' meeting of 2013.

5. Sundry.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2010019365/29/20.

ABN AMRO Multi-Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.762.

An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at 10.00 a.m. on Friday <i>5 March 2010 at the premises of Fortis Investment Mana-

gement Luxembourg S.A., bâtiment H2O, bloc B, 1 

er

 étage, sis 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered office from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange and consequent modification of

Article 2 of the Articles of Association;

2. Modification of the second paragraph of Article 2 of the Articles of Association as follows: "The registered office

may be transferred by simple decision of the Board of Directors, either within the commune or, within the limits
authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxembourg.";

3. Modification of Article 4 of the Articles of Association in order to allow the Company to invest in all securities

and/or other liquid financial assets, within the limits permitted by the Act of 20 December 2002 on collective
investment undertakings ("the Act");

4. Modification of Articles 7 and 8 of the Articles of Association in order to reduce the maximum time frame for

subscriptions and redemptions from 10 to 7 days;

5. Modification of the asset valuation methods as provided for in Article 11 of the Articles of Association;
6. Modification of Article 11 in order to limit the maximum total amount of annual fees payable by a sub-fund, category

or sub-category to 5% of its average net assets;

7. Modification of Article 11 in order to allow the Board of Directors to calculate a second net asset value under

certain circumstances (Swing Pricing);

8. Modification of Article 12 of the Articles of Association in order to provide for the calculation of Net Asset Values

(NAVs) at least twice a month in conformity with the Act;

9. Modification of Article 12 of the Articles of Association in order to add the cases of suspension of calculation of

the following NAVs: a) as soon as a decision is taken to liquidate a sub-fund; b) in the event of any merger, asset
transfer, demerger transaction or any restructuring operation within, by or in one or more sub-funds; and c) in all
cases where justified by the interests of the shareholders;

10. Modification of Article 12 of the Articles of Association in order to allow the Board of Directors to reduce and/

or defer redemption/conversion applications when these concern more than 10% of the net assets;

11. Modification of Article 12 of the Articles of Association in order to allow the Board of Directors, where justified

by the shareholders' interests, not to determine the net asset value in the event of subscriptions, redemptions or
conversions exceeding 10% of the assets of a sub-fund until such time as the required purchases and sales of
securities have been made;

12. Modification of Article 15 of the Articles of Association in order to provide for the possibility of collective mana-

gement of all or part of the assets of the Company;

18051

13. Modification of point 1) e) 4 

th

 dash of Article 19 of the Articles of Association in order to limit investments in

UCITS and other undertakings for collective investment to a maximum of 10% of the net assets of each sub-fund,
apart from the sub-funds managed as "Funds of Funds";

14. Movement of the Annual General Meeting of shareholders to 2.00 p.m. on the last Friday of April, and consequent

modification of Article 23 of the Articles of Association;

15. Modification of Article 25 of the Articles of Association in order to allow a sub-fund to be merged with a sub-fund

of another UCITS falling under Part I of the Act by a simple decision of the Board of Directors of the Company;

16. Deletion of Articles 18 (Consultative committee), 21 (Directors' remunerations and allowances) and 33 (Decla-

ration);

17. Complete overhaul of the Articles of Association of the Company.

In compliance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended by the

Law of 7 September 1987, the Meeting's deliberations are only valid if at least one-half of the Company's capital is present
or represented. Decisions must be taken by a minimum of two-thirds of the shares present or represented.

Holders of bearer shares who wish to attend or be represented at the Meeting are requested to deposit their shares,

at least five clear days before the Meeting, at the offices of the financial service agents, as mentioned in the prospectus.

Holders of registered shares who wish to attend or be represented at the Meeting will be admitted on production of

proof of identity, provided they have given notice of their intention to take part at least five days before the meeting.

The new draft Articles of Association, the current prospectus and the latest periodic report are available from the

organisations indicated in the prospectus.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2010019368/755/59.

Dresdner Portfolio Management, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 41.022.

Wir geben hiermit bekannt, dass die

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber der Dresdner Portfolio Management SICAV ("die Gesellschaft") am <i>25. März 2010 um 14.30 Uhr

MEZ am Geschäftssitz 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg stattfinden wird.

Da auf der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 12. Februar 2010 nicht die nötige Beschluss-

fähigkeit erreicht wurde, wird am 25. März 2010 eine zweite außerordentliche Generalversammlung einberufen, um die
folgenden Angelegenheiten zu erörtern und darüber abzustimmen:

<i>Tagesordnung:

1. Umbenennung der Gesellschaft in "CB Lux"

<i>Abstimmung:

Die Beschlüsse auf der Tagesordnung können ohne Quorum mit mindestens zwei Dritteln der auf der Versammlung

abgegebenen Stimmen gefasst werden.

<i>Abstimmungsregelung:

Zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind Anteilinhaber, die der Verwaltungsgesellschaft Allianz

Global Investors Luxembourg S.A., 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, bis spätestens zum Ge-
schäftsschluß des 19. März 2010 eine Bestätigung ihres Depotinstituts vorlegen können, aus der die Anzahl der Anteile
im Besitz des Anteilinhabers hervorgeht, einschließlich einer Bestätigung, dass die Anteile bis zum Tag nach der Ver-
sammlung der Anteilinhaber gesperrt sind.

Alle Anteilinhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürfen einen Stellvertreter

ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtsformular ist nur gültig, wenn es ordnungsgemäß ausgefüllt und
eigenhändig vom ernennenden Anteilinhaber oder von dessen Bevollmächtigtem unterzeichnet wird (oder, falls der Stell-
vertreter  von  einer  Gesellschaft  ernannt  wird,  mit  dem  Firmensiegel  oder  der  Unterschrift  eines  ordnungsgemäß
bevollmächtigten Angestellten versehen ist) und bis spätestens zum Geschäftsschluß des 19. März 2010 bei der Verwal-
tungsgesellschaft Allianz Global Investors Luxembourg S.A., 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
eingegangen ist.

Vollmachtsformulare erhalten eingetragene Anteilinhaber bei der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Lu-

xembourg S.A., 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Eine zum Stellvertreter ernannte Person muss
kein Anteilinhaber der Gesellschaft sein. Durch die Ernennung eines Stellvertreters ist ein Anteilinhaber nicht von der
Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.

Senningerberg, Februar 2010.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010019371/755/36.

18052

Mondeltone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.847.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mars 2010 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015553/795/17.

Febex Technique S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 33.873.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 8 mars 2010 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Adoption par la société de l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et de la dénomination

"FEBEX TECHNIQUE S.A., société de gestion de patrimoine familial" et modification subséquente des articles
afférents des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "FEBEX TECHNIQUE S.A., société de gestion de patrimoine
familial", qui sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial
("SPF")".
"La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus
large et notamment:
a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à
des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de
créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;
b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat
ou d'échange ;
c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instru-
ments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;
d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières
précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques ;
f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents
éléments,
que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou
tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.
La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.
Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une
participation directe.
La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

2. Modification, de la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante :

"La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le
cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la

18053

signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des
dispositions de l'article 10 des statuts."

3. Refonte des statuts de la société.

Une première assemblée générale extraordinaire a été tenue le 26 janvier 2010 pour statuer sur le même ordre
du jour. Celle-ci n'a pas rempli les conditions de quorum de présence requises par l'article 67-1 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Dès lors, la présente assemblée a été convoquée conformément
aux conditions légales par des avis reproduisant l'ordre du jour et indiquant la date et le résultat de l'assemblée
précédente et autorisant une délibération valable quelle que soit la proportion du capital représenté. Que donc
l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du
jour lui soumis.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010013098/29/52.

Fairchild Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 96.317.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010 

 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2008 et 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015555/795/15.

Galli S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.111.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010  à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2009.

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation sur les sociétés.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016321/1023/17.

Outre-Mer Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 59.166.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010  à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;

18054

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015558/534/16.

Tollamen SPF, SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 16.551.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010 

 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015560/795/15.

Tempura S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 57.083.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 mars 2010 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015562/795/15.

Nomura U.S. High Yield Bond Income, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné au 26 février 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Global Funds Management S.A.
Signature

Référence de publication: 2010016297/9.
(100013839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Ford Export Services, Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 149.866.

COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER PLAN OF MERGER

I. The directors of
3000 Schaefer Road Company, a corporation incorporated under the laws of Michigan, having its registered office at:

c/o The Corporation Company; 30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, Ml 48025, United States and being
registered with the Michigan Department of Labor and Economic Growth, Bureau of Commercial Services under number
144453

("Acquiring Company"); and

18055

II. the managers of
Ford Export Services Luxembourg, a société à responsabilité limitée
incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and being registered with the R.C.S. Luxembourg under number B
149.866.

("Disappearing Company"),
Taking into consideration:
that all issued and outstanding shares in the share capital of the Acquiring Company and in the share capital of the

Disappearing Company are held by Ford Motor Company, a company organized under the laws of the state of Delaware,
United States, having its place of business at One American Road, Michigan 48126 Dearborn, United States and registered
with the Registrar of Companies of the State of Delaware, United States under number 3389398 ("Ford Motor Company");

propose to effect a cross-border legal merger in accordance with Chapter 7, Act 284, P.A. of 1972, the Business

Corporation Act, of the State of Michigan (the "Laws of the State of Michigan") and Section XIV of the Luxembourg Law
of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law of 1915"), whereby the Disappearing Company
will cease to exist and the Acquiring Company will acquire the assets and liabilities of the Disappearing Company by
operation of law ("the Merger").

a. Name, legal form and registered office of the merging companies
1. Acquiring Company:
3000 Schaefer Road, a company incorporated under the laws of Michigan in the form of a corporation having its

registered office at: c/o The Corporation Company; 30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, Ml 48025, United
States.

2. Disappearing Company:
Ford Export Services Luxembourg, a company incorporated under the laws of Luxembourg in the form of a société à

responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

b. Outstanding Shares of Merging Companies
1. Acquiring Company:
(a) 10 shares of Common stock outstanding. Each share of common stock is entitled to one vote at shareholders

meetings. Common stockholders are entitled to vote as a class on certain matters (the voluntary liquidation, dissolution,
or winding up of the corporation, and the amendment, alteration, or modification, of any provision of the Articles of
Incorporation). The Common stockholders also are entitled to vote as a class to elect at least one director.

(b) 10 shares of Preferred stock outstanding, each share of preferred stock is entitled to 19 votes at shareholders

meetings. Common stockholders are entitled to vote as a class on certain matters (the redemption of all or any part of
the preferred stock, the voluntary liquidation, dissolution, or winding up of the corporation, and the amendment, alte-
ration, or modification, of any provision of the Articles of Incorporation).

2. Disappearing Company: 107 shares, each of which is entitled to one vote at shareholders meetings.
c. Exchange ratio; mechanism for the delivery of the shares
Ford Motor Company, in its capacity of sole shareholder of the Disappearing Company, shall acquire additional shares

in the capital of the Acquiring Company to be newly issued pursuant to the Merger against the contribution of all assets
and liabilities of the Disappearing Company. The exchange ratio shall be 107 share(s) of the Acquiring Company for all
the 107 shares of the Disappearing Company.

On the Effective Date (as defined below), each share of the Disappearing Company shall be cancelled and converted

into one share of the Acquiring Company.

Ford Motor Company shall be registered in the shareholders' register of the Acquiring Company as owner of the

newly issued shares of the Acquiring Company which shall be allocated to it as described above on the Effective Date.

d. Date as from which those shares or corporate units shall carry the rights to participate in the profits and any special

condition regarding that right

The new shares in the Acquiring Company will carry the rights to participate in the profits as from their issue.
e. Date from which the operations of the Disappearing Company shall be treated for accounting proposes as being

carried out on behalf of the Acquiring Company

The date on which the operations of the Disappearing Company will, for accounting purposes, be treated as having

been carried out on behalf of the Acquiring Company, is set at 1 

st

 January 2010.

f. Absence of special rights referred to in article 261 (2) f) of the Law of 1915
There are no persons having special rights in the Disappearing Company as referred to in Article 261 (2) f) of the Law

of 1915 and accordingly no special rights are granted by the Acquiring Company.

g. Benefits, which will be attributed in connection with the legal merger to the managing directors, statutory auditors

or the experts of the merging companies, or to any third parties

18056

There are no benefits which will be attributed in connection with the Merger to the managing directors, statutory

auditors or experts of each of the merging companies, or to any third party.

h. Articles of incorporation and by-laws
The Articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") and by laws (the "By-Laws") of the Acquiring Company

as in effect immediately prior to the Effective Date, until further amended, shall be and remain the Articles of Incorporation
and By-Laws of the Acquiring Company following the Merger.

The Articles of Incorporation are attached to this proposal as Annex A.
i. Board of Directors and Officers
The Board of Directors of the Acquiring Company on the Effective Date shall remain the Board of Directors of the

Acquiring Company after the Merger. Such directors shall serve as directors of the Acquiring Company until the next
annual meeting of shareholders of the Acquiring Company or until such time as their successors have been duly appointed
or elected. The officers of the Acquiring Company immediately prior to the Effective Date shall be the officers of the
Acquiring Company after the Merger. Such officers shall serve as officers of the Acquiring Company until the next annual
meeting of shareholders of the Acquiring Company or until such time as their successors have been duly elected or
appointed in accordance with the By-Laws of the Acquiring Company.

j. Effects of the Merger
Upon the Effective Date, the Disappearing Company shall be merged with and into the Acquiring Company, which

shall continue its existence under the laws of the State of Michigan. The separate corporate existence and corporate
organization of the Disappearing Company shall cease upon the Effective Date. All property, personal, intellectual, and
mixed, and all debts due on whatever account, including subscriptions to shares, and all other choses in action, and all
and every other interest, of or belonging to or due to the Disappearing Company, shall be taken and deemed to be
transferred to and vested in the Acquiring Company without further act or deed; and the title to any real estate or
intellectual property, or any interest therein, vested in the Disappearing Company shall not revert or be in any way
impaired by reason of such Merger. Neither the rights of creditors nor any liens upon the property of the Disappearing
Company shall be impaired by the Merger, and all debts, liabilities and duties of the Disappearing Company shall thence-
forth attach to the Acquiring Company and may be enforced against the Acquiring Company to the same extent as if the
debts, liabilities and duties had been incurred or contracted by the Acquiring Company. Any existing claim, action or
proceeding, whether civil, criminal, or administrative, by or against the Disappearing Company may be prosecuted to
judgment or decree as if the Merger had not taken place, or the Acquiring Company may be substituted in such action
or proceeding.

k. Effect of the Merger on employment
The Merger will have no effect on employees as none of the merging companies has any employees or any subsidiaries.
I. Information on the valuation of the assets and liabilities which are transferred to the Acquiring Company by operation

of law

The assets and liabilities of the Disappearing Company that will be acquired by the Acquiring Company have been

valued at book value.

m. Dates of the Merging Companies' accounts used to establish the conditions for the Merger

st

 January 2010.

n. The rights of creditors of the Merging Companies
Creditors of the Disappearing Company may exercise their rights in accordance with Article 268 of the Law. For

further information, please contact the registered office of the Disappearing Company, where more detailed information
may be obtained free of charge. Creditors of the Acquiring Company may obtain this information free of charge at the
registered office of the Acquiring Company.

o. General meeting of shareholders of the merging companies
It is proposed to Ford Motor Company, in its capacity of sole shareholder of each of the merging companies, to approve

the proposed Merger at an Extraordinary General Meeting of Shareholders of each of the merging companies. The general
meeting of shareholders of the Disappearing Company will be held before a Luxembourg notary public at the earliest one
month following the publication of the present common draft terms of cross-border merger.

p. Effective date of the Merger
Pursuant to article 273ter of the Law of 1915, the effective date of the Merger (the "Effective Date") shall be the date

of filing of the Merger with the Michigan Department of Labor and Economic Growth, Bureau of Commercial Services.

q. Annexes
Annexes to this proposal form an integrated part of this proposal

Luxembourg, February, 17, 2010.

1. Ford Export Services Luxembourg
Yannick Poos
<i>managing director

18057

Dearborn, MI, USA, February, 12, 2010.

2. 3000 Schaefer Road Company
Peter J. Sherry, Jr
Dearborn, MI, USA
<i>Secretary

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE, PLAN DE FUSION

I. Les administrateurs de
3000 Schaefer Road Company, une société constituée sous les lois du Michigan, ayant son siège social à: c/o The

Corporation Company; 30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, MI 48025, États-Unis, et inscrite au Michigan
Department of Labor and Economic Growth, Bureau of Commercial Services sous le numéro 144453

("Société Absorbante"); ainsi que
II. les gérants de
Ford Export Services Luxembourg, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 149.866. ("Société Absorbée"),

prenant en considération:
que la totalité des parts émises et en circulation dans le capital social de la Société Absorbante et dans le capital social

de la Société Absorbée sont détenues par Ford Motor Company, une société constituée selon les lois de l'État du De-
laware, États-Unis, ayant son siège social au One American Road, Michigan 48126 Dearborn, États-Unis et inscrite au
Registre des Sociétés de l'État du Delaware, États-Unis sous le numéro 3389398 ("Ford Motor Company");

proposent d'entreprendre une fusion transfrontalière conformément au Chapitre 7, Acte 284, P.A. de 1972, le Business

Corporation Act, de l'État du Michigan (les "Lois de l'Etat du Michigan") et à la Section XIV de la Loi luxembourgeoise
du  10  août  1915  relative  aux  sociétés  commerciales,  telle  que  modifiée  (la  "Loi  de  1915"),  selon  laquelle  la  Société
Absorbée cessera d'exister et la Société Absorbante acquerra l'actif et le passif de la Société Absorbante de plein droit
(la "Fusion").

a. Dénomination, forme juridique et siège social des sociétés fusionnantes
1. Société Absorbante:
3000 Schaefer Road Company, une société constituée sous les lois du Michigan, sous la forme d'une corporation ayant

son siège social à: c/o The Corporation Company; 30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, Ml 48025, États-
Unis.

2. Société Absorbée:
Ford Export Services Luxembourg S.àr.l., une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg sous

la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Grand-Duché de
Luxembourg.

b. Parts sociales en circulation des Sociétés Fusionnantes
1. Société Absorbante:
(a) 10 actions ordinaires en circulation. Chaque action ordinaire donne droit à un vote aux assemblées des actionnaires.

Les actionnaires ordinaires ont le droit de voter en tant que classe sur certaines matières (liquidation volontaire, liqui-
dation  ou  dissolution  de  la  Société,  amendement,  changement  ou  modification  des  dispositions  des  Statuts).  Les
actionnaires ordinaires ont le droit, en tant que classe, d'élire au moins un administrateur.

(b) 10 actions préférentielles, chaque action préférentielle donnant droit à 19 voix aux assemblées des actionnaires.

Les actionnaires préférentiels ont le droit de voter en tant que classe sur certaines matières (le rachat de plusieurs ou
de tous les actions préférentielles, la liquidation volontaire, liquidation ou dissolution de la Société, amendement, chan-
gement ou modification des dispositions des Statuts).

2. Société Absorbée: 107 parts sociales, chacune donnant droit à une voix aux assemblées générales des actionnaires

à un vote.

c. Ratio d'échange; mécanisme de délivrance des parts
Ford Motor Company, en sa qualité d'associé unique de la Société Absorbée acquerra les parts supplémentaires dans

le capital de la Société Absorbante qui seront nouvellement émises conformément à la Fusion en contrepartie de l'apport
de l'intégralité de l'actif et du passif la Société Absorbée. Le ratio d'échange sera de 107 actions de la Société Absorbante
pour l'ensemble des 107 parts de la Société Absorbée.

À la Date Effective (telle que définie ci-après), chaque part de la Société Absorbée sera supprimée et convertie en une

action de la Société Acquérante.

Ford Motor Company sera inscrite au registre des associés de la Société Absorbante en tant que propriétaire des

parts nouvellement émises de la Société Absorbante, qui lui seront allouées comme décrit ci-dessus à la Date Effective.

18058

d. Date à laquelle les nouvelles parts seront assorties de droits de participation aux bénéfices et toute condition

particulière relative à ce droit

Les nouvelles parts de la Société Absorbante seront assorties de droits de participation aux bénéfices à partir de leur

émission.

e. Date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées, d'un point de vue comptable, comme

accomplies pour le compte de la Société Absorbante

La date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront, à des fins comptables, traitées comme étant réalisées

au nom et pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 1 

er

 janvier 2010.

f. Absence de droits particuliers auxquels il est fait référence à l'article 2 261 (2) f) de la Loi de 1915
Aucune personne ne bénéficie de droits particuliers dans la Société Absorbée, tel que prévu à l'Article 261 (2) f) de

la Loi de 1915 et par conséquent aucun droit particulier n'est accordé par la Société Absorbante.

g. Les Bénéfices qui, dans la cadre de la fusion, sont attribués aux administrateurs, réviseurs ou experts des sociétés

fusionnantes ou à des tiers

Aucun bénéfice ne sera, dans le cadre de la fusion, attribué aux administrateurs, réviseurs ou experts des sociétés

fusionnantes ou à des tiers.

h. Statuts de la Société Absorbante
Les Statuts de la Société Absorbante (les "Statuts") avec effet immédiat avant la Date Effective, jusqu'à modification

ultérieure, seront et demeureront les Statuts de la Société Absorbante à l'issue de la Fusion. Les Statuts sont joints au
présent projet en Annexe A.

i. Conseil d'administration et dirigeants
Le conseil d'administration de la Société Absorbante à la Date Effective restera le conseil d'administration de la Société

Absorbante après la fusion.

Tels administrateurs serviront en tant qu'administrateurs de la Société Absorbante jusqu'à la prochaine assemblée

générale des actionnaires de la Société Absorbante ou jusqu'au moment où leurs successeurs auront été dûment nommés
ou élus.

Les dirigeants de la Société Absorbante immédiatement avant la Date Effective resteront les dirigeants de la Société

Absorbante après la fusion. Tels dirigeants serviront en tant que dirigeants de la Société Absorbante jusqu'à la prochaine
assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante ou jusqu'au moment où leurs successeurs auront été
dûment nommés ou élus en vertu des Statuts de la Société Absorbante.

j. Les effets de la Fusion
Au  moment  de  la  Date  Effective,  la  Société  Absorbée  fusionnera  avec  la  Société  Absorbante,  laquelle  continuera

d'exister sous les lois de l'État du Michigan. L'existence et l'organisation sociale de la Société Absorbée cesseront au
moment de la Date Effective. Toute la propriété, qu'elle soit individuelle, intellectuelle, et mixte ainsi que toutes les dettes
dues, quels que soient les comptes, y compris les souscriptions de parts sociales et tous autres droits corporels, ainsi que
tous autres intérêts, qu'ils soient dus à ou dus par la Société Absorbante, seront transmis ou considérés comme étant
transmis et donnés à la Société Absorbante, cela sans qu'un acte supplémentaire ne soit nécessaire; les titres relatifs aux
biens immobiliers ou à la propriété intellectuelle, ou tout intérêt y relatif, de la Société Absorbée ne seront perdus,
diminués voire détériorés suite à la Fusion. Ni les droits des créanciers, ni les privilèges sur la propriété de la Société
Absorbé ne seront diminués du fait de la Fusion, et toutes les dettes, responsabilités et obligations de la Société Absorbée
seront de ce fait transmises à la Société Absorbante et pourront être réclamés à la Société Absorbante de la même
manière que si ces dettes, responsabilités et obligations avaient été encourues ou contractées par la Société Absorbante.
Toute plainte, action ou procédure existante, qu'elle soit de nature civile, pénale ou administrative, exercée par ou contre
la Société Absorbée, pourra être poursuivie par jugement ou ordre comme si la Fusion n'avait pas eu lieu, ou la Société
Absorbante pourra être remplacée à l'occasion de pareille action ou procès.

k. Effet de la Fusion sur l'emploi
La Fusion n'aura aucun impact sur le statut des employés, étant donné qu'aucune des sociétés fusionnantes n'a d'em-

ployés ou de filiales

l. Des informations sur l'évaluation de l'actif et du passif transférés à la Société Absorbante de plein droit
L'actif et le passif de la Société Absorbée qui seront acquis par la Société Absorbante seront évalués à leur valeur

comptable.

m. Les dates des comptes des sociétés fusionnantes aux fins d'établir conditions de la Fusion

er

 Janvier 2010.

n. Droits des créanciers des Sociétés fusionnantes
Les créanciers de la Société Absorbante et de la Société Absorbée peuvent exercer leurs droits conformément à

l'article 268 de la Loi. Pour plus d'informations, veuillez contacter le siège social de la Société Absorbante où de plus
amples renseignements peuvent être obtenus gratuitement. Les créanciers de la Société Absorbée peuvent gratuitement
obtenir des informations au siège social de la Société Absorbée.

18059

o. Assemblée générale des associés des sociétés fusionnantes
Il est proposé à Ford Motor Company, en sa qualité d'associé unique de chacune des sociétés fusionnantes, d'approuver

la Fusion proposée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de chacune des sociétés fusionnantes.
L'assemblée générale des associés de la Société Absorbante se tiendra devant un notaire luxembourgeois au plus tôt un
mois après la publication du projet commun de fusion transfrontalière.

p. Prise d'effet de la Fusion
En vertu de l'article 273ter de la Loi de 1915, la date effective de la Fusion (la "Date effective") sera la date de l'enre-

gistrement de la Fusion avec le Michigan Department of Labor and Economic Growth, Bureau of Commercial Services.

q. Annexes
Les annexes à ce formulaire de proposition font parties intégrantes de cette proposition.

Annex 1

ARTICLES OF INCORPORATION

OF

3000 SCHAEFFER ROAD COMPANY

These Articles of Incorporation are signed and acknowledged by the incorporator for the purpose of forming a cor-

poration for profit under the provisions of Act No. 327 of the Public Acts of 1931, as amended, known as the Michigan
General Corporation Act, as follows:

<i>First:

The name of the Corporation is 3000 SCHAEFER ROAD COMPANY.

<i>Second:

The purposes for which the Corporation is formed are:
To acquire by purchase, subscription, contract or otherwise, to hold for investment or otherwise, to sell, exchange,

mortgage pledge or otherwise dispose of or turn to account, and generally to deal in and with any and all kinds of securities
issued or created in any and all parts of the world by corporations, associations, partnerships, firms, trustees, syndicates,
individuals, governments, states, municipalities or other political or governmental divisions or subdivisions, or by any
combinations, organisations or entities whatsoever, irrespective of their form or the name by which they may be des-
cribed, and to issue in exchange therefor or in payment thereof, in any manner permitted by law and by these Articles
of Incorporation, its own securities of any kind, or to make payment there for by any other lawful means of payment
whatsoever to exercise any and rights, powers and privileges of individual ownership or interest in respect of any and all
such securities, including the right to vote thereon and to consent and otherwise act in respect thereto: to do any and
all acts and things for the preservation, protection, improvement and enhancement in value of any and all such securities,
and to aid by loan, subsidy, guaranty, or otherwise, these issuing, creating, or responsible for any such securities or
evidences of interest therein; to acquire or become interested in any such securities, as aforesaid, by original subscription,
underwriting, loan, participation in syndicates or otherwise, irrespective of whether or not such, securities by fully paid
or subject, to further payments: and to make payments thereon as called for or in advance of calls or otherwise, and to
underwrite or subscribe for the same conditionally or otherwise and either with a view to investment or for re-sale or
for any other lawful purpose. The term "securities" shall for the purposes of this Article, without limitation of the generality
thereof, he deemed to include any stocks, shares, hands, debentures, notes, mortgages or other obligations, and any
certificates, receipts or other instruments representing rights to receive, purchase or subscribe for the same, or repre-
senting any other rights or interests therein or in any property or assets.

To purchase, hold, cancel, reissue, sell, exchange, transfer or otherwise deal in its own securities, including shares of

Its capital stock of any class, from time to time to such an extent, and in such manner and upon such terms as the Board
of Directors shall determine; provided that this Corporation shall not use its funds or property for the purchase of its
own shares of capital stock when such, use would cause any impairment of its capital: and provided further that shares
of its own capital stock belonging to this Corporation shall not be voted upon directly or indirectly.

To apply for, obtain, purchase, lease or otherwise acquire, and to hold, use, own, operate, improve and introduce, and

to sell, assign, hypothecate, mortgage or otherwise dispose of, any letters patent, application for letters patent, licences
or grants in respect of letters patent, inventions, privileges, licenses, improvements, processes, trademarks and trade
names, copyrights, devices and formulae used in connection with, or secured under, letters patent of the United States
or elsewhere, or otherwise; and to use, exercise, develop, grant licenses in respect of, or otherwise turn to account any
such patents, applications for letters patent, licences, processes., inventions, improvements, devices, formulae, trade-
marks, copyrights and trade names, or the like, or any such property or rights, and to supervise or otherwise exercise
such control over its said licenses and the business conducted by them, as may be agreed upon in its contracts with such
licences for the protection of its rights in said patents, applications for letters patent, inventions, privileges, processes,
formulae, improvements, devices, trade-mark, copyrights and trade names and to secure to it the payment, of agreed
royalties, and to manufacture or deal in any article, product, or by-product, produced as the result or by the use of any

18060

such invention or process, or the like, or under any such patents, or any articles of any description used or suitable to
be used in connection therewith.

To take, purchase, lease, hire or otherwise acquire: to hold, own, occupy, use and enjoy: to manage, improve, develop,

operate and work; to grant, sell, let, lease, sub-lease, demise, exchange and otherwise dispose of and generally to deal,
in real estate, buildings and improvements and any and every right, interest or estate therein, without limit as to the cost,
amount, or value thereof and wheresoever the same may be situated, as well outside as within the State of Michigan; to
erect, construct, alter, repair, renew and equip buildings and other structures, and to make, enter into or assume any
and every kind of contract, agreement and obligation by or with any person, firm, association, or corporation for the
erection, construction, alteration, repair, renewal, equipment, improvement, development, use, enjoyment, leasing, ma-
nagement, operation or control of any buildings or structures of any kind whatever and wheresoever the same may be
situated.

To acquire by purchase, exchange or otherwise, all, or any part of, or any interest in, the properties, assets, business

and good will of any one or more persons, firms, associations, corporations or syndicates; to pay for the same in cash,
property or its own or other securities; to hold, operate, reorganise, liquidate, sell or or in any manner dispose of the
whole or any part thereof; and in connection therewith, to assume or guarantee performance, of any liabilities, obligations
or contracts of such persons, firms, associations, corporations or syndicates, and to conduct in any lawful wanner the
whole or any part of any business thus acquired.

To cause to be formed, merged, consolidated, reorganized or liquidated, and to promote, take charge of and aid in

any way permitted by law, the formation, merger, consolidation, liquidation or reorganisation of any corporation, asso-
ciation, syndicate or organization of any kind, domestic or foreign, and to form, organize, promote, manage, control and
maintain and dissolve, merge or consolidate one or more corporations in any of the securities of which this corporation
may be or become interested.

To organize or cause to he organized under the laws of any state, district, territory, nation, colony, province or

government, a corporation or corporations for the purpose of accomplishing any or all of the objects for which this
Corporation is organized, and to dissolve, wind up, liquidate, merge or consolidate any such corporation or corporations
or to cause the same to be dissolved, wound up, liquidated, merged or consolidated.

To borrow money for any of the purposes of this Corporation, from time to time, and without limit as to amount; to

issue and sell its own securities in such amounts, on such terms and conditions, for such purposes and for such prices,
as the Board of Directors may determine: and to secure such securities, to the extent now or hereafter permitted by
the laws of the State of Michigan and by these Articles of Incorporation, by mortgage upon, or the pledge of, or the
conveyance or assignment in trust of, the whole or any part of the properties, assets, business and good will of this
Corporation, then owned or thereafter acquired.

To lend its uninvested funds from time to time to such extent and to such persons, firms, associations, corporations,

syndicates, governments of subdivisions thereof, and on such terms and on such security, if any, as the Board of Directors
may determine.

To promote or aid it any manner, financially or otherwise, any corporation, association, partnership, firm, trustee,

syndicate, individual, government or political subdivision thereof, in which this Corporation may be or become interested,
directly or indirectly, and for this purpose, to endorse or guarantee the payment of principal, or interest upon, and to
guarantee the performance of sinking fund or other obligations, of any securities, and to guarantee in any way permitted
by law the performance of any of the contracts or other undertakings incurred by said entities.

To manufacture, purchase, or otherwise acquire, own, mortgage, pledge, sell, assign and transfer, or otherwise dispose

of, to invest, trade, deal in and deal with goods, wares and merchandise and real and personal property of every class and
description.

To enter into co-partnerships and joint agreements with any other corporation or corporations, individual or indivi-

duals and/or co-partnerships, firms or associations of any kind and description, for the purpose of and through, which to
acquire any property, conduct any business and do any act or thing which this corporation is authorised to do by virtue
of these Articles of Incorporation.

To enter into, make and perform contracts of every kind and description with any person, firm, association or cor-

poration, municipality, body politic, country, territory, state, government or colony or dependency thereof.

To carry out all or any of the foregoing objects and purposes in the State of Michigan and in any other country, state

or locality, as principal, agent, factor or broker and alone or with associates as a member of, or as the owner or holder
of any stock of, or any shares or interest in, any firm, association, trust, corporation or syndicate, and to conduct its
business in all of its branches without restrictions or limit us to extent and to have have or more offices out of the State
of Michigan.

To do, in the State of Michigan and in any other country, state or locality, all and everything necessary, suitable,

convenient or proper for the accomplishment of any of the purposes or attainment of any one or more of the objects
herein enumerated or incidental to the powers herein specified or which shall at any time appear conducive to or ex-
pedient to the accomplishment of any of the purposes or attainment of any of the objects herein enumerated, or which
may be exercised or done by this Corporation, whether conferred by any present or future statute, or by these Articles
of Incorporation or any amendment thereof, or by the By-Laws of this Corporation or any amendment thereof, and to

18061

the same extent as a natural person might or could do in any part of the world. In so far as the same are not inconsistent
with the laws of the State of Michigan or with the laws of the country, state or locality where the same shall he done by
this Corporation and to execute from time to time such general or special powers of attorney, and to such persons as
the Board of Directors may approve, granting to such persons all powers, either in the United states of America or in
any other country, state or locality which the Board of Directors may been proper, and to revoke such powers of attorney
as and when the Board of Directors may desire.

The objects and purposes set forth it the foregoing clauses of this Article Second shall not, unless otherwise specified

herein, be in any wise limited or restricted by reference to, or inference from, the terms of any other clause of this or
any other article in these Articles of Incorporation, but the objects and purposes specified in each of said clauses shall be
regarded as independent objects and purposes.

The foregoing clauses shall be construed as powers as well as objects and purposes, and the foregoing enumeration

of specific powers shall not be held to limit or restrict in any manner the general powers of this Corporation: and generally
this Corporation shall be authorized to exercise and enjoy all other powers, rights and privileges granted by the laws of
the State of Michigan, now or hereafter in effect, to corporations of the character of this Corporation; provided, however,
that this Corporation shall not in any state, territory, or country, carry on any business, of exercise any powers, whether
herein enumerated or not, which a corporation organized under the laws of said state, territory, or country, could, not
carry on or exercise, except to the extent, permitted or authorized by the laws of said state, territory or country; and
all other provisions of this Article Second are subject to the provisions of this paragraph.

<i>Third:

The registered office of the Company in the State of Michigan is to be located at: c/o The Corporation Company;

30600 Telegraph Road, Suite 2345; Bingham Farms, MI 48025.

<i>Fourth:

The total number of shares of capital stock which the Corporation shall have the authority to issue is five hundred

fifty-five thousand seven hundred -and fifty (555,750) shares, consisting of two hundred seventy thousand seven hundred
and fifty (270,750) shares of preferred stock of the par value of one hundred dollars ($100) each, and two hundred eighty-
five thousand (285,000) shares of common stock of the par value of five dollars ($5) each.

The designations and the powers, preferences, and rights, and the qualifications, limitations, or restrictions, of the

preferred stock and common stock of the Corporation are as follows:

<i>General

Each Stockholder shall be entitled to vote at any meeting of Stockholders, for the election of Directors or upon any

other question which may come before such meeting, and shall have the right to cast, in person or by proxy, one (1) vote
for each share of common stock standing in his name anon the books of the corporation, and nineteen (19) vote for each
share of preferred stock standing in his name upon the books of the Corporation.

At all elections of Directors, each Stockholder shall be entitled to as many votes as shall equal the number of Directors

to be elected, multiplied, by the number of votes to which he is entitled by stock ownership under the previsions of this
Article, and shall be permitted to distribute such votes as he pleases among the candidates or to cast them all for one
candidate if he chooses and these persons receiving the highest number of votes so cast, shall be declared elected Di-
rectors; provided, however, that at any election of Directors, the common stockholders shall in any event he entitled to
elect at least one Director, and at all times shall have the right to have on the Board of Directors at least one Director
elected or designated by the common stockholders.

The redemption of all or any part of the preferred stock, the voluntary liquidation, dissolution, or winding up of the

Corporation, and the amendment, alteration, or modification, of any provision of the Articles of incorporation, shall each
require  the  consent  of  the  holders  of  at  least  two-thirds  (2/3)  of  each  class  of  the  outstanding  capital  stock  of  the
Corporation given at a meeting duly called and held: provided, however, that the preferred shares and common shares
of stock shall be subject to the issuance by the Corporation of any additional shares of preferred stock (par-value one
hundred dollars ($100) and full-paid and non-assessable), which may he required no be issued by the Corporation under
any agreement which it may enter into with the parent of Shares Co., Inc. (the term "parent'" of Shares Co., Inc., wherever
need in these Articles of Incorporation, means that certain corporation, which, shall control the voting stock of Shares
Co., Inc. as of the date of the filing of these Articles of Incorporation and shall continue to have such meaning during the
life of this Corporation, whether or not such certain corporation shall continue to control the voting stock of Shares
Co., Inc., and whether or not, Shares Co,, Inc. shall continue its existence throughout such period.) pursuant to a certain
ruling of the Commissioner of Internal Revenue relating to said parent dated July 6, 1948, such additional shares to be
identical in all respects with the shares of presently authorised preferred stock of the Corporation; and every holder of
preferred shares and common shares of the Corporation shall be deemed to have consented to the authorization and
issuance of such additional shares of stock to the parent of Shares Co., Inc.. as, and when, such issuance nay be required.

18062

<i>Preferred stock

(1) Dividend Preference - The holders of the preferred stock shall be entitled to receive, in preference to the holders

of the common stock, with respect to each fiscal year, out of net profits of the Corporation for such year available for
dividends under the laws of the State of Michigan, (or from earned, surplus in the case of any cumulative dividend herei-
nafter provided for), preferential dividends, if, when, and as, declared by the Directors, of five dollars ($5) a share, per
annum, payable at such periods as shall be fixed by the Directors: and after the payment of a dividend of one dollar ($1)
a share, per annum, on the common stock, shall be entitled to participate as hereinafter provided, in any additional
dividends declared by the Directors.

Such preferential, dividends on the preferred stock shall be noncumulative, and the holders of the preferred stork shall

have no right or claim with respect to such preferential dividends (unless the same shall have been declared, by the Board
of Directors), except with respect to any fiscal year of the Corporation in which the Corporation shall have had net
profits, available for dividends tinder the laws of the state of Michigan, in an amount sufficient to pay such dividends, or
in which the parent of Shares Co,, Inc. shall have had net profits, available for dividends in an amount which, if distributed
as dividends, would have resulted in the realization by the Corporation of net profits, available for dividends under such
laws, in an amount sufficient to pay such dividends on its preferred shares. In any such event, the preferential dividends
or, the preferred stock of the Corporation for any such year shall he cumulative, so that if for any such year the same
shall not have been declared, the right thereto shall accumulate as against the shares of common stock of the Corporation,
and all arrears so accumulated shall be paid to the holders of the preferred stock of the Corporation before any dividends
shall be paid upon the common stock. Accumulated preferential dividends on the preferred stock shall not bear interest.

No dividend in excess of the sum above specified shall be declared or paid on said preferred stock of the Corporation

with respect to any fiscal, year unless and until a dividend at the rate of one dollar ($1) per share shall have been declared
and paid with respect to such fiscal year upon each outstanding share of common stock.

After the payment, with respect to any year, of all preferential dividends (current or accumulated) upon each of the

outstanding shares of preferred stock and the payment of an amount equal, to one dollar ($1) upon each, of the outstanding
shares of common stock (as hereinafter provided), the then outstanding preferred shares and common shares of the the
Corporation shall be entitled to participate in any further dividends declared by the Directors, out of the remaining net
profits of the Corporation, if any, available for dividends under the laws of the State of Michigan, or out of any earned
surplus of the Corporation, in the ratio of the comparative aggregate par values of such preferred shares and common
shares, respectively. Such participating dividend, rights shall not be cumulative, and the failure of the Directors, to declare
any such dividends shall not prevent the Corporation from using any such excess net profits or earned surplus or any
part thereof for any other purpose, including, without limitation, the redemption of the Corporation's then outstanding
shares of preferred stock.

(2) Assets Preference - In the event of any liquidation, dissolution, or winding up, whether voluntary or involuntary,

of the Corporation, the holders of its preferred stock shall be entitled to be paid out of the assets of the Corporation
the sum of one hundred ten dollars ($110) per share and an amount equal to unpaid accumulated dividends thereon, if
any, before any amount shall be paid to the holders of any other class of stock; but in no event snail the holders of the
preferred stock be entitled to receive any other or further payment out of such assets.

(3) Redemption - The outstanding shares of preferred stock, or any part thereof, may be called for redemption at any

time and from time to time, if the Stockholders, by action taken at any Stockholders meeting, shall so direct, at one
hundred ten dollars ($110) per share, plus unpaid accumulated dividends, if any, upon sixty (60) days' notice by mail to
the holders of record thereof. If less than all of the outstanding shares of preferred stock are to be redeemed, the shares
to be redeemed shall be selected by lot in such manner as the board of Directors shall determine. On and after such
redemption date, each holder of shares of preferred stock so called for redemption shall be entitled to receive payment
of the redemption price of such shares (without interest) upon surrender to the Corporation, at the price designed in
such redemption notice, of the certificate or certificates therefor, duly endorsed in blank or accompanied by proper
instruments of assignment and transfer; and on and after the redemption date (unless default shall be made by the Cor-
poration in the payment of the redemption price), the shares of stock so called for redemption shall cease to be entitled
to any dividends, interest, on right, in the Corporation, and shall only be entitled to the amount of the redemption price,
plus accumulated dividends, if any, to the redemption date. Upon redemption by the Corporation of any preferred stock,
the Corporation shall forthwith retire and cancel all of the stock so redeemed.

<i>Common stock

(1) Dividends - The holders of the common stock shall he entitled to receive, with respect to each fiscal year, out of

net profits of the Corporation for such fiscal year, available for dividends, under the laws of the State of Michigan, or
earned surplus, remaining after the payment of all preferential dividends (current or accumulated) payable upon the shares
of preferred stock (as hereinbefore provided), noncumulative dividends, if, when, and as, declared by the Directors, up
to an aggregate amount not in excess of one dollar ($1) a share on the then outstanding common stock.

After the payment with respect to any year of all preferential dividends (current or or accumulated) upon each of the

outstanding shares of preferred stock and the payment of an amount equal to one dollar ($1) upon each of the outstanding
shares of common stock (as hereinbefore provided), the then outstanding preferred shares and common shares of the

18063

Corporation shall be entitled to participate in any further dividends declared by the Directors, out of the remaining net
profits of the Corporation, if any, available for dividends under the laws of the State of Michigan, or any earned surplus
of the Corporation, in the ratio of art comparative aggregate par values of such preferred shares and common shares,
respectively.

(2) Distribution of Assets - In the event of any liquidation, dissolution, or winding up, whether voluntary or involuntary,

of the Corporation, Shares Co., Inc., is hereby granted the right (which right shall be assignable to the parent of Shares
Co., Inc.) to purchase at the cash value of such shares (calculated in the manner provided in the next succeeding section
for the valuation of such shares in connection with the purchase of common stock of the Corporation) all, or any part,
of the shares of the parent of Shares Co., Inc. then held by the Corporation; and thereafter, after there shall have been
paid to or set aside for the holders of the shares of preferred stock the full preferential amounts to which, such shares
are entitled, the holders of shares of common stock shall be entitled to receive pro rata distribution, upon the shares
held by them, of all remaining assets of the Corporation available for distribution to its stockholders.

(3) Restrictions on Transfer - The sale, transfer (including any transfer by operation of law), pledge, hypothecation, or

other disposition of, or encumbrance upon, shares of common stock of the Corporation by or from any person other
than Shares Co., Inc., or its parent, shall be subject to the following restrictions and limitations:

In the event (a) that any holder, or the executor or administrator or other legal representative of any deceased holder,

or any pledgee or other lienor, or such shares of common stock shall for any reason desire to sell, transfer, pledge,
hypothecate, or otherwise dispose of or encumber, any of such shares, at any time or from time to time, he shall notify
the parent of Shares Co., Inc., in writing of his desire to do so; (b) that any holder of such shares shall cease for any reason
to be an employee of the parent of Shares Co., Inc.; (c) of any sale, transfer (other than by operation of law) pledge,
hypothecation, or other disposition of or encumbrance upon, any such shares by any person other than Shares Co., Inc.
or its parent without prior written notice thereof to the parent of Shares Co., Inc.; or (d) of a transfer by operation of
law, then and in any such event, Shares Co., Inc., is hereby granted the right (which right shall, be assignable to the parent
of Shares Co., Inc.) at any time within ninety (90) days after the receipt of such notice, after such termination of em-
ployment, or after the receipt by Shares Co., Inc. of subsequent written notice of any such sale, transfer (by operation
of law, or otherwise), pledge, hypothecation, or other disposition or encumbrance, as the case may be, to purchase such
shares at a price per share which shall be equal to the sum to which each such share of common stock would be entitled
upon liquidation in cash of the corporation as of the last day of the fiscal year immediately preceding, (1) the date of
receipt of such notice of desire to sell, transfer, pledge, hypothecate, or otherwise dispose of or encumber, such shares,
(2) the date of such cessation of employment, or (3) the date of such sale, transfer (by operation of law, or otherwise),
pledge, hypothecation, or other disposition or encumbrance, as the case may be.

For this purpose, the cash value of each share of the parent of Share Co., Inc., held by the Corporation shall be

conclusively determined by the independent public accountants who shall then be auditing the books of the parent of
Shares Co., Inc., who shall determine such value as an amount equal to the sum of:

(a)  One  fourth  (1/4)  of  the  consolidated  net  asset  value  per  share  of  said  stock,  which  shall  be  the  value  of  the

consolidated net assets of the parent of Shares Co., Inc. (without allowance for good will) per share, less its liabilities
(including, without limitation, reserves other than surplus reserves) per share, as such assets and liabilities shall appear
from the books of the parent of Shares Co., Inc., and its consolidated subsidiaries as of the last day of such fiscal year;
plus

(b) Three-fourths (3/4) of the consolidated net earning-power value per share of said stock, capitalized at twelve and

one-half percent (12-1/2%); i.e., multiplied by eight (8); such earning power value per share shall be determined as the
average of the annual consolidated net income of the parent of Shares Co., Inc. per share, after all taxes, as such net
income shall appear from the books of the parent of Snares Co., Inc. and. its consolidated subsidiaries for the five (5)
years immediately preceding the last day of such fiscal year; plus

(c) An amount determined by dividing the aggregate redemption value of such additional shares of preferred stock of

the Corporation as may have been required to be issued by the Corporation (under any agreement which may be entered
into with the parent of Shares Co., Inc. pursuant to ruling of the Commissioner of Internal Revenue, relating to said parent
dated July 6, 1948), by a number equal to the total number of shares of such stock of the parent of Shares Co., Inc. held
by the Corporation.

For the purpose, of the foregoing, calculation, the bocks of the parent of Shares Co., Inc. and its consolidated subsi-

diaries shall be conclusive. The method of and principles governing consolidation shall be these employed by the parent
of Shares Co., Inc. in preparing the then last previous annual report to its Stockholders, including, without limitation,
appropriate provision for taxes both foreign and domestic which might be incurred in remitting income of the consolidated
subsidiaries to the parent of Shares Co., Inc. The decisions of the independent public accountants of the parent of Shares
Co., Inc. as to procedures to he adopted in maintaining the books of the parent of Shares Co., Inc. and its subsidiaries,
the preparation of balance sheets and income statements and in the determination of consolidated net income, the method
of and adjustments made in consolidation, the treatment of reserves as liabilities or net worth, and all matters of accounting
practice and procedure shall at all times and from time to time be conclusive.

In the event (a) of any sale, transfer (other than by operation, of law), pledge, hypothecation., or other disposition of

or encumbrance upon, any such shares by any person other than Shares Co., Inc., or its parent without prior written

18064

notice thereof to the parent of Shares Co., Inc., (b) of a transfer by operation of law, without written notice to the parent
of Shares Co., Inc. within at least thirty (30) days after such transfer, or (c) written notice shall have been given to the
parent of Shares Co., Inc.. of a proposed sale, transfer, pledge, hypothecation, or other disposition of or encumbrance
upon, such shares, but such transaction shall have been effected prior to the expiration of ninety (90) days after the receipt
of such notice, then and in any such event, the vendee, transferee, pledgee, lienor, legatee, executor, administrator, or
other personal representative, or any other person claiming any right, title, or interest in any such shares, by or through
any such transaction or event, shall not be entitled, as a stockholder or otherwise, to any right with respect to such
shares, excepting (a) the right no sell all of such shares to Shares Co., Inc. or its parent, and to receive therefor a price
per share in an amount computed as provided in this Section 3 of Article Fourth, relating to the grant of the right of
Shares Co., Inc. to purchase shares of common stock of the Corporation; and (c) the right to receive any dividends
declared but unpaid on such shares prior to the date of such transfer. In the event of such transfer, Shares Co., Inc., or
its  parent  as  its  assignee,  in  addition  to  all  other  rights  which  it  may  have  under  these  Articles  of  Incorporation  or
otherwise, shall be entitled to collect from either the transferred or the transferee, or both, the amount of any dividends
paid upon such stock subsequent to the date of such transfer, and prior to the receipt try the parent of Shares Co., Inc.,
of written notice thereof.

Any failure in any case by Shares Co., Inc., or its parent as its assignee to exercise its right to purchase any shares of

the common stock of the Corporation shall not constitute a waiver of such right or of the foregoing restrictions and
limitations, in connection with any subsequent transaction, either with respect to the same shares or with respect to any
other shares, in the hands of any person.

The minimum amount of capital with which the Corporation will commerce, business is one thousand, dollars ($1,000).

<i>Fifth:

The name and place of residence or business of the incorporator are as follows:

Name

Residence or

Number of Shares Subscribed

Business Address

Preferred

Common

George B. Mullin

29090 Morlock

Farmington, Michigan

10

<i>Sixth:

The names and addresses of the first Board of Directors are as follows:

Name

Address

George. B. Mullin

29090 Morlock Farmington, Michigan

Henry G. Canda, Jr.

1638 Dime Building Detroit, Michigan

M. A. Capoferi

1638 Dime Building Detroit, Michigan

<i>Seventh:

The term of the Corporation's existence is perpetual.

<i>Eighth:

The  private  property  of  the  Stockholders  shall  not  be  subject  to  the  payment,  of  corporate  debts  to  any  extent

whatever, except, as otherwise provided by the laws of the State of Michigan.

<i>Ninth:

The business of the corporation shall be managed by the Board of Directors except as may be otherwise provided in

these Articles of Incorporation or By-Laws as from time to time amended. In furtherance and not in limitation of the
general powers conferred by the laws of the State of Michigan the hoard of Directors is expressly authorised:

To make, alter, or repeal, the By-Laws of the Corporation, except as such power is limited by one or more By-Laws

of the Corporation made by the Stockholders; to fix the amount to be reserved as or for working capital or for any other
proper purpose; to fund such reserve or reserves and to abolish such reserve or reserves, fund or funds, or any part
thereof; to authorize and cause to be executed mortgages and liens upon the real and personal property of the Corpo-
ration, subject, however, to approval of the Stockholders in such cases as may be required by Michigan law.

From time to time to determine pursuant to the provisions of the By-Laws, whether and to what extent, and at what

times and places, and under what conditions and regulations, the accounts and books of the Corporation, or any of them,
shall be open to inspection of Stockholders; and no Stockholder shall have any right of inspecting any account, book or
document of the Corporation except as conferred by statute, unless duly authorised to do so by a resolution of a majority
of the stockholders or of the Directors.

Subject to the provisions of the statutes of Michigan to exercise any and all other cowers in addition to the powers

expressly conferred by law and by these Articles of Incorporation, which may be conferred upon it by the Corporation
through appropriate By-Law provisions.

18065

<i>Tenth:

The Corporation may enter into contracts and otherwise transact business as vendor, purchaser, or otherwise, with

its Directors, Officers, and Stockholders, and with corporations, joint stock companies, trusts, firms, and associations, in
which they are or may be, or become, interested as director's, officers, shareholders, members, trustees, beneficiaries,
or otherwise, as freely as though such adverse interest did not exist even though the vote, action or presence of such
director, officer, or stockholder, may be necessary to obligate the Corporation upon such contract or transaction; and
no such: contract or transaction shall, be avoided, and no such director, officer, or stockholder, shall be held liable to
account to the Corporation or to any creditor or Stockholder of the Corporation for any profit or benefit realized by
him, directly or indirectly, through any such contract or transaction, by reason of such adverse interest now by reason
of any fiduciary relationship of such director, officer, or stockholder, to the Corporation arising out of such office or
stock ownership.

Ownership or beneficial interest in a minority of the stock or securities of another corporation, joint stock company,

trust, firm, or association, shall not be deemed to constitute an interest adverse no this Corporation in such other
corporation, joint stock company, trust, firm, or association. The authorizing or ratifying vote of a majority of the capital
stock of the Corporation outstanding and entitled to vote passed at a meeting duly called and held for the purpose shall
validate any such contract or transaction as against all Stockholders of the Corporation, whether of record or not at the
time of such vote, and as against all creditors and other claimants, under the Corporation and no contract or transaction
shall be avoided by reason of any provisions of this Article Tenth which would be valid but for these provisions.

<i>Eleventh:

Elections of Directors need not be by ballot, unless any meeting of Stockholders called for the purpose of electing

Directors shall by resolution of a majority of Stockholders present vote otherwise.

<i>Twelfth:

Except as may be otherwise expressly provided in these Articles of Incorporation as from time to time amended, no

Stockholder shall have any pre-emptive right to subscribe to any issue of stock of the Corporation whether now or
hereafter authorized or to any issue of any obligations on the Corporation convertible into stock of the Corporation,
for whatever consideration the same may be issued, whether or not such additional stock or obligations are offered to
any other holders of stock or obligations of the Corporation.

<i>Thirteenth:

The Stockholders and Directors shall have power to hold their meetings if the By-Laws so provide, and keep the books

except the original or duplicate stock ledger, documents, and papers, of the Corporation, outside of the State of Michigan,
and to have one or more offices within or without the State of Michigan, at such places as may be from time to time
designated by the By-Laws or by resolution of the Stockholders or Directors, except as otherwise required by the laws
of Michigan.

<i>Fourteenth:

Whenever a compromise or arrangement or any plan of reorganisation of this Corporation is proposed between this

Corporation and its creditors or any class of their, and/or between this Corporation and its Shareholders or any class
of them, any court of equity jurisdiction within the State of Michigan, may on the application of this Corporation or of
any creditor or any Shareholder thereof, or on the application of any receiver or receivers appointed for this Corporation,
order a meeting of the creditors or class of creditors, and/or of the Shareholders or class of Shareholders, as the case
may be, to be affected by the proposed compromise or arrangement on reorganization, to be summoned in such manner
as said court directs. If a majority in number representing three-fourths (3/4) in value of the creditors or class of creditors,
and/or of the Shareholders or class of Shareholders, as the ease may be, to be affected by the proposed compromise or
arrangement or reorganisation, agree to any compromise, or arrangement or to any reorganization of this Corporation
as a consequence of such compromise or arrangement, said compromise or arrangement and said reorganization shall,
if sanctioned by the court to which the said application has been made, be binding on all the creditors or class of creditors,
and/or on all the Shareholders or class of Shareholders, as the case may be, and also on this Corporation.

IN WITNESS WHEREOF in the incorporator has signed these Articles of Incorporation this 23 

rd

 day of September,

A. D. 1948.

S/d George B. Mullin (L.S.).

STATE OF MICHIGAN
COUNTY OF INGHAM
SS.
On this 23 

rd

 day of September, A.D. 1948, before me a notary public in and for said county, personally appeared

George B. Mullin, known to me to be the person named in, and who executed the foregoing instrument, and acknowledged
that he executed the same freely and for the Intents and purposes therein mentioned.

18066

My Commission Expires May 22, 1949

S/d Vernita Easton
<i>Notary Public

Référence de publication: 2010018709/643.
(100025097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2010.

Racine Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.298.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010 

 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015563/795/15.

Petrus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 55.363.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mars 2010 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2008 et 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010015564/795/15.

Star Group S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 63.756.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010  à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2009.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016320/1023/18.

18067

Defibresil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 125.382.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010  à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2009.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016322/1023/16.

Business Management Group Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 59.384.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>March 1, 2010 at 13.15 p.m.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2009 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending December 31, 2009.

4. Miscellaneous.

<i>THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2010016323/1023/16.

Nomura U.S. High Yield Bond Income, Fonds Commun de Placement.

L'acte modificatif au règlement de gestion au 26 février 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Global Funds Management S.A.
Signature

Référence de publication: 2010016298/9.
(100013848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

PO Invest 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 115.493.

L'an deux mille neuf, le premier février 2010.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et des porteurs de parts bénéficiaires de la société

anonyme PO Invest 1 S.A., ayant son siège social au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.493, constituée selon acte reçu par Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1215 en date du 22 juin 2006, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 5 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1376
en date du 16 juillet 2009 (la "Société").

18068

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Melle Laura GEHLKOPF, employée, ayant son adresse professionnelle

au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15,

côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rachel UHL, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Tous les actionnaires et porteurs de parts bénéficiaires ont été dûment convoqués et ont connaissance de l'ordre

du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Les actionnaires et autres porteurs de parts bénéficiaires présents ou représentés et le nombre d'actions ou titres

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire
soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des quatre mille quatre cents (4.400) actions de catégorie A

et la totalité des deux mille six cents (2.600) actions de catégorie B, toutes d'une valeur nominale de mille Euro (EUR
1.000,-)  chacune,  représentant  ensemble  l'intégralité  du  capital  social  actuellement  fixé  à  sept  millions  d'Euro  (EUR
7.000.000,-), ainsi que la totalité des quatre mille quatre cents (4.400) parts bénéficiaires sans désignation de valeur et
jouissant du même droit de vote que les actions représentatives du capital social, sont présentes ou représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Modification de l'alinéa 2 de article 3 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
"Sauf dispositions contraires d'un pacte conclu entre les actionnaires (le "Pacte d'Actionnaires"), toutes les actions ont

les mêmes droits et obligations quelle que soit la catégorie.";

2. Suppression de l'article 4 des statuts de la Société;
3. Renumérotation subséquente des articles suivants l'article supprimé.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'alinéa 2 de article 3 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur

suivante:

"Sauf dispositions contraires d'un pacte conclu entre les actionnaires (le "Pacte d'Actionnaires"), toutes les actions ont

les mêmes droits et obligations quelle que soit la catégorie."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'article 4 des statuts de la Société.

<i>Troisième résolution

Subséquemment aux résolutions précédentes, l'assemblée décide de renuméroter les articles suivants l'article 4 sup-

primé, de l'article quatre (4) à treize (13).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge, à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille Euro (EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, statut et demeure, les membres du

bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. GEHLKOPF, H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 février 2010. Relation: LAC/2010/5477. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 février 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010018401/66.
(100023705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2010.

18069

Blatteus S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 36.120.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>2 mars 2010 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2009.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016324/1023/16.

Agaka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 127.350.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> mars 2010  à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2009.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010016325/1023/16.

DZ PB, Société Anonyme,

(anc. DZ Private Wealth Managementgesellschaft).

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 133.555.

Im Jahre zweitausendundzehn, am zwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,
ist  zu  einer  außerordentlichen  Generalversammlung  (die  Versammlung)  erschienen,  die  DZ  BANK  AG  Deutsche

Zentral-Genossenschaftsbank,  Frankfurt  am  Main,  eine  Aktiengesellschaft  deutschen  Rechts,  mit  Gesellschaftssitz  in
D-60265 Frankfurt am Main, Platz der Republik, eingetragen im Handelsregister des Registergerichts Frankfurt am Main,
Hessen, unter der Nummer HRB 45651 (der Alleinige Aktionär), alleiniger Aktionär der Aktiengesellschaft DZ Private
Wealth Managementgesellschaft, mit Sitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 133.555 (hiernach "die Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde,
aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 8. November 2007, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 2877 vom 11. Dezember 2007.

Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. Dezember 2007, veröffentlicht

im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 484 vom 26. Februar 2008.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Klaus-Peter Bräuer, Bankangestellter, beruflich ansässig in Strassen, 4, rue

Thomas Edison,

welcher Frau Petra Gören, Bankangestellte, beruflich ansässig in Strassen, 4, rue Thomas Edison, zur Schriftführerin

bestellt.

Die Versammlung bestimmt zur Stimmenzählerin Frau Johanna Sandvoß, Bankangestellte, beruflich ansässig in Strassen,

4, rue Thomas Edison

18070

(der Vorsitzende, die Schriftführerin und die Stimmenzählerin bilden das "Büro" der Versammlung).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass der Alleinige Aktionär in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder

rechtlich vertreten ist; diese Anwesenheitsliste wurde vom Aktieninhaber beziehungsweise dessen Vertreter sowie von
den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit der-
selben einregistriert zu werden.

Ebenso bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß

durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar "ne varietur" paraphierte Vollmacht des vertretenen
Alleinigen Aktionärs.

II.  In  Anbetracht  der  Anwesenheit  beziehungsweise  Vertretung  des  Aktieninhabers  ist  die  Generalversammlung

regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten.
2. Änderung der Satzung

Art. 1. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "DZ PB" (die Gesellschaft).

Art. 15. ... Sobald jedoch mindestens ein Geschäftsführer benannt wird, der nicht Verwaltungsratsmitglied ist, ist eine

Geschäftsordnung für Geschäftsführer zwingend erforderlich. Diese wird vom Verwaltungsrat verabschiedet.

Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende

Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Versammlung vertreten ist, verzichtet die Ver-

sammlung auf die Frist- und Einberufungsformalitäten; der Alleinige Aktionär betrachtet sich als ordnungsgemäß einbe-
rufen und bestätigt, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihm im Voraus übermittelt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft in "DZ PB" abzuändern.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den ersten Absatz von Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 1. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "DZ PB" (die Gesell-

schaft)."

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 15 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann,

unter Berücksichtigung von Artikel 8 c) der Satzung, eine oder mehrere Personen als Geschäftsführer benennen (délégué
à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht
hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betref-
fen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen. Sobald jedoch
mindestens ein Geschäftsführer benannt wird, der nicht Verwaltungsratsmitglied ist, ist eine Geschäftsordnung für Ge-
schäftsführer  zwingend  erforderlich.  Diese  wird  vom  Verwaltungsrat  verabschiedet.  Der  Verwaltungsrat  kann  die
Geschäftsführer jederzeit abberufen.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Ver-

waltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Ferner kann der Verwaltungsrat die Mitglieder eines Beirats benennen, dessen Aufgaben und Befugnisse, durch den

Verwaltungsrat geregelt werden."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER PROTOKOLL, aufgenommen in Luxemburg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: K.-P. BRÄUER, P. GÖREN, J. SANDVOß und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., 26 janvier 2010. Relation: LAC/2010/3825. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

18071

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 3. Februar 2010.

Référence de publication: 2010018625/80.
(100017520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2010.

Trustcapital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.

R.C.S. Luxembourg B 39.680.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010018030/10.
(100012241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

352 Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.

R.C.S. Luxembourg B 74.803.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010018031/10.
(100012240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Luxriviera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 97.586.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010018032/9.
(100012237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Matsip Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 107.063.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22.01.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010017997/10.
(100011939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

TransArdenna S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R.C.S. Luxembourg B 52.065.

Les comptes annuels au 31 juillet 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010017998/10.
(100011785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

18072

Immobilière et Commerciale Graas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 12.853.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018001/10.
(100011782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Café Number 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 87.839.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018055/10.
(100012350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Dorsol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 87.881.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018056/10.
(100012393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Uniker Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 52.303.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018057/10.
(100012391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010018067/14.
(100011864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

18073

Atlantis Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 143.051.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018058/10.
(100012390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Madras Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 109.360.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018059/10.
(100012389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Deutsche Finanz A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 108.028.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018060/10.
(100012388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Lindner Isoliertechnik GmbH, Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5560 Remich, 11, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 116.728.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018063/10.
(100012427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.587.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010018068/14.
(100011860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

18074

Malux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 132, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 86.424.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018062/10.
(100012413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Peinture Baranowsky S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 52, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 117.800.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018064/10.
(100012419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

H + A Montage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6850 Manternach, 3, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 75.578.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018065/10.
(100012417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Frank Kienel S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 30, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 101.111.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018066/10.
(100012416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 115.142.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010018069/14.
(100011858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

18075

BEBAU Swiss Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 120.567.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 Janvier 2010.

Christophe Gammal
<i>Manager

Référence de publication: 2010018061/12.
(100012415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 115.154.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010018070/14.
(100011856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 115.138.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010018071/14.
(100011853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

ProLogis Czech Republic XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 108.472.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010018072/14.
(100011851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

18076

Georue 2, Société Anonyme.

Siège social: L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé.

R.C.S. Luxembourg B 150.727.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1. La société à responsabilité limitée "GEOFINANCE", établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42.582.

2. Madame Tessy GOEDERT, pharmacienne, née à Luxembourg, le 11 mai 1969, demeurant à L-2522 Luxembourg,

12, rue Guillaume Schneider.

Les deux sont ici représentées par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles
procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte

constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "GEORUE 2" (ci-après la "Société"), régie par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la commune de Mamer. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la

commune par simple décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente,

échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger,
ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.

Elle  a  également  pour  objet  l'aliénation  de  participations,  de  quelque  manière  que  ce  soit,  dans  d'autres  sociétés

luxembourgeoises et/ou étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles
elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 4.000 (quatre mille) actions d'une

valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions de la Société seront exclusivement émises sous forme nominative.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les actions entre ses seules mains, la Société est une société

anonyme unipersonnelle au sens de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à

18077

directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle. Lorsque la Société ne comporte qu'une seule
personne, celle-ci est dénommée "associé unique". La Société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi
que par réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la
dissolution de la Société.

Art. 6. Transmission des actions
6.1. Droit de préemption
Toute cession ou transfert de propriété d'actions, même entre actionnaires, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux,

est soumise au droit de préemption des autres actionnaires dans les conditions ci-après.

Tout actionnaire de la Société qui désire transférer tout ou partie de ses actions de la Société notifiera son intention,

par lettre recommandée avec accusé de réception, au Conseil d'Administration qui le notifiera immédiatement, aux autres
actionnaires de la Société en précisant notamment:

- pour un cessionnaire personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, et adresse,
- pour un cessionnaire personne morale, sa dénomination sociale, sa forme, le montant de son capital, le siège, le RCS,

la composition de son actionnariat,

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée,
- le prix offert par action et les conditions de la cession.
Cette notification de l'actionnaire cédant vaudra promesse unilatérale de vente de sa part.
En cas d'exercice du droit de préemption, le prix par action sera celui obtenu par l'actionnaire cédant de la part d'un

acquéreur de bonne foi.

A compter de la réception de cette notification, les actionnaires de la Société disposeront d'un délai de trente (30)

jours  calendaires  pour  notifier,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  au  Conseil  d'Administration  leur
décision d'exercer leur droit de préemption et de se porter acquéreurs de la totalité des actions proposées.

En cas de pluralité d'actionnaires qui désirent se porter acquéreurs, la répartition des actions se fera au prorata de

leurs participations respectives dans le capital de la Société avant l'exercice du droit de préemption. Dans l'hypothèse où
l'intégralité des actions concernées n'aurait pas été préemptée, les actionnaires intéressés pourront notifier au Conseil
d'Administration leur intention d'exercer à nouveau chacun leur droit de préemption respectif sur le solde restant des
actions; les actions étant ainsi réparties entre eux librement sauf convention contraire des actionnaires.

Si dans une cession, le droit des actionnaires n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la Société

peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette
fin, d'un délai complémentaire de soixante (60) jours.

Si, à l'expiration du délai de soixante (60) jours susmentionné et sous réserve qu'il y ait une offre d'un tiers acquéreur,

aucun des actionnaires concernés ou la Société n'a exercé son droit de préemption ou le droit de préemption n'a pas
été exercé sur la totalité des actions concernées, la cession desdites actions sera soumise à l'agrément de l'assemblée
générale des actionnaires pris à l'unanimité des voix exprimées.

6.2. Agrément
En cas de projet transfert par un actionnaire de la Société de tout ou partie de ses actions de la Société à un acquéreur

tiers de la Société et sous réserve que les droits de préemption n'aient pas été exercés sur l'intégralité des actions à
céder, l'offre dont le contenu est identique à celui sur base duquel la procédure d'exercice du droit de préemption a été
exercée, sera soumise à l'agrément de tous les actionnaires réunis en assemblée générale et pris à l'unanimité des voix
exprimées.

Toute décision ainsi prise par l'assemblée générale des actionnaires est souveraine et soumise à leur libre appréciation

sans qu'ils soient dans l'obligation de se justifier ou motiver une telle décision de quelque manière que ce soit et/ou à
l'égard de qui que ce soit.

En cas d'agrément, le transfert d'actions devra être réalisé effectivement, conformément aux présentes dispositions,

dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de l'agrément. Pour les besoins des présentes dispositions, tout transfert
non réalisé effectivement conformément aux présentes dispositions et dans le délai d'un (1) mois tel que requis, sera
réputé comme nouveau et donc soumis une nouvelle fois aux procédures de préemption et d'agrément telles que décrites
par les présentes dispositions.

Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est

déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du
tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

En cas de refus, l'intégralité des actions de l'actionnaire cédant devra être rachetée par la Société et/ou un ou plusieurs

actionnaires et/ou tout candidat de leur choix, à des conditions et modalités au moins égales à celles contenues dans
l'offre soumise à agrément. La décision sera ensuite notifiée immédiatement par le Conseil d'Administration, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l'actionnaire cédant.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de

18078

capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes
dénommées.

6.3. Cessions libres
Tout transfert d'actions de la Société du fait d'une restructuration de la Société, à quelque titre que ce soit et sous

quelque forme que ce soit, est libre sous réserve qu'une telle restructuration n'aboutisse pas à un changement d'un ou
plusieurs bénéficiaires économiques de la Société; les dispositions relatives à la procédure de préemption et d'agrément
n'étant dés lors pas applicables.

6.4. Décès d'un des actionnaires personnes physiques
Dans l'hypothèse du décès d'un des actionnaires personnes physiques de la Société, les actionnaires s'engagent à

racheter ou faire racheter l'intégralité de la participation du défunt à un prix par action tel que convenu préalablement
par les actionnaires ou à défaut sur base du bilan moyen des trois (3) derniers exercices sociaux clôturés de la Société.

Les  actionnaires  conviennent  que  la  présente  disposition  s'applique  également  aux  bénéficiaires  économiques  des

actionnaires personnes morales de la Société.

Les actionnaires et/ou les bénéficiaires économiques de la Société conviennent que la présente disposition vaut pro-

messe unilatérale de vente à leur égard.

Les actionnaires s'engagent, au titre des présentes dispositions, pour eux-mêmes ainsi que, le cas échéant, pour leurs

héritiers et ayants-droits.

Titre III. Administration

Art. 7. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle. Toutefois,
lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté
que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre
dénommé administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
associé.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la Société.

Art. 8. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. En

cas d'empêchement de l'un et de l'autre, ils sont remplacés par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-

président, ou à défaut, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué
chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Lorsque le conseil d'administration est limité à un administrateur unique, cet article n'est pas d'application.

Art. 9. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 10. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d'un administrateur-délégué ou par la signature de l'administrateur unique, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil
d'Administration en vertu des dispositions de l'article 11 des statuts.

Art. 11. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'Administration, poursuites et diligences de son président, d'un administrateur délégué à ces fins ou de l'administrateur
unique.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations,

le 2 

èm

 

e

 vendredi du mois de juin à 15.00 heures.

18079

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.
3. Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les parties comparantes dûment représentées, déclarent souscrire au

capital de la Société comme suit:

1) La société "GEOFINANCE", prédésignée, trois mille six-cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600
2) Madame Tessy GOEDERT, préqualifiée, quatre cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Total: quatre mille actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 100.000,- (cent mille

euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les parties comparantes pré-mentionnées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée elles ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Les personnes suivantes sont nommées aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Tessy GOEDERT, pharmacienne, née à Luxembourg, le 11 mai 1969, demeurante L-2522 Luxembourg, 12,

rue Guillaume Schneider,

- Madame Annette GOEDERT-STOFFEL, pharmacienne, née à Luxembourg, le 6 mars 1938 demeurant profession-

nellement à L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé,

- Monsieur Jean-Claude LUCIUS, expert-comptable, né à Luxembourg, le 13 novembre 1966, demeurant profession-

nellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

18080

<i>Troisième résolution

La société à responsabilité limitée "SWL S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85.782,
est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société.

<i>Quatrième résolution

Les  mandats des  administrateurs  et  du  commissaire  ainsi  nommés prendront  fin à l'issue  de l'assemblée  générale

ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la Société est établi à L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), Madame Annette GOEDERT-STOFFEL, préqualifiée,

est nommée jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2015, aux fonctions:

- de Président du Conseil d'Administration, et
- d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la

gestion journalière.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille quatre cents euros.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ès-qualités qu'il agit, connu du

notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Ch. DOSTERT - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2010, Relation: GRE/2010/97. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINCK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 19 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015714/242.
(100009422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

COREAL Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 110.529.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010018046/9.
(100012325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

EGL Holding Luxembourg AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 103.420.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth of December.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of «EGL Holding Luxembourg AG», (hereinafter the

"Company"), a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at
7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 103.420, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, on 21 September 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1302, page
62488 dated 20 December 2004. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary, on 20 October 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 2255, page 108206 dated 11 November 2009.

18081

The meeting is opened at 3.30 pm, with Mr Alexander OLLIGES, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, in the chair,
who designates Ms Inken MÜLLER, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg as secretary.
The meeting designates Ms Raphaela SAVELSBERG, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg as scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to state, whereby the meeting agrees, that:
- all the shareholders are present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance

list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies ne varietur will be registered with the deed;

- pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented in this extraordinary general

assembly and the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda
prior to the meeting, and agree to waive the notice requirements;

- the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from

its current amount of two million three hundred and fifty-one thousand six hundred euro (EUR 2,351,600.-) up to two
million three hundred and fifty-one thousand seven hundred euro (EUR 2,351,700.-) through the issue of one (1) new
share with a par value of hundred euro (EUR 100.-) and to be subscribed by Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria
GmbH for the price of three million one hundred and fifteen thousand two hundred euro (EUR 3,115,200.-), whereby
one hundred euro (EUR 100.-) shall be allocated to the share capital and three million one hundred and fifteen thousand
one hundred euro (EUR 3,115,100.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as

follows:

Art. 5. The corporate capital is set at two million three hundred and fifty-one thousand seven hundred euro (EUR

2,351,700.-) divided into twenty-three million five hundred and seventeen (23,517) shares with a par value of one hundred
Euro (EUR 100.-) each.

The shares of the Company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in

certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements."
3. Miscellaneous.
After duly considering each item on the agenda, the general meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR

100.-) so as to raise it from its current amount of two million three hundred and fifty-one thousand six hundred euro
(EUR 2,351,600.-) up to two million three hundred and fifty-one thousand seven hundred euro (EUR 2,351,700.-) through
the issue of one (1) new share with a par value of hundred euro (EUR 100.-) each.

The new share is subscribed by Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH, an Austrian private limited liability

company with registered office at Eschenbachgasse 11/8, 1010 Vienna, registered with the Gesellschaftsregister am Han-
delsgericht Wien under the number 211073b, here represented by Mr Alexander OLLIGES, previously named, by virtue
of a proxy, for the price of three million one hundred and fifteen thousand two hundred euro (EUR 3,115,200.-).

The share so subscribed by Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH has been paid up by a contribution in

kind consisting of (i) eight thousand (8,000) common registered shares, as incorporated and reflected under the numbers
"0001" to "2,000" in the shares certificate number "001" and under the numbers "4,001" to "10,000" in the share certificate
number "004" with a nominal value of ten euro (EUR 10) each and (ii) eight thousand (8,000) common registered shares
subscribed by Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH in the extraordinary general assembly of the share-
holders dated 7 September 2009 in E.G.L. HELLAS ELECTRICITY, ENERGY AND NATURAL GAS TRADING COM-
PANY with the trading name E.G.L. Hellas S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Greece,
having its registered office at 64, L. Riankour Street, 115 23 Athens, Greece.

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been confirmed by the report issued by

Ernst &amp; Young dated 16 December 2009. The conclusion of the report is the following:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe

that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 1 new share
with a nominal value of EUR 100 to be issued with total related share premium of EUR 3,115,100, hence total consideration
amounting to EUR 3,115,200".

The report will remain annexed to the present deed.

18082

The total contribution consists of one hundred euro (EUR 100.-) for the share capital and three million one hundred

and fifteen thousand one hundred euro (EUR 3,115,100.-) for the share premium the Company.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth

read as follows:

Art. 5. The corporate capital is set at two million three hundred and fifty-one thousand seven hundred euro (EUR

2,351,700.-) divided into twenty-three million five hundred and seventeen (23,517) shares with a par value of one hundred
Euro (EUR 100.-) each.

The shares of the Company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in

certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements."

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to three thousand euro.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version; on the request of the appearing parties and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holders of the appearing parties, known to the notary by name, first

name, and residence, the said proxy holders signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes.

Im Jahre zweitausendneun, am sechzehnten Dezember.
Vor dem Unterzeichnenden, Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim Großherzogtum Luxemburg,

Wird eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der EGL Holding Luxembourg AG (im Folgenden die

"Gesellschaft") abgehalten, einer unter Luxemburger Recht gegründeten und bestehenden société anonyme mit Sitz in 7,
place du Théâtre, L-2613 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer
B 103.420, gegründet am 21. September 2004 gemäß einer Urkunde des Notars Jean Seckler mit Amtssitz in Junglinster,
Großherzogtum Luxemburg, welche am 20. Dezember 2004 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Num-
mer 1302, Seite 62488 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 20. Oktober 2009 gemäß
einer Urkunde des unterzeichneten Notars geändert, welche am 11. November 2009 im Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 2255, Seite 108206 veröffentlicht wurde.

Die Generalversammlung wurde um 15.30 Uhr mit Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

als Vorsitzendem eröffnet,

welcher Frau Inken Müller, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg als Sekretär ernannte.
Die Generalversammlung wählte Frau Raphaela Savelsberg, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg als Stimmenzähler.
Der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar, das Folgende zu beurkunden, wobei die Versammlung zustimmt, dass:
- alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesen-

heitsliste verzeichnet sind, und welche von den anwesenden Aktionären, den Vertretern der vertretenen Aktionäre sowie
dem Versammlungsausschuss ordnungsgemäß unterzeichnet wird. Diese Liste wird ebenso wie die Vollmachten ne vari-
etur werden mit dieser Urkunde hinterlegt;

- aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und alle

anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass ihnen vor der Generalversammlung die Tagesordnung mitgeteilt
wurde und sie diese zur Kenntnis genommen haben und sie auf die Erfordernisse einer formellen Einberufung verzichten;

- die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß besetzt ist und daher rechtmäßig über die folgende Tagesordnung

befinden kann:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von einhundert Euro (EUR 100,-), um es von seinem

derzeitigen Betrag von zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsechshundert Euro (EUR 2.351.600,-) auf einen
Betrag von zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsiebenhundert Euro (EUR 2.351.700,-) zu erhöhen durch die
Ausgabe von einer (1) neuen Aktie mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-), zu zeichnen von Elektri-
zitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH zum Preis von drei Millionen einhundertfünfzehntausendzweihundert Euro

18083

(EUR 3.115.200,-), bestehend aus einhundert Euro (EUR 100,-) für das Stammkapital und drei Millionen einhundertfünf-
zehntausendeinhundert Euro (EUR 3.115.100,-), für das Agiokonto ("prime d'émission") der Gesellschaft.

2. Anschließende Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher von nun an wie folgt lautet:

"Art.  5.  Das  Stammkapital  wird  auf  zwei  Millionen  dreihunderteinundfünfzigtausendsiebenhundert  Euro  (EUR

2.351.700,-) festgesetzt, aufgeteilt in dreiundzwanzigtausendfünfhundertsiebzehn (23.517) Aktien mit einem Nominalwert
von je einhundert Euro (EUR 100,-).

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden."
3. Verschiedenes.
Nach der Beratung über die Tagesordnungspunkte hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse ge-

fasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von einhundert Euro (EUR

100,-), um es von seinem derzeitigen Betrag von zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsechshundert Euro (EUR
2.351.600) auf einen Betrag von zwei Millionen dreihunderteinundfünfzigtausendsiebenhundert Euro (EUR 2.351.700,-)
zu erhöhen durch die Ausgabe von einer (1) Aktie mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-).

Die neue Aktie wurde von der Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH gezeichnet, einer österreichischen

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der Eschenbachgasse 11/8, 1010 Wien, eingetragen bei dem Gesell-
schaftsregister am Handelsgericht Wien unter der Nummer 211073b, hier vertreten durch Herrn Alexander OLLIGES,
vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht, zum Preis von drei Millionen einhundertfünfzehntausendzweihundert Euro (EUR
3.115.200,-), bestehend aus einhundert Euro (EUR 100,-) für das Stammkapital und drei Millionen einhundertfünfzehn-
tausendeinhundert Euro (EUR 3.115.100,-), für das Agiokonto ("prime d'émission") der Gesellschaft.

Die so von der Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH wurde durch eine Sacheinlage erbracht bestehend

aus (i) achttausend (8.000) Stamm-Namensaktien (common registered shares), aufgenommen und dargestellt unter den
Nummern "0001" bis "2.000" im Aktienzertifikat Nummer "001" und unter den Nummern "4.001" bis "10.000" im Akti-
enzertifikat Nummer "004" mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10) und (ii) achttausend (8.000) Stamm-
Namensaktien (common registered shares), gezeichnet von Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH in einer
ausserordentlichen Hauptversammlung vom 7. September 2009 in E.G.L. HELLAS ELECTRICITY, ENERGY AND NA-
TURAL GAS TRADING COMPANY mit dem Handelsnamen E.G.L. Hellas S.A., einer griechischen Aktiengesellschaft mit
Sitz in 64, L. Riankour Street. 115 23 Athen, Griechenland.

Der Beweis des Vorhandenseins und des Wertes der oben bezeichneten Einlage wurden durch den Bericht von Ernst

&amp; Young vom 16. Dezember 2009 bestätigt. Die Schlussfolgerung des Berichts lautet wie folgt:

"Auf der Grundlage der oben ausgeführten und beschriebenen Prüfung sind uns keine Umstände bekannt geworden,

die darauf hindeuten würden, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens der Anzahl und dem Nominalwert der
einen (1) neuen Aktie mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-), welche mit einem zugehörigen Betrag
von EUR 3,115,100 für das Agio ausgegeben wird, somit der gesamten Gegenleistung von EUR 3,115,200 entspricht."

Der Bericht wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Die gesamte Einlage besteht aus einhundert Euro (EUR 100,-) für das Stammkapital und drei Millionen einhundert-

fünfzehntausendeinhundert Euro (EUR 3.115.100,-), für das Agio ("prime d'émission") der Gesellschaft.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher von nun an wie folgt

lautet:

"  Art.  5.  Das  Stammkapital  wird  auf  zwei  Millionen  dreihunderteinundfünfzigtausendsiebenhundert  Euro  (EUR

2.351.700,-) festgesetzt, aufgeteilt in dreiundzwanzig-tausendfünfhundertsiebzehn (23.517) Aktien mit einem Nominalwert
von je einhundert Euro (EUR 100,-).

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden."

18084

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund dieses Aktes entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare

oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. dreitausend Euro geschätzt.

Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn erwähnten Tag aufgenommen wurde.
Der unterzeichnete Notar, der die englische und deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag der er-

schienenen Partei, dass diese Urkunde auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen
der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen des englischen vom deutschen Text ist die englische Fassung
maßgebend.

Die vorstehende Niederschrift ist den erschienen Personen, die dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz

bekannt sind, verlesen worden und von dem Notar zusammen mit den erschienen Personen unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. OLLIGES, I. MÜLLER, R. SAVELSBERG, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 22. Dezember 2009. Relation: EAC/2009/15921. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75.- EUR).

<i>Der Einnehmer

 (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2010015527/192.
(100009798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Lotoise Gourmande S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5710 Aspelt, 17, Peiter vun Uespelt-Stroos.

R.C.S. Luxembourg B 110.915.

Le bilan au 30/06/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010018049/9.
(100012316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Lotoise Gourmande S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5710 Aspelt, 17, Peiter vun Uespelt-Stroos.

R.C.S. Luxembourg B 110.915.

Le bilan au 30/06/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010018050/9.
(100012314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Lotoise Gourmande S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5710 Aspelt, 17, Peiter vun Uespelt-Stroos.

R.C.S. Luxembourg B 110.915.

Le bilan au 30/06/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010018051/9.
(100012310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Facility S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 97.091.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010018052/9.
(100012309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

18085

Cinemotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5460 Trintange, 16, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 150.747.

STATUTS

L'an deux mille dix, le sept janvier.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Richard CZAPLA-STOEHR, directeur, né le 28 mai 1981 à Thionville (France), demeurant au 6A, rue du

Cimetière, F-57180 Terville,

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «CINEMOTION S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Trintange.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente et l'installation de produits issus du monde audiovisuel, ainsi que le

développement, l'acquisition et l'exploitation de tout droit de propriété intellectuelle, comme des brevets, des marques
déposées, des dessins, des modèles et des droits d'auteur sur des logiciels, qu'ils soient ou non protégés.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-EUR) représenté par CENT (100) actions

d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (l'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

18086

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un
intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

18087

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV: Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2010.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, déclare souscrire les cent (100) actions.
Toutes les actions ont été libérées à hauteur de vingt-cinq pourcent (25%), de sorte que la somme de SEPT MILLE

SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (1.300.-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

18088

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2.- Est nommé administrateur, le terme de son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2015:
Monsieur Richard CZAPLA-STOEHR, directeur, né le 28 mai 1981 à Thionville (France), demeurant au 6A, rue du

Cimetière, F-57180 Terville.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, le terme de son mandat venant à échéance lors de l'assemblée

générale de l'année 2015:

DEC S.à r.l., ayant son siège à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de Commerce

du Grand-Duché du Luxembourg sous la section B numéro 143.543.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-5460 Trintange, 16, route de Remich.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Czapla - Stoehr et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 janvier 2010. LAC/2010/1585. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015548/178.
(100009857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Stenton Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 150.755.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mrs Berglind Bjork Jonsdottir, born in Reykjavik on September 7 

th

 , 1969, resident in Jokulhaed 4, 210 Gardabaer,

Iceland,

here represented by Mr Ingi Karl Ingolfsson, with professional residence at 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, by

virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with the registration
authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder (the Shareholder) of Stenton Consulting SA, a company incorporated

and organized under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Marcy Building, 2 

nd

 Floor Purcell

Estate, PO Box 2416, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the British Virgin Islands Register of
Commerce and Companies under number 508051 (the Company),

II. That by a resolution of the sole director of the Company validly adopted on December 10, 2009, a copy of which

shall remain annexed to the present deed, the Company resolved to transfer its registered office and central administration
of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, effective as of the date
hereof without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities
required under the laws of the British Virgin Islands to give effect to that resolution have been duly performed.

III. That it results from (i) a balance sheet of the Company that, as of October 31, 2009, the net assets of the Company

correspond at least to the value of the share capital of the Company, and (ii) from a certificate of the management of the
Company December 15, 2009, that since the date of the balance sheet and as of the date hereof, no material change in
the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the financial statements as
per October 31, 2009 have become materially incorrect and do not give a true and fair view of the Company's situation
as of the date hereof. A copy of such balance sheet and such certificate, after having been signed ne varietur by the proxy
holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and
shall be filed with such deed with the registration authorities.

IV. The agenda of the meeting is the following:

18089

1.  Transfer  of  the  registered  office  and  central  administration  of  the  Company  from  the  British  Virgin  Islands  to

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect, without the Company being dissolved but on the
contrary with full corporate and legal continuance;

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

with the name Stenton Consulting S.à r.l. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the
registered office and central administration of the Company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

3. Approval of the balance sheet of the Company as at October 31, 2009;
4. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws

of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to the Lu-
xembourg company act, with the Company having a share capital of fifty thousand US Dollars (USD 50.000,-) divided into
five thousand (5,000) shares, with a nominal value often US Dollars (USD 10,-) each;

5. Acknowledgement of the resignation of Amicorp Management Limited as sole director of the Company effective as

of the date hereof and full discharge to the resigning director for the performance of its duty as sole director of the
Company from the date of its appointment until the date of its resignation;

6. Appointment of (i) Mr. Dennis Bosje, company director, born on November 20, 1965 in Amsterdam, The Nether-

lands and (ii) Mr. Sinan Sar, company director, born on June 5, 1980, in Luxembourg, both having their professional address
at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, as managers of the Company for an indefinite period;

7. Establishment of the registered office and central administration of the Company at 5, avenue Gaston Diderich,

L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

8. Miscellaneous.
These facts exposed and recognised accurate by the Shareholders, the Shareholders resolve to take the following

resolutions:

<i>First resolution

The sole Shareholder resolves to transfer the registered office and central administration of the Company from the

British Virgin Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect, without the Company being
dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. The sole Shareholder further declares that all
formalities required under the laws the British Virgin Islands to give effect to such transfer have been duly performed.

<i>Second resolution

The sole Shareholder resolves that the Company adopts the legal form of a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) with the name Stenton Consulting S.à r.l., and accepts the Luxembourg nationality and shall as
from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The sole Shareholder approves the balance sheet of the Company as at October 31, 2009, a copy of which shall remain

attached to the present deed.

The share capital is fixed at fifty thousand US Dollars (USD 50.000,-) divided into five thousand (5,000) shares, with a

nominal value of ten US Dollars (USD 10,-) each, attributed to Mrs Berglind Bjork Jonsdottir, born in Reykjavik on
September 7 

th

 , 1969, resident in Jokulhaed 4, 210 Gardabaer, Iceland.

<i>Fourth resolution

The sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Company's articles of association in the form

presented to the Shareholders so as to conform them to Luxembourg laws at the occasion of the transfer of the Company
and its continuation in the Grand Duchy of Luxembourg.

The restated articles of association of the Company shall read as follows:

Art. 1. There is formed by those present partners and all persons and entities who may become partners in future,

a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an entity
as well as by present articles.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company.  It  may  also  give  guarantees  and  grant  securities  in  favour  of  third  parties  to  secure  its  obligations  or  the

18090

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5.  The  Company  may  carry  out  any  commercial  and/or  financial  transactions  with  respect  to  direct  or  indirect

investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "Stenton Consulting S.á r.l.".

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at FIFTY THOUSAND UNITED STATES DOLLARS (50,000.- USD) divided into five thousand

(5,000) share quotas of TEN UNITED STATES DOLLARS (10.- USD) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of

these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. The company's shares are transferable between partners, however any share transfer between partners is

subject to prior written approval of all existing partners. They may only be disposed of to new partners following the
passing of a resolution of all the partners in general meeting, stating prior written approval from all existing partners
representing one hundred percent of the total share capital of the Company.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers the resolutions of the board of managers shall be adopted unanimously.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, except for actions performed and/
or transactions concluded by the manager and/or the board of managers outside the scope of authorization given to the
manager and/or the board of managers by the Articles of the Company.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each

partner has voting rights commensurate with his share holding. Each partner may appoint a proxy to represent him at
meetings.

18091

Collective decisions are only validly taken in so far as they are jointly adopted by all the partners of the Company,

representing the Company's total share capital. Resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company
may only be carried by all the partners jointly, owning the Company's total share capital.

Art. 15. The Company's year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31 

st

 of December, the Company's accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles."

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31 

st

 , 2009.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Amicorp Management

Limited as director and as officer of the Company effective as of the date hereof and full discharge to the resigning director
and officer for the performance of its duty as director and as officer of the Company from the date of its appointment
until the date of its resignation.

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to appoint as managers with immediate effect and for an indefinite period:
(i) Mr. Dennis Bosje, company director, born on November 20, 1965 in Amsterdam, The Netherlands and
(ii) Mr. Sinan Sar, company director, born on June 5, 1980, in Luxembourg, both having their professional address at

L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office and central administration of the Company at 5, avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between
the English and the French text, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg.

18092

A COMPARU:

Madame Berglind Bjork Jonsdottir, née à Reykjavik, le 7 septembre 1969, demeurant à Jokulhaed 4, 210 Gardabaer,

Islande,

Ici représentée par Monsieur Ingi Karl Ingolfsson, avec adresse professionnelle au 15, rue Louvigny, L-1946 Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante

et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des
autorités compétentes.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que la partie comparante est l'associé unique de Stenton Consulting SA, une société constituée et régie selon les

lois des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social se situé à Marcy Building, 2nd Floor Purcell Estate, PO Box 2416,
Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques, sous le
numéro 508051 (la "Société"),

II. Que la Société a décidé, par une résolution de l'administrateur unique de la Société valablement prise le 10 décembre

2009, dont une copie restera attachée au présent acte, de transférer son siège social et l'administration centrale de la
Société des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la date de ce jour, sans
dissolution de la Société mais au contraire, avec complète continuation de sa personnalité juridique. Toutes les formalités
requises par le droit des Iles Vierges Britanniques afin de donner effet à cette décision ont d'ores et déjà été accomplies.

III. Qu'il résulte (i) d'un bilan de la Société que, en date du 31 octobre 2009, l'actif net de la Société correspond au

moins à la valeur du capital social de la Société, et (ii) d'un certificat de la direction de la Société du 15 décembre 2009,
que depuis la date du bilan et à la date qu'en tête, aucun événement dans la marche de la Société et les activités de la
Société n'est survenu qui aurait eu pour conséquence de rendre les états financiers du 31 octobre 2009 matériellement
incorrects et de ne pas donner une image fidèle et sincère de la situation de la Société à la date qu'en tête. Une copie de
ce bilan et de ce certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante
et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés ensemble avec celui-ci.

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans que la Société soit dissoute, mais au contraire avec complète
continuité légale et statutaire;

2. Adoption par la Société de la forme légale d'une société à responsabilité limitée avec la dénomination Stenton

Consulting  S.à  r.l.  et  acceptation  de  la  nationalité  luxembourgeoise  découlant  du  transfert  de  son  siège  social  et  de
l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

3. Approbation du bilan de la Société du 31 octobre 2009;
4. Modification et refonte complète des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois luxem-

bourgeoises, en conséquence de la Société devenant une société de droit luxembourgeois régie par la loi sur les sociétés
commerciales, la Société ayant un capital social de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-) divisé
en cinq mille (5.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 10,-);

5. Reconnaissance de la démission de Amicorp Management Limited en tant que seul administrateur de la Société avec

effet à la date qu'en tête et décharge pleine et entière à l'administrateur unique ci-dessus pour l'exécution de son mandat
depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission;

6. Confirmation de la nomination de (i) Mr. Dennis Bosje, company director, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam,

Pays-Bas and (ii) Monsieur Sinan Sar, company director, né le 5 juin 1980 à Luxembourg, les deux demeurant profes-
sionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée;

7. Etablissement du siège social et de l'administration centrale de la Société au 5, avenue Diderich, L-1420 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg.

8. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, ils prennent les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social et l'administration centrale de la Société des Iles Vierges Britanniques

à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans que la Société soit dissoute, mais au contraire
avec une complète continuité légale et statutaire. Les associés déclarent en outre que toutes les formalités requises selon
les lois des Iles Vierges Britanniques afin de donner effet à un tel transfert, ont été dûment accomplies.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée avec la dénomination Stenton

Consulting S.à r.l. et accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à la date du présent acte, soumise aux lois du Grand-
Duché de Luxembourg.

18093

<i>Troisième résolution

Les associés approuvent le bilan de la Société au 31 octobre 2009, dont une copie restera attachée au présent acte.
Le capital social est fixé à cinquante mille dollars des Etats-Unis (50.000.- USD) représenté par cinq mille (5.000) parts

sociales d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (10.- USD) chacune, attribuées à Madame Berglind Bjork
Jons-dottir, née à Reykjavik, le 7 septembre 1969, demeurant à Jokulhaed 4, 210 Gar-dabaer, Islande.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier et de refondre entièrement les Statuts de la Société dans la forme présentée aux

associés afin de les mettre en conformité avec les lois luxembourgeoises à l'occasion du transfert de la Société et de sa
continuité au Grand-Duché de Luxembourg.

Les statuts coordonnés de la Société auront la teneur suivante:

 Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce

soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt
et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination "Stenton Consulting S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE DOLLARS DES ETATS-UNIS (50.000.- USD)

représenté par cinq mille (5.000) parts sociales de DIX DOLLARS DES ETATS-UNIS (10.- USD) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité

avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Les parts sociales sont cessibles entre associés, cependant tout transfert de parts sociales entre associés est

soumis préalablement à une approbation écrite de la part de la totalité des associés existants. Elles ne peuvent être cédées

18094

entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés indiquant l'approbation
écrite préalable de tous les associés existants représentant 100% du capital social total de la société.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité des gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées unanimement.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, excepté pour les opérations et/ou transactions conclues
par le gérant unique et/ou le conseil de gérance en dehors de l'autorisation donnée au gérant unique et/ou conseil de
gérance par les Statuts de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées conjointement par tous

les associés de la société, représentant la totalité du capital social de la société. Toute résolution en relation avec le
changement des statuts et particulièrement la liquidation de la société ne peut être décidée que par la totalité des associés,
conjointement, ceux-ci détenant la totalité du capital social de la société.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi."

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2009.

18095

<i>Cinquième résolution

Les associés confirment la démission de Amicorp Management Limited en tant que seul administrateur de la Société

avec effet à la date qu'en tête et décharge pleine et entière à l'administrateur unique ci-dessus pour l'exécution de son
mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission.

<i>Sixième résolution

Les associés confirment la nomination en tant que gérants avec effet immédiat pour une durée illimitée:
(i) Mr. Dennis Bosje, Company director, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam, Pays-Bas et
(ii) Monsieur Sinan Sar, company director, né le 5 juin 1980 à Luxembourg, les deux demeurant professionnellement

à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich,

<i>Septième résolution

Les associés décident d'établir le siège social et l'administration centrale de la Société au 5, avenue Diderich, L-1420

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

DONT ACTE

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, certifie par la présente qu'à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre les versions
anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date qu'en tête des présentes au Grand-Duché de Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le

présent acte.

Signé: I. K. INGOLFSSON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57600. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015729/384.
(100010006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Luxriviera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 97.586.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010018034/9.
(100012234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Optima Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 35, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 76.895.

Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010018035/9.
(100012233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Coljon Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8442 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 97.721.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010018045/9.
(100012327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

18096


Document Outline

352 Investors S.A.

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Agaka S.A.

Atlantis Investments Holding S.A.

BEBAU Swiss Holding S.àr.l.

Blatteus S.A.

Business Management Group Holding S.A.

Café Number 1 S.à r.l.

Cinemotion S.A.

Coljon Sàrl

COREAL Construction S.à r.l.

Defibresil S.A.

Deutsche Finanz A.G.

DISA-Distribution Investments S.A.

Dorsol S.A.

Drayton S.A.

Dresdner Portfolio Management

DZ PB

DZ Private Wealth Managementgesellschaft

EGL Holding Luxembourg AG

eOffice Invest S.A.

Facility S.A.

Fairchild Participations S.A.

Febex Technique S.A.

Ford Export Services, Luxembourg

Frank Kienel S. à r.l.

Galli S.A.

Georue 2

H + A Montage S.à r.l.

Immobilière et Commerciale Graas S.A.

Lindner Isoliertechnik GmbH, Niederlassung Luxemburg

Lotoise Gourmande S.à r.l.

Lotoise Gourmande S.à r.l.

Lotoise Gourmande S.à r.l.

Luxriviera S.A.

Luxriviera S.A.

Madras Investments Holding S.A.

Malux S.à r.l.

Matsip Consulting S.A.

Mondeltone S.A.

Nomura U.S. High Yield Bond Income

Nomura U.S. High Yield Bond Income

Optima Consulting Sàrl

Outre-Mer Invest S.A.

Peinture Baranowsky S.à r.l.

Petrus International S.A.

PO Invest 1 S.A.

ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l.

ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l.

ProLogis Czech Republic XVI S.à r.l.

ProLogis Czech Republic XV S.à r.l.

ProLogis Czech Republic XXI S.à r.l.

ProLogis Czech Republic XX S.à r.l.

Racine Investissement S.A.

Star Group S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"

Stenton Consulting S.à r.l.

Tabiadasc Real Estate S.A.

Tempura S.A.

Tollamen SPF, SA

TransArdenna S.A

Trustcapital S.A.

Uniker Investments Holding S.A.