logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 261

5 février 2010

SOMMAIRE

Advantage Participation S.A. . . . . . . . . . . . .

12499

aeris CAPITAL Amperio S.à r.l.  . . . . . . . . .

12511

Airport Partner International S.A. . . . . . . .

12528

Alphastock Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12522

Alsena S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12510

Bairlinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12510

Biminvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12523

BtoBe Luxemburg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

12482

Caragana S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12507

Cardinal Health Luxembourg 420 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12487

CIPA Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

12504

Clover Investments Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

12503

Compagnie Financière du Quinzième Siè-

cle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12504

Delta Courtage International S.à.r.l.  . . . . .

12506

Dova Société Immobilière S.A.  . . . . . . . . . .

12506

Duchess Street Holdings SA  . . . . . . . . . . . .

12518

Eneris Wind Italia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12500

Evanio Investments Holding S.A.  . . . . . . . .

12518

Everest Investholding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

12487

Fario Luxembourg S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

12486

Field Point I-A RE 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12499

Field Point I-A RE 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

12501

Fina Cold II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12504

Fina Cold II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12505

Freelander Investholding S.à r.l.  . . . . . . . . .

12487

Future Entertainment S. à r.l.  . . . . . . . . . . .

12500

Gadwall Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12518

Genesis Smaller Companies . . . . . . . . . . . . .

12522

Glaxosmithkline Dungarvan and Stafford-

Miller (Ireland) S.N.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

12519

GLH Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12482

Global Group Financial Services (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12504

Intrawest Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

12523

June S.C.A., SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . .

12505

Keyhow Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12528

Keyhow Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12527

LBREM II NW Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

12505

LSREF Kachidoki Investments S.à r.l.  . . . .

12507

LSREF Lux Investments VIII S.à r.l.  . . . . . .

12507

Luxdeftec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12486

LYXOR CTA Diversified Fund  . . . . . . . . . .

12509

MGE Objekt Berlin S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

12509

Multi Units Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

12500

OCM Luxembourg Glasnost Holdings SCA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12488

Oterna Holding B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12502

Oterna Holding B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12503

Oterna Holding B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12503

Oterna Holding B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12503

Oxford Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

12502

Pegasus Investments Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

12504

ProLogis Belgium Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12485

ProLogis France CX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

12527

ProLogis Poland LXIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

12485

Ril Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12503

Riz Europe (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

12486

Rock Ridge RE 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12501

Rock Ridge RE 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12502

Rock Ridge RE 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12502

Romford Investment Holding S.à r.l.  . . . . .

12523

S5 Finco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12501

Software Development & Consulting  . . . .

12505

Tractim S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12510

12481

GLH Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 109.178.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 décembre 2009 que:
Le siège social est transféré à L-2613 Luxembourg 1, Place du Théâtre.
Monsieur Robert MEHRPAHL, né le 25.08.1947 à Neustadt/Holstein (Allemagne), est révoqué avec effet immédiat de

son mandat d'administrateur.

Monsieur Jean-Pierre VERNIER, né le 02.10.1952 à Nantes (France), demeurant à L-2210 Luxembourg, 84, boulevard

Napoléon 1 

er

 , administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015, avec droit de signature individuelle.

Monsieur Jean-Pierre VERNIER, né le 02.10.1952 à Nantes (France), demeurant à L-2210 Luxembourg, 84, boulevard

Napoléon  1 

er

  ,  administrateur-délégué  jusqu'à  l'assemblée  générale  qui  se  tiendra  en  2015,  avec  droit  de  signature

individuelle.

Monsieur André HARPES, né le 17.03.1960 à Luxembourg, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre,

administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015, avec droit de signature individuelle.

Madame Carine BITTLER, née le 10.10.1949 à Horgenzell (Allemagne), demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du

Théâtre, administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015, avec droit de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010011093/26.
(100003367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

BtoBe Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 74.575.

Im Jahre zwei tausend neun,
den sechzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft BtoBe Luxemburg S.A., mit Sitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 74.575 (NIN 2000 2204 844),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitze in Sassenheim, am

28. Januar 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 430 vom 16. Juni 2000.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung

vom 20. Februar 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 872 vom 12. Oktober
2001.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf dreissig tausend neun hundert sechsundachtzig Euro neunundsechzig Cents

(€ 30.986,69) und ist eingeteilt in ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Thierry HELLERS, Wirtschaftsberater, beruflich ansässig in L-1273

Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.

Er beruft zum Schriftführer Frau Audrey DEL DEGAN, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-1273 Luxemburg, 19, rue

de Bitbourg,

und zum Stimmzähler Frau Juliette BEICHT, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

12482

1.- Abänderung von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist:
- das Betreiben einer Werbeagentur;
- den allgemeinen Handel;
- die Vermietung von Immobilien jeder Art;
- die Inwertsetzung von eigenen Immobilien;
- die Verwertung von geistigem Eigentum.
Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren und sonstigen Vermögensgegenstände erwerben, sei

es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder
sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  zu  tätigen,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck  verbunden  werden  können  und  der  Entwicklung  der
Gesellschaft förderlich sind.

2.- Abschaffung des genehmigten Kapitals.
3.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von dreizehn Euro einunddreissig Cent (€ 13,31) um es von

derzeit dreissig tausend neun hundert sechsundachtzig Euro neunundsechzig Cents (€ 30.986,69) auf einunddreissig tau-
send Euro (€ 31.000,-) zu bringen mittels Bareinzahlung des Betrages von dreizehn Euro einunddreissig Cent (€ 13,31)
durch die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital.

4.- Abänderung von Artikel 5 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€31.000,-) und ist eingeteilt in

ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie für Sa-

tzungsänderungen zu fassen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
5.- Annahme des Rücktritts der Aktiengesellschaft G.T. Fiduciaires S.A. als Mitglied des Verwaltungsrates.
6.- Ernennung von Frau Diane PÜNDEL, Direktorin, beruflich ansässig in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, als

Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Delegierte des Verwaltungsrates.

7.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der An-

wesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitglie-
dern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert,

welche das gesamte Kapital von dreissig tausend neun hundert sechsundachtzig Euro neunundsechzig Cents (€ 30.986,69)
darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist
somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten
und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie

rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist:
- das Betreiben einer Werbeagentur;
- den allgemeinen Handel;
- die Vermietung von Immobilien jeder Art;
- die Inwertsetzung von eigenen Immobilien;
- die Verwertung von geistigem Eigentum.

12483

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren und sonstigen Vermögensgegenstände erwerben, sei

es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder
sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  zu  tätigen,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck  verbunden  werden  können  und  der  Entwicklung  der
Gesellschaft förderlich sind.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das genehmigte Kapital abzuschaffen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von dreizehn Euro einunddreissig Cent

(€ 13,31) zu erhöhen, um es von derzeit dreissig tausend neun hundert sechsundachtzig Euro neunundsechzig Cents (€
30.986,69) auf einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) zu bringen mittels Bareinzahlung des Betrages von dreizehn Euro
einunddreissig Cent (€ 13,31) durch die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital,
wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 5 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-) und ist eingeteilt in

ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie für Sa-

tzungsänderungen zu fassen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von der Aktiengesellschaft G.T. Fiduciaires S.A. als Mitglied des Ver-

waltungsrates an und erteilt ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum neuen Mitlied des Verwaltungsrates sowie als Delegierte des Verwaltungsrates,

ihr Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2015:

Frau Diane PÜNDEL, Direktorin, geboren in Luxemburg, am 18. September 1970, beruflich ansässig in L-1273 Lu-

xembourg, 19, rue de Bitbourg,

mit der Befugnis die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, durch ihre alleinige Unterschrift rechts-

gültig zu vertreten und zu verpflichten.

<i>Siebter Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. HELLERS, A. DEL DEGAN, J. BEICHT, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 17 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1920. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): J.- M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 24. Dezember 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010010010/135.
(100002369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.

12484

ProLogis Poland LXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 113.545.

à rayer: Suite à un contrat daté du 27 novembre 2009 sept mille deux cents (7200) parts sociales détenues dans la

Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis Developments Holding Sàrl ont été transférées à ProLogis Management
II Sàrl agissant pour le compte de ProLogis European Properties Fund II (the "Fund"), ayant son siège social à L-1930
Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de
la Société par un de ses gérants.

à rayer: Suite à un contrat daté du 27 novembre 2009 sept mille deux cents (7200) parts sociales détenues dans la

Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis Management II Sàrl agissant pour le compte de ProLogis European
Properties Fund II (the "Fund") ont été transférées à ProLogis European Holdings X Sàrl, ayant son siège social à L-1930
Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de
la Société par un de ses gérants.

à rayer: Suite à un contrat daté du 27 novembre 2009 sept mille deux cents (7200) parts sociales détenues dans la

Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis European Holdings X Sàrl ont été transférées à ProLogis European
Holdings XII Sàrl, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté. Cette cession des parts
sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 27 novembre 2009 sept mille deux cents (7200) parts sociales détenues dans la

Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis European Holdings XII Sàrl ont été transférées à ProLogis European
Finance XII Sàrl, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté. Cette cession des parts sociales
a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Finance XII Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7200 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7200 parts sociales

Le 09 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010011104/34.
(100003691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

ProLogis Belgium Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 60.855.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 30 novembre 2009 vingt (20) parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaire unique, càd, ProLogis European Finance VI Sàrl Sàrl ont été transférées à ProLogis European Finance XVII
Sàrl, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté. Cette cession des parts sociales a été
approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

ProLogis European Finance XVII Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts sociales

Le 30 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010011328/20.
(100003628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

12485

Riz Europe (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 90.793.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert, signé en date du 4 décembre 2007, que les parts sociales de la société, de EUR 25,-

chacune, sont désormais réparties comme suit:

Désignation des associés

Nombre

de parts

RIGRE GmbH
Nottendorfer Gasse 11
A-1030 Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2010011339/18.
(100004268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Luxdeftec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 38, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 110.692.

<i>Extrait de l'assemblée

<i>générale extraordinaire du 7 janvier 2010

Le conseil d'administration nouvellement en fonction, prend la décision suivante:
Est élu président du conseil d'administration conformément à l'article 12 des statuts de la société Monsieur Stephan

DAUB. Cette nomination prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

<i>Pour la société
PKF Weber &amp; Bontemps
<i>Réviseurs d'Entreprises, Experts Comptables et Fiscaux

Référence de publication: 2010011340/17.
(100004270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Fario Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 146.124.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale

<i>extraordinaire tenue en date du 29 décembre 2009 au siège social

L'assemblée acte et décide:
- D'accepter la démission de Madame Zamyra H. Cammans de son mandat de gérante de la société avec effet le 11

décembre 2009.

- De nommer au titre de gérant Monsieur Pierre Laloyaux, résidant professionnellement au 2, rue des Dahlias, L-1411

Luxembourg, avec effet le 11 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc:
- Mme Petra Dunselman
- M. Pierre Laloyaux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011401/19.
(100004544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12486

Everest Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.606.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du
4 janvier 2010 à 10.00 heures
a été nommé gérant unique Monsieur Gerardus H.M. OSSEVOORT, né le 27 août 1963 à Arnhem, Pays-Bas, demeurant

professionnellement à 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg

à effet du 7 janvier 2010 en remplacement de Monsieur Jan Herman VAN LEUVENHEIM.

Le 8 janvier 2010.

EVEREST INVESTHOLDING SARL
Gérard H.M. OSSEVOORT
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2010011343/17.
(100004431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Freelander Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine fa-

milial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 100.410.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du
4 janvier 2010 à 14.00 heures
a été nommé gérant unique Monsieur Gerardus H.M. OSSEVOORT, né le 27 août 1963 à Arnhem, Pays-Bas, demeurant

professionnellement à 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg

à effet du 7 janvier 2010 en remplacement de Monsieur Jan H. VAN LEUVENHEIM.

Le 8 janvier 2010.

FREELANDER INVESTHOLDING SARL
Gérard H.M. OSSEVOORT
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2010011344/18.
(100004432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Cardinal Health Luxembourg 420 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 97.342.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale

<i>extraordinaire tenue en date du 29 décembre 2009 au siège social

L'assemblée acte et décide:
- D'accepter la démission de Madame Zamyra H. Cammans de son mandat de gérante de la société avec effet le 11

décembre 2009.

- De nommer au titre de gérant Monsieur Pierre Laloyaux, résidant professionnellement au 2, rue des Dahlias, L-1411

Luxembourg, avec effet le 11 décembre 2009.

A partir de cette date, les gérants de la société sont donc:
- Mme Petra Dunselman
- M. Pierre Laloyaux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011396/19.
(100004500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12487

OCM Luxembourg Glasnost Holdings SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 150.476.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) OCM Luxembourg EPOF II S.àr.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 133.551,

here represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given

under private seal;

2) OCM Luxembourg Glasnost Holdings GP, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 149.222,

here represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given

under private seal;

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the under-

signed notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a société en commandite par actions, which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is hereby established between OCM Luxembourg Glasnost Holdings GP, subscriber of the GP

shares as general partner (the GP Shareholder), the subscribers and all those who may become owners of the GP Shares
or Ordinary Shares issued by the Company, a société en commandite par actions under the name of OCM Luxembourg
Glasnost Holdings SCA (hereinafter the Company), which shall be governed by the law of August 10, 1915, on commercial
companies, as amended (the Law), as well as by these articles of association (these Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the GP Shareholder. The registered office may
further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the GP Shareholder. Where the GP Shareholder determines that extraordinary political or military de-
velopments or events have occurred or are imminent as determined in its sole discretion and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more  generally  any  securities  and/or  financial  instruments  issued  by  any  public  or  private  entity  whatsoever.  It  may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2 The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt

and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies and the Company
may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of
its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company,

12488

and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those
activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate

to its object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the Shareholders of the Company adopted in the

manner required to amend the Articles.

4.3  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting any of the Shareholders. In case of death, incapacity or inability of the GP
Shareholder, article 112 of the Law shall apply.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) represented by:
(i) one (1) GP share (the GP Share), and
(ii) thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) ordinary shares (the Ordinary Shares).
The Ordinary Shares and the GP Share(s) are collectively hereinafter referred to as the Shares, and individually, as a

Share.

All the Shares are in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each, subscribed and fully paid-up.
The Ordinary Shares are held by the Ordinary Shareholders. The Ordinary Shareholders are hereafter referred to as

the Limited Shareholders. The Limited Shareholders and the GP Shareholder are hereafter collectively referred to as the
Shareholders.

5.2 The authorised share capital of the Company is set at ten million euro (EUR 10,000,000) and the GP Shareholder

is authorised to issue in addition to the existing Shares of the Company, an aggregate number of nine million nine hundred
and sixty-nine thousand (9,969,000) Shares, having a par value of one euro (EUR 1) and an aggregate par value of nine
million nine hundred and sixty-nine thousand euro (EUR 9,969,000).

5.3 The GP Shareholder shall be authorized for a period of 5 (five years) starting on the date of the incorporation of

the Company, to increase the corporate capital of the Company, in one or several times, from thirty-one thousand euro
(EUR 31,000) to ten million euro (EUR 10,000,000),

(i) by the creation and issuance of new GP Shares and/or Ordinary Shares;
(ii)  by  determination  of  the  date  and  place  at  which  the  notarial  deed  acknowledging  the  capital  increase  will  be

executed;

(iii) by the withdrawal or limitation of the Shareholders' preferential subscription rights in respect of such issue(s) of

Shares and the issuance of such Shares to such person(s) as the GP Shareholder decides;

(iv) by the record by way of a notarial deed for each and any share capital increase effected within the limits of the

authorised share capital and amendment of article 5.1 of the Articles accordingly; and

(v) by amendment to the Share register of the Company every time an increase of the share capital is effected within

the limits of the authorised share capital.

5.4  The  share  capital  of  the  Company  may  be  increased  or  reduced  by  resolution  of  the  general  meeting  of  the

Shareholders of the Company adopted in the manner required to amend the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares are and shall remain in registered form.
6.2 The Ordinary Shares
(a) All Ordinary Shares shall have the rights and obligations granted to them in accordance with the Articles and shall

be identical in all respects.

(b) Each Ordinary Share is entitled to one vote at the general meetings of shareholders.
6.3 The GP Share(s)
(a) All GP Share(s) shall have the rights and obligations granted to them in accordance with the Articles and shall be

identical in all respects.

(b) Each GP Share is entitled to one vote at the general meetings of shareholders.
6.4 A Share register shall be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each Shareholder which so requests.

12489

6.5 Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the Shareholders' register of the

Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to
the Company.

6.6 Any distribution made on Shares, whether in cash or in kind, in whatever form (including without limitation) as

dividends, liquidation proceeds, redemption proceeds or otherwise, shall be paid and distributed to the Shareholders out
of  the  sums  available  for  distribution  in  accordance  with  article  72-1,  paragraph  (1)  of  the  Law  or,  in  the  case  of  a
redemption, in accordance with article 49-8 of the Law.

6.7 Transfer of Shares may be restricted pursuant to any agreement between the Company and the Shareholders.
6.8. Towards the Company, the Shares are indivisible and only one owner per share shall be recognized by the Com-

pany. Joint co-owners shall appoint one sole person as their representative towards the Company.

6.9 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law and the Articles.

Art. 7. Liability of the Shareholders.
7.1 The GP Shareholder is jointly and severally liable for all liabilities of the Company to the extent that they cannot

be paid out of the assets of the Company.

7.2 The Limited Shareholders are liable up to the amount of the capital committed by them to the Company on

subscribing the Shares.

III. Management - Representation

Art. 8. Management of the Company.
8.1 The Company shall be managed by the GP Shareholder.
8.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the Shareholders or to the Supervisory

Board (as defined hereafter) fall within the competence of the GP Shareholder, which shall have all powers to carry out
and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.3 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether or not

Shareholders, by the GP Shareholder.

8.4 The GP Shareholder is authorised to delegate the day-to-day management of the Company and the power to

represent the Company in respect thereto to one or more officers, or other agents, whether or not Shareholders, acting
individually or jointly.

8.5 The Company shall be bound towards third parties by the signature of the GP Shareholder or by the joint or single

signature of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated and within the limits of such power.

8.6 No contract or other transaction between the Company and any other company or person shall be affected or

invalidated by the fact that the GP Shareholder or any officer of the Company is interested in the transaction, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or person.

Art. 9. Liability.
9.1 To the extent permissible under Luxembourg law, the GP Shareholder and other officers of the Company, as well

as those persons to whom such signatory powers have been validly delegated in accordance with articles 8.3 and 8.4 of
these Articles, shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and
expenses incurred or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may
be made a party by reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any
transaction carried out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted,
in connection with the execution of their duties, save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or
wilful default, in each case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.

IV. General meetings of shareholders

Art. 10. Powers and Voting rights.
10.1 The general meeting of Shareholders validly constituted represents all the Shareholders of the Company.
10.2 Resolutions of the Shareholders shall be adopted at general meetings in accordance with the Law and these

Articles.

Art. 11. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.
11.1 General meetings of Shareholders of the Company shall be convened by the General Partner or by the Supervisory

Board by a notice setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight (8) days prior to the meeting to each
Shareholder at the Shareholder's address recorded in the Share register.

11.2 General meetings of Shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the

convening notices of the meetings.

12490

11.3 The meeting may be held without prior notice if all the Shareholders of the Company are present or represented

at a meeting of the Shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda of the meeting.

11.4 A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Company by appointing another person (who

need not be a Shareholder) as his proxyholder in writing, using any means of written communication including telegram,
telex, facsimile or e-mail.

11.5 Each Shareholder may also participate in any meeting of the Shareholders of the Company by telephone or video

conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation
in person to such meeting.

11.6 Each Shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain

the date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each
proposed resolution, three boxes allowing the Shareholders to vote in favour, against or abstain from voting on the
proposed resolution. The voting forms must be sent by the Shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to
the registered office of the Company. The Company shall only accept the voting forms which are received prior to the
time of the meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the
proposed resolutions) nor an abstention shall be null and void.

11.7 Except as otherwise required by the Law or these Articles, resolutions at a general meeting of the Shareholders

of the Company duly convened shall be passed by a simple majority of those Shareholders present or represented,
regardless of the number of Shareholders present or represented and the proportion of the share capital present or
represented at such meeting.

11.8 An extraordinary general meeting of the Shareholders convened to amend any provisions of the Articles shall

not validly deliberate unless at least one-half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amend-
ments to the Articles. If this quorum is not reached, a second meeting shall be convened, in the manner prescribed by
the Articles and the Law. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital repre-
sented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes cast.

V. Supervision - Annual accounts - Allocation of profits

Art. 12. Supervisory Board.
12.1 The supervision of the Company, including the supervision of its books and accounts, shall be entrusted to a

supervisory board of at least three members (the Supervisory Board), who need not be Shareholders. The members of
the Supervisory Board shall be appointed by the general meeting of the Shareholders of the Company which shall deter-
mine their number, their remuneration and the term of their office. They shall be elected for a term not exceeding six
years and shall be re-eligible.

12.2 The Supervisory Board must appoint a chairman among its members and it may choose a secretary.
12.3 The Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by the Law.
12.4 The Supervisory Board shall be consulted by the GP Shareholder on such matters as the GP Shareholder may

determine and it shall authorise any actions of the GP Shareholder that may, pursuant to the Law or these Articles, exceed
the powers of the GP Shareholder.

12.5 The Supervisory Board shall meet upon convocation by the GP Shareholder or by any of its members.
12.6 Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Supervisory Board.

12.7 No such written notice is required if all members of the Supervisory Board are present or represented during

the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting.
The written notice may be waived by the consent in writing, using any means of written communication including telegram,
telex, facsimile or e-mail, of each member of the Supervisory Board. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory
Board.

12.8 Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing, in writing,

using any means of written communication including telegram, telex, facsimile or e-mail, another member as his proxy.

12.9 The Supervisory Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the Supervisory Board are validly taken by a majority of the vote cast. In the event that at any meeting the
number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote. The reso-
lutions of the Supervisory Board shall be recorded in minutes signed by all the members present or represented at the
meeting or by the secretary (if any).

12.10 Any member may participate in any meeting of the Supervisory Board by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and

12491

speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.

12.11 Circular resolutions signed by all the members of the Supervisory Board shall be valid and binding in the same

manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by an original, or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

12.12 The members of the Supervisory Board assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

12.13 To the extent permissible under Luxembourg law, the members of the Supervisory Board shall be indemnified

out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained by them
in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being or
having been members of the Supervisory Board, in connection with the execution of their duties, save for liabilities and
expenses arising from their gross negligence or wilful default, in each case without prejudice to any other rights to which
they may be entitled.

Art. 13. Accounting year and Annual general meeting.
13.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December of such year.

13.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the GP Shareholder must prepare the balance sheet

and the profit and loss account of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the officers, directors,
members of the supervisory board and statutory auditors of the Company.

13.3 The GP Shareholder shall, one month before the annual general meeting of Shareholders, deliver documentary

evidence and a report on the operations of the Company to the Supervisory Board of the Company who must prepare
a report setting forth its proposals.

13.4 The annual general meeting of the Shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Friday of June of each year at
10.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.

13.5 The annual general meeting of the Shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the GP Shareholder, exceptional circumstances as stated into Article 2.2 of the Articles so require.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.

14.2 The general meeting of Shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits

shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes will best suit the
corporate purpose and policy.

14.3 Dividends, when payable, shall be distributed at the time and place fixed by the GP Shareholder, in accordance

with the decision of the general meeting of Shareholders. The dividends may be paid in euro or any other currency
selected by the GP Shareholder.

14.4 The GP Shareholder may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in

the Law.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be Shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of Shareholders which shall
determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the Shareholders or by
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

15.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the Shareholders in proportion to the Shares held by each Shareholder in the Company.

VII. General provision

16.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provisions are made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2010.

12492

Subscription - Payment

Thereupon,
OCM Luxembourg Glasnost Holdings GP, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for one

(1) GP Share in registered form, with a par value of one euro (EUR 1), and to fully pay it up by way of a contribution in
cash amounting to one euro (EUR 1).

OCM Luxembourg EPOF II S.àr.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for thirty thousand

nine hundred and ninety-nine (30,999) Ordinary shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each,
and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to thirty thousand nine hundred and ninety-nine euro
(EUR 30,999).

The amount of thirty one thousand euro EUR 31,000 is at the disposal of the Company, as has been proved to the

undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders of the Company, representing the entirety of

the subscribed share capital have passed the following resolutions:

The following persons are appointed as members of the Supervisory Board of the Company for a term which shall

expire at the first coming annual general meeting of the Shareholders of the Company:

- Mr Justin BICKLE, born on January 11, 1971 in Plymouth, United Kingdom, residing professionally at 27 Knightsbridge,

London SW1X 7LY, England;

- Mr. Hugo NEUMAN, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16, rue J.B. Fresez,

L-1724 Luxembourg; and

- Mr. Jabir CHAKIB, born on November 5, 1967 in Casablanca, Morocco, residing professionally at 53, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg.

H.R.T. Révision S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 51.238, is appointed as auditor of the Company for a term which shall expire at the first coming annual general meeting
of the Shareholders of the Company.

The registered office of the Company is set at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties who signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-six novembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1) OCM Luxembourg EPOF II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 133.351,

ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé,

2) OCM Luxembourg Glasnost Holdings GP, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 149.222,

ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé,

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

12493

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon

suivante les statuts d'une société en commandite par actions qui est ainsi constituée:

I. Nom - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé entre OCM Luxembourg Glasnost Holdings GP, souscripteur de l'action de

commandité en qualité d'actionnaire commandité (l'Actionnaire Commandité), les souscripteurs et tous ceux qui de-
viendront  propriétaires  d'Actions  de  Commandité  et  d'Actions  Ordinaires  émises  par  la  Société,  une  société  en
commandite par actions sous la dénomination de OCM Luxembourg Glasnost Holdings SCA (ci-après la Société), qui
sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans les limites de la commune par une résolution de l'Actionnaire Commandité. Le siège social peut par ailleurs être
transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution des Actionnaires délibérant de la manière
requise pour la modification des Statuts.

2.2 Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision de l'Actionnaire Commandité. Lorsque l'Actionnaire Commandité estime que des événements extraordi-
naires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la
communication de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, malgré ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres,
Actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette,
et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à
la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre effectuer
directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un portefeuille de
brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre,

obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra
prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs
de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés et la Société peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de
ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres
sociétés et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas,
pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en

vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou

indirectement ou se rapportent à son objet.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée illimitée.
4.2 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des Actionnaires de la Société délibérant de la

manière requise pour la modification des Statuts.

4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un des Actionnaires. En cas de décès, d'incapacité ou d'empêchement de
l'Actionnaire Commandité, l'article 112 de la Loi s'appliquera.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par
(i) une (1) action de commandité (l'Action de Commandité), et
(ii) trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ordinaires (les Actions Ordinaires),
Les Actions Ordinaires et la(les) Action(s) de Commandité sont collectivement désignées les Actions et individuelle-

ment une Action.

12494

Toutes les Actions sont nominatives, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, souscrites et entièrement

libérées.

Les Actions Ordinaires sont détenues par les Actionnaires Ordinaires. Les Actionnaires Ordinaires sont désignés ci-

après les Actionnaires Commanditaires. Les Actionnaires Commanditaires et l'Actionnaire Commandité sont ensemble
désignés les Actionnaires.

5.2 Le capital social autorisé de la Société est fixé à dix millions d'euros (EUR 10.000.000) et l'Actionnaire Commandité

est autorisé à émettre en plus des Actions existantes de la Société, un nombre total de neuf millions neuf cent soixante-
neuf mille (9.969.000) Actions, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et d'une valeur nominale totale de neuf
millions neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 9.969.000).

5.3 L'Actionnaire Commandité est autorisé pendant une période de 5 (cinq) ans à compter de la date de la constitution

de la Société à augmenter le capital social de la Société, à une ou plusieurs reprises, de trente-et-un mille euros (EUR
31.000) à dix millions d'euros (EUR 10.000.000),

(i) par la création et l'émission de nouvelles Actions de Commandité et/ou Actions Ordinaires;
(ii) par la détermination de la date et du lieu auxquels l'acte notarié constatant l'augmentation de capital sera passé;
(iii) par la renonciation ou limitation des droits de souscription préférentielle des Actionnaires concernant cette ou

ces émissions d'Actions et l'émission de ces Actions à la personne ou aux personnes, tel que l'Actionnaire Commandité
le décide;

(iv) par l'enregistrement par acte de notarié toute augmentation du capital social effectuée dans les limites du capital

autorisé et modification de l'article 5.1 des Statuts en conséquence; et

(v) par la modification du registre des Actions de la Société chaque fois qu'une augmentation du capital social est

effectuée dans les limites du capital social autorisé.

5.4 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des Ac-

tionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2 Les Actions Ordinaires.
(a) Toutes les Actions Ordinaires auront les droits et obligations qui leur seront accordés en vertu des Statuts et

seront identiques à tous les égards.

(b) Chaque Action Ordinaire donne droit à une voix aux assemblées générales des Actionnaires.
6.3 L'(es) Action(s) de Commandité.
(a) Toutes les Actions de Commandité auront les droits et obligations qui leur seront accordés en vertu des Statuts

et seront identiques à tous les égards.

(b) Chaque Action de Commandité donne droit à une voix aux assemblées générales des Actionnaires.
6.4 Un registre des Actions sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi, et il peut

être consulté par chaque Actionnaire qui le désire.

6.5 Les Actions seront cédées par une déclaration écrite de cession inscrite dans le registre des Actions de la Société,

qui sera exécutée par le cédant et le cessionnaire ou par leur mandataire respectif. La Société peut aussi accepter d'autres
instruments de cession qu'elle jugera satisfaisants comme preuve de cession.

6.6 Toute distribution versée sur les Actions, soit en numéraire ou en nature, sous toutes les formes (en ce compris

sans limitation) comme dividende, boni de liquidation, produits de rachat ou autre, sera payée et distribuée aux Action-
naires en prélevant sur les sommes disponibles à la distribution conformément à l'article 72-1, paragraphe (1) de la Loi,
ou en cas de rachat, conformément à l'article 49-8 de la Loi.

6.7 La Cession d'Actions peut être restreinte en vertu de tout contrat entre la Société et les Actionnaires.
6.8 Envers la Société, les Actions sont indivisibles, et la Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par Action. Les

copropriétaires indivis désigneront une seule personne qui les représentera auprès de la Société.

6.9 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites fixées par la Loi et les Statuts.

Art. 7. Responsabilité des Actionnaires.
7.1 L'Actionnaire Commandité est solidairement responsable pour les dettes de la Société dans la mesure où elles ne

peuvent pas être couvertes par les actifs de la Société.

7.2 Les Actionnaires Commanditaires sont responsables à hauteur du montant du capital qu'ils ont engagé dans la

Société en souscrivant les Actions.

III. Gestion - Représentation

Art. 8. Gestion de la Société.
8.1 La Société est administrée par l'Actionnaire Commandité.

12495

8.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux Actionnaires ou au Conseil

de Surveillance (défini ci-après) seront de la compétence de l'Actionnaire Commandité qui aura tous les pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.3 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

Actionnaires ou non, par l'Actionnaire Commandité.

8.4 L'Actionnaire Commandité est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société et le pouvoir de représenter

la Société dans le cadre de cette gestion journalière à un ou plusieurs fondés de pouvoir ou autres agents, Actionnaires
ou non, agissant individuellement ou conjointement.

8.5 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'Actionnaire Commandité ou par la signature indi-

viduelle ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été valablement délégué et dans les
limites de ce pouvoir.

8.6 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou personne ne sera affecté ou invalidé

par le fait que l'Actionnaire Commandité ou autres fondés de pouvoir de la Société a un intérêt dans la transaction, ou
est un directeur, Actionnaire, agent ou employé de cette autre société ou personne.

Art. 9. Responsabilité.
9.1 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, l'Actionnaire Commandité et les autres fondés de pouvoir

de la Société, ainsi que les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux
articles 8.3 et 8.4 des présents Statuts, seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les
coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès
ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou
délégués de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie,
ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages
et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits
dont peuvent jouir ces personnes.

IV. Assemblées générales des associés

Art. 10. Pouvoirs et Droits de vote.
10.1 L'assemblée générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l'organe entier des Actionnaires de

la Société.

10.2 Les résolutions des Actionnaires sont adoptées en assemblées générales conformément à la Loi et aux Statuts.

Art. 11. Convocation, Quorum, Majorité et Procédure de vote.
11.1 Les assemblées générales des Actionnaires de la Société sont convoquées par l'Actionnaire Commandité ou par

le Conseil de Surveillance par une convocation fixant l'ordre du jour et envoyée par lettre recommandé au moins huit
(8) jours avant l'assemblée à chaque Actionnaire à l'adresse mentionnée dans le registre des Actions.

11.2 Les assemblées des Actionnaires de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations

respectives des assemblées.

11.3 Si tous les Actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des Actionnaires de la Société

et se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra
se tenir sans convocation préalable.

11.4 Un Actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant une autre

personne comme mandataire (qui n'a pas besoin d'être un Actionnaire) par écrit, soit en original, soit par télégramme,
télex, facsimile ou courrier électronique.

11.5 Chaque Actionnaire peut également participer à toute assemblée des Actionnaires de la Société par conférence

téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, permettant à toutes les personnes
participant à l'assemblée de s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à une assemblée par ces moyens équivaut
à une participation en personne à ladite assemblée.

11.6 Chaque Actionnaire peut également voter grâce aux formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires

de vote contiennent la date et le lieu de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des résolutions proposées
ainsi que pour chaque résolution proposée, trois cases permettant aux Actionnaires de voter en faveur, contre ou de
s'abstenir de voter s'agissant de la résolution proposée. Les formulaires de vote doivent être envoyés par les Actionnaires
par courrier, télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique au siège social de la Société. La Société n'acceptera
que les formulaires de vote reçus avant la date de l'assemblée précisée dans la convocation. Les formulaires de vote qui
ne contiennent ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention seront nuls.

11.7 Sauf dispositions contraires prévues par la Loi ou les Statuts, les résolutions à une assemblée des Actionnaires de

la Société dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté à cette assemblée.

11.8 Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée pour modifier les Statuts ne pourra valable-

ment délibérer que si la moitié au moins du capital social est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications

12496

statutaires proposées. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée dans les formes statutaires
et de la Loi. La seconde assemblée délibèrera valablement quelle que soit la proportion du capital représentée. Dans les
deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.

V. Supervision - Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 12. Conseil de Surveillance.
12.1 La surveillance de la Société, en ce compris la surveillance de ses livres et comptes, sera confiée à un conseil de

surveillance composé d'au moins trois membres (le Conseil de Surveillance) qui n'ont pas besoin d'être Actionnaires. Les
membres du Conseil de Surveillance seront nommés par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société qui déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Ils seront élus pour une durée maximale de six ans
et seront rééligibles.

12.2 Le Conseil de Surveillance doit nommer un président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire.
12.3 Le Conseil de Surveillance aura les pouvoirs d'un commissaire aux comptes, tels que prévus par la Loi.
12.4 Le Conseil de Surveillance sera consulté par l'Actionnaire Commandité sur toutes les questions que l'Actionnaire

Commandité déterminera, et il pourra autoriser toutes les initiatives de l'Actionnaire Commandité qui, selon la Loi ou
les présents Statuts, dépassent les pouvoirs de l'Actionnaire Commandité.

12.5 Le Conseil de Surveillance est convoqué par l'Actionnaire Commandité ou par l'un de ses membres.
12.6 Une convocation écrite à toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins 24

(vingt-quatre) heures avant la date fixée de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances
sera précisée dans la convocation de ladite réunion du Conseil de Surveillance.

12.7 Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou

représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour de
la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du Conseil de Sur-
veillance de la Société soit en original, soit par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex. D'autres convocations
écrites ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un lieu prévus dans un calendrier préalablement
adopté par une résolution du Conseil de Surveillance.

12.8 Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant

par écrit, soit en original ou par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre membre comme son
mandataire.

12.9 Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité des voix exprimées. Si à une réunion,
il y a égalité du nombre de voix pour et contre une résolution, le vote du président sera prépondérant. Les résolutions
du Conseil de Surveillance seront consignées en procès-verbaux, signés par tous les membres présents ou représentés
à la réunion ou par le secrétaire (le cas échéant).

12.10 Tout membre peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou vidéo-

conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, permettant à toutes les personnes participant à la
réunion de s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation
en personne à ladite réunion.

12.11 Des résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Surveillance seront valables comme si

elles avaient été adoptées à une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures peuvent être apposées sur un
document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être envoyées en original, par télégramme,
télex, facsimile ou courrier électronique.

12.12 Les membres du Conseil de Surveillance ne contractent à raison de leur fonction aucune responsabilité per-

sonnelle  relativement  aux  engagements  régulièrement  pris  par  eux  au  nom  de  la  Société,  dans  la  mesure  où  ces
engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

12.13 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les membres du Conseil de Surveillance seront indemnisés

par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses qui leur incombent
en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut
actuel ou passé de membre du Conseil de Surveillance, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des
dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou dol, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ils
peuvent jouir.

Art. 13. Exercice social et Assemblée générale annuelle.
13.1 L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

13.2 Chaque année, à la fin de l'exercice, l'Actionnaire Commandité dresse le bilan et le compte de résultat de la

Société ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication de l'actif et du passif de la Société avec une annexe résumant tous
les engagements de la Société et les dettes des gérants, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes
de la Société.

12497

13.3 L'Actionnaire Commandité fournira, un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, les

pièces justificatives et un rapport sur les opérations de la Société au Conseil de Surveillance de la Société qui devra
préparer un rapport exposant ses projets.

13.4 L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société se tiendra, conformément au droit luxembourgeois,

au Luxembourg, à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que
stipulé dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas
un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

13.5 L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société peut se tenir à l'étranger, si l'Actionnaire Com-

mandité considère de manière absolue que des circonstances exceptionnelles telles qu'indiquées à l'Article 2.2 des Statuts
l'exigent.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette

affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social souscrit de
la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps en temps selon l'article 5 de ces
Statuts.

14.2 L'assemblée générale des Actionnaires de la Société décidera de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels

et décidera de payer des dividendes de temps en temps et à sa propre discrétion aux moments qu'elle jugera opportun
au regard des objectifs et de la politique de la Société.

14.3 Les dividendes, si exigibles, seront distribués au moment et au lieu fixés par l'Actionnaire Commandité confor-

mément à la décision de l'assemblée générale des Actionnaires. Les dividendes peuvent être payés en euro ou en toute
autre devise choisie par l'Actionnaire Commandité.

14.4 L'Actionnaire Commandité peut décider de payer des acomptes sur dividendes aux conditions et dans les limites

fixées par la Loi.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas

besoin d'être Actionnaires, nommés par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires qui déterminera leurs
pouvoirs et leur rémunération.

Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des Actionnaires de la Société, les liquidateurs seront investis

des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société.

15.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué

aux Actionnaires proportionnellement au nombre d'Actions détenues par chaque Actionnaire dans la Société.

VI. Disposition générale

16.1 Il est fait référence aux dispositions de la Loi pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique

dans ces présents Statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2010.

<i>Souscription et Paiement

Sur ces faits,
OCM Luxembourg Glasnost Holdings GP, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à

une (1) Action de Commandité sous forme nominative, d'une valeur d'un euro (EUR 1), et la libérer par un apport en
espèces s'élevant à un euro (EUR 1).

OCM Luxembourg EPOF II S.à r.l., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente

mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30.999) Actions Ordinaires sous forme nominative, d'une valeur d'un euro (EUR
1) chacune, et les libérer par un apport en espèces s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR
30.999).

Le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire

instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à EUR 1.500.-

<i>Résolutions des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les Actionnaires de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit ont pris les résolutions suivantes:

12498

Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Surveillance de la Société pour une durée qui expirera

à la première assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société:

- M. Justin BICKLE, né le 11 janvier 1971 à Plymouth, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 27 Knights-

bridge, Londres SW1X 7LY, Angleterre;

- M. Hugo NEUMAN, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, les Pays-Bas, ayant sa résidence au 16, rue J.B. Fresez,

L-1724 Luxembourg; et

- M. Jabir CHAKIB, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse professionnelle au 53, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg.

H.R.T. Révision S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 27, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.238, est
nommée réviseur de la Société pour une durée qui expirera à la première assemblée générale annuelle des Actionnaires
de la Société.

Le siège social de la Société est établi au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version
anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé, avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2009. Relation: LAC/2009/51991. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010010520/634.
(100003310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Advantage Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 132.389.

Les administrateurs de la société ADVANTAGE PARTICIPATION S.A., société anonyme de droit luxembourgeois,

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132 389, jusqu'alors établi
au 8-10, Rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, ont démissionné de leur poste d'administrateur de la société avec effet
au 06 janvier 2010.

Luxembourg, le 06 janvier 2010.

Nathalie MAGER / Helena TONINI-DI VITO / Pierfrancesco AMBROGIO
<i>Présidente/Administrateur démissionnaire / Administrateur démissionnaire / Administrateur démissionnaire

Référence de publication: 2010011155/14.
(100003266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Field Point I-A RE 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.073.

AUSZUG

Es muss folgendes beachtet werden:
Die Aktionäre haben am 25. November 2009 beschlossen Herrn Julien Goffin, geboren am 27. März 1980 in Verviers

(Belgien), 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, als Geschäftsführer B des Geschäftsführerrats zu ernennen mit sofortiger
Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Luxemburg, den 08/01/2010.

Vincenzo Viceconte.

Référence de publication: 2010011430/14.
(100003927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12499

Future Entertainment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 400.000,00.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

R.C.S. Luxembourg B 145.414.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 18 décembre 2009 et amendé le 29 décembre

2009 que

la société Virgin Media Investment Holdings Limited, ayant son siège social à 160 Great Portland Street, London W1W

5QA, enregistrée sous le numéro 3173552 au Registre des sociétés à Cardiff

a cédé les 400 000 (quatre cent mille) parts sociales de valeur nominale GPB 1,00 (une livre sterling) qu'elle détenait

dans la société Future Entertainment Sàrl RCS Luxembourg B 145.414, Luxembourg

à la société Virgin Media Investments Limited, ayant son siège social à 160 Great Portland Street, London W1W 5QA,

enregistrée sous le numéro 7108297 au Registre des sociétés à Cardiff

avec effet au 1 

er

 janvier 2010 («transfer time 00.01 am GMT»)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010011176/21.
(100003362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Multi Units Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.129.

<i>Extrait de la résolution prise lors du conseil d'administration du 25 novembre 2009

1. Démission de Monsieur Matthieu FORTIN en tant qu'Administrateur.
Le Conseil d'administration prend note de la démission de Monsieur Matthieu FORTIN, résidant professionnellement

au 17, Cours Valmy, F-92 987 Paris - La Défense, France, de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 25 novembre
2009.

2. Cooptation de Monsieur Lionel PAQUIN en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Matthieu FOR-

TIN.

Conformément aux prescriptions de l'article 21 des Statuts coordonnés du 5 octobre 2009, le Conseil d'administration

décide de coopter, Monsieur Lionel PAQUIN, résidant professionnellement au 17, Cours Valmy, F-92 987 Paris-La Dé-
fense,  France,  aux  fonctions  d'Administrateur,  en  remplacement  de  Monsieur  Matthieu  FORTIN,  avec  effet  au  25
novembre 2009 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Générale Securities Services Luxembourg
MJ. FERNANDES / Signature

Référence de publication: 2010011177/21.
(100003287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Eneris Wind Italia SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 107.759.

La Fiduciaire du Large porte à la connaissance du grand public qu'en date du 29 décembre 2009 elle a dénoncé, avec

effet au 1 

er

 janvier 2010, son contrat de domiciliation avec la société ENERIS WIND ITALIA SA (RCSL: B107759).

De ce fait, la société ENERIS WIND ITALIA SA n'est plus domiciliée à L-5753 Frisange, 43 Parc Lésigny.

Fiduciaire du Large
R. CIMOLINO
<i>Associé-Gérant

Référence de publication: 2010011584/12.
(100004313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12500

Field Point I-A RE 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.585.

AUSZUG

Es muss folgendes beachtet werden:
Der Aktionär hat am 25. November 2009 beschlossen Herrn Julien Goffin, geboren am 27. März 1980 in Verviers

(Belgien), 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, als Geschäftsführer B des Geschäftsführerrats zu ernennen mit sofortiger
Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Luxemburg, den 08/01/2010.

Vincenzo Viceconte.

Référence de publication: 2010011431/14.
(100003932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

S5 Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 105.950.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société "S5 Finco,

S.à r.l.", reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 14 décembre 2009, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15592.

- que la société "S5 Finco, S.à r.l." (la "Société"), société anonyme, établie et ayant son siège social au 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
105950,

constituée suivant acte du notaire soussigné du 18 juin 2004 et publié au Mémorial C numéro 501 du 27 mai 2005;
se trouve à partir de la date du 14 décembre 2009 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 29 janvier 2007 aux termes de laquelle la

Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l'occurrence au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME délivré aux fins de publication au Mémorial C.

Belvaux, le 8 janvier 2010.

Référence de publication: 2010011560/25.
(100003829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Rock Ridge RE 10, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 126.091.

AUSZUG

Es muss folgendes beachtet werden:
Die Aktionäre haben am 30. November 2009 beschlossen Herrn Julien Goffin, geboren am 27. März 1980 in Verviers

(Belgien), 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, als Geschäftsführer B des Geschäftsführerrats zu ernennen mit sofortiger
Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Luxemburg, den 08/01/2010.

Vincenzo Viceconte.

Référence de publication: 2010011433/14.
(100003940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12501

Rock Ridge RE 8, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.529.

AUSZUG

Es muss folgendes beachtet werden:
Die Aktionäre haben am 30. November 2009 beschlossen Herrn Julien Goffin, geboren am 27. März 1980 in Verviers

(Belgien), 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, als Geschäftsführer B des Geschäftsführerrats zu ernennen mit sofortiger
Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Luxemburg, den 08/01/2010.

Vincenzo Viceconte.

Référence de publication: 2010011434/14.
(100003941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Rock Ridge RE 20, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.240.

AUSZUG

Es muss folgendes beachtet werden:
Die Aktionäre haben am 26. November 2009 beschlossen Herrn Julien Goffin, geboren am 27. März 1980 in Verviers

(Belgien), 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, als Geschäftsführer B des Geschäftsführerrats zu ernennen mit sofortiger
Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Luxemburg, den 08/01/2010.

Vincenzo Viceconte.

Référence de publication: 2010011435/14.
(100003947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Oxford Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 109.929.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 30 octobre 2009

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société du 69, Boulevard de la Pétrusse, L - 2320

Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L - 1130 Luxembourg avec effet au 1 

er

 janvier 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010011592/12.
(100004496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Oterna Holding B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 99.106.

Le bilan au 31.12.2007 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010011698/11.
(100003908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12502

Oterna Holding B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 99.106.

Le bilan au 31.12.2005 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010011700/11.
(100003904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Oterna Holding B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 99.106.

Le bilan au 31.12.2004 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010011701/11.
(100003902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Oterna Holding B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 99.106.

Le bilan au 31.12.2003 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010011702/11.
(100003900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Clover Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 129.901.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010011789/10.
(100004423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Ril Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.663.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010011777/11.
(100004611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12503

CIPA Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 129.003.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2010011778/11.
(100004610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Pegasus Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 129.904.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010011790/10.
(100004421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Matthijs Bogers
<i>Administrateur et président du conseil d'administration

Référence de publication: 2010011791/12.
(100004417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Compagnie Financière du Quinzième Siècle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.200.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010011793/10.
(100004411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Fina Cold II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 106.661.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2010011796/13.
(100004465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12504

Fina Cold II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 106.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2010.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2010011797/12.
(100004463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

June S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.707.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010011645/14.
(100004113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Software Development &amp; Consulting, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R.C.S. Luxembourg B 29.056.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

<i>Pour SOFTWARE DEVELOPMENT &amp; CONSULTING S.A.
Pierre HOFFMANN
<i>Commissaire aux Comptes

Référence de publication: 2010011748/14.
(100004041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

LBREM II NW Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.599.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 Décembre 2009.

<i>Pour LBREM II NW Holdings S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010011649/13.
(100004176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12505

Dova Société Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 132.411.

Par décision du Conseil d'administration du 29 décembre 2009, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L - 1145 Luxembourg au 283, route d'Arlon, L -1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 0 7 JAN. 2010.

<i>Pour DOVA SOCIETE IMMOBILIERE S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner
<i>Vice-Président / -

Référence de publication: 2010011575/16.
(100004025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Delta Courtage International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 76.474.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement du 07/01/2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a

déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société Delta Courtage International S.A.R.L., avec
siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a ordonné
la publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge du Trésor.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Me Radia DOUKHI.

PAGE DIFFUSION S.A. (en liquidation)
Siège social: 11A, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 67788

<i>Extrait

Par jugement du 07/01/2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a

déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société Page Diffusion S.A., avec siège social à L-1840
Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a ordonné la publication du
dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge du Trésor.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Me Radia DOUKHI.

EUROPEENNE FAST INVEST S.A. (en liquidation)
Siège social: 180, Rue des Aubépines
L-1145 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 63964

<i>Extrait

Par jugement du 07/01/2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a

déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société Européenne Fast Invest S.A., avec siège
social à L-1145 Luxembourg, 180, Rue des Aubépines, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a ordonné la
publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge du Trésor.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Me Radia DOUKHI.

Référence de publication: 2010011600/37.
(100004547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12506

Caragana S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 26.100.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion

<i>du Conseil d'Administration tenue le 5 mai 2009

<i>Résolutions

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Joseph WINANDY comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2010011405/15.
(100003975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

LSREF Kachidoki Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LSREF Lux Investments VIII S.à r.l.).

Capital social: EUR 16.375,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.866.

In the year two thousand and nine, on the twentieth day of November.
Before Us Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stumper, L-2557

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by
Mr Philippe Detournay,

here represented by Miss Julie Carbiener, paralegal, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Luxembourg on 19 November 2009,

(the Sole Shareholder),
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF

Kachidoki Investments S.à r.l. (formerly LSREF Lux Investments VIII S.à. r.l) (the Company), established under the laws
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 147.866, incorporated
pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 21 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations C-N° 1837 of 23 September 2009, amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer dated 16 November 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that

it may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand

five hundred euro) by an amount of EUR 3,875 (three thousand eight hundred seventy-five euro) to an amount of EUR
16,375 (sixteen thousand three hundred seventy-five euro) by the issuance of 31 (thirty-one) new ordinary shares, with
a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, and to pay a share premium of EUR 26.85 (twenty-six
euro and eighty-five cent); and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company. This having been declared, the Sole Share-

holder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500

(twelve thousand five hundred euro), represented by 100 (one hundred) ordinary shares with a nominal value of EUR
125 (one hundred and twenty-five euro) each, by an amount of EUR 3,875 (three thousand eight hundred seventy-five
euro) to an amount of EUR 16,375 (sixteen thousand three hundred seventy-five euro), represented by 131 (one hundred
thirty-one) ordinary shares with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, by way of the

12507

issuance of 31 (thirty-one) new ordinary shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro)
each, and to pay a share premium of EUR 26.85 (twenty-six euro and eighty-five cent).

All the 31 (thirty-one) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share

premium has been paid by Lone Star Capital Investments S.à r.l. so that the amount of EUR 3,901.85 (three thousand
nine hundred and one euro and eighty-five cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the
undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the share capital increase, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 131 (one hundred thirty-

one) ordinary shares of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association

of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR16,375 (sixteen thousand three hundred seventy-five

euro), represented by 131 (one hundred thirty-one) ordinary shares with a nominal value of EUR125 (one hundred and
twenty-five euro) each."

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt novembre.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg.

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stumper, L-2557

Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée
par Philippe Detournay,

ici représentée par Mlle Julie Carbiener, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Luxembourg le 19 novembre 2009,

(l'Associé Unique),
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée LSREF Kachidoki Investments S.à r.l. (précédemment LSREF Lux Invest-
ments VIII S.à. r.l.) (la Société), société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.866, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer du 21 août 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N°1837 du 23 septembre 2009, modifié par acte de Maître
Martine Schaeffer du 16 novembre 2009, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation de capital de la Société de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) par un

montant de EUR 3.875 (trois mille huit cent soixante-quinze euros) à un montant de EUR 16.375 (seize mille trois cent
soixante-quinze euros) par voie d'émission de 31 (trente et une) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur
nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et paiement d'une prime d'émission de EUR 26,85 (vingt-six euros
et quatre-vingt-cinq cents); et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR

12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de
EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par le biais d'une augmentation de EUR 3.875 (trois mille huit cent soixante-
quinze euros) à un montant de EUR 16.375 (seize mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par 131 (cent trente

12508

et une) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'émis-
sion de 31 (trente et une) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq
euros) chacune, et de payer une prime d'émission d'un montant de EUR 26,85 (vingt-six euros et quatre-vingt-cinq cents).

Toutes les 31 (trente et une) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et libérées

en numéraire et la prime d'émission a été payée par Lone Star Capital Investments S.à r.l., de sorte que la somme de EUR
3.901,85 (trois mille neuf cent un euros et quatre-vingt-cinq cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 131 (cent trente et une) parts

sociales ordinaires émises par la Société.

<i>Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'associé unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société,

dont la version française aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 16.375 (seize mille trois cent soixante-quinze euros),

représenté par 131 (cent trente et une) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq
euros) chacune."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: J. Carbiener, C. Wersandt.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 novembre 2009. LAC/2009/49933. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010010054/122.
(100002871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.

LYXOR CTA Diversified Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.488.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Générale Securities Services Luxembourg
<i>Corporate and Domiciliary Agent
MJ. FERNANDES / Signature

Référence de publication: 2010011703/12.
(100003891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

MGE Objekt Berlin S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.036.

Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MGE Objekt Berlin S. à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010011712/12.
(100003974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

12509

Bairlinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 94.272.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion

<i>du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 1 

<i>er

<i> juillet 2009

<i>Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Joseph WINANDY comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2010011417/15.
(100003886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Alsena S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 141.707.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale

<i>Ordinaire tenue au siège de la société le 23 décembre 2009

Les actionnaires prennent note du nouveau commissaire, PKF Abax Audit, R.C.S. B 142.867, ayant son siège social au

6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en remplacement de la société PKF Abax Audit, R.C.S. B 27.761, ayant son siège
social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2010011364/17.
(100004152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Tractim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.200.000,00.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.

R.C.S. Luxembourg B 98.174.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique datées du 7 décembre 2009

L'Associé Unique a décidé de prendre les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission avec effet au 7 décembre 2009 de:
* M. Uwe Schuht, gérant unique
- de nommer comme nouveau gérant de la société, avec effet au 7 décembre 2009 pour une durée illimitée:
* M. Denis Pradon, gérant unique ayant son adresse privée au 193 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

<i>Pour Tractim S.à r.l.
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2010011160/22.
(100003034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

12510

aeris CAPITAL Amperio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 150.462.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the eleventh of December
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

The company aeris CAPITAL Holding GmbH, having its registered office at Schützenstrasse 4, CH-8808 Pfäffikon SZ,

registered at the Trade and Companies' Registrar of Kanton Schwyz under number CH-170.3.029.220-5.

here represented by Diane Wolf, private employee, with professional address at 21, avenue de la Liberté, L-1931

Luxemburg,

by virtue of a proxy, given on December 10, 2009.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is declared organized and the
articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of aeris CA-

PITAL Amperio S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control
and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies or  funds  in  which it holds  a  direct  or  indirect  participation or which form  part of  the same  group  of
companies/funds as the Company, grant loans or otherwise assist the companies or funds in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies/funds as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any

debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several
managers, of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred EUR (EUR 12,500.-) represented by one

hundred twenty five (125) shares with a par value of one hundred EUR (EUR 100.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

three quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.

12511

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder

is subject to the approval of such transfer given by shareholders representing at least three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors,
subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided

by law.

Art. 9. The death, legal incapacity, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any similar event

regarding the sole shareholder or any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who
fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be,
the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the individual signature of any manager and by the signature of any duly authorised signatory within the limits
of such authorisation.

Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and, as the case may be, a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail
or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at
a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his
colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous
basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting; in case of tied votes, the chairman shall have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

12512

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

Art. 15. The manager or, in case of several managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on

the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.

D. Supervision of the company

Art. 16. The operations of the Company may be supervised by one or several statutory auditors, which need not be

shareholders. The general meeting of shareholders may appoint one or more statutory auditor(s) and determines the
term of its (their) office. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the general meeting of
shareholders will appoint one or more statutory auditor(s).

If the Company exceeds the limits of two of the three criteria determined by article 35 of the law of 19 December

2002 concerning the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings for a
period as set out by article 36 of the same law, the institution of statutory auditor(s), if any, is suppressed and one or
more independent auditor(s) (réviseur d'entreprise) chosen among the members of the Institut des Réviseurs d'Entre-
prises will be designated by the general meeting of shareholders, which fixes their number and the term of their office.

E. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18 .The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as
they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least.

Art. 19; In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general
meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as
applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's financial year commences on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of the same year.

Art. 21. Each year on 31 

st

 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until

such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who need not be shareholders, and who are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 24. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg

law.

All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

12513

aeris CAPITAL Holding GmbH, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 shares

All the shares subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of this deed of the Company and shall terminate on 31. December 2010.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>General meeting of shareholders

The sole shareholder, exercising the powers of the general meeting of shareholders and representing the entire share

capital of the Company, has immediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg;
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:
- Achim Welschoff, born in Trier on 16 

th

 August 1965, professionally residing at 21, avenue de la Liberté, L-1931

Luxemburg

- Mario Warny, born in St. Vith (Belgium) on 22 

nd

 September 1973, professionally residing at 21, avenue de la Liberté,

L-1931 Luxemburg

-

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahr zweitausendneun am elften Dezember.
vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

Die Gesellschaft aeris CAPITAL Holding GmbH, mit Geschäftssitz Schützenstrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ, eingetragen

im Handels- und Gesellschaftsregister vom Kanton Schwyz unter Nummer CH-170.3.029.220-5.

hier vertreten durch Frau Diane Wolf, Privatangestellte, geschäftlich ansässig in 21, avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xemburg,

aufgrund einer am 10. Dezember 2009 ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht.
Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Partei und

den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben angegeben, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, wie hiermit beschlossen wird und deren Satzung wie folgt
lautet:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Firmennamen

aeris CAPITAL Amperio S.à r.l. (nachstehend die "Gesellschaft") welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handels-
gesellschaften  vom  10.  August  1915  in  seiner  aktuellen  Fassung  (das  "Gesetz  über  Handelsgesellschaften")  und  den
Bestimmungen der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften/Fonds, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten

12514

einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften/Fonds zu sichern, ihnen Kredite ge-
währen oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell

alle Arten von Schuld- bzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen
Recht ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang

mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich er-
scheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz

kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Be-
schluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern,

durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
errichten.

Sollten der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaft-

liche  oder  gesellschaftliche  Entwicklungen  aufgetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen,  welche  die  gewöhnlichen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Nor-
malisierung der Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf
die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxem-
burgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in hundertfünfund-

zwanzig (125) Anteile zu je hundert Euro (EUR 100,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei

viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Handelsgesellschaften geändert
werden.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,

so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.

Im Fall des Todes eines Gesellschafters können die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an einen Dritten nur mit

Zustimmung der Inhaber von Anteilen, die drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten und im Übereinstimmung
mit unter den Voraussetzungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden. Eine derartige Zustimmung
ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, jedoch höchstens vierzig (40), sofern sich gesetzlich

nichts Gegenteiliges vorgeschrieben ist.

Art. 9. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch Geschäftsunfähigkeit, noch durch Entmündigung, Auflösung,

Bankrott oder Zahlungsunfähigkeit einer ihrer Gesellschafter, oder irgendein ähnliches Ereignis betreffend den Alleinge-
sellschafter, aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müs-

sen.

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer,

unter allen Umständen unbeschränkt befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck
im Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesell-
schafter bzw. durch die Gesellschafter bestellt, welche(r) die Dauer ihrer Amtszeit festlegt(festlegen). Die Bestellung eines
Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von den Gesellschaftern
widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäfts-

führern  durch  die  Einzelunterschrift  jedes  Geschäftsführers  und  durch  die  Unterschrift  eines  jeden  ordnungsgemäß
Bevollmächtigten im Rahmen dieser Bevollmächtigung verpflichtet.

12515

Art. 11. Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch den Rat der Geschäftsführer geleitet,

welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen kann. Sie
kann außerdem einen Schriftführer bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokolle
der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem im Einladungs-

schreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht
anders im Einladungsschreiben bestimmt. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung
wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen
anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt

ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einla-
dungsschreiben angegeben werden müssen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, Fax, Email
oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für
Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäfts-
führungsbeschluss festgesetzt wurden.

Sind alle Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder bei Falle schriftlichen Beschlüssen, denen alle

Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein Einladungsschreiben er-
forderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels

einer schriftlich oder durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten
lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares

Kommunikationsmittel  teilnehmen,  sofern  dieses  den  an  der  Sitzung  teilnehmenden  Personen  eine  ununterbrochene
Verständigung untereinander erlaubt und eine effektive Teilnahme dieser Teilnehmer an der Sitzung ermöglicht. Eine
derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit der Ge-

schäftsführer  bei  einer  Sitzung  anwesend  oder  vertreten  ist.  Beschlüsse  der  Geschäftsführung  werden  mit  einfacher
Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit hat der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit
der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

Art. 12. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge der Protokolle,
die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 13. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 14. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen

der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 15. Der Geschäftsführer oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer kann

entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von dem oder den Geschäftsführer(n) erstellten vorläufigen Ab-
schlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die
auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht
um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die
aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten
dürfen.

D. Beaufsichtigung der Gesellschaft

Art. 16. Die Geschäfte der Gesellschaft können der Beaufsichtigung durch einen oder mehrere satzungsgemäße Rech-

nungsprüfer unterstellt sein, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung kann einen
oder mehrere Rechnungsprüfer ernennen und ihre Amtszeit festlegen. Sofern die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig
(25) Gesellschafter hat, muss die Hauptversammlung einen oder mehrere satzungsgemäße Rechnungsprüfer ernennen.

Falls die Gesellschaft zwei der drei in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- und Ge-

sellschaftsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmten Kriterien innerhalb des
in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraumes überschreitet, wird das Amt des satzungsgemäßen Rechnungs-
prüfers abgeschafft und ein oder mehrere unabhängige Rechnungsprüfer (réviseur d'entreprise) unter den Mitgliedern

12516

des Institut des Réviseurs d'Entreprises durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche auch die Anzahl
sowie deren Amtszeit festlegen.

E. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen

teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 18. Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die durch Gesetz und diese Satzung verliehenen Befugnisse.

Sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vorschreibt, werden gemeinsame Beschlüsse nur wirksam gefasst,
soweit sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet werden.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere Änderung der Satzung bedarf

der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt

XII  des  Gesetzes  über  Handelsgesellschaften  verliehenen  Befugnisse  aus.  In  diesem  Fall  ist  jede  Bezugnahme  auf  die
"Hauptversammlung der Gesellschafter" je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als eine Bezugnahme auf den
Alleingesellschafter zu verstehen und die der Hauptversammlung der Gesellschafter verliehenen Befugnisse werden von
dem Alleingesellschafter ausgeübt.

F. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der

Rat der Geschäftsführer erstellt eine Bestandsaufnahme, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlich-
keiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in diese Bestandsaufnahme und
die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

G. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der

Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung be-
stimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die weitestgehenden
Befugnisse im Hinblick auf die Realisierung der Vermögenswerte und die Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft.

Der Überschuss, der aus der Realisierung der Vermögenswerte und der Begleichung der Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesell-
schaftskapital aufgeteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 24. Auf diese Satzung sollen die Gesetze Luxemburgs Anwendung finden, nach welchen sie errichtet und ausgelegt

werden soll.

Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils

gültigen Fassung geregelt.

<i>Zeichnung und Zahlung der Anteile

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

aeris CAPITAL Holding GmbH, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile

Der Ausgabebetrag aller gezeichneten Anteile wurde vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab sofort zur Verfügung steht, was dem beurkundenden Notar nach-
gewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare

oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. EUR 1.500.- geschätzt.

12517

<i>Hauptversammlung der Gesellschafter

Der Alleingesellschafter, handelnd in Ausübung der Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter und das

gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertretend, hat unmittelbar anschließend an die Gründung der Gesellschaft fol-
gende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg.
2. Als Geschäftsführer der Gesellschaft werden bestellt für eine unbestimmte Dauer:
- Herr Achim Welschoff, geboren am 16. August 1965 in Trier, geschäftlich ansässig in 21, avenue de le Liberté, L-1931

Luxemburg

- Herr Mario Warny, geboren am 22. September 1973 in St. Vith (Belgien), geschäftlich ansässig in 21, avenue de le

Liberté, L-1931 Luxemburg

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf

Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird;
auf Verlangen der erschienenen Partei und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung, kommt
der englischen Fassung Vorrang zu.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienen Partei, welcher dem Notar mit Name, Vorname und

Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienen Partei unter-
zeichnet worden.

Gezeichnet: D. WOLF und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55237. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE - zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 23. Dezember 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010010521/399.
(100003116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Gadwall Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 138.977.

Le bilan au 31 Décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010011713/12.
(100003970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Duchess Street Holdings SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.766.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010011757/10.
(100004349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Evanio Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 67.949.

Le bilan au 31 Décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

12518

Luxembourg, le 7 janvier 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010011714/12.
(100003965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Glaxosmithkline Dungarvan and Stafford-Miller (Ireland) S.N.C., Société en nom collectif.

Capital social: EUR 10.896,00.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.398.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of December.
Before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN and
STAFFORD-MILLER (IRELAND) S.N.C, a Luxembourg general partnership ("société en nom collectif), having its re-

gistered office at 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a notarial deed of
Maître Henri Hellinckx dated 21 December 2006, registered with the Luxembourg trade and companies register under
number B 123.398, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 347 and dated 10
March 2007 (the "Company"). The articles of association of the Company have been lastly amended by notarial deed
enacted on 21 April 2009, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 933 and
dated 8 May 2009.

The meeting is presided by Marc Albasser, residing professionally at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Jérôme Schmit, residing professionally in Esch/Alzette, and the meeting elects as

scrutineer Michele Sensi, residing professionally in Esch/Alzette.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders of the Company (i) GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, a company organized under the laws of

the Republic of Ireland, having its registered office at Knockbrack, Dungarvan, Dungarvan. Co. Waterford, Republic of
Ireland ("GSKDL") and (ii) Stafford-Miller (Ireland) Limited, a company organized under the laws of the Republic of Ireland,
having its registered office at Clocherane, Youghal Road, Dungarvan. Co. Waterford, Republic of Ireland ("SMIL"), are
duly represented by Mrs Catherine Baflast, lawyer from the law firm Noble &amp; Scheidecker, with professional address at
398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to proxies given under private seal on 17
December 2009. The number of units held by the shareholders of the Company is shown on an attendance list. That list
and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list all the 120 (one hundred twenty) units, representing the whole capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders
expressly state that they have been duly informed beforehand

III. - The shareholders waive their rights to the prior notice of the current meeting; they acknowledge being sufficiently

informed beforehand on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. The shareholders resolve further that all the documentation produced to the meeting have
been put at their disposal within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

IV.  -  The  Company,  GLAXOSMITHKLINE  DUNGARVAN  and  STAFFORD-MILLER  (IRELAND)  S.N.C.  (formerly

known as AstraZeneca Tika S.N.C), a Luxembourg general partnership ("société en nom collectif), having its registered
office at 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a notarial deed dated 21
December 2006, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 123.398, published in
the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 347 and dated 10 March 2007.

V. - The corporate capital of the Company is fixed at EUR 10.896 (ten thousand eight hundred ninety-six Euros) divided

into 120 (one hundred twenty) units without a fixed nominal value, which is entirely subscribed and fully paid up.

VI. - GSKDL is the owner of 95% of the units of the Company and SMIL is the owner of 5% of the units of the Company.
VII. - The shareholders approve the interim balance sheet of the Company as at that the date hereof attached hereto

(the "Schedule A") and declare that the Company's activities having ceased, the shareholders decide to proceed with the
dissolution of the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

VIII. - GSKDL is appointed as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any acts

and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes
of this act.

That the shareholders resolve to renounce to the appointment of a liquidation auditor.
GSKDL, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:

12519

(i) the Company does no longer carry out any activity;
(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in

Schedule A, are hereby assigned, transferred and conveyed to GSKDL and SMIL in proportion of their respective share-
holdings in the Company, which have acknowledged and consented to this assignment;

(iii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described

in Schedule A, are hereby assumed, transferred and conveyed to GSKDL and SMIL in proportion of their respective
shareholdings in the Company which have acknowledged and consented to this transfer;

(iv) any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly supplied with and GSKDL and SMIL,

irrevocably undertake to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company up
to their respective participation in the Company.

IX. - Discharge is given to the managers of the Company:
- Georges Dassonville, manager A, residing at 5, rue Henri Kirpach, L-8237 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg;
- Stephen Charlesworth, manager B, residing at 20, Van Deventerlaan, NL-3528 AE Utrecht, Netherlands;
X. - GSKDL declares that the liquidation of the Company is closed.
XI. - The shareholders of the Company also resolve to grant all specific powers to Mr. Georges Dassonville, prenamed,

in order:

(i) to do and perform all and everything necessary with respect to the dissolution and liquidation further to its closing,

in particular but not only to transfer any remaining funds to the shareholders and to close any bank account of the
Company.

XII. - The shareholders of the Company resolve to grant all powers to any employee of the notary office of the

undersigned notary, in order:

(i) to proceed to the filings and publications as required by Article 151 of the Law of 10 August 1915 concerning

commercial companies as amended; and

(ii) to do and to execute any document or notices with respect to the filings and publications referred to here above.
XIII. - The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years in Luxembourg at the

former registered office of the Company, 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg.

That the share register of the Company has then been cancelled

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 1,000.-

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deux décembre.
Par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN and STAF-

FORD-MILLER (IRELAND) S.N.C., une société en nom collectif, ayant son siège social à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer,
Grand-duché de Luxembourg, constitué selon acte notarié de Maître Henri Hellinckx du 21 décembre 2006, inscrite au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 123.398, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 347 et daté du 10 mars 2007 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par acte notarié passé en date du 21 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations numéro 933 et daté du 8 mai 2009.

L'assemblée est présidée par Marc Albasser, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Jérôme Schmit, résidant professionnellement à Esch/Alzette et l'assemblée

choisit comme scrutateur Michèle Sensi, résidant professionnellement à Esch/Alzette.

Le président demande au notaire d'acter que:
I.- Les associés de la Société, (i) GlaxoSmithKIine Dungarvan Limited, société de droit irlandais, ayant son siège social

à Knockbrack, Dungarvan, Dungarvan. Co. Waterford, Irlande ("GSKDL") et (ii) Stafford-Miller (Ireland) Limited, société
de droit Irlandais, ayant son siège social à Clocherane, Youghal Road, Dungarvan. Co. Waterford, Irlande ("SMIL"), re-
présentées par Maître Catherine Baflast, Avocat à la Cour au sein de l'étude Noble &amp; Scheidecker, résidant profession-
nellement à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé données le 17 décembre

12520

2009. Le nombre de parts détenues par les associés de la Société est repris dans la liste de présence. La liste de présence
et les procurations, paraphées par le comparant et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 120 (cent-vingt) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social

de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à
l'ordre du jour et pour lesquels les associés déclarent expressément avoir été dûment informés.

III.- Les associés renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; ils reconnaissent avoir été

suffisamment informés auparavant de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence
acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les associés décident en outre que
l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à leur disposition dans un laps de temps
suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

IV.-  La  Société  GLAXOSMITHKLINE  DUNGARVAN  and  STAFFORD-MILLER  (IRELAND)  S.N.C.,  (anciennement

connue sous le nom de AstraZeneca Tika S.N.C.), société en nom collectif de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, constituée selon acte notarié du 21 décembre 2006,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 123.398, publié au Mémorial C sous le
numéro 347 le 10 mars 2007.

V.- Le capital social de la Société est fixé à 10.896 EUR (dix mille huit cent quatre-vingt-seize euros) divisé en 120

(cent-vingt) parts sociales sans valeur nominale, qui est entièrement souscrit et réglé.

VI.- GSKDL est le détenteur de 95% des parts sociales de la société et SMIL est le détenteur de 5% des parts sociales

de la société.

VII.- Les associés approuvent le bilan intérimaire de la Société en date de la présente et annexé aux présentes (l'

"Annexe A") et déclarent que les activités de la Société ayant cessé, les associés décident de procéder à la dissolution de
la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

VIII.- GSKDL est nommé liquidateur de la Société et aura tous pouvoirs de signer, exécuter, et délivrer tous actes et

tous documents, de faire toute déclaration et de réaliser tout acte nécessaire ou utile pour donner effet à l'objet de cet
acte.

Les associés décident de renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
GSKDL, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) La Société ne poursuit plus d'activité;
(ii) Tous les droits, titres, intérêts et obligations, en rapport avec l'actif existant de la Société, tels que décrits dans

l'annexe A, sont dorénavant confiés, transférés et transmis à GSKDL et SMIL en proportion de leur participation dans la
Société, qui ont reconnu et consenti à ce transfert.

(iii) Tous les droits, titres, intérêts et obligations, en rapport avec le passif existant de la Société, tels que décrits dans

l'annexe A, sont dorénavant assumés, transférés et transmis à GSKDL et SMIL en proportion de leur participation dans
la Société, qui ont reconnu et consenti à ce transfert,

(iv) Tout passif exceptionnel en relation avec la clôture de la liquidation est dûment pris en charge par GSKDL et SMIL,

qui entreprennent définitivement d'assumer et de régler toute dette actuellement inconnue ou impayée de la Société
dissoute; IX.- Décharge donnée aux gérants de la Société:

- Georges Dassonville, gérant A, résidant à 5, rue Henri Kirpach, L - 8237 Mamer, Grand Duché de Luxembourg;
- Stephen Charlesworth, gérant B, résidant à 20, Van Deventerlaan, NL - 3528 AE Utrecht, Pays-Bas;
X.- GSKDL déclare que la liquidation de la Société est close. XI.- Les associés décident également d'accorder tous

pouvoirs à M. Georges Dassonville, soussigné, afin de:

(i) accomplir tous les actes nécessaires en lien avec la dissolution et la liquidation après sa clôture et notamment de

procéder au transfert de tout fonds restant au profit des associés ainsi que de la clôture de tout compte bancaire de la
Société.

XII.- Les associés décident également d'accorder tous pouvoirs à tout employé de l'Etude du notaire soussigné, afin

de:

(i) procéder aux dépôts et aux publications requises par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales telle que modifiée;

(ii) établir ou signer tout document ou notification en rapport avec les dépôts et publications mentionnées ci-dessus.
XIII.- Les livres et les documents de la Société seront conservés pour une période de 5 (cinq) ans au Luxembourg à

l'ancien siège social de la Société, 53, route d'Arlon, Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.

Il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 1.000,- EUR.

12521

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé ensemble avec nous, notaire, le présent

acte.

Signé: M. Albasser, J. Schmit, M. Sensi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 23 décembre 2009. Relation: EAC/2009/16057. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2010.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2010010525/178.
(100003271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Alphastock Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.684.

<i>Extrait de cession de parts sociales

Il résulte de conventions de cession de parts sous seing privé entre Monsieur Olivier Chassagne, né le 16 avril 1965 à

Issy-Les-Moulineaux (France), demeurant rue des Bois 78 à B-7100 La Louvière et Madame Maryline PROTIN, née le
15/10/1964 à St-Mard (Belgique), demeurant rue des Bois 78 à B-7100 La Louvière,

Depuis le 01/12/2009, les associés de la société ALPHASTOCK Sàrl sont composés comme suit:

- PROTIN Maryline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Née le 15/10/1964 à St Mard (Belgique)
Rue des Bois, 78
B-7100 La Louvière

80 parts sociales

- CHASSAGNE Olivier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Né le 16/04/1965 à Issy-Les-Moulineaux (France)
Rue des Bois, 78
B-7100 La Louvière

20 parts sociales

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

(100 parts sociales d'une valeur nominale de 125,00€ chacune soit un capital de 12.500,- €.)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010011151/24.
(100003473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Genesis Smaller Companies, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 53.867.

Par une résolution circulaire datée du 30 octobre 2009, le Conseil d'Administration de la société d'investissement à

capital variable 'Genesis Smaller Companies' a coopté Richard Goddard demeurant 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxem-
bourg, au poste d'administrateur avec effet au 30 octobre 2009 et jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires qui statuera des comptes annuels de la société au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 7 janvier 2010.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2010011186/14.
(100003228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

12522

Intrawest Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.505.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 120.197.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution écrite de l'associé unique de la Société prise en date du 23 décembre 2009, que l'associé

unique de la Société a décidé de nommer en tant que gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée avec
effet immédiat:

- M. Michael Forsayeth, dont l'adresse professionnelle est à Suite 710 - 375 Water Street, BC V6B 5C6 Vancouver,

Canada.

Le conseil de gérance de la Société est dès lors constitué comme suit:
- M. David Eric Stiepleman, Gérant de classe A;
- M. Dwight Hawes, Gérant de classe A; et
- M. Michael Forsayeth, Gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2010.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010011169/23.
(100003436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Biminvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 95.821.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion

<i>du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 25 mai 2009

<i>Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Joseph WINANDY comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2010011418/15.
(100003884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Romford Investment Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 207.570,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 117.263.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second of December.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1- Mr Joseph Cosgrave, born in Dublin on March 31 

st

 , 1959, residing at Ardilea House, Mount Anville Road, Dublin

14, Ireland;

2- Mr Peter Cosgrave, born in Dublin on May 30 

th

 , 1960, residing at Saint Kilda, Sandycove Avenue East, Sandycove,

Co Dublin, Ireland; and

3- Mr Michael Cosgrave, born in Dublin on December 7 

th

 , 1962, residing at 7, Hillside Drive, Rathfarnham, Dublin

14, Ireland,

12523

here represented by Mrs. Peggy SIMON, private employee, residing in Berdorf, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue

of three proxies established on December 17, 2009.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company ("Société à responsabilité limitée")

established in Luxembourg under the name of "Romford Investment Holding S.à r.l." (hereafter the "Company"), registered
with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 117263, incorporated pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, on June 14 

th

 , 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, number 1580 of August 19 

th

 , 2006, and amended for the last time by a deed of the undersigned notary

on January 27 

th

 , 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 422 of February 26

th

 , 2009.

II. The Company's share capital is set at one hundred and sixteen thousand one hundred and twenty-seven British

Pounds (£ 116,127.-) represented by six thousand eight hundred and thirty-one (6,831) shares of seventeen British Pounds
(£ 17.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of ninety-one thousand four

hundred and forty-three British Pounds (£ 91,443.-) in order to raise it from its present amount of one hundred and
sixteen thousand one hundred and twenty-seven British Pounds (£ 116,127.-) to two hundred and seven thousand five
hundred and seventy British Pounds (£ 207,570.-) by creation and issue of five thousand three hundred and seventy-nine
(5,379) new shares of seventeen British Pounds (£ 17.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr Joseph Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares to subscribe to one thousand seven

hundred and ninety-three (1,793) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of thirty thousand
four hundred and eighty-one British Pounds (£ 30,481.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subse-
quent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "First Contribution") in the total
amount of thirty thousand four hundred and eighty-four British Pounds and fifty-two Pence (£ 30,484.52), owed by the
Company  to  Mr.  Joseph  Cosgrave,  and  resulting  from  a  declaration  of  the  receiver  of  the  First  Contribution  dated
December 17, 2009, as well as from a declaration of the contributor of the First Contribution dated December 17, 2009.

A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.
The excess contribution of three British Pounds and fifty-two Pence (£ 3.52) is allocated to the legal reserve of the

Company, in order to round down the amount of the share capital.

Thereupon, Mr Peter Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares to subscribe to one thousand seven

hundred and ninety-three (1,793) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of thirty thousand
four hundred and eighty-one British Pounds (£ 30,481.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subse-
quent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "Second Contribution") in the total
amount of thirty thousand four hundred and eighty-four British Pounds and fifty-two Pence (£ 30,484.52), owed by the
Company to Mr Peter Cosgrave, and resulting from a declaration of the receiver of the Second Contribution dated
December 17, 2009, as well as from a declaration of the contributor of the Second Contribution dated December 17,
2009.

A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.
The excess contribution of three British Pounds and fifty-two Pence (£ 3.52) is allocated to the legal reserve of the

Company, in order to round down the amount of the share capital.

Thereupon, Mr Michael Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares to subscribe to one thousand seven

hundred and ninety-three (1,793) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of thirty thousand
four hundred and eighty-one British Pounds (£ 30,481.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subse-
quent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "Third Contribution") in the total
amount of thirty thousand four hundred and eighty-four British Pounds and fifty-two Pence (£ 30,484.52), owed by the
Company to Mr Michael Cosgrave, and resulting from a declaration of the receiver of the Third Contribution dated
December 17, 2009, as well as from a declaration of the contributor of the Third Contribution dated December 17, 2009.

A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.
The excess contribution of three British Pounds and fifty-two Pence (£ 3.52) is allocated to the legal reserve of the

Company, in order to round down the amount of the share capital.

<i>Effective implementation of the contribution

Mr Joseph Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares that:
- he is the unrestricted owner of the First Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally

and conventionally freely transferable;

12524

- the transfer of the First Contribution is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the First Contribution in order to duly

carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Mr Peter Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares that:
- he is the unrestricted owner of the Second Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally

and conventionally freely transferable;

- the transfer of the Second Contribution is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the Second Contribution in order to

duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Mr Michael Cosgrave, prenamed, through his proxy holder, declares that:
- he is the unrestricted owner of the Third Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally

and conventionally freely transferable;

- the transfer of the Third Contribution is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the Third Contribution in order to duly

carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

IV. Pursuant to the above resolutions, the shareholders resolve to amend the first paragraph of the article 6 of the

articles of association which shall henceforth read as follows:

"The share capital is set at two hundred and seven thousand five hundred and seventy British Pounds (£ 207,520,-)

represented by twelve thousand two hundred and ten (12,210) shares of seventeen British Pounds (£ 17.-) each."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1- M. Joseph Cosgrave, né à Dublin le 31 mars 1959, résidant à Ardilea House, Mount Anville Road, Dublin 14, Irlande;
2- M. Peter Cosgrave, né à Dublin le 30 mai 1960, résidant à Saint Kilda, Sandycove Avenue East, Sandycove, Co Dublin,

Irlande; et

3- M. Michael Cosgrave, né à Dublin le 7 décembre 1962, résidant au 7, Hillside Drive, Rathfarnham, Dublin 14, Irlande,
ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf, Grand-Duché de Luxembourg, en

vertu de trois procurations données le 17 décembre 2009.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de "Romford Investment Holding S.à r.l." (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire, résidant à Luxembourg, en date du 14 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1580 du 19 août 2006 et modifié pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire, daté du 27 janvier
2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 422 du 26 février 2009.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent seize mille cent vingt-sept Livres Sterling (£ 116.127,-) représenté par

six mille huit cent trente et une (6.831) parts sociales d'une valeur nominale de dix-sept Livres Sterling (£ 17,-) chacune.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social par un montant de quatre-vingt-onze mille quatre cent quarante-

trois Livres Sterling (£ 91.443,-) pour le porter de son montant actuel de cent seize mille cent vingt-sept Livres Sterling
(£ 116.127,-) à deux cent sept mille cinq cent soixante-dix Livres Sterling (£ 207.570,-) par la création et l'émission de
cinq mille trois cent soixante-dix-neuf (5.379) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de dix-sept Livres Sterling
(£ 17,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, M. Joseph Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à mille sept cent quatre-vingt-treize

(1.793) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant de trente mille quatre cent quatre-vingt-

12525

une Livres Sterling (£ 30.481,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine,
liquide et exigible (ci-après le "Premier Apport") d'un montant total de trente mille quatre cent quatre-vingt-quatre Livres
Sterling et cinquante-deux Pence (£ 30.484,52) détenue par M. Joseph Cosgrave envers la Société, et résultant d'une
déclaration des représentants de la société bénéficiaire du Premier Apport datée du 17 décembre 2009 ainsi que d'une
déclaration de rapporteur datée du 17 décembre 2009.

Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.
L'apport excédentaire de trois Livres Sterling et cinquante-deux Pence (£ 3,52) est alloué à la réserve légale de la

Société, afin d'arrondir le montant du capital social.

Sur ce, M. Peter Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à mille sept cent quatre-vingt-treize

(1.793) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant de trente mille quatre cent quatre-vingt-
une Livres Sterling (£ 30.481,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine,
liquide et exigible (ci-après le "Deuxième Apport") d'un montant total de trente mille quatre cent quatre-vingt-quatre
Livres Sterling et cinquante-deux Pence (£ 30.484,52) détenue par M. Peter Cosgrave envers la Société, et résultant d'une
déclaration des représentants de la société bénéficiaire du Deuxième Apport datée du 17 décembre 2009 ainsi que d'une
déclaration de l'apporteur datée du 17 décembre 2009.

Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.
L'apport excédentaire de trois Livres Sterling et cinquante-deux Pence (£ 3,52) est alloué à la réserve légale de la

Société, afin d'arrondir le montant du capital social.

Sur ce, M. Michael Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare souscrire à mille sept cent quatre-vingt-treize

(1.793) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant de trente mille quatre cent quatre-vingt-
une Livres Sterling (£ 30.481,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine,
liquide et exigible (ci-après le "Troisième Apport") d'un montant total de trente mille quatre cent quatre-vingt-quatre
Livres Sterling et cinquante-deux Pence (£ 30.484,52) détenue par M. Michael Cosgrave envers la Société, et résultant
d'une déclaration des représentants de la société bénéficiaire du Troisième Apport datée du 17 décembre 2009 ainsi que
d'une déclaration de l'apporteur datée du 17 décembre 2009.

Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.
L'apport excédentaire de trois Livres Sterling et cinquante-deux Pence (£ 3,52) est alloué à la réserve légale de la

Société, afin d'arrondir le montant du capital social.

<i>Réalisation effective de l'apport

M. Joseph Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare que:
- Il est le plein propriétaire du Premier Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissible;

- Le transfert du Premier Apport est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la

cession du Premier Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

M. Peter Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare que:
- Il est le plein propriétaire du Deuxième Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissible;

- Le transfert du Deuxième Apport est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la

cession du Deuxième Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

M. Michael Cosgrave, prénommé, par son mandataire, déclare que:
- Il est le plein propriétaire du Troisième Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissible;

- Le transfert du Troisième Apport est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la

cession du Troisième Apport et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des

statuts pour avoir désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à deux cent sept mille cinq cent soixante-dix Livres Sterling (£ 207.570,-) représenté par

douze mille deux cent dix (12.210) parts sociales d'une valeur nominale de dix-sept Livres Sterling (£ 17,-) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, représentées comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

12526

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1988. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 28 décembre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010010533/193.
(100003676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

ProLogis France CX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.617.

à rayer: Suite à un contrat daté du 21 décembre 2009 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaire unique, càd, ProLogis European Developments B.V. ont été transférées à ProLogis European Finance VI Sàrl,
ayant son siège social au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Cette cession des parts sociales a été approuvée
au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Finance VI Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts sociales

Date: le 23 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2010011101/21.
(100003713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Keyhow Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 84.444.

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 27 novembre 2009

A l'Assemblée Générale des Actionnaires de Keyhow Europe S.A. ("la société"), il a été décidé comme suit:
1. De renouveler le mandat de Luxembourg Corporation Company S.A.,ayant son siège social a 20, Rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société, avec effet rétroactif à partir de Novembre 22, 2006, le
mandat expirant lors de l'Assemblée Annuelle devant se tenir en 2011;

2. De confirmer le transfert du siège social de Luxembourg Corporation Company S.A. de 9, Rue Schiller, L-2519

Luxembourg à 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

3. De renouveler le mandat de T.C.G. Gestion S.A., ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,

en tant qu'Administrateur de la société avec effet rétroactive à partir de Novembre 22, 2006, le mandat expirant lors de
l'Assemblée Annuelle devant se tenir en 2011;

4. De confirmer le transfert du siège social de T.C.G. Gestion S.A. de 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg à 20, Rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg;

5. De renouveler le mandat de CMS Management Services S.A., ayant son siège social à 20, Rue de la Poste, L-2346

Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société, avec effet rétroactive à partir de Novembre 22, 2006, le mandat
expirant lors de l'Assemblée Annuelle devant se tenir en 2011;

6. De confirmer le transfert du siège social de CMS Management Services S.A. de 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg

à 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

7. De renouveler le mandat de C.A.S. Services S.A., ayant son siège social à 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,

en tant que Commissaire aux comptes de la société avec effet rétroactive à partir de Novembre 22, 2006, le mandat
expirant lors de l'Assemblée Annuelle devant se tenir en 2011;

12527

8. De confirmer le transfert du siège social de C.A.S. Services S.A. de 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg à 20, Rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg;

9. D'approuver la résignation de Luxembourg Management Company Limited et de Interman Services Limited.

Luxembourg, le 27 Novembre 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signature
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2010011588/34.
(100004418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Keyhow Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 84.444.

<i>Extrait des minutes d'une réunion du conseil d'administration tenu le 24 novembre 2009

Lors d'une réunion du Conseil d'Administration de la société KEYHOW EUROPE SA, il a été décidé comme suit:
1. De transférer le siège social de la société à 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet immédiat.
2. De renouveler le mandat de Luxembourg Corporation Company S.A., ayant son siège social à 20, Rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg, en tant qu'Administrateur délégué de la société avec effet rétroactif à partir de Novembre 22, 2006,
le mandat expirant lors de l'Assemblée Annuelle devant se tenir en 2011;

3. De prendre note du transfert du siège social de Luxembourg Corporation Company S.A. en tant qu'Administrateur

délégué de la Société de 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg à 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 Novembre 2009.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Administrateur Délégué
Signature

Référence de publication: 2010011589/19.
(100004420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Airport Partner International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 133.923.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 29 décembre 2009 a pris note du non-renouvellement de la candidature de Monsieur Jean

François DUSSY aux fonctions d'administrateur et a nommé en remplacement:

- Monsieur Roger JANSSENS, administrateur de société, demeurant Lieu-dit Aux Banits, F-32400 Verlus, France, aux

fonctions d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'Assemblée générale du 29 décembre 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Rudy DE WULF, Administrateur, employé privé, 1632 Bonita Bluff Ct, Floride, FL 33570 Ruskin, Etats Unis;
- Monsieur Bernard BAEYENS, Administrateur-Délégué &amp; Président, ingénieur, 32 Chemin des Bas Campons, F-06480

La Colle sur Loup, France.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L'assemblée générale du 29 décembre 2009 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

<i>Pour AIRPORT PARTNER INTERNATIONAL S.A.
Signature

Référence de publication: 2010011142/24.
(100003060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

12528


Document Outline

Advantage Participation S.A.

aeris CAPITAL Amperio S.à r.l.

Airport Partner International S.A.

Alphastock Sàrl

Alsena S.A.

Bairlinvest S.A.

Biminvest S.A.

BtoBe Luxemburg S.A.

Caragana S.A.

Cardinal Health Luxembourg 420 S.à r.l.

CIPA Investissements S.A.

Clover Investments Sàrl

Compagnie Financière du Quinzième Siècle S.A.

Delta Courtage International S.à.r.l.

Dova Société Immobilière S.A.

Duchess Street Holdings SA

Eneris Wind Italia SA

Evanio Investments Holding S.A.

Everest Investholding S.à r.l.

Fario Luxembourg S. à r.l.

Field Point I-A RE 1

Field Point I-A RE 5 S.à r.l.

Fina Cold II S.A.

Fina Cold II S.A.

Freelander Investholding S.à r.l.

Future Entertainment S. à r.l.

Gadwall Sàrl

Genesis Smaller Companies

Glaxosmithkline Dungarvan and Stafford-Miller (Ireland) S.N.C.

GLH Shipping S.A.

Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A.

Intrawest Holdings S.à.r.l.

June S.C.A., SICAV-FIS

Keyhow Europe S.A.

Keyhow Europe S.A.

LBREM II NW Holdings S.à r.l.

LSREF Kachidoki Investments S.à r.l.

LSREF Lux Investments VIII S.à r.l.

Luxdeftec S.A.

LYXOR CTA Diversified Fund

MGE Objekt Berlin S. à r.l.

Multi Units Luxembourg

OCM Luxembourg Glasnost Holdings SCA

Oterna Holding B.V.

Oterna Holding B.V.

Oterna Holding B.V.

Oterna Holding B.V.

Oxford Investments S.A.

Pegasus Investments Sàrl

ProLogis Belgium Sàrl

ProLogis France CX S.à r.l.

ProLogis Poland LXIII S.à r.l.

Ril Invest S.A.

Riz Europe (Luxembourg) S.à r.l.

Rock Ridge RE 10

Rock Ridge RE 20

Rock Ridge RE 8

Romford Investment Holding S.à r.l.

S5 Finco S.à r.l.

Software Development &amp; Consulting

Tractim S.à r.l.