This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 26
6 janvier 2010
SOMMAIRE
Avindale Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
1227
Balfour & Partners Management S.A. . . . .
1247
Balfour & Partners Management S.A. . . . .
1247
Café-Auberge KIRCH S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
1247
Church Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1228
Consortium International S.A. . . . . . . . . . .
1237
Crab International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1247
Cybertrust Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
1237
Dresdner Leasing 2 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
1226
EGE SERAMIK Trading Holding S.A. . . . .
1227
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Dritte S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1211
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Erste S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1206
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Vierte S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1214
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Zweite S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1209
EKIAM S. à r. l. & Cie. S.T. Erste S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1204
Gemalog S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1225
G.O. II - Luxembourg Alfamar S.à r.l. . . . .
1226
G.O. II - Luxembourg Finance S.à r.l. . . . .
1226
G.O. II - Luxembourg Finance S.à r.l. . . . .
1226
G.O. II - Luxembourg Walt S.à r.l. . . . . . . .
1227
Groupement Forestier Clervaux . . . . . . . .
1248
GSLP International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1238
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante cinquiè-
me (65.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1204
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante cinquiè-
me (65.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1206
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante huitiè-
me (68.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1212
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante huitiè-
me (68.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1214
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante septiè-
me (67.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1209
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante septiè-
me (67.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1211
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante sixième
(66.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1207
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante sixième
(66.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1209
INNCONA S.à r.l. & Cie. Trente Cinquiè-
me (35.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1202
INNCONA S.à r.l. & Cie. Trente Cinquiè-
me (35.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1204
Lastminute.com Luxembourg S.à r.l. . . . .
1214
Lastminute.com Luxembourg S.à r.l. . . . .
1223
Liégeois Strassen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
1238
Luxengineering Bevilacqua & Associés S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1237
Mezzanine Management Central Europe
Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1237
Pembroke S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1225
Peterstreet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1238
proma Unternehmensberatung S.à r.l. . . .
1238
REM624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1225
Sands Crédit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1227
Select Line S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1226
SEMTAN Luxembourg SCA . . . . . . . . . . . .
1239
SOF European Hotel Co-Invest Holdings,
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1227
Winab S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1237
Winab S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1236
Winab S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1236
Zafini Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1238
1201
INNCONA S.à r.l. & Cie. Trente Cinquième (35.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 149.796.
STATUTEN
Gesellschaftsvertrag
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Trente Cinquième (35.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-
burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-
weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.
Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen.
Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 128.812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.
Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Thomas, Dr. Stephan
Straße: Kantplatz 3
Postleitzahl/Wohnort: 30625 Hannover
Geburtsdatum/Geburtsort: 02.11.65 / Hannover
Beruf: Zahnarzt
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist
erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.
Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-
rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.
(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle
Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:
a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-
titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen;
c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei
Versicherungsschäden;
f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
1202
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von
300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
i) Aufnahme neuer Gesellschafter.
Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht
einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.
Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-
schafterversammlung einberufen.
(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu
machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.
(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie
auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.
(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von
Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu
übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.
(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.
Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.
(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht
mehr.
(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem
Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75% der Stimmen.
(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und
den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres
und endet am 30.06. des Folgejahres.
Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).
1203
Schengen, den 26. Juni 2007.
INNCONA Management S.à r.l.
Unterschrift
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157621/116.
(090190976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
EKIAM S. à r. l. & Cie. S.T. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple,
(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Trente Cinquième (35.) S.e.c.s.).
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.796.
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S.à r. l. & Cie. S.T. Erste S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.
Grevenmacher, 12.11.2009.
EKIAM Management S. à r. I.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157623/20.
(090190976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante cinquième (65.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 149.789.
STATUTEN
Gesellschaftsvertrag
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante cinquième (65.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-
burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-
weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.
Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen.
Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 128.812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.
Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
1204
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: v. Lueder, Martin
Straße: Theodor-Storm-Str. 17
Posteitzahl/Wohnort: 74564 Crailsheim
Geburtsdatum/Geburtsort: 18.05.57 / Altdorf
Beruf: Geschäftsführer
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt Der Kommanditist
erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist
Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-
rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.
(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle
Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:
a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-
titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen;
c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei
Versicherungsschäden;
f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von
300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
i) Aufnahme neuer Gesellschafter.
Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht
einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.
Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschanen wird jährlich eine ordentliche Gesell-
schafterversammlung einberufen.
(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu
machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.
(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie
auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.
(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von
Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt die unverzüglich allen Gesellschaftern zu
übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
1205
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich
beim Vorsitzenden widersprochen hat.
(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r. l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.
Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.
(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht
mehr.
(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem
Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75% der Stimmen.
(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und
den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres
und endet am 30.06. des Folgejahres.
Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).
Schengen, den 13.06.2007.
INNCONA Management S.à r.l.
Unterschrift
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157615/116.
(090190864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple,
(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante cinquième (65.) S.e.c.s.).
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.789.
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S.à r. l. & Cie. M.v.L. Erste S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.
Grevenmacher, 12.11.2009.
EKIAM Management S. à r. I.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157616/20.
(090190864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
1206
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante sixième (66.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 149.790.
STATUTEN
Gesellschaftsvertrag
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante sixième (66.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-
burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-
weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.
Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen.
Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 128.812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.
Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname,Vorname: v. Lueder, Martin
Straße: Theodor-Storm-Str. 17
Postleitzahl/Wohnort: 74564 Crailsheim
Geburtsdatum/Geburtsort: 18.05.57 / Altdorf
Beruf: Geschäftsführer
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist
erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.
Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-
rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schaftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.
(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle
Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:
a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-
titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen;
c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei
Versicherungsschäden;
f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
1207
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von
300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
i) Aufnahme neuer Gesellschafter.
Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht
einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.
Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-
schafterversammlung einberufen.
(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu
machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.
(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie
auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort Tagungszeit Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.
(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von
Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu
übermitteln ist Die Niederschrift gilt als genehmigt wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.
(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsniaßnahmen der INNCONA Management S.à r. l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.
Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.
(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht
mehr.
(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem
Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75% der Summen.
(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und
den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres
und endet am 30.06. des Folgejahres.
Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).
1208
Schengen, den 13.06.2007.
INNCONA Management S.à r.l.
Unterschrift
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157611/116.
(090190869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple,
(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante sixième (66.) S.e.c.s.).
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.790.
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S.à r. l. & Cie. M.v.L. Zweite S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.
Grevenmacher, 12.11.2009.
EKIAM Management S. à r. I.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157613/20.
(090190869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante septième (67.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 149.791.
STATUTEN
Gesellschaftsvertrag
Art. 1 Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschan führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante septième (67.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-
burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-
weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.
Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen.
Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 128.812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.
Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
1209
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: v. Lueder, Martin
Straße: Theodor-Storm-Str. 17
Postleitzahl/Wohnort: 74564 Crailsheim
Geburtsdatum/Geburtsort: 18.05.57 / Altdorf
Beruf: Geschäftsführer
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist
erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.
Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-
rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.
(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle
Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:
a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-
titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen;
c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei
Versicherungsschäden;
f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von
300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
i) Aufnahme neuer Gesellschafter.
Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht
einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.
Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-
schafterversammlung einberufen.
(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu
machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.
(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie
auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort Tagungszeit Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.
(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von
Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu
übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
1210
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.
(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.
Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.
(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht
mehr.
(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem
Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75% der Stimmen.
(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und
den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres
und endet am 30.06. des Folgejahres.
Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).
Schengen, den 13.06.2007.
INNCONA Management S.à r.l.
Unterschrift
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157618/116.
(090190870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Dritte S.e.c.s., Société en Commandite simple,
(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante septième (67.) S.e.c.s.).
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.791.
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S.à r. l. & Cie. M.v.L. Dritte S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.
Grevenmacher, 12.11.2009.
EKIAM Management S. à r. I.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157619/20.
(090190870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
1211
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante huitième (68.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 149.792.
STATUTEN
Gesellschaftsvertrag
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft fuhrt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante huitième (68.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-
burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-
weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.
Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen.
Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 128.812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.
Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname,Vorname: v. Lueder, Martin
Straße: Theodor-Storm-Str. 17
Postleitzahl/Wohnort: 74564 Crailsheim.
Geburtsdatum/Geburtsort: 18.05.57 / Altdorf
Beruf: Geschäftsführer
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist
erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.
Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-
rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.
(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle
Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:
a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-
titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen;
c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei
Versicherungsschäden;
f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
1212
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von
300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
i) Aufnahme neuer Gesellschafter.
Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht
einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.
Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschanen wird jährlich eine ordentliche Gesell-
schafterversammlung einberufen.
(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu
machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.
(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie
auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.
(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von
Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu
übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.
(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsrmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.
Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.
(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht
mehr.
(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem
Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75% der Stimmen.
(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und
den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres
und endet am 30.06. des Folgejahres.
Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).
1213
Schengen, den 13.06.2007.
INNCONA Management S.à r.l.
Unterschrift
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157608/116.
(090190927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Vierte S.e.c.s., Société en Commandite simple,
(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante huitième (68.) S.e.c.s.).
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.792.
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S.à r. l. & Cie. M.v.L. Vierte S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L-6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S.à r.l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.
Grevenmacher, 12.11.2009.
EKIAM Management S. à r. I.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2009157610/20.
(090190927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Lastminute.com Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 61.585.825,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 110.199.
In the year two thousand and nine, on the ninth day of the month of December.
Before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Lastminute.com Luxembourg S.à r.l. (the "Compa-
ny"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
incorporated by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 5
th
August 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 7
th
January 2006 number 4 7 and registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 110.199.
The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of Me Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, on 30
th
June 2006, published in the Mémorial of 28
th
October 2006 number 2028.
The meeting was chaired by Maître Mariya Gadzhalova, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as secretary Maître Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit and Maître Ana Bramão, maître
en droit as scrutineer, both residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented at the meeting and their respective shareholdings are shown on an attendance list
which is signed ne varietur by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
Such attendance list shall remain attached to this deed to be submitted with it to the registration authorities.
2. As it appears from said attendance list, that all one million seven hundred fifty-nine thousand five hundred ninety-
five (1,759,595) shares in issue in the Company are represented at this meeting and all shareholders declared having had
prior knowledge of the agenda of the meeting and waived any right to prior notice so that the meeting was validly
constituted and could validly deliberate and resolve on all items of the agenda.
3. The agenda of the meeting was as follows:
A. Amendment of the first paragraph of article 4 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
1214
" Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association,
provided that in relation to a decision to transfer the registered office abroad, the decision shall be adopted by 100% of
the shareholders in accordance with article 10."
B. Change of the current accounting year end from 31
st
December 2009 to 9
th
December 2009 and change of the
following accounting years of the Company so as to start on 10
th
December of each year and to finish on 9
th
December
of the following year; consequential amendment of article 11 of the articles of association; approval of the Company's
accounts for the financial year ended as at the date of this extraordinary general meeting of the shareholders approving
the migration of the Company to the State of Delaware, United States of America and approval to carry forward the loss
of the current accounting year of an amount of fifty-nine million two hundred fifty thousand four hundred sixty-six United
States Dollars (USD 59,250,466).
C. Transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to the State of Delaware, United States of
America, YCS&T Services LLC, 1000 West Street, 17
th
Floor, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801,
without prior dissolution, consequent transformation of the Company's nationality, submission to the laws of the State
of Delaware with effect as from the registration of the Company with the Secretary of State for the State of Delaware
(the "Effective Date"), all in accordance with Section 18-212 of the Limited Liability Company Act of the State of Delaware,
6 Del. C. §§ 18-101 et seq.
D. Subject to the approval of item C. above, change of the Company's name to "lastminute.com LLC" and adoption
of a limited liability company agreement containing the articles of association of the Company according to the laws of
the State of Delaware with effect as from the Effective Date, (a copy of which, executed by each shareholder of the
Company is attached to the power of attorney given by each shareholder and signed by it for identification).
E. Subject to the approval of item C. above, confirmation, without limitation, of the assumption by the Company,
henceforth submitted to the laws of the State of Delaware, of all the assets and liabilities of the Company previously of
Luxembourg nationality.
F. Subject to the approval of item C. above, approval, with effect from the Effective Date, of the resignation of all
managers of the Company currently in office; granting of discharge for the execution of their mandates and confirmation
of the appointment as from the Effective Date of all shareholders of the Company as member-managers in accordance
with the laws of the State of Delaware.
G. Subject to the approval of item C. above, instruction, authorisation and granting of a power to (a) any authorised
signatory of the Company under the laws of the State of Delaware and any manager of the Company currently in office,
acting alone and with full power of substitution to take the appropriate steps to have the Company registered with the
Secretary of State of the State of Delaware, United States of America; and (b) to any manager of the Company currently
in office, acting alone and with full power of substitution to acknowledge in front of a public notary of his choice in
Luxembourg the registration of the Company with the Secretary of State of the State of Delaware and the Effective Date.
The following decisions have been taken by the sole shareholder:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
" Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association ,
provided that in relation to a decision to transfer the registered office abroad, the decision shall be adopted by 100% of
the shareholders in accordance with article 10."
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to change the current accounting year end from 31
st
December 2009 to 9
th
December 2009
of the Company so as to start on 10
th
December of each year and to finish on 9
th
December of the following year and
to amend article 11 of the Company's articles of association so as to read as follows:
" Art. 11. Accounting year. The accounting year begins on the tenth of December of each year and ends on the ninth
December of the following year."
The meeting resolved to approve the Company's accounts, including the profit and loss accounts, for the financial year
ended as at the date hereof. The result of the financial year is a loss of an amount of fifty-nine million two hundred fifty
thousand four hundred sixty-six United States Dollars (USD 59,250,466) that the meeting resolved to carry forward.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to State of Delaware, United
States of America, YCS&T Services LLC, 1000 West Street, 17
th
Floor, Wilmington, New Castle County, Delaware,
19801 without prior dissolution.
1215
It is furthermore resolved that the Company's nationality be changed accordingly and that the Company be transformed
simultaneously into a limited liability company subject to the laws of the State of Delaware, to be submitted to the laws
of the State of Delaware with effect as from the registration of the company with the Secretary of State of the State of
Delaware (the "Effective Date"), all in accordance with Section 18-212 of the Limited Liability Company Act of the State
of Delaware, 6 Del. C. §§ 18-101 et seq.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolved to change the name of the Company to "lastminute.com LLC" and to adopt, with effect from
the Effective Date and to have executed by each shareholder of the Company, a limited liability company agreement
containing the new articles of association of the Company which reads as follows:
"LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT
OF
lastminute.com LLC
THIS LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT (the "Agreement") is made effective as of December 9, 2009, by
and among the members listed on Exhibit A hereto (the "Initial Members", and each, an "Initial Member") and
lastminute.com LLC, a Delaware limited liability company, and shall be binding upon such other individuals and members
as may be added pursuant to the terms of this Agreement.
1. Formation of the Company. By execution of this Agreement, the members hereby ratify the filing of that certain
certificate of formation (the "Certificate") filed with the Secretary of State of the State of Delaware for the purpose of
forming lastminute.com LLC (the "Company"), a limited liability company formed under the Delaware Limited Liability
Company Act, 6 Del. C. §§ 18-101 - 18-1109 (the "Act") .
2. Name of the Company. The name of the Company to be stated in the Certificate and the limited liability company
governed by this Agreement shall be "lastminute.com LLC".
3. Purpose. This Company is formed for the purpose of, and the nature of the business to be conducted and promoted
by the Company is, engaging in any lawful act or activity for which limited liability companies may be formed under the
Act and engaging in any and all activities necessary or incidental to the foregoing.
4. Registered Office; Registered Agent. The registered office of the Company in the State of Delaware is located at
1000 West Street, 17
th
Floor, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, and the name of its registered agent
at such address is YCS&T Services LLC.
5. Units.
(a) The interests of members in the Company shall be represented by Class A units ("Class A Units") and/or Class B
units ("Class B Units", and together with Class A Units, "Units") and shall for all purposes be personal property. Each Unit
held by a member shall represent a pro-rata share of all of such member's limited liability company interest in the Company.
Units may be issued, transferred, assigned, and held in fractions. No member or holder of Units shall have any interest
in specific Company assets or property, including assets or property contributed to the Company by such member as a
part of any capital contribution. Units are securities governed by Article 8 of the Uniform Commercial Code as in effect
in the State of Delaware.
(b) Class A Units shall entitle each member who is a holder thereof to one vote per whole Class A Unit held, and a
fractional vote commensurate with any fractional Class A Unit held, on the following: (i) matters that may be submitted
to the members for a vote; (ii) matters that members are entitled to vote upon, decide, or effectuate pursuant to this
Agreement; and (iii) whenever a member vote is required under the Act as construed in light of this Agreement. In each
such case, the affirmative vote or written consent of the members holding a majority of the outstanding Class A Units
shall be the act of the members. A member' s Class A Units shall together constitute such member's "Class A Interest".
(c) Class B Units shall not entitle a member or any other holder thereof to vote except as may be required under the
Act as construed in light of this Agreement, in which case Class B Units shall entitle each member who is a holder thereof
to one vote per whole Class B Unit held, and a fractional vote commensurate with any fractional Class B Unit held. A
member's Class B Units shall together constitute such member's "Class B Interest". In all other respects, Class B Units
shall be identical to Class A Units.
(d) A member's Class A Interest, if any, and Class B Interest, if any, shall together constitute all of such member's
limited liability company interest in the Company.
6. Capital Contributions by the Initial Members. Upon the conversion of lastminute.com S.à r.l. into the Company
pursuant to the Certificate of Limited Liability Company Domestication filed with the Secretary of State of the State of
Delaware by lastminute.com S.à r.l., each of the Initial Members is deemed to have contributed to the Company the equity
represented by such Initial Member's stock or convertible preferred equity certificates in lastminute.com S.à r.l., which
contribution is credited to such Initial Member's capital account, in exchange for the number of Class A Units issued to
such Initial Member in such Initial Member's name, as set forth in Exhibit A hereto. Except for the foregoing consideration,
the Initial Members shall not be obligated to make capital contributions to the Company, and upon their issuance, the
Units issued to the Initial Members shall be fully paid and nonassessable.
1216
7. Capital Accounts. A separate capital account shall be maintained for each member, and such capital accounts shall
be maintained in accordance with the provisions of § 704 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code"),
and the Treasury Regulations promulgated thereunder.
8. Allocation of Profits and Losses. The Company's profits and losses shall be allocated among the capital accounts of
all Unit holders in proportion to the number of Units held by each Unit holder, and it shall be the intent of the members
and the Company that each Unit holder's distributive share of income, gain, loss, deduction, or credit (or item thereof)
shall be determined and allocated in accordance with this Section 8 to the fullest extent permitted by §§ 704 (b) and (c)
of the Code and the Treasury Regulations promulgated thereunder.
9. Distributions. Distributions shall be made to the members at the times and in the aggregate amounts determined
by the Management Committee (defined below), if any, and otherwise by the Initial Members. Unless otherwise required
by the Code or the Treasury Regulations promulgated thereunder, such distributions shall be allocated among the mem-
bers in proportion to the number of Units held.
10. Appointment and Removal of Manager. At any time, and from time to time, the Initial Members may elect one or
more individuals or entities to manage the Company (such one or more individuals or entities, the "Management Com-
mittee") . The Management Committee shall govern by majority vote, each individual or entity on the Management
Committee having one vote. The Management Committee shall be responsible for any and all such duties as the Initial
Members may choose to confer upon it in this Agreement. Any individual or entity on the Management Committee shall
be automatically removed therefrom upon (i) such individual or entity's resignation or (ii) such individual or entity's
removal by the Initial Members, whichever is earlier. Any vacancy on the Management Committee may be filled as directed
by the Initial Members. No individual or entity on the Management Committee need be a member of the Company or
resident of the State of Delaware.
11. Officers. The Management Committee, if any, and otherwise the Initial Members may, from time to time, delegate
to one or more persons such authority and duties as it may deem advisable. The Management Committee or Initial
Members, as the case may be, may assign titles, in writing, to any person, including, without limitation, the titles of
President, Vice President, Secretary, Assistant Secretary, Treasurer, and Assistant Treasurer. Any number of titles may
be held by the same person. Unless otherwise provided, if the title is one commonly used for officers of a business
corporation formed under the Delaware General Corporation Law, the assignment of such title shall constitute the
delegation to such person (an "Officer") of the authority and duties that are normally associated with that title. Each
officer shall hold office until his successor shall be duly designated or until the earlier of his death, resignation, or removal.
The salaries or other compensation, if any, of the officers and agents of the Company shall be fixed by the Management
Committee, if any, and otherwise by the Initial Members. Any delegation pursuant to this Section 11 may be revoked,
with or without cause, at any time by the Management Committee, if any, or otherwise by the Initial Members. Any officer
may resign as such at any time. Such resignation shall be made in writing and shall take effect at the time specified therein
or, if no time be specified, at the time of its receipt by the Company. The acceptance of a resignation shall not be necessary
to make it effective, unless expressly so provided in the resignation.
12. Authority of Members. Unless expressly authorized to do so by this Agreement, by the Management Committee,
if any, or by the Initial Members, if there be no Management Committee, no member, agent, or employee of the Company
shall have any power or authority to bind the Company in any way, to pledge its credit, or to render it liable pecuniarily
for any purpose; provided, however, that an individual or entity on the Management Committee may act by a duly
authorized attorney-in-fact.
13. Limitations on Authority. The authority of the Management Committee over the conduct of the affairs of the
Company shall be subject only to such limitations as are expressly stated in this Agreement or in the Act.
14. Dissolution. The Company shall dissolve, and its affairs shall be wound up, upon the first to occur of the following:
(a) the written consent of the Initial Members, (b) the entry of a decree of judicial dissolution under § 18-802 of the Act,
or (c) as otherwise required under the Act.
15. Transferability of Interests; Admission of Members; Authority of Initial Members.
(a) Any member may transfer or assign its limited liability company interest in the Company in whole or in part. The
transfer or assignment by a member of any or all of such member' s Units shall constitute the transfer or assignment of
the pro-rata share represented by such Units of all of such member's limited liability company interest in the Company.
Unless otherwise expressly agreed to by the transferor and transferee, or assignor and assignee (as the case may be), any
transferee or assignee of a Unit or Units shall be admitted as a member, automatically and without any action on the part
of the Company or any other person or persons, effective immediately prior to such transfer or assignment.
(b) In the event the Company shall issue certificates representing Units, a transferee or assignee of certificated Units
shall, promptly after such transfer or assignment, present the certificates representing such Units, along with evidence of
the transfer or assignment satisfactory to the Company, for the recording of such transfer or assignment on the books
of the Company, but failure of a transferee or assignee so to present such certificates shall not affect or delay the validity
of a transfer or assignment pursuant to this Section 15.
(c) Any power or authority that an Initial Member has hereunder shall cease as to such Initial Member, and such Initial
Member shall cease to be an Initial Member, upon such Initial Member's transfer or assignment of all of its limited liability
1217
company interest in the Company. If at any time there shall be no Initial Members, then all power and authority granted
to the Initial Members herein shall henceforth be granted to and exercisable by the members holding Class A Units.
16. Limitation of Liability. This Agreement hereby eliminates any and all liabilities of a member for breach of contract
and breach of duties (including fiduciary duties) of a member to the Company, any other member or Unit holder, or any
assignee of any interest in the Company; provided, however, that this Agreement does not limit or eliminate liability for
any act or omission that constitutes a bad faith violation of the implied contractual covenant of good faith and fair dealing.
17. Limitation of Duties. To the extent that, at law or in equity, a members has duties (including fiduciary duties) to
the Company, any other member or Unit holder, or any assignee of any interest in the Company, such duties are hereby
eliminated by this Agreement; provided, however, that this Agreement does not eliminate the implied contractual cove-
nant of good faith and fair dealing.
18. Amendments. Except as otherwise provided in this Agreement, this Agreement may be amended only by the Initial
Members.
19. Governing Law. This Agreement shall be construed and enforced in accordance with, and governed by, the laws
of the State of Delaware without regard to principles of conflict of laws to the extent that such principles would cause
the laws of any other jurisdiction to apply.
20. Counterparts; Execution.
(a) This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which shall be deemed an original and all
of which together shall constitute one and the same Agreement. A member need not execute this Agreement in order
to be bound by its terms.
(b) Sterling L. Miller is hereby constituted an authorized person under the provisions of 6 Del. C. § 18-204 for the sole
purpose of executing this Agreement on behalf of the Company.
21. Tax Elections. The Management Committee, if any, and otherwise the Initial Members shall have the power to
cause the Company to make all elections required or permitted to be made for income tax purposes.
22. Construction. As used herein, the term "member" includes any one of the Initial Members, and the term "members"
includes any two or more of the Initial Members. Wherever this Agreement provides that an action or approval may be
taken or given by members or Unit holders holding a specified class and proportion of Units, such action or approval
shall not be invalid solely on the grounds that it was taken or given by a single member or Unit holder, as the case may
be, holding at least the specified class and proportion of Units."
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolved to approve the opening balance sheet of the Company newly named "lastminute.com LLC" in
the State of Delaware specifying the value of all assets and liabilities as well as all the items of the Luxembourg company
balance sheet on the date of transfer of its registered office together with all the assets and liabilities without limitation,
said assets and liabilities being assumed in their entirety by the Company henceforth submitted to the laws of Delaware
from the Company of previously Luxembourg nationality without limitation or condition.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolved to approve the resignation of all managers of the Company currently in office as at the date
hereof with effect from the Effective Date and to grant them discharge for the execution of their mandates until the date
hereof.
The meeting further resolved to confirm the appointment of all shareholders of the Company as member-managers
of the Company with effect from the Effective Date in accordance with the laws of the State of Delaware.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting resolved to instruct, authorise and empower:
a) any authorised signatory of the Company under the laws of the State of Delaware, and any manager of the Company
currently in office, acting alone and with full power of substitution, to take the appropriate steps to have the Company
registered with the Secretary of State of the State of Delaware, United States of America; and
b) any manager of the Company in office at the date hereof acting alone and with full power of substitution, to have
the registration of the Company with the Secretary of State of Delaware, United States of America to be acknowledged
in front of a public notary of his choice in Luxembourg and to record the Effective Date.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the transfer of its registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the State of Delaware, United
States of America are estimated at € 1,500.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing
parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
1218
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de Lastminute.com Luxembourg S.à r.l. (la "Société"),
une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée
suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 2005, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 7 janvier 2006 numéro 47 et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B 110.199.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg du 30 juin 2006, publié au Mémorial du 28 octobre 2006, numéro 2028.
L'assemblée était présidée par Maître Mariya Gadzhalova, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée a désigné comme secrétaire Maître Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, et Maître Ana Bramão,
maître en droit comme scrutateur, les deux demeurant à Luxembourg.
Le Président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. Les associés représentés à l'assemblée et le nombre de leurs parts sociales respectives apparaissent sur la liste de
présence signée ne varietur par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.
2. Il résulte de la liste de présence que toutes les un million sept cents cinquante neuf mille cinq cent quatre-vingt-
quinze (1.759.595) parts sociales émises par la Société sont représentées à l'assemblée et tous les associés de la Société
ont déclaré avoir connaissance préalable de l'ordre du jour et ont renoncé à tout droit à une convocation préalable, de
sorte que l'assemblée a été valablement constituée et pouvait décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour.
3. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
A. Modification du premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société comme suit.
" Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou vers l'étranger en vertu d'une résolution de l'as-
semblée générale extraordinaire délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts, étant entendu
que concernant la résolution de transférer le siège social à l'étranger, la résolution devra être adoptée par 100% des
associés conformément à l'article 10."
B. Modification de la fin de l'année sociale en cours du 31 décembre 2009 au 9 décembre 2009 et modification des
années sociales suivantes de la Société de sorte qu'elles commencent le 10 décembre de chaque année et se terminent
le 9 décembre de l'année suivante; modification subséquente de l'article 11 des statuts; approbation des comptes de la
Société pour l'année sociale se terminant à la date de la présente assemblée approuvant la migration de la Société vers
l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique et approbation du report de la perte de l'année sociale en cours d'un montant
de cinquante neuf millions deux cent cinquante mille quatre cent soixante-six dollars des Etats-Unis (USD 59.250.466).
C. Transfert du siège social de la Société de Luxembourg vers l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, YCS&T
Services LLC, 1000 West Street, 17
e
Etage, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, sans dissolution préalable
de la Société, changement conséquent de la nationalité de la Société, soumission aux lois de l'Etat de Delaware avec effet
à compter de l'enregistrement de la Société avec le Secretary of State for the State of Delaware (la "Date Effective"),
conformément à la Section 18-212 du Limited Liability Company Act of the State of Delaware, 6 Del. C. §§ 18-101 et
subséquent.
D. Sous réserve de l'approbation du point C. ci-dessus, changement du nom de la Société en "lastminute.com LLC" et
adoption d'un contrat d'une limited liability company comprenant les statuts de la Société conformément aux lois de l'Etat
de Delaware avec effet à compter de la Date Effective (une copie duquel, signée par chaque associé de la Société est
annexée à la procuration émise par chaque associé et signée pour identification).
E. Sous réserve de l'approbation du point C. ci-dessus, confirmation, sans réserve, de la reprise par la Société, désormais
soumise aux lois de l'Etat de Delaware, de tous les avoirs et dettes de la Société précédemment de nationalité luxem-
bourgeoise.
F. Sous réserve de l'approbation du point C. ci-dessus, approbation, avec effet à compter de la Date Effective, de la
démission de tous les gérants de la Société actuellement en fonction décharge pour l'exécution de leur mandat et con-
firmation de la nomination à compter de la Date Effective de tous les associés de la Société en tant que membre-gérant
conformément aux lois de l'Etat de Delaware.
G. Sous réserve de l'approbation du point C. ci-dessus, instruction, autorisation et mandat à (a) chaque signataire
autorisé de la Société en vertu des lois de l'Etat de Delaware et chaque gérant de la Société actuellement en fonction,
agissant seul et avec pouvoir de substitution à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'immatriculation de la
1219
Société avec le Secretary of State of the State of Delaware, Etats-Unis d'Amérique; et (b) à chaque gérant de la Société
actuellement en fonction, agissant seul et avec pouvoir de l'Etat de Delaware de constater devant un notaire de son choix
l'immatriculation de la Société avec le Secretary of State of the State of Delaware et de la Date Effective.
Les résolutions suivantes ont été prises par l'actionnaire unique:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société comme suit:
" Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou vers l'étranger en vertu d'une résolution de l'as-
semblée générale extraordinaire délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts, étant entendu
que concernant la résolution de transférer le siège social à l'étranger, la résolution devra être adoptée par 100% des
associés conformément à l'article 10."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé de modifier la fin de l'année sociale en cours du 31 décembre 2009 au 9 décembre 2009, de
modifier les années sociales subséquentes de la Société de sorte qu'elles commencent le 10 décembre de chaque année
et se terminent le 9 décembre de l'année suivante et de modifier l'article 11 des statuts comme suit:
" Art. 11. Année sociale. L'année sociale commence le 10 décembre de chaque année et se termine le 9 décembre de
l'année suivante."
L'assemblée a décidé d'approuver les comptes de la Société, y inclus les comptes de profit et pertes, pour l'année
sociale qui se termine à la date de la présente assemblée. Le résultat de l'année sociale est une perte d'un montant de
cinquante-neuf millions deux cent cinquante mille quatre cent soixante-six dollars des Etats-Unis (USD 59.250.466), que
l'assemblée a décidé de reporter.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée a décidé de transférer, le siège de la Société de Luxembourg vers l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amé-
rique, YCS&T Services LLC, 1000 West Street, 17
e
Etage, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, sans
dissolution préalable.
Il a été en outre décidé de changer la nationalité de la Société et de la transformer concomitamment en une société
à responsabilité limitée soumise aux lois de l'Etat de Delaware, à être soumise aux lois de l'Etat de Delaware avec effet
à compter de la date d'enregistrement de la Société avec le Secretary of State of the State of Delaware (la "Date Effective") ,
tout conformément à la Section 18-212 du Limited Liability Company Act of the State of Delaware, 6 Del. C. §§ 18-101
et subséquent.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le nom de la Société en "lastminute.com LLC" et d'adopter avec effet à compter de la
Date Effective et faire signer par tous les associés de la Société, le limited liability company agreement contenant les
nouveaux statuts de la Société, comme suit:
"LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT
DE
lastminute.com LLC
THIS LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT (the "Agreement") is made effective as of December 9, 2009, by
and among the members listed on Exhibit A hereto (the "Initial Members", and each, an "Initial Member") and
lastminute.com LLC, a Delaware limited liability company, and shall be binding upon such other individuals and members
as may be added pursuant to the terms of this Agreement.
1. Formation of the Company. By execution of this Agreement, the members hereby ratify the filing of that certain
certificate of formation (the "Certificate") filed with the Secretary of State of the State of Delaware for the purpose of
forming lastminute.com LLC (the "Company"), a limited liability company formed under the Delaware Limited Liability
Company Act, 6 Del. C. §§ 18-101 - 18-1109 (the "Act").
2. Name of the Company. The name of the Company to be stated in the Certificate and the limited liability company
governed by this Agreement shall be "lastminute.com LLC".
3. Purpose. This Company is formed for the purpose of, and the nature of the business to be conducted and promoted
by the Company is, engaging in any lawful act or activity for which limited liability companies may be formed under the
Act and engaging in any and all activities necessary or incidental to the foregoing.
4. Registered Office; Registered Agent. The registered office of the Company in the State of Delaware is located at
1000 West Street, 17
th
Floor, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, and the name of its registered agent
at such address is YCS&T Services LLC.
5. Units.
1220
(a) The interests of members in the Company shall be represented by Class A units ("Class A Units") and/or Class B
units ("Class B Units", and together with Class A Units, "Units") and shall for all purposes be personal property. Each Unit
held by a member shall represent a pro-rata share of all of such member's limited liability company interest in the Company.
Units may be issued, transferred, assigned, and held in fractions. No member or holder of Units shall have any interest
in specific Company assets or property, including assets or property contributed to the Company by such member as a
part of any capital contribution. Units are securities governed by Article 8 of the Uniform Commercial Code as in effect
in the State of Delaware.
(b) Class A Units shall entitle each member who is a holder thereof to one vote per whole Class A Unit held, and a
fractional vote commensurate with any fractional Class A Unit held, on the following: (i) matters that may be submitted
to the members for a vote; (ii) matters that members are entitled to vote upon, decide, or effectuate pursuant to this
Agreement; and (iii) whenever a member vote is required under the Act as construed in light of this Agreement. In each
such case, the affirmative vote or written consent of the members holding a majority of the outstanding Class A Units
shall be the act of the members. A member's Class A Units shall together constitute such member's "Class A Interest".
(c) Class B Units shall not entitle a member or any other holder thereof to vote except as may be required under the
Act as construed in light of this Agreement, in which case Class B Units shall entitle each member who is a holder thereof
to one vote per whole Class B Unit held, and a fractional vote commensurate with any fractional Class B Unit held. A
member's Class B Units shall together constitute such member's "Class B Interest". In all other respects, Class B Units
shall be identical to Class A Units.
(d) A member's Class A Interest, if any, and Class B Interest, if any, shall together constitute all of such member's
limited liability company interest in the Company.
6. Capital Contributions by the Initial Members. Upon the conversion of lastminute.com S.à r.l. into the Company
pursuant to the Certificate of Limited Liability Company Domestication filed with the Secretary of State of the State of
Delaware by lastminute.com S.à r.l., each of the Initial Members is deemed to have contributed to the Company the equity
represented by such Initial Member's stock or convertible preferred equity certificates in lastminute.com S.à r.l., which
contribution is credited to such Initial Member's capital account, in exchange for the number of Class A Units issued to
such Initial Member in such Initial Member's name, as set forth in Exhibit A hereto. Except for the foregoing consideration,
the Initial Members shall not be obligated to make capital contributions to the Company, and upon their issuance, the
Units issued to the Initial Members shall be fully paid and nonassessable.
7. Capital Accounts. A separate capital account shall be maintained for each member, and such capital accounts shall
be maintained in accordance with the provisions of § 704 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code") ,
and the Treasury Regulations promulgated thereunder.
8. Allocation of Profits and Losses. The Company's profits and losses shall be allocated among the capital accounts of
all Unit holders in proportion to the number of Units held by each Unit holder, and it shall be the intent of the members
and the Company that each Unit holder's distributive share of income, gain, loss, deduction, or credit (or item thereof)
shall be determined and allocated in accordance with this Section 8 to the fullest extent permitted by §§ 704 (b) and (c)
of the Code and the Treasury Regulations promulgated thereunder.
9. Distributions. Distributions shall be made to the members at the times and in the aggregate amounts determined
by the Management Committee (defined below) , if any, and otherwise by the Initial Members. Unless otherwise required
by the Code or the Treasury Regulations promulgated thereunder, such distributions shall be allocated among the mem-
bers in proportion to the number of Units held.
10. Appointment and Removal of Manager. At any time, and from time to time, the Initial Members may elect one or
more individuals or entities to manage the Company (such one or more individuals or entities, the "Management Com-
mittee"). The Management Committee shall govern by majority vote, each individual or entity on the Management
Committee having one vote. The Management Committee shall be responsible for any and all such duties as the Initial
Members may choose to confer upon it in this Agreement. Any individual or entity on the Management Committee shall
be automatically removed therefrom upon (i) such individual or entity's resignation or (ii) such individual or entity's
removal by the Initial Members, whichever is earlier. Any vacancy on the Management Committee may be filled as directed
by the Initial Members. No individual or entity on the Management Committee need be a member of the Company or
resident of the State of Delaware.
11. Officers. The Management Committee, if any, and otherwise the Initial Members may, from time to time, delegate
to one or more persons such authority and duties as it may deem advisable. The Management Committee or Initial
Members, as the case may be, may assign titles, in writing, to any person, including, without limitation, the titles of
President, Vice President, Secretary, Assistant Secretary, Treasurer, and Assistant Treasurer. Any number of titles may
be held by the same person. Unless otherwise provided, if the title is one commonly used for officers of a business
corporation formed under the Delaware General Corporation Law, the assignment of such title shall constitute the
delegation to such person (an "Officer") of the authority and duties that are normally associated with that title. Each
officer shall hold office until his successor shall be duly designated or until the earlier of his death, resignation, or removal.
The salaries or other compensation, if any, of the officers and agents of the Company shall be fixed by the Management
Committee, if any, and otherwise by the Initial Members. Any delegation pursuant to this Section 11 may be revoked,
with or without cause, at any time by the Management Committee, if any, or otherwise by the Initial Members. Any officer
1221
may resign as such at any time. Such resignation shall be made in writing and shall take effect at the time specified therein
or, if no time be specified, at the time of its receipt by the Company. The acceptance of a resignation shall not be necessary
to make it effective, unless expressly so provided in the resignation.
12. Authority of Members. Unless expressly authorized to do so by this Agreement, by the Management Committee,
if any, or by the Initial Members, if there be no Management Committee, no member, agent, or employee of the Company
shall have any power or authority to bind the Company in any way, to pledge its credit, or to render it liable pecuniarily
for any purpose; provided, however, that an individual or entity on the Management Committee may act by a duly
authorized attorney-in-fact.
13. Limitations on Authority. The authority of the Management Committee over the conduct of the affairs of the
Company shall be subject only to such limitations as are expressly stated in this Agreement or in the Act.
14. Dissolution. The Company shall dissolve, and its affairs shall be wound up, upon the first to occur of the following:
(a) the written consent of the Initial Members, (b) the entry of a decree of judicial dissolution under § 18-802 of the Act,
or (c) as otherwise required under the Act.
15. Transferability of Interests; Admission of Members; Authority of Initial Members.
(e) Any member may transfer or assign its limited liability company interest in the Company in whole or in part. The
transfer or assignment by a member of any or all of such member's Units shall constitute the transfer or assignment of
the pro-rata share represented by such Units of all of such member's limited liability company interest in the Company.
Unless otherwise expressly agreed to by the transferor and transferee, or assignor and assignee (as the case may be), any
transferee or assignee of a Unit or Units shall be admitted as a member, automatically and without any action on the part
of the Company or any other person or persons, effective immediately prior to such transfer or assignment.
(f) In the event the Company shall issue certificates representing Units, a transferee or assignee of certificated Units
shall, promptly after such transfer or assignment, present the certificates representing such Units, along with evidence of
the transfer or assignment satisfactory to the Company, for the recording of such transfer or assignment on the books
of the Company, but failure of a transferee or assignee so to present such certificates shall not affect or delay the validity
of a transfer or assignment pursuant to this Section 15.
(g) Any power or authority that an Initial Member has hereunder shall cease as to such Initial Member, and such Initial
Member shall cease to be an Initial Member, upon such Initial Member's transfer or assignment of all of its limited liability
company interest in the Company. If at any time there shall be no Initial Members, then all power and authority granted
to the Initial Members herein shall henceforth be granted to and exercisable by the members holding Class A Units.
16. Limitation of Liability. This Agreement hereby eliminates any and all liabilities of a member for breach of contract
and breach of duties (including fiduciary duties) of a member to the Company, any other member or Unit holder, or any
assignee of any interest in the Company; provided, however, that this Agreement does not limit or eliminate liability for
any act or omission that constitutes a bad faith violation of the implied contractual covenant of good faith and fair dealing.
17. Limitation of Duties. To the extent that, at law or in equity, a members has duties (including fiduciary duties) to
the Company, any other member or Unit holder, or any assignee of any interest in the Company, such duties are hereby
eliminated by this Agreement; provided, however, that this Agreement does not eliminate the implied contractual cov-
enant of good faith and fair dealing.
18. Amendments. Except as otherwise provided in this Agreement, this Agreement may be amended only by the Initial
Members.
19. Governing Law. This Agreement shall be construed and enforced in accordance with, and governed by, the laws
of the State of Delaware without regard to principles of conflict of laws to the extent that such principles would cause
the laws of any other jurisdiction to apply.
20. Counterparts; Execution.
(h) This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which shall be deemed an original and all
of which together shall constitute one and the same Agreement. A member need not execute this Agreement in order
to be bound by its terms.
(i) Sterling L. Miller is hereby constituted an authorized person under the provisions of 6 Del. C. § 18-204 for the sole
purpose of executing this Agreement on behalf of the Company.
21. Tax Elections. The Management Committee, if any, and otherwise the Initial Members shall have the power to
cause the Company to make all elections required or permitted to be made for income tax purposes.
22. Construction. As used herein, the term "member" includes any one of the Initial Members, and the term "members"
includes any two or more of the Initial Members. Wherever this Agreement provides that an action or approval may be
taken or given by members or Unit holders holding a specified class and proportion of Units, such action or approval
shall not be invalid solely on the grounds that it was taken or given by a single member or Unit holder, as the case may
be, holding at least the specified class and proportion of Units."
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée a décidé d'approuver le bilan d'ouverture de la Société nouvellement nommée "lastminute.com LLC" dans
l'Etat de Delaware précisant la valeur de tous les avoirs et dettes et de tous les postes du bilan de la société luxembour-
1222
geoise à la date du transfert de son siège social ensemble avec tous les avoirs et dettes, sans réserve, lesdits avoirs et
dettes étant repris intégralement par la Société désormais soumise aux lois de Delaware de la Société précédemment de
nationalité luxembourgeoise sans limite ni condition.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée a décidé d'approuver la démission de tous les gérants de la Société actuellement en fonction à la date de
la présente assemblée avec effet à compter de la Date Effective et de leur donner décharge pour l'exécution de leur
mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.
L'assemblée a en outre décidé de confirmer la nomination de tous les associés de la Société en tant que membres-
gérants de la Société avec effet à compter de la Date Effective conformément aux lois de l'Etat de Delaware.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée a décidé de donner instruction, d'autoriser et de mandater:
(a) chaque signataire autorisé de la Société en vertu des lois de l'Etat de Delaware et chaque gérant de la Société
actuellement en fonction, agissant seul et avec pouvoir de substitution, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue
de l'immatriculation de la Société avec le Secretary of State of the State of Delaware, Etats-Unis d'Amérique; et
(b) chaque gérant de la Société en fonction à la date de la présente assemblée, agissant seul et avec pouvoir de
substitution de constater l'immatriculation de la Société avec le Secretary of State of the State of Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, et la Date Effective devant un notaire de son choix au Luxembourg.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société du fait du transfert
de son siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique sont évalués à €
1.500,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes,
ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes,
en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Fait à Luxembourg à la date prémentionnée.
Après avoir lu ce procès-verbal les membres du bureau et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: M. Gadzhalova, A. Hermelinski-Ayache, A. Bramao, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15157. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2009.
Blanche MOUTRIER.
Référence de publication: 2009158569/518.
(090192115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.
Lastminute.com Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 61.585.825,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 110.199.
In the year two thousand and nine, on the tenth day of the month of December.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.
THERE APPEARED:
Me Mariya Gadzhalova, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 10 December 2009 (which
after being signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed
to be registered with it) on behalf of Mr Dominique Robyns, accountant, residing in Luxembourg on behalf of
lastminute.com LLC (previously Lastminute.com Luxembourg S.àr.l.), a limited liability company having its registered office
at YCS&T Services LLC, 1000 West Street, 17
th
Floor, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, United States
of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4762505 (the "Company"),
previously having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed of Me Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 5
th
August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial") of 7
th
January 2006 number 47 and registered with the Registre de Commerce et des
Sociétés in Luxembourg under number B 110.199, duly authorised by the seventh resolution of the extraordinary general
1223
meeting of the shareholders enacted as notarial deed of the undersigned notary dated 9th December 2009, not yet
published in the Mémorial (the "Deed").
The appearing party requested the notary to record his declarations as follows:
1. That pursuant to the Deed, the general meeting of the shareholders resolved to transfer the registered office of
the Company from Luxembourg to the State of Delaware, United States of America and to consequently change the
nationality of the Company, such transfer of registered office and the change of nationality of the Company to become
effective upon the date of the registration of the Company with the Secretary of State of the State of Delaware, United
States of America;
2. That the Company was registered with the Secretary of State of the State of Delaware on 9
th
December 2009
under number 4762505 and that the transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to the State of
Delaware, United States of America and the consequential change of nationality of the Company are thus effective as
from such date.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at € 1,000.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, it signed together with Us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le dixième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A COMPARU:
Me Mariya Gadzhalova, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 10 décembre
2009 (qui, après avoir été signé né varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée avec lui) au nom de M. Dominique Robyns, comptable, demeurant à Luxembourg, pour le
compte de lastminute.com LLC (précédemment Lastminute.com Luxembourg S.à r.l.), une limited liability company ayant
son siège social à YCS&T Services LLC, 1000 West Street, 17
e
Etage, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801,
Etats-Unis d'Amérique enregistrée avec le Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 4762505 (la
"Société"), avec siège social précédemment au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée par acte de Me
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 août 2005, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le "Mémorial") du 7 janvier 2006 sous le numéro 47 et enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés
a Luxembourg sous le numéro B 110.199, dûment autorisé par la septième résolution de l'assemblée générale extraor-
dinaire des associés suivant acte notarié du notaire instrumentant du 9 décembre 2009, non encore publié au Mémorial
(l'"Acte").
La personne comparant a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:
1. Que conformément à l'Acte, l'assemblée générale des associés a décidé de transférer le siège social de la Société
de Luxembourg vers l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique et de changer en conséquence la nationalité de la Société,
cette migration de la Société et ce changement de nationalité devant être effectifs à compter de l'immatriculation de la
Société avec le Secretary of State of the State of Delaware, Etats-Unis d'Amérique;
2. Que la Société a été immatriculée avec le Secretary of State of the State of Delaware le 9 décembre 2009 sous le
numéro 4762505 et que la migration de la Société de Luxembourg vers l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique et le
changement conséquent de la nationalité de la Société sont effectifs depuis cette date.
<i>Expensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société du fait du présent
acte sont évalués à € 1.000,-.
Dont Acte, fait et passé au Luxembourg au jour mentionné précédemment.
Après avoir lu le présent acte à la partie comparante, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le
présent acte a été rédigé en anglais et suivi d'une traduction française; à la demande de la partie comparante, en cas de
divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Signé: M. Gadzhalova, Moutrier Blanche.
1224
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15156. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2009.
Blanche MOUTRIER.
Référence de publication: 2009158573/81.
(090192129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.
Gemalog S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 130.938.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Référence de publication: 2009158471/10.
(090192291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.
Pembroke S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 24.777.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui tenue le 12 octobre 2009 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenuei>
<i>de la Porte - Neuvei>
- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Koen LOZIE et de COSAFIN S.A. repré-
sentée par M. Jacques BORDET demeurant 10 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Administrateurs et de Pierre
SCHILL, Commissaire aux Comptes.
- L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Joseph WINANDY, Administrateur, demeurant 92 rue de
l'Horizon L-5960 ITZIG Administrateur en remplacement de Monsieur Jean QUINTUS.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30.06.2010.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009155553/19.
(090188214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2009.
REM624, Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.486.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 02 décembre du Conseil d'Administrationi>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 02 décembre 2009 que les
Administrateurs ont décidé que le siège social de la société est fixé au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.
Luxembourg, le 02 décembre 2009.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2009156697/14.
(090190685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2009.
1225
Select Line S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 56.722.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés, dans leur version abrégée, au Registre de Commerce et des
Sociétés conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Michèle Grisard
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009155776/12.
(090188767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2009.
Dresdner Leasing 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 118.887.
Les comptes annuels au 30 septembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009157627/11.
(090190889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
G.O. II - Luxembourg Alfamar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 118.517.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009157630/10.
(090190862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
G.O. II - Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 113.851.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009157631/10.
(090190861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
G.O. II - Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 113.851.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009157633/10.
(090190859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
1226
EGE SERAMIK Trading Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 42.795.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009157622/12.
(090190891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
SOF European Hotel Co-Invest Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 108.776.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009157624/11.
(090190887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
G.O. II - Luxembourg Walt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 114.692.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009157636/10.
(090190858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Sands Crédit S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 20.448.
Le bilan au 30 juin 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2009157638/10.
(090190845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Avindale Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 114.817.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009157661/10.
(090190806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
1227
Church Re, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 149.829.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh day of November.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg,
(Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:
"Kyrkans Försäkring AB", having its registered office Västra kyrkogatan 6, SE 721 03 Västerås, Sweden,
here represented by Mrs Lena Lauer, Account Manager, residing professionally at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Lu-
xembourg
pursuant to a proxy given in Västerås on November 20
th
, 2009.
The proxy, initialled by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a
société anonyme which it declared organized as follows:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a company (the "Company") in the form of a société anonyme which
will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the "Articles
of Incorporation").
The Company will exist under the name of "CHURCH RE".
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
board of directors.
In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere
with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or
between such office and persons abroad, the board of directors may resolve that the registered office be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of
the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.
Art. 3. Object. The object of the Company is to effect, in Luxembourg or abroad, mainly all reinsurance operations
of risks of the Swedish Church (Svenska kyrkan), except direct insurance operations, the direct or indirect participation
in all companies or undertakings with the same or a similar corporate object and which may favour the development of
its activities, more generally all operations on movables or on real estate, commercial, civil or financial operations which
are directly linked to the corporate object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in
conformity with the provisions of the law.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at THIRTY THREE MILLION THREE HUN-
DRED THOUSAND SWEDISH KRONA (SEK 33.300.000.-) divided into THREE THOUSAND THREE HUNDRED
THIRTY (3.330) shares with a par value of TEN THOUSAND SWEDISH KRONA (SEK 10.000.-) per share.
Art. 6. Shares. The shares shall be and will remain in the form of registered shares.
A shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register
will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof.
Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company
will be entitled to rely on the last address thus communicated.
Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders' register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and
signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried out
1228
in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Furthermore,
the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or
other document showing the consent of the transferor and the transferee.
Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
The Company may issue multiple share certificates.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital of the Company may be increased or reduced in one or several
times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation
or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.
The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders
in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The board of directors shall determine the
period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.
Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-
ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the board
of directors to do so.
Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the
law.
Chapter III. - Board of Directors
Art. 9. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors composed of at least three
members who need not be shareholders.
The directors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not
exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote
a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The board of directors will choose from among its members a chairman.
It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two
directors so require.
The chairman of the board of directors will preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but
in his absence the general meeting or the board will appoint another director or another person as chairman pro tempore
by vote of the majority present at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's written notice
of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the
business to be transacted.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by e-mail of each director. No separate notice is
required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax or by e-mail another
director as his proxy.
A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several directors.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors will be
signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
chairman or by any two members of the board of directors or by the Licensed Manager.
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all
acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the
Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.
1229
Art. 13. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and the
representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees
or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined
permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal
interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the
Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, he shall make known to the board such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction,
and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of
shareholders.
The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.
Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of
any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been
delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the board, but only within the limits of such power.
Chapter IV. - Meeting of Shareholders
Art. 16. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company
represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.
Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered
office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the thirty-first
of March of each year, at 11.00 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 18. Other General Meetings. The board of directors may convene other general meetings. Such meetings must
be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company's capital so require.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of
directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 19. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the board of directors made in the forms provided for
by law. The notice will contain the agenda of the meeting.
If all of the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax or by e-mail as his
proxy another person who need not be a shareholder.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders'
meeting.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes, irrespective of the number
of the shares represented.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting of the board of directors to be produced in judicial proceedings or
otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors or by the Licensed Manager.
Art. 20. Amendment of Articles of Incorporation. Except as otherwise provided for by law, the general meeting of
shareholders, resolving as set out hereafter, may amend any provision of the Articles of Incorporation. The general
meeting of shareholders shall not validly deliberate or act unless at least one half of the subscribed corporate capital is
present or represented. If this quorum is not reached in a first meeting, a second meeting may be convened, in the manner
1230
set out in the Articles of Incorporation. The convening notice for this second meeting shall reproduce the agenda and
indicate the date of the second meeting and the presence at the first meeting. This second meeting shall validly deliberate
or act irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the
shareholders present or represented.
Notwithstanding the above, the nationality of the Company may only be changed and the commitments of the share-
holders may only be increased with the unanimous consent of all the shareholders and, as the case may be, all the
bondholders.
Chapter V. - Supervision of the accounts
Art. 21. Independent auditor. The supervision of the accounts of the Company must be entrusted to an independent
auditor ("réviseur d'entreprises indépendant") appointed by the meeting of shareholders.
Chapter VI. - Financial year, Distribution of profits
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of the same year.
The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and
accounting practice.
Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to
the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder
of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as
dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an interim dividend. The board fixes the
amount and the date of payment of that interim dividend.
Chapter VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the
same quorum and majority as for the amendment of the Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
Chapter VIII. - Applicable Law
Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and with the Luxembourg law of
December 6, 1991 on the insurance sector, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of the Company have been drawn up by the appearing party. This party has subscribed for the number
of shares shown below and has paid in cash the amount illustrated:
Shareholders
Subscribed
capital
Number
of shares
"Kyrkans Försäkring AB" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK 33,300,000.-
3.330
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
26 of the 1915 Law have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind, borne by the Company as a result of its formation, are estimated
at approximately EUR 3,700.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end in 31st December 2010.
The first annual General Meeting of Shareholders shall be held in 2011.
<i>Resolution of the sole shareholderi>
The sole shareholder has resolved:
1 that the number of directors is set at three (3) and that the following persons are appointed as directors for a period
ending at the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2011:
1231
- Mr Leif ERIKSSON, with professional address: Västra kyrkogatan 6, SE 721 03 Västerås
- Mr Tony NORDBLAD, with professional address: 12, rue Leon Lavale, L-3372 Leudelange
- Mr Göran SEVEBRANT, with professional address Strandvagen 53 B, SE 296 38 Åhus
Mr Göran SEVEBRANT, previously named is appointed Chairman of the Board of Directors.
2 The registered office shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3 "KPMG Audit" a company having its registered office at 9, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg (RCS Luxembourg, section B number 103590) is appointed as independent auditor of the Company. The
term of office of the auditor shall end at the date of the Annual General Meeting to be held in 2011.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands the English language, states that on request of the above appearing person
the present deed is worded in English and followed by a French version. At the request of the same person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname,
first name, civil status and residence, has been signed by the person appearing as an original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg. (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
"Kyrkans Försäkring AB", ayant son siège social Västra kyrkogatan 6, SE 721 03 Västerås, Suède,
représentée par Madame Lena Lauer, Account Manager, demeurant professionnellement 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg
en vertu d'une procuration donnée à Västerås le 20 novembre 2009.
La procuration, signée par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte, aux fins d'enregistrement.
La partie comparante, agissant en sa qualité susdite, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle
déclare constituée comme suit:
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société (la "Société") sous forme de société
anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les "Statuts").
La Société adopte la dénomination "CHURCH RE".
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de
transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant
qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet d'effectuer, au Luxembourg et à l'étranger, principalement toutes opérations de
réassurance des risques de l'Eglise Suédoise (Svenska Kyrkan), dans toutes les branches, à l'exception de l'assurance
directe, de prendre des participations directes ou indirectes dans toutes sociétés ou entreprises avec un objet social
identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le développement de ces activités et plus particulièrement d'ef-
fectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières qui sont directement liées à
l'objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues par
la loi.
Chapitre II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à TRENTE-TROIS MILLIONS TROIS CENT MILLE COU-
RONNES SUEDOISES (SEK 33.300.000.-) divisé en TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE (3.330) actions d'une valeur
nominale de DIX MILLE COURONNES SUEDOISES (SEK 10.000.-) par action.
Art. 6. Forme des Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
1232
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre
contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions, l'indication des paiements
effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.
Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La
Société sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.
La propriété des actions nominatives résultera de l'inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d'actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et
signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d'actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la Société
peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance ou autre
document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.
Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d'actions multiples.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées
par ces Statuts et par la loi pour toute modification des Statuts.
Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.
Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel ou autoriser le Conseil d'Administration à le faire.
Art. 8. Rachat d'Actions Propres. La Société peut racheter ses propres actions.
L'acquisition et la détention de ses actions propres se feront en accord avec les conditions et dans les limites établies
par la loi.
Chapitre III. - Conseil d'administration
Art. 9. Conseil d'administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d'élire par
un vote majoritaire un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 10. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il
pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des
procès- verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si
deux administrateurs le demandent.
Le président du conseil d'administration présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil
d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre
administrateur ou une autre personne pour présider la réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette
réunion. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur ou par courrier
électronique de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Toute réunion du conseil d'administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d'adminis-
tration peut de temps en temps déterminer.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par
télécopieur ou par courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
1233
En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait
été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil
d'administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès- verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du
conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par le Dirigeant Agréé.
Art. 12. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expres-
sément à l'assemblée générale par la loi ou les Statuts sont de la compétence du conseil d'administration.
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de
pouvoirs, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs
ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
Art. 14. Conflit d'Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoirs
de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une
autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour
le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes
opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en
avisera le conseil d'administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la
connaissance de la prochaine assemblée générale.
La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique
que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède
n'exclut pas pour les personnes sus-nommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux
administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée,
dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes
à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.
Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires
Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée re-
présente l'ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 17. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège
social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le 31 mars de chaque année à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De
telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le
demandent.
Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.
Art. 19. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d'administration conformément
aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle- ci peut se tenir sans convocations préalables.
1234
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par courrier électronique
un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d'actions
représentées.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par le Dirigeant Agréé.
Art. 20. Modification des Statuts. Sauf dispositions contraires de la loi, l'assemblée générale des actionnaires, décidant
conformément à ce qui suit, peut modifier les dispositions des Statuts. L'assemblée générale des actionnaires ne pourra
délibérer et agir valablement que si au moins la moitié du capital souscrit et présente ou représentée. Au cas où ce quorum
n'est pas atteint à la première assemblée, une deuxième assemblée pourra être convoquée conformément aux Statuts.
La convocation pour cette deuxième assemblée indiquera l'ordre du jour et la date de la deuxième assemblée, ainsi que
le nombre de présence à la première assemblée. Cette deuxième assemblée délibère et agit valablement quel que soit le
nombre d'actions présentes ou représentées.
Lors des deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Nonobstant ce qui précède, la nationalité de la Société ne peut être changée et les apports des actionnaires ne peuvent
être augmentés que par l'accord unanime de tous les actionnaires et, s'il y a lieu, de tous les obligataires.
Chapitre V. - Surveillance
Art. 21. Réviseur d'entreprises indépendant. La surveillance des comptes de la Société doit être confiée à un réviseur
d'entreprises indépendant. Ce réviseur d'entreprises indépendant est nommé par l'assemblée générale.
Chapitre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
la même année.
Le conseil d'administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-
tiques comptables.
Art. 23. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.
Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde
des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VIII. - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément à la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et conformément à la loi modifiée du 6 décembre 1991
sur le secteur des assurances.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre d'actions indiqué ci-dessous et
a libéré en espèces le montant tel que ci-après énoncé:
Associé unique
Capital souscrit
Nombre
d'actions
Kyrkans Försäkring AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK 33.300.000
3.330
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article
26 de la Loi de 1915 ont été respectées.
1235
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ 3.700,- EUR.
<i>Dispositions Transitoiresi>
La première année sociale commence à la date de constitution et se termine le 31 décembre 2010.
La première assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2011.
<i>Résolution de l'associé uniquei>
L'associé unique a adopté les résolutions suivantes:
1 Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour
une période allant jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011:
- Monsieur Leif ERIKSSON, avec adresse professionnelle Västra kyrkogatan 6, SE 721 03 Västerås;
- Monsieur Tony NORDBLAD, avec adresse professionnelle 12, rue Léon Lavale, L-3372 Leudelange;
- Monsieur Göran SEVEBRANT, avec adresse professionnelle Strandvägen 53 B, SE 296 38 Åhus.
Monsieur Göran SEVEBRANT, prénommé, est nommé président du Conseil d'Administration.
2 Le siège social est fixé au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3 "KPMG Audit", une société ayant son siège social établi au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg (RCS Luxembourg, section B numéro 103590), est nommé en tant que réviseur d'entreprises indépendant
de la Société. Le mandat du réviseur d'entreprises indépendant expire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2011.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande du même comparant, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. LAUER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/51074. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2009157467/465.
(090191329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Winab S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 110.256.
Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009157662/10.
(090190808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Winab S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 110.256.
Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009157663/10.
(090190809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
1236
Winab S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 110.256.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009157664/10.
(090190810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Mezzanine Management Central Europe Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 91.841.
Les comptes annuels audités au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009157563/11.
(090190918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Cybertrust Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 87.367.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2009157564/11.
(090190923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Consortium International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 85.133.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009157567/10.
(090190931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Luxengineering Bevilacqua & Associés S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adelaïde.
R.C.S. Luxembourg B 25.907.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2009157572/11.
(090190945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
1237
proma Unternehmensberatung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 111.865.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2009157573/12.
(090190951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Zafini Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 114.674.
Les comptes annuels au 29 Février 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2009157574/11.
(090190952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Peterstreet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 62.124.
Le Bilan au 31 octobre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009157659/10.
(090190805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
GSLP International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 3, place Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 26.363.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009157667/10.
(090190813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Liégeois Strassen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 127.935.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009157685/10.
(090191479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
1238
SEMTAN Luxembourg SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 149.811.
STATUTS
L'an deux mille neuf, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) SEMTAN MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Nicosie, Chypre, 12 Egypt Street, PC1097, enregistrée
auprès du registre des sociétés de Chypre sous la référence HE248285
2) INTERGEM HOLDING S.A., avec siège social à Panama, east 53
rd
Street, Marbellla, Swiss bank building, 2
n
d
floor,
enregistrée auprès du Registre Public de Panama sous la référence 536450
3) MONEGATE HOLDING S.A. avec siège à Panama, east 53
rd
Street, Marbellla, Swiss bank building, 2
nd
floor,
enregistrée auprès du Registre Public de Panama sous la référence 536435
Toutes trois représentées aux fins des présentes par Monsieur Stéphane Biver, employé privé, demeurant profes-
sionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, en vertu de trois procurations données le 23 octobre
2009.
Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants, et par le notaire instrumentant, res-
teront annexées aux présentes
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
en commandite par action dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Nom et Forme.
Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront associés par la suite une société luxembourgeoise sous
forme de société en commandite par actions sous la dénomination de "SEMTAN Luxembourg SCA".
Art. 2. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par
décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Objet social.
La Société a pour objet la mise en valeur de ses actifs apportés ainsi que la prise de participations sous quelque forme
que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces
participations, ainsi que l'acquisition et la mise en valeur de créances et plus généralement de tout instrument financier.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
Art. 4. Siège social.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Au cas où le commandité estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de
nature à compromettre l'activité normale au siège social se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provi-
soirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise .
Art. 5. Capital.
Le capital social est fixé à TREIZE MILLIONS QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS (EUR 13.420.000,-) réparti en:
- DIX (10) actions de commandité et,
- SIX CENTS (600) actions de commanditaire,
chacune d'une valeur nominale de VINGT-DEUX MILLE EUROS (EUR 22.000,-).
Art. 6. Cessibilité des actions de commanditaire.
La cession entre vifs ou pour cause de mort des actions de commanditaire doit être approuvée par les actionnaires
possédant la majorité simple des actions de commanditaire votant comme une catégorie d'actionnaire et par les action-
naires représentant la majorité simple des actions de commandité votant comme une catégorie d'actionnaires. Lors du
vote de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur l'agrément d'un nouvel actionnaire, les droits de vote des
actions proposées à la cession sont suspendus.
1239
En cas du refus d'un transfert proposé, les titulaires d'actions de commanditaire à transférer pourront, dans le mois
du refus, proposer un autre bénéficiaire.
En cas de nouveau refus, les titulaires d'actions de commanditaires autres que le cédant, auront le droit, en proportion
de leur participation dans les actions de commanditaire, d'acquérir les actions de commanditaire proposées à la vente au
prix représentant la valeur du marché déterminée par un expert spécialisé en valorisation de sociétés et reconnu, désigné
par l'actionnaire commandité, se basant sur la capacité bénéficiaire de la société et la valeur de son actif net, agissant
comme arbitre en conformité des dispositions du code de procédure civile tel qu'il sera en vigueur.
A défaut d'acquisition des actions de commanditaire proposées à la cession par les titulaires d'actions de commanditaire
autres que l'actionnaire commanditaire cédant, les actions seront acquises aux conditions fixées au paragraphe précédent
par la société conformément à la Loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 7. Les actions de commandité sont incessibles.
Art. 8. Saisie.
En cas de saisie d'actions de commanditaire, le droit de vote des actions de commanditaire saisies est suspendu jusqu'à
l'issue de la procédure de saisie.
Les actions de commandité sont insaisissables.
Art. 9. Forme des actions - Registre.
Les actions de commandité et de commanditaire sont émises uniquement sous forme nominative.
Toutes les actions nominatives seront enregistrées dans un registre des actionnaires qui sera tenu par la société. Ce
registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son domicile réel ou élu, le nombre des actions qu'il détient divisé
entre les différentes catégories ainsi que le montant libéré sur chacune de ces actions.
Art. 10. Responsabilité des actionnaires.
Le propriétaire d'actions de commandité est responsable de toutes dettes et pertes ne pouvant être payées sur les
actifs de la société.
Les détenteurs d'actions de commanditaire ne sont tenus que de leurs mises dans la société.
Art. 11. Convocation aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le commandité ou par le conseil de surveillance des commissaires aux
conditions et délais prévus par la loi.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Art. 12. Délibérations de l'assemblée générale.
L'assemblée générale délibérera uniquement sur celles des matières qui ne sont pas réservées au commandité par ces
statuts.
Toute assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société et sera présidée par un président désigné par le commandité.
Art. 13. Date et lieu de l'Assemblée ordinaire.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, le deuxième mardi du mois de
mai à 11.00 heures.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans l'avis de convocation.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit ou téléfax une autre
personne comme son mandataire.
Art. 14. Droits de vote.
Toute action de commandité et toute action de commanditaire comporte un droit de vote à chaque assemblée d'ac-
tionnaires, sauf disposition contraire de la loi luxembourgeoise ou des présents statuts.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi et les statuts, les résolutions de l'assemblée générale
des actionnaires seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Aucune décision de l'assemblée ne sera valablement prise sans l'accord du commandité.
Les distributions de dividendes seront déterminées par le commandité avec l'approbation de l'assemblée générale des
actions votantes.
Le commandité est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités
fixées par la loi.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre monnaie choisie par le commandité, ainsi qu'aux
endroits et dates déterminés par le commandité. Ce dernier déterminera souverainement le taux de change applicable
pour la conversion des dividendes dans leur monnaie de paiement.
1240
Art. 15. Nomination de l'actionnaire commandité.
Le commandité sera SEMTAN MANAGEMENT LIMITED, Nicosie, Chypre, 12 Egypt Street, PC1097, enregistrée
auprès du registre des sociétés de Chypre sous la référence HE248285.
Art. 16. Pouvoirs et Rémunération de l'actionnaire commandité.
Le commandité dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous actes d'administration et de disposition dans
l'intérêt de la société et sera indemnisé de toutes dépenses relatives à sa qualité de commandité.
Le commandité pourra être rémunéré. Sa rémunération sera alors décidée et fixée par l'Assemblée générale des
actionnaires.
Art. 17. Délégation.
Le commandité peut, à tout moment, nommer des agents de la société tel que nécessaire pour les opérations et la
gestion de celle-ci sous réserve toutefois que les propriétaires d'actions de commanditaire ne peuvent agir au nom de la
société sans perdre le bénéfice de leur responsabilité limitée. Les agents nommés auront les pouvoirs et devoirs qui leur
auront été conférés par le commandité.
Art. 18. Conflits d'intérêts.
Aucun contrat ni aucune transaction entre la société et une autre société ou entité ne pourra être affecté ou invalidé
par le fait que le commandité ou un ou plusieurs de ses agents ont un intérêt dans cette autre société ou entité ou en
sont administrateurs, responsables ou employés.
Tout commandité ou responsable de la société qui est administrateur, ou responsable d'une société ou entité avec
laquelle la société passe des contrats ou entre autrement en relations d'affaires ne saurait être, en raison de cette affiliation
avec une autre société ou entité, privé du droit de délibérer et de voter sur les matières ayant trait à pareil contrat ou
affaire.
Art. 19. Représentation et Modes de signatures.
La société sera engagée par la signature individuelle du commandité, de son représentant permanent ou par les signa-
tures individuelle ou conjointes de toutes personnes porteuses de pouvoirs conférés par le commandité.
Art. 20. Conseil de Surveillance.
Les opérations de la société seront supervisées par un conseil de surveillance composé de trois commissaires au moins.
Ceux-ci seront élus par l'assemblée générale pour une période de six ans maximum, étant entendu cependant que les
commissaires pourront être démis avec ou sans motivation et remplacés à tout moment par un vote des actionnaires.
Art. 21. Exercice social.
L'exercice social de la société commencera le premier janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Répartition du bénéfice.
Le bénéfice net de la société sera réparti comme suit:
1) avant toute autre affectation ou distribution, cinq pour cent du bénéfice net sera affecté à la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire aussitôt et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent du capital
social;
2) le solde sera soit distribué aux actionnaires, soit affecté à une ou plusieurs réserves spéciales, soit reporté à nouveau
pour l'exercice suivant en fonction des décisions de l'assemblée générale des actionnaires.
3) En cas de distribution aux actionnaires, dix pour cent du bénéfice sera distribué aux titulaires d'actions de com-
mandité et le solde sera distribué aux actionnaires commanditaires.
Art. 23. Dissolution.
En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins du commandité.
Le produit de la liquidation, sera distribué à concurrence dix pour cent aux titulaires d'actions de commandité et le
solde sera distribué aux actionnaires commanditaires.
Art. 24. Modification des statuts.
Les présents statuts pourront être modifiés ainsi qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires sou-
mise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise ainsi qu'aux dispositions de l'article 14
des présents statuts.
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2009.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010
1241
<i>Souscription libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, tous prénommés et représentés tels que dit ci-avant,
déclarent séparément souscrire les SIX CENT DIX (610) actions comme suit:
<i>Actions de commandité:i>
- SEMTAN MANAGEMENT LIMITED préqualifiée - DIX (10) actions
Total DIX (10) actions de commandité
<i>Actions de commanditaire:i>
- INTERGEM HOLDING S.A. préqualifiée - CENT CINQUANTE (150) actions
- MONEGATE HOLDING S.A.préqualifiée - QUATRE CENT CINQUANTE (450) actions
Total SIX CENTS (600) actions de commanditaire
SEMTAN MANAGEMENT LIMITED, INTERGEM HOLDING S.A. et MONEGATE HOLDING S.A. déclarent libérer
les actions intégralement par apport en nature consistant en soixante et une 61 "Notes" d'une valeur nominale de cent
vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) émises par la société Estates S.A., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg,
370, route de Longwy RC.S. Luxembourg B 106.770 ("l'Apport"),
Les Souscripteurs ont déclaré que qu'il n'existe aucun obstacle au libre transfert de l'Apport à la Société, et que des
instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires
pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.
La preuve de l'existence et de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné
Conformément à l'article 26 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les obligations apportées
ont fait l'objet d'un rapport daté du ...... établi par Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'entreprise, demeurant L-9088
Ettelbruck, rue de Warken, 147, qui conclut comme suit:
<i>"Conclusioni>
Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des
apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale respectivement au pair comptable des actions à
émettre en contrepartie."
Ce rapport, après avoir été signé ne variatur par le mandataire des comparants et par le soussigné notaire, restera
annexé au présent acte afin d'être enregistré avec ce dernier.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigée par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été observées.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ cinq mille cinq cents euros (5.500,-
EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des membres du conseil de surveillance est fixé à trois.
2. Les personnes suivantes sont élues membres du conseil de surveillance:
- Monsieur Stéphane Biver, employé privé, né à Watermaël Boitsfort (Belgique) le 3 août 1968 demeurant au profes-
sionnellement 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
- M
e
Benoit Caillaud, avocat, né à Paris (France) le 11 octobre 1976, demeurant au professionnellement 128, boulevard
de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
- Monsieur Alain Noullet, employé pivé, né à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) le 2 novembre 1960 demeurant au
professionnellement 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
3. Le mandat des membres du conseil de surveillance prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2014.
4. L'adresse de la société est fixée à L-1931 Luxembourg, avenue de la liberté, 55, C/O Liberty center.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
1242
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand nine, on the twenty-seventh day of November.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
1) SEMTAN MANAGEMENT LIMITED, with registered office at Nicosia, Cyprus, 12 Egypt Street, PC1097, registered
with the trade registrar under the reference HE248285
2) INTERGEM HOLDING S.A., with registered office at Panama, east 53
rd
Street, Marbellla, Swiss bank building, 2
nd
floor, registered with the public registrar under the reference 536450
3) MONEGATE HOLDING S.A. with registered office at Panama, east 53
rd
Street, Marbellla, Swiss bank building, 2
nd
floor, registered with the public registrar under the reference 536435
all represented by Mr Stéphane Biver, employee, with professional address at 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330
Luxembourg, by virtue of three proxy given on 23
rd
October 2009.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain attached to
the present deed
Such appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to inscribe as follows the
articles of association of a "société en commandite par actions":
Art. 1. Company name and Form.
Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Lux-
embourg company under the form of a Society en Commandite par Actions is hereby formed under the title "SEMTAN
Luxembourg SCA".
Art. 2. Duration.
The Company is established for an unlimited period from the date hereof. The Company may be dissolved prior to
the end of its life by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles
of Incorporation.
Art. 3. Object.
The object of the Company is the development of its assets and the holding of participations, in any form whatsoever,
in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these partici-
pations and the acquisition and development of claims and more generally of any financial tools.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.
Art. 4. Registered office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any effect
on this company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the head office, will remain a Luxembourg
company.
Art. 5. Capital.
The subscribed capital is fixed at THIRTEEN MILLION FOUR HUNDRED TWENTY THOUSAND EURO (EUR
13,420,000.-) represented by:
- TEN (10) Management ("actions de commandité") shares, hereinafter referred to as a "management shares" and,
- SIX HUNDRED (600) Ordinary ("actions de commanditaire") shares, hereinafter referred to as "ordinary shares".
With a par value of TWENTY-TWO THOUSAND EURO (EUR 22,000.-) each.
Art. 6. Assignment of ordinary shares.
No assignment of ordinary shares amongst shareholders or to any heirs-at-law shall be made without the approval of
the shareholders holding the simple majority of the ordinary shares voting as a category of shareholders and without the
approval of the shareholders holding the simple majority of the management shares voting as a category of shareholders.
The voting rights of the shares proposed for transfer will be suspended at the shareholders meeting deciding on the
approval or unapproval of the proposed assignment.
In case of refusal of the proposed assignment the holder of the ordinary shares to be transferred may, in the month
of the refusal, propose another beneficiary.
1243
In case of another refusal of the assignment, the shareholders holding the ordinary shares, except the holder of the
ordinary shares to be transferred, shall have the right to acquire the ordinary shares to be transferred in proportion of
their participation in ordinary shares at a Price representing the market value determined on the earning capacities and
the asset value of the company by a renowned expert in valuing companies appointed by the shareholders holding the
management shares, acting as a referee in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure in force.
In case the above mentioned preemption right is not used, the shares will be acquired by the company under the
conditions of the amended law of August 15, 1915 about commercial companies.
Art. 7. The management shares shall not be assigned.
Art. 8. Seizure of shares.
In case of seizure of ordinary shares, the voting rights attached to them will be immediately suspended until the end
of the seizure process.
The management shares can not be subject to any kind of seizure. .
Art. 9. Form of the shares.
The management and ordinary shares of the company shall be in registered form.
All the shares of each category shall be registered in a shareholders' register to be maintained by the Company. The
register will mention the shareholder's name and its effective or elected domicile, the number of shares of each category
owned, and the paid up amount of each shares.
Art. 10. Partner's liability.
The owner of the management share is liable for all losses which cannot be recovered on the company's assets.
The holders of ordinary shares are only liable up to the amount of their capital contribution to the company.
Art. 11. Gathering of the General Meeting.
The general meeting may be convened by the Manager or by the Supervisory Board subject to the conditions and time
limits foreseen by the law
If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and when they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 12. Decisions of the General Meeting.
The general meeting of shareholders shall deliberate only on the matters which are not reserved to the Manager by
the articles of incorporation
Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of shareholders of
the Company and shall be presided over by a chairman appointed by the Manager.
The meeting of shareholders shall deliberate only on the matters which are not reserved to the Manager by the articles
of incorporation.
Art. 13. Date and Hour.
The annual General Meeting of shareholders shall be held on the second Tuesday of May at 6.00 a.m. at the Company's
registered office
The other general meetings of shareholders may be held at a time and a place as specified in the notice of meetings.
Any shareholders can take part in the general meeting by appointing in writing or by cable, telex or telefax another
person as his faithful attorney.
Art. 14. Voting rights and Dividends.
Any management share and any ordinary share is carrying one voting right in the general meeting, except when oth-
erwise required by the law.
Except as otherwise required by law or by the articles of association, resolutions at the meeting of shareholders, shall
be passed by a simple majority of those present and voting.
No decision shall be validly taken without the approval of the Manager.
The distribution of dividends shall be decided by the Manager with the approval of the general meeting of shareholders.
The Manager is authorized to proceed with the payment of interim dividends within the limits laid down by the law.
The dividends may be paid in euro or in any other currency, at the date and the place determined by the Manager.
The Manager is entitled to determine the exchange rate applicable for the conversion of any dividends in their currency
of payment.
Art. 15. Appointment of the Manager.
The Manager shall be SEMTAN MANAGEMENT LIMITED, with registered office at Nicosia, Cyprus, 12 Egypt Street,
PC1097, registered with the trade registrar under the reference HE248285 (herein "The Manager")
1244
Art. 16. Powers of the Manager and Remuneration.
The Manager is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Com-
pany's interest and shall be refunded for all expenses and disbursements relating to the management of the company. The
Manager may be entitled to a remuneration, which should be decided by the general meeting of the shareholders.
Art. 17. Appointment of attorneys and Agents.
The Manager may, at any time, appoint agents of the company as required for the affairs and management of the
company, provided the owners of ordinary shares cannot act on behalf of the company without loosing the benefit of
their limited liability. The appointed agents shall be entrusted with the powers and duties conferred to them by the
Manager.
Art. 18. Unlimited interlocking mandates.
No contracts or other transactions between the company and any other company or entity shall be affected or
invalidated by the fact that the Manager or any of its directors officers or employees is interested in, or is a director, or
officer or employee of such other company or entity.
In addition, the exercise of function in any other company by the Manager or one of its representatives, employees
or agents will not prevent The Manager or its representatives, officers, employees or agents to use their voting or decision
rights into the Company.
Art. 19. Signature rights.
The company will be bound by the single signature of the Manager , by its permanent representative or by the single
or joint signatures of any person to whom such power shall be delegated by the Manager.
Art. 20. Supervision board.
The supervision of the operations of the company will be entrusted to a Supervisory board of at least three members.
They are elected by the general meeting for a maximum period of six years. The members of the supervisory board may
at any time be removed and replaced with or without justification by the shareholders.
Art. 21. Accounting year.
The accounting year of the company begins on 1
s
t
(first) January and terminates on 31
st
(thirty-first) December of
the year.
Art. 22. Profit allocation.
The annual net profit shall be allocated as follows:
1) Five percent (5%) of the net profit shall be allocated at the legal reserve before any other allocation or distribution
of profit. This allocation shall cease to be required as soon as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%)
of the subscribed capital of the company.
2) The remainder shall be either distributed to the shareholders, either allocated to one or more special reserves or
carried forward in accordance with the decisions of the general meeting of shareholders.
3) In case of dividend distribution, 10% of the dividends are deemed to the Manager shares while the remaining will
be equally distributed to the ordinary shares.
Art. 23. Winding up / Dissolution of the company.
In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by the Manager.
Art. 24. Modification of the articles of association.
These articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorums and voting
requirements provided by Luxembourg law.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
th
August, 1915 governing Commercial Companies.
<i>Transitory dispositionsi>
The first accounting year which will begin on the date hereof and shall terminate on 31
s
t
(thirty-first) December
2009.
The first annual general meeting shall be held on 2010.
<i>Subscription paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing parties, all pre-named and represented as stated
here above, declare separately to subscribe for the SIX HUNDRED TEN (610) shares as follows:
<i>Management share:i>
- SEMTAN MANAGEMENT LIMITED, Cyprus- TEN (10) shares
Total TEN (10) Management shares
1245
<i>Ordinary shares:i>
- INTERGEM HOLDING S.A. - ONE HUNDRED AND FIFTY (150) shares
- MONEGATE HOLDING S.A. - FOUR HUNDRED AND FIFTY (450) shares
Total SIX HUNDRED TEN (600) Ordinary shares
SEMTAN MANAGEMENT LIMITED, INTERGEM HOLDING S.A. et MONEGATE HOLDING S.A. declare that all
these shares have been paid up in totality through the contribution in kind consisting of sixty-one (61) "notes" with a
nominal value of ONE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND EURO (EUR 125,000.-) issued by Estates S.A., having
its registered office at L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy RC.S. Luxembourg B 106.770 ("The Contribution")
The subscribers declared that that there exists no impediments to the free transferability of the Contribution to the
Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.
Proof of the existence and the ownership of such Contribution has been given to the undersigned notary.
In respect of article 26 of the modified law dated August 10th, 1915 on commercial companies, the contribution of
the notes has been estimated in an independent auditor's report established by Mr Mangen FONS, "réviseur d'entreprises",
residing in L-9088 Ettelbruck, rue de Warken, 147, which confirms the following:
<i>"Conclusioni>
Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des
apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale respectivement au pair comptable des actions à
émettre en contrepartie."
The auditor's report, after being signed "ne variatur" by the appearing parties and the Notary will remain attached to
the present deed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in Article 26 of
the Commercial Companies Act and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately five thousand five hundred euro (EUR 5,500.-)
<i>General Meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of the members of the Supervisory board is set at three.
2. The following persons are elected members of the Supervisory board:
- Mr Stéphane Biver, employee, born in Watermaël Boitsfort (Belgium) on 3rd August 1968, with professional address
at 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
- M
e
Benoit Caillaud, avocat, born in Paris on 11 October 1976, with professional address at 128, boulevard de la
Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
- Mr Alain Noullet, employee, born in Berchem-Sainte-Agathe (Belgium) on 2nd November 1960, with Professional
address at 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
3. The term of office of the members of the Supervisory board shall end at the annual general meeting in 2014.
4. The address of the company is L-1931 Luxembourg, avenue de la Liberté, 55, C/O Liberty center.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by her surname, Christian name, civil
status and residence, the said appearing persons signed together with the notary the present original deed.
Signé: S. BIVER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/50998. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
1246
Luxembourg, le 10 décembre 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009157475/420.
(090191157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Balfour & Partners Management S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 86.051.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009157665/9.
(090190811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Balfour & Partners Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 86.051.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009157666/9.
(090190812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Crab International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 131.366.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2008 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du
contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009157651/16.
(090190801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Café-Auberge KIRCH S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-9010 Ettelbruck, 5, rue de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 104.204.
DISSOLUTION
L'an deux mille neuf, le premier décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1. Monsieur Jeannot KIRCH, indépendant, demeurant à L-9053 Ettelbruck, 7a, Impasse J.F. Kennedy;
2. Madame Marie-Astride HENTGES, indépendante, épouse de Monsieur Jeannot KIRCH, demeurant à L-9053 Ettel-
bruck, 7a, Impasse J.F. Kennedy.
Les deux sont ici représentés par Madame Sophie BATARDY employée privée, demeurant professionnellement à
L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration,
après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin
d'être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme
suit leurs déclarations:
1247
a) Que la société à responsabilité limitée "Café-Auberge KIRCH S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-9010
Ettelbruck, 5, rue de Bastogne, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 104204, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire alors de
résidence à Mersch, en date du 11 octobre 2000, publié Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
227 du 28 mars 2001.
b) Que le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur de dix euros (EUR 10,-) chacune.
c) Que les comparants, en tant que seuls et uniques associés de la Société (les "Associés") prononcent la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liquidation.
d) Que les Associés déclarent avoir pleine connaissance des statuts de la Société et qu'ils connaissent parfaitement la
situation financière de la Société.
e) Que les Associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent que l'activité de la Société a cessé et que
le passif connu de la Société a été payé ou provisionné.
f) Que les Associés sont investis de tout l'actif et qu'ils s'engagent expressément à prendre à leur charge tout passif
pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour au prorata de sa participation
dans la Société.
g) Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
h) Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat.
i) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins chez Monsieur
Jeannot KIRCH à L-9053 Ettelbruck, 7a, Impasse J.F. Kennedy.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante
euros et les comparants, en tant qu'associés, s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, ès qualités qu'elle agit, connue du
notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: BATARDY - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 décembre 2009. Relation GRE/2009/4534. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Junglinster, le 14 décembre 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009157517/53.
(090190774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Groupement Forestier Clervaux, Association sans but lucratif.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 30.
R.C.S. Luxembourg F 6.537.
Laut Beschluss der Generalversammlung vom 23.November 2009 wurde der Sitz
(lt Artikel 1 der Statuten)
vom
Groupement Forestier a.s.b.l.
Maison 21
L-9753 Heinerscheid
verlegt nach:
Maison 30
L-9980 Wilwerdange
Wilwerdange, 11.12.2009.
Unterschrift.
Référence de publication: 2009157879/17.
(090191545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
1248
Avindale Investments S.A.
Balfour & Partners Management S.A.
Balfour & Partners Management S.A.
Café-Auberge KIRCH S.à r.l.
Church Re
Consortium International S.A.
Crab International S.A.
Cybertrust Luxembourg S.à r.l.
Dresdner Leasing 2 S.àr.l.
EGE SERAMIK Trading Holding S.A.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Dritte S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Erste S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Vierte S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Zweite S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. S.T. Erste S.e.c.s.
Gemalog S.A.
G.O. II - Luxembourg Alfamar S.à r.l.
G.O. II - Luxembourg Finance S.à r.l.
G.O. II - Luxembourg Finance S.à r.l.
G.O. II - Luxembourg Walt S.à r.l.
Groupement Forestier Clervaux
GSLP International S.à r.l.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante cinquième (65.) S.e.c.s.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante cinquième (65.) S.e.c.s.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante huitième (68.) S.e.c.s.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante huitième (68.) S.e.c.s.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante septième (67.) S.e.c.s.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante septième (67.) S.e.c.s.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante sixième (66.) S.e.c.s.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante sixième (66.) S.e.c.s.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Trente Cinquième (35.) S.e.c.s.
INNCONA S.à r.l. & Cie. Trente Cinquième (35.) S.e.c.s.
Lastminute.com Luxembourg S.à r.l.
Lastminute.com Luxembourg S.à r.l.
Liégeois Strassen S.à r.l.
Luxengineering Bevilacqua & Associés S.A.
Mezzanine Management Central Europe Investment S.A.
Pembroke S.A.
Peterstreet S.A.
proma Unternehmensberatung S.à r.l.
REM624
Sands Crédit S.A.
Select Line S.A.
SEMTAN Luxembourg SCA
SOF European Hotel Co-Invest Holdings, S.à r.l.
Winab S.A.
Winab S.A.
Winab S.A.
Zafini Holding