logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2491

22 décembre 2009

SOMMAIRE

ArcelorMittal Long Carbon Europe  . . . . . .

119565

Arno Glass Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119554

Beda Regiebau Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

119566

Ben Luxembourg 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119566

Ben Luxembourg 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119566

Birkdale Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119555

Bluegems Investments Sicar, S.à r.l.  . . . . .

119565

Bucher Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

119555

Bucher Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119555

Cetinblew Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . .

119568

Cirsa Funding Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

119528

Cork Supply Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119542

D & G Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119565

DP Investment (Holding) S.A.  . . . . . . . . . . .

119541

Elgin Credit Plus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119540

FLE Finco S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119525

FLE SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119524

G.A. - Fund -L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119539

Gavilon Luxembourg HoldCo II S.à r.l.  . . .

119525

Gavilon Luxembourg HoldCo S.à r.l. . . . . .

119526

GSI Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119522

GSMP 3 Onshore S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119554

Head IT S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119550

Hôtel-Restaurant Chez Jean Sàrl  . . . . . . . .

119566

IMP East Real Estate Investments S.A.  . . .

119524

Intel Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119541

JMW Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

119564

JMW Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

119564

Jog S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119528

Krokus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119550

Labmed S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119523

Laboratoire Dentaire Fleischhauer S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119523

Levanter Real 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119560

Levanter Real 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119560

Levanter Real 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119555

Levhold Germany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

119565

LFPI Property S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119526

Libidama International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

119523

Logwin Road + Rail Luxemburg S.à r.l.  . . .

119564

Marroni Finances Holding S.A.  . . . . . . . . . .

119550

Medine-Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119564

MW Unitexx S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119524

Nabi Biopharmaceuticals Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119526

Orlando Italy Special Situations SICAR

(SCA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119561

Pike Environment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119560

Property Finance France S.A.  . . . . . . . . . . .

119522

QOA Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119525

Rusta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119522

Solar Generation Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

119550

Sopawa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119567

STK Metall S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119567

Svelux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119563

Tecanox Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119554

Thiel EuroLogistics Services S.à r.l.  . . . . . .

119564

Thinnes Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119567

Tribal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119564

Trivox S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119565

Waru S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119567

Wesley S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119554

119521

Rusta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 77, rue des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 110.999.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RUSTA S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009152063/12.
(090184328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

GSI Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 93.227.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GSI HOLDING S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009152064/12.
(090184193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Property Finance France S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 82.080,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 64.844.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 9 décembre 2008 de la société Property

Finance France S.A. que les Actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. La démission de M. Dietmar Koch, avec adresse professionnelle au Taunusstrasse 1, 65193 Wiesbaden, Allemagne,

de son mandat de Gérant de la Société avec effet immédiat a été acceptée.

2. M. Michael Krzanowski, avec adresse professionnelle au Taunusstrasse 1, 65193 Wiesbaden, Allemagne, a été nommé

nouveau Gérant de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

3. La durée du mandat des Gérants existants, M. Bernhard Klinger et Roland Burgmaier a été renouvelée jusqu'à

l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

Par conséquence, le nouveau conseil de gérance est composé de la façon suivante:
1. M. Roland Burgmaier
2. M. Bernhard Klinger
3. M. Stefan Krausch
4. M. Michael Krzanowski
5. M. Oliver May
6. M. Dirk Ruppert
Il est également à noter que l'adresse professionnelle de M. Dirk Ruppert, un des Gérants de la société, est désormais

au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2009.

<i>Pour Property Finance France S.A.
Oliver May
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009153060/30.
(090185411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

119522

Labmed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 42.028.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B+C s.à.r.l.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009152065/12.
(090184560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Laboratoire Dentaire Fleischhauer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8255 Mamer, 40, rue Mont Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.494.

Les comptes annuels au 30.06.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B+C s.à.r.l.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009152066/12.
(090184559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Libidama International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 20.717.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 09 novembre 2009 à Luxembourg

L'assemblée générale décide de remplacer les administrateurs actuels du Conseil d'Administration avec adresse pro-

fessionnelle à L-1420 Luxembourg, 5-11 avenue Gaston Diderich à savoir Monsieur Marcel Dell, Madame Isabelle Jurain,
Monsieur Pol Thielen, Monsieur Pierre Thielen, Monsieur Olivier Wagner avec effet immédiat.

Sont nommés nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2013:
Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman
Monsieur Raymond Henschen, administrateur, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman
Madame Bénédicte Robaye, administrateur, demeurant à B-6860 Léglise, 40, rue des Combattants
Est nommé administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2013:
Madame Monique Henschen-Haas, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.
Elle peut engager la société par sa seule signature.
L'assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes Monsieur Daniel Cravatte avec adresse pro-

fessionnelle à L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich avec effet immédiat.

Est  nommé  nouveau  commissaire  aux  comptes  la  société  Fiduplan  S.A.,  RCS  B-44.563  avec  siège  social  à  L-1635

Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

Son mandat expirera à l'assemblée générale de l'année 2013.
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de
L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich à
L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A
Signature

Référence de publication: 2009153194/30.
(090185497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

119523

FLE SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.600.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FLE SICAV-FIS
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009152067/13.
(090184195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

IMP East Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.547.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMP East Real Estate Investments S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009152068/12.
(090184555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

MW Unitexx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.178.

<i>Extrait du Procès-Verbal

<i>de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 27 novembre 2009

L'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le nombre d'Administrateurs de 1 [un] à 3 [trois] de nommer aux fonc-

tions d'Administrateurs les personnes suivantes:

- Mademoiselle Candice De Boni, employée privée, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Lu-

xembourg;

- Madame Catherine Koch, employée privée, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxem-

bourg

Jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2009.
L'Assemblée Générale a décidé de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes Grant Thornton, établie et

ayant son siège social au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 133.733 jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée
à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2009.

<i>Pour MW Unitexx S.A.
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009153369/29.
(090186360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

119524

Gavilon Luxembourg HoldCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.870.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Gavilon Luxembourg HoldCo II S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009152069/12.
(090184554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

FLE Finco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.841.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FLE Finco S. à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009152070/12.
(090184196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

QOA Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 54.628.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 09 novembre 2009 à Luxembourg

L'assemblée générale décide de remplacer les administrateurs actuels du Conseil d'Administration avec adresse pro-

fessionnelle à L-1420 Luxembourg, 5-11 avenue Gaston Diderich à savoir Madame Isabelle Jurain, Monsieur Pol Thielen,
Monsieur Pierre Thielen avec effet immédiat.

Sont nommés nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2013:
Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman
Monsieur Raymond Henschen, administrateur, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman
Madame Bénédicte Robaye, administrateur, demeurant à B-6860 Léglise, 40, rue des Combattants
Est nommé administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2013:
Madame Monique Henschen-Haas, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.
Elle peut engager la société par sa seule signature.
L'assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes Madame Aude Szternberg avec adresse pro-

fessionnelle à L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich avec effet immédiat.

Est nommé nouveau commissaire aux comptes la société Fiduplan S.A., RCS B-44.563 avec siège social à
L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
Son mandat expirera à l'assemblée générale de l'année 2013.
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de
L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich à
L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A
Signature

Référence de publication: 2009153196/30.
(090185503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

119525

Gavilon Luxembourg HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.880.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Gavilon Luxembourg HoldCo S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009152071/12.
(090184553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

LFPI Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 134.639.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LFPI Property S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009152072/12.
(090184197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Nabi Biopharmaceuticals Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 102.597.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the twenty-third of November.
Before us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

Has appeared:

Nabi Biopharmaceuticals Holding (Europe) Limited, an Irish company having its registered office at 29 Earlsfort Terrace,

Dublin 2, Ireland, registered at the Trade Register of Ireland under number 137231,

here represented by Mrs. Peggy Simon, private employee, residing in Berdorf, by virtue of a proxy given under private

seal on October 30, 2009.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxy holder, has requested the notary to state as follows:
- "Nabi Biopharmaceuticals Luxembourg S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company ("Société à respon-

sabilité limitée"), with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register, under number B 102597, (hereinafter referred to as "the Company"), has been incor-
porated by deed of Maître Joseph Elvinger on January 15 

th

 , 2004, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number 1099 of October 29 

th

 , 2004.

- The share capital of the Company presently amounts to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) consisting

of one hundred and twenty-five (125) ordinary shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

- The appearing person is the sole owner of all the shares of the Company.
The appearing person, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated

dissolution of the Company.

- The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all liabilities of the Company have been settled.
- The activity of the Company has ceased; all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who is

personally liable for all liabilities and commitments of the Company, even those actually unknown; accordingly, the liqui-
dation of the Company is considered to be closed.

119526

The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company for the exercise of their

mandate as of today.

- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the

registered office of the dissolved Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name,

civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

Nabi Biopharmaceuticals Holding (Europe) Limited, une société de droit irlandais, avec siège social à 29 Earlsfort

Terrace, Dublin 2, Irlande, enregistrée au Registre de Commerce d'Irlande sous le numéro 137231,

ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf, en vertu d'une procuration sous

seing privé établie le 30 octobre 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- "Nabi Biopharmaceuticals Luxembourg S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec

siège social à 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 102597 (ci-après la "Société"), a été constituée par acte reçu par Maître Joseph Elvinger
le 15 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1099 du 29 octobre 2004.

- La Société a actuellement un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

- La comparante est propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif de la Société est réglé.
- L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les

engagements de la Société même inconnus à ce jour; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et
clôturée.

- L'associé unique donne pleine et entière décharge aux gérants pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la Société

dissoute.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

représentée comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom et prénom, état et demeure,

elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 25 novembre 2009. Relation: ECH/2009/1723. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

<i>Le Receveur (signé): J.- M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 30 novembre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009154074/84.
(090186873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

119527

Jog S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 82.895.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JOG S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009152073/11.
(090184551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Cirsa Funding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 149.519.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twentieth day of November.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Cirsa Gaming Corporation S.A., a company established under the laws of Spain, having its registered office at Ctra. de

Castellar, 298, E- 08226 Terrassa (Barcelona), Spain; registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce
of Barcelona under number B-380; and

Being represented by Flora Gibert, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the herein above stated capacities, has requested the notary to draw up the following

articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declared to establish.

Chapter I.- Name, Registered office, Object, duration.

1. Form, Corporate name.
1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") go-

verned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the "1915 Law") and by the present articles (the "Articles").

1.2 The Company exists under the name of "Cirsa Funding Luxembourg S.A.".

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder") or in case of plurality of shareholders by means of a
resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments
to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorised to change the address of the

Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social event of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

3. Objects.
The objects of the Company are:
3.1 the granting of loans or other forms of financing directly or indirectly (including, but not limited to, by the sub-

scription for bonds, debentures and other debt instruments, the making of advances, the entry into loan agreements, the
granting of pledges or the issuing of any guarantees of any kind) to any person (including, without limitation, any person
which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with
the Company and any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest), and with or without
security;

119528

3.2 to borrow, raise and secure the payment of money in any way including, without limitation, through the issuance

of listed or unlisted notes and other debt instruments (including but not limited to bonds, notes, loan participation notes
and subordinated notes) including, without limitation, under medium term note and commercial paper programmes;

3.3 to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation,
contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in
any form whatsoever, and to administer, develop and manage such holding of interests;

3.4 to purchase, take on lease, exchange and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege

over or in respect of it;

3.5 to sell, lease, exchange and dispose of any real or personal property including, without limitation, the benefit of

any debts owed to the Company and/or any notes held by the Company, for such consideration as the Board of Directors
thinks fit, including without limitation for debts owed or notes issued by any person; to hold any assets, debts, notes and
other securities so acquired, to manage, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account
and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.6 to grant security for funds raised, including notes and other debt instruments issued, and for the obligations of the

Company (including without limitation to the obligations of the Company under any guarantee);

3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee

and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money by any person including
(but not limited to) any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is
for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the
Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether
direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's
undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article
3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction
of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or
services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be res-
ponsible for, any indebtedness of any other person;

3.8 to enter into all agreements, including, but not limited to underwriting agreements, marketing agreements, mana-

gement agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements,
deposit agreements, hedging agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative
agreements, bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and any
agreements creating any kind of security interest;

3.9 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Directors thinks fit;
3.10 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons; and

3.11 to do all things (including, without limitation, entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements

and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Directors incidental or conducive
to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers.

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector without due authorisation under any laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital

5. Capital.
The  subscribed  capital  is  set  at  thirty-one  thousand  Euro  (€  31,000.-),  divided  into  three  hundred  and  ten  (310)

registered shares with a par value of one hundred Euro (€ 100.-) each, fully paid up (by 100 %).

6. Form of the shares.
6.1 The shares may be issued in registered or bearer form, at the request of the shareholders and subject to legal

conditions.

6.2 Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

6.3 The Company may, to the extent and under the terms permitted by the 1915 Law, purchase its own shares.

7. Payment of shares.
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions, which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all
outstanding shares, which are not fully paid up.

119529

8. Modification of capital.
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by the 1915 Law.

Chapter III.- Bonds, Notes and Other debt instruments

9. Registered or bearer form.
The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, notes or

other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

Chapter IV.- Directors, Board of directors, Statutory auditors

10. Board of directors.
10.1 In case the Company is established by a plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of

Directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.

10.2 In case the Company is established by a sole shareholder the Board of Directors will be composed of one or

more A directors which shall always be Luxembourg resident (the "A Directors") and one or more B directors (the "B
Directors"). The A Directors and the B Directors are collectively referred to as the "Directors". A legal entity may be a
member of the Board of Directors of the Company. In such case, such legal entity must designate a permanent repre-
sentative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only
remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.

10.3 The Directors are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are

re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in
function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his
mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

10.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next
general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

11. Meetings of the board of directors.
11.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") who shall be chosen among the A Directors. The

first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present,
he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case all the Directors

are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented

by proxies and at least one of the A Directors and one of the B Directors are present or represented.

11.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram or telefax

another Director as his proxy.

A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.
11.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast.
11.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed, provided that each participating

Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

11.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all Directors

in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions
shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened. The date of such
resolutions shall be the date of the last signature.

11.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event

such vote is confirmed in writing.

11.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts

shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

12. General powers of the board of directors.
12.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the 1915 Law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the Board of Directors.

12.2 The Board of Directors is authorised to transfer, assign and dispose of the assets of the Company in such manner

as the Board of Directors deems appropriate.

119530

13. Delegation of powers.
13.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company

and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board
of Directors, Directors, managers, officers or other agents who need not be shareholders of the Company, under such
terms and with such powers as the Board shall determine.

13.2 The Board of Directors or one A Director together with one B Director may also confer all powers and special

mandates to any persons who need not to be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.

13.3 The first person entrusted with the daily management may be appointed by the first general meeting of share-

holders.

14. Representation of the company.
14.1 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be bound by the joint signature of two Directors,

one A Director together with one B Director or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall
be delegated by the joint signature of one A Director together with one B Director, but only within the limits of such
power.

14.2 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case a daily manager has been appointed

in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the daily manager, but only within the limits of such power.

15. Statutory auditor.
15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors.
15.2 The general meeting of shareholders appoints the statutory auditor(s) and determines their number, their re-

muneration and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the
statutory auditor(s) are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for 6 years
from the date of their election.

15.3 The statutory auditors are re-eligible.

16. Conflict of interests.
16.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has an interest in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm, provided that paragraph 16.3 is complied with.

16.2 Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

16.3 In the event that any Director of the Company may have any opposing interest in any transaction of the Company,

such Director shall make known to the Board of Directors such opposing interest and shall not consider or vote upon
any such transaction, and such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following
general meeting of the shareholders of the Company.

16.4 The provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors

concern day-to-day operations engaged in normal conditions.

Chapter V.- General Meeting of shareholders

17. Powers of the sole shareholder / General Meeting of shareholders.
17.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be

held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the company.

17.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting

of shareholders and shall take the decision in writing.

17.3 In the event of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

17.4 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by

registered  letter  at  least  fifteen  (15)  days  before  the  meeting.  In  the  event  that  all  the  shareholders  are  present  or
represented and if they declare that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening
requirements and formalities of publication.

17.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

119531

17.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive

or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three
(3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to shall be taken into account.

17.7 The shareholders are entitled to participate in the meeting by teleconference or by way of telecommunications

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means of
communication must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the de-
liberations are transmitted on a continuous basis.

17.8 Unless otherwise provided by the 1915 Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general

meeting of shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital
represented.

17.9 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the 1915 Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-thirds of the votes cast of the shareholders
present or represented.

17.10 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.

18. Place and Date of the annual general meeting of shareholders.
The  annual  general  meeting  of  shareholders  is  held  in  the  City  of  Luxembourg,  at  a  place  specified  in  the  notice

convening the meeting in Luxembourg on the third Friday of June at 15:00 o'clock, and for the first time in 2010. If such
day is a public holiday, the annual general meeting of shareholders will be held on the next following business day.

19. Other general meetings.
Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the

shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

20. Votes.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of

shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

Chapter VI.- Business year, Distribution of profits

21. Business year.
21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of

each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2009. 21.2 The Board of Directors shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It
shall submit these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the
annual general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such
documents.

22. Distribution of profits.
22.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This

allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the
Company.

22.2  After  allocation  to  the  legal  reserve,  the  general  meeting  of  shareholders  determines  the  appropriation  and

distribution of net profits.

22.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by the

1915 Law.

Chapter VII.- Dissolution, Liquidation

23. Dissolution, Liquidation.
23.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders adopted in accordance with

the procedure applicable to the amendment of the Articles or by a decision of the Sole Shareholder.

23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders.

23.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders, the Directors

shall be deemed to be liquidator(s) vis-a-vis third parties.

119532

Chapter VIII.- Applicable law

24. Applicable law.
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for three hundred and ten (310)

registered shares as follows:

Cirsa Gaming Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-) is forthwith at the

free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euro.

<i>First resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Cirsa Gaming Corporation S.A., consi-

dering itself as duly convened, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to
the meeting of the shareholders passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as A Directors, each with a mandate expiring on the annual general meeting of

shareholders to be held in 2015:

(a) John Kleynhans, companies director, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg;

(b) Noel McCormack, companies director, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg; and

(c) Christian Tailleur, companies director, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

3. The following have been elected as B Directors, each with a mandate expiring on the annual general meeting of

shareholders to be held in 2015:

(a) Manuel Lao Gorina, companies director, with professional address at 298, Ctra. De Castellar, Terrassa, E-08226

Barcelona, Spain; and

(b)  Isaac  Lahuerta  Barbero,  companies  director,  with  professional  address  at  298,  Ctra.  De  Castellar,  Terrassa,

E-08226Barcelona, Spain.

4. The following has been appointed statutory auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders

in 2015:

Ernst &amp; Young S.A., a public limited liability company (société anonyme), with registered office at 7, parc d'activité

Syrdall, L-5364, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg
under number B 47.771. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of
the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Cirsa Gaming Corporation S.A., une société établie sous les lois de l'Espagne ayant son siège social à Ctra. de Castellar,

298, E-08226 Terrassa (Barcelone), Espagne; immatriculée auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce
de Barcelone sous le numéro B-380; et

119533

Etant représentée par Flora Gibert, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé, laquelle, paraphée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant selon la dite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une

société anonyme qu'elle déclare constituer (la "Société").

Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (et en

particulier, la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi de 1915")) et par les présents
statuts (les "Statuts").

1.2 La Société adopte la dénomination "Cirsa Funding Luxembourg S.A.".

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution
de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société

à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.

3. Objets.
Les objets de la Société sont les suivants:
3.1 Octroyer des prêts ou d'autres formes de financement directement ou indirectement (y compris, mais non limité

à, par la souscription d'obligations, et autres titres représentatifs de dette, l'octroi d'avances, la conclusion de contrats
de prêts, l'octroi de gages ou l'émission de garanties de toute sorte) au profit de toute personne (y compris, mais non
limité à, toute personne étant à ce moment un membre de la Société ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société
ou étant associée à la Société et toute personne morale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect) et avec
ou sans sûreté;

3.2 Emprunter, réunir des fonds et garantir le payement de fonds par tout moyen, y compris, mais non limité à, par

l'émission de titres de créances cotés ou non cotés et d'autres titres représentatifs de dette (y compris, mais non limité
à, obligations, titres de créances, titres participatifs d'emprunt et titres subordonnés) y compris, mais non limité à, en
application de programmes d'émission de titres de créance à moyen terme et d'effets de commerce;

3.3 Acquérir et détenir des intérêts, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres

entités luxembourgeoises ou étrangères, notamment par voie de souscription ou d'acquisition de tous titres et droits
par l'intermédiaire de participations, contributions, souscriptions, achats d'entreprise ou options, négociation ou par toute
autre moyen, ou d'autres titres représentatifs d'une dette financière sous quelque forme que ce soit, et administrer,
développer et gérer une telle prise d'intérêts;

3.4 Acheter, prendre à bail, échanger et acquérir des biens meubles et immeubles et tous droits et privilèges s'y

rapportant;

3.5 Vendre, louer, échanger et disposer de biens meubles ou immeubles y compris, mais non limité à, le bénéfice de

dettes dues à la Société et/ou des titres de créance détenus par la Société, pour toute contrepartie que le Conseil
d'Administration estimera adéquate y compris, mais non limité à, des dettes dues ou des titres de créance émis par toute
personne; détenir des actifs, des dettes, des titres de créance et d'autres valeurs mobilières ainsi acquis, gérer, vendre,
échanger, louer, hypothéquer, disposer de, garantir des options, mettre à profit et s'occuper de tout ou partie des biens
et droits de la Société;

3.6 Accorder des sûretés pour des fonds levés, y compris des titres de créance et autres titres représentatifs de dette,

ainsi que pour les obligations de la Société (y compris, mais non limité à, les obligations de la Société sous une garantie
quelconque);

3.7 Prendre une garantie ou passer un contrat d'indemnisation ou de cautionnement, et octroyer des sûretés, y compris

la garantie et la prestation de sûretés pour l'exécution des obligations et le payement de toute somme d'argent par toute
personne y compris (mais non limité à) toute personne morale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou
toute personne étant à ce moment un membre de la Société ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou
étant associée à la Société dans toute affaire ou entreprise, la Société recevant ou non une quelconque contrepartie ou

119534

un quelconque avantage (direct ou indirect), que ce soit par engagement personnel ou hypothèque ou gage sur tout ou
partie de l'exploitation de la Société, de ses biens, de ses actifs ou de son capital non appelé (présent et futur) ou par
tout autres moyens; pour les besoins de l'Article 3.6, le terme "garantie" inclut toute obligation, peu important sa des-
cription, de payer, acquitter, fournir des fonds pour le payement ou l'acquittement de (y compris, par avance d'argent,
achat ou souscription d'actions ou autres titres et achat d'actifs ou de services), indemniser et continuer à indemniser
contre les conséquences d'un défaut de payement, ou être responsable au titre de l'endettement de toute autre personne;

3.8 Conclure tous les contrats, y compris, mais non limité à, souscrire à des contrats, accords de commercialisation,

à des contrats de gestion, à des contrats de conseil, à des contrats d'administration et autres contrats de services, à des
contrats de vente, à des contrats de dépôt, à des contrats de couverture, des risques de change, à des contrats d'échanges
sur devises ou taux d'intérêts et autres contrats sur des produits dérivés, à des contrats bancaires et de gestion de fonds,
à des contrats de lignes de crédit, aux contrats d'assurance-crédit et tous autres contrats créant des garanties de toute
sorte;

3.9 Investir avec et gérer l'argent et les fonds de la Société de toute manière jugée appropriée par le Conseil d'Ad-

ministration;

3.10 Faire tout ou partie des choses citées dans un des paragraphes de cet Article 3 (a) à n'importe quel endroit dans

le monde; (b) en tant que mandant, mandataire, entrepreneur, fiduciaire ou autres; (c) par ou à travers de fiduciaires,
mandataires, sous-traitants ou autres; et (d) seul ou avec une ou d'autres personnes; et

3.11 Faire toutes les choses (y compris, et non limité à, conclure, exécuter et fournir des contrats, des actes, des

convention  et  des  accords  avec  ou  en  faveur  de  toute  personne)  qui  sont,  selon  l'avis  du  Conseil  d'Administration,
accessoires ou favorables à la réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de
ses pouvoirs.

DANS LA MESURE OÙ la Société n'entre pas dans une transaction qui constituerait une activité réglementée du

secteur financier sans les autorisations requises sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital

5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (€ 31,000.-), divisé en trois cent dix (310) actions nominatives

d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100,-) chacune, lesquelles sont entièrement libérées (à raison de 100 %).

6. Nature des actions.
6.1 Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur, à la demande des actionnaires et soumis aux conditions légales.
6.2 Les actions de la Société peuvent être représentées au choix du propriétaire sous la forme de titres unitaires ou

de certificats représentant deux ou plusieurs actions.

6.3 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les limites et aux conditions prévues par la Loi de

1915.

7. Versements.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux

dates et aux conditions que le Conseil d'Administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé s'impute
à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en

matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la Loi de 1915.

Titre III.- Obligations et Autres titres représentatifs d'une dette

9. Nominatif ou au porteur.
La Société pourra émettre des obligations et autres titres représentatifs de dette sous forme nominative ou au porteur.

Ces obligations et autres titres représentatifs de dette sous forme nominative ne pourront pas être échangés ou convertis
en titres au porteur.

Titre IV.- Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaires aux comptes

10. Conseil d'administration.
10.1 Au cas où la Société est établie par plusieurs actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Ad-

ministration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

10.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique, le Conseil d'Administration sera composé d'un ou plusieurs

administrateurs A qui doivent toujours résider au Luxembourg (les "Administrateurs A") et d'un ou plusieurs adminis-

119535

trateurs B (les "Administrateurs B"). Les Administrateurs A et les Administrateurs B sont dénommés collectivement les
"Administrateurs". Une société peut être membre du Conseil d'Administration de la Société. Dans ce cas, une telle
personne  morale  nommera  un  représentant  permanent  qui  assurera  ses  fonctions  au  nom  et  pour  le  compte  de  la
personne morale. La personne morale en question ne peut révoquer son représentant permanent qu'en nommant en
même temps un successeur.

10.3 Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un mandat qui ne peut excéder

six années et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués par une simple résolution de l'assemblée générale des actionnaires.
Ils resteront en fonction jusqu'à la date de nomination de leurs successeurs. Dans le cas où un administrateur est élu sans
indication sur la durée de son mandat, il est considéré qu'il est élu pour une période de six années à compter de la date
de son élection.

10.4 En cas de vacance du poste d'un Administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-

trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

11. Réunions du conseil d'administration.
11.1 Le Conseil d'Administration élira un président (le "Président") qui sera choisi parmi les Administrateurs A. Le

premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du
Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée par procuration et si au moins l'un des Administrateurs A et l'un des Administrateurs B sont
présents ou représentés.

11.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un

autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, transmise par télégramme
ou par téléfax. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter.
Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

11.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis.
11.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont

signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement. Cette approbation peut résulter d'un seul
ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité
que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions
doit être la date de la dernière signature.

11.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou

par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

11.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.
12.1 Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi de 1915 ne réserve pas expressément à l'assemblée
générale des actionnaires relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

12.2 Le Conseil d'Administration est autorisé à transmettre, céder et disposer des actifs de la Société d'une manière

telle que le Conseil d'Administration considère comme appropriée.

13. Délégation de pouvoirs.
13.1 Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société

et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil
d'Administration, Administrateurs, gérants, fondés de pouvoir et autres agents, actionnaires de la Société ou non, agissant
à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

13.2 Le Conseil d'Administration, ou un Administrateur A ensemble avec un Administrateur B, pourront également

conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

13.3 La première personne à qui la gestion journalière est confiée peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

119536

14. Représentation de la société.
14.1 Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux Adminis-

trateurs, un Administrateur A ensemble avec un Administrateur B, ou par l'unique signature de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par les signatures conjointes d'un Administrateur A ensemble avec un
Administrateur B mais seulement dans les limites des pouvoirs qui lui auront été conférés.

14.2 Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera également engagée, dans le cas où un administrateur

délégué a été nommé pour mener la conduite de la gestion journalière de la Société et représenter la Société dans le
cadre de cette gestion journalière, par l'unique signature de l'administrateur délégué mais seulement dans les limites des
pouvoirs qui lui auront été conférés.

15. Commissaire aux comptes.
15.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
15.2 L'assemblée générale des actionnaires nomme le(s) commissaire (s) aux comptes et détermine leur nombre, leur

rémunération et la durée de leur mandat. Leur mandat ne doit cependant pas excéder une durée de six ans. Dans le cas
où le(s) commissaire(s) aux comptes est/sont élu(s) sans indication sur la durée de son/leur mandat, il(s) est/sont considéré
(s) avoir été élu(s) pour une période de six ans à compter de la date de son/leur élection.

15.3 Les commissaires aux comptes sont rééligibles.

16. Conflit d'intérêts.
16.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entreprise ne seront affectés ou

annulés du fait qu'un ou plusieurs des Administrateurs ou dirigeants de la Société y ont un intérêt, ou du fait qu'il soit
administrateur, collaborateur, dirigeant ou employé de cette autre société ou entreprise, à condition que le paragraphe
16.3 soit respecté.

16.2 Tout Administrateur ou dirigeant de la Société qui agit comme administrateur, dirigeant ou employé de toute

société avec lesquels la Société doit contracter ou autrement s'engager en affaire ne doit pas, seulement du fait de cette
affiliation avec cette autre société ou entité, s'empêcher de prendre en compte et de voter ou d'agir dans toutes matières
en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.

16.3 Dans le cas où tout Administrateur de la Société aurait tout intérêt opposé dans toute transaction de la Société,

cet Administrateur doit informer le Conseil d'Administration de cet intérêt opposé dans toute transaction de la Société
et ne doit pas considérer ou voter toute transaction, et cette transaction, et cet intérêt de l'Administrateur doit être
mentionné à la suivante assemblée générale des actionnaires de la Société.

16.4 Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du Conseil d'Admi-

nistration concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Titre V.- Assemblée Générale des actionnaires

17. Pouvoirs de l'actionnaire unique / Assemblée générale des actionnaires.
17.1 La Société peut avoir un Actionnaire Unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions

en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'Actionnaire Unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

17.2 S'il y a seulement un actionnaire, l'Actionnaire Unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

17.3 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.

17.4 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire

nominatif au moins quinze (15) jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et
s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de
convocation ou de publication.

17.5 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

17.6 Les actionnaires peuvent voter par correspondance, au moyen d'un formulaire mentionnant l'option pour un vote

positif ou négatif ou l'abstention. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus
par la société trois (3) jours avant la réunion de l'assemblée générale.

17.7 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par

des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

17.8 Sauf dans les cas déterminés par la Loi de 1915 ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des

actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

119537

17.9 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des

Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde
assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la Loi de 1915. Cette convocation reproduit
l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement,
quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent
être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

17.10 Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements

des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

18. Lieu et Date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué

dans les convocations le troisième vendredi du mois de juin, à 15.00 heures, et pour la première fois en 2010. Dans le
cas où ce jour constituerait un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.

19. Autres assemblées générales.
Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur

la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

20. Votes.
Chaque  action  donne  droit  à  une  voix.  Un  actionnaire  peut  se  faire  représenter  à  toute  assemblée  générale  des

actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

21. Année sociale.
21.1 L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, sauf pour

la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2009.

21.2 Le Conseil d'Administration établira le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

22. Répartition des bénéfices.
22.1 Chaque année cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du
capital social de la Société.

22.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

22.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la Loi de 1915.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

23. Dissolution, Liquidation.
23.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts ou par une décision de l'Actionnaire Unique.

23.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'Actionnaire Unique ou l'assemblée générale des actionnaires.

23.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'Actionnaire Unique ou l'assemblée générale des actionnaires, les

Administrateurs seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII.- Loi applicable

24. Loi applicable.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé

par les présents Statuts.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les trois cent dix (310)

actions nominatives comme suit:

Cirsa Gaming Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

119538

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille Euros (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à mille quatre cents Euros.

<i>Première assemblée de l'actionnaire unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la partie mentionnée ci-avant, Cirsa Gaming Corporation S.A.,

représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoquée, exerçant les pouvoirs incombés à l'as-
semblée générale, a pris les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs A, chacun pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale

annuelle des actionnaires à tenir en 2015:

(a) John Kleynhans, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 58, rue Charles Martel, L-2134 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

(b) Noël McCormack, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 58, rue Charles Martel, L-2134

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

(c) Christian Tailleur, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 58, rue Charles Martel, L-2134

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3.  Sont  appelés  aux  fonctions  d'Administrateurs  B,  chacun  pour  un  mandat  expirant  lors  de  l'assemblée  générale

annuelle des actionnaires à tenir en 2015:

(a) Manuel Lao Gorina, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 298, Ctra. De Castellar, Terrassa,

E-08226 Barcelone, Espagne; et

(b) Isaac Lahuerta Barbero, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 298, Ctra. De Castellar, Ter-

rassa, E-08226 Barcelone, Espagne.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée

générale ordinaire statutaire de l'année 2015:

- Ernst &amp; Young S.A., une société anonyme ayant son siège social au 7, parc d'activité Syrdall, L-5364, Grand-Duché

de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
47.771. Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes
comparantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture, les comparants prémentionnés, tous connus par le notaire par leurs noms, prénoms, état civil et

résidences, ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 novembre 2009. Relation: LAC/2009/49418. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009152766/637.
(090185321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

G.A. - Fund -L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 69.871.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119539

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

<i>Pour G.A.-FUND-L
BGL BNP Paribas
Signatures

Référence de publication: 2009152077/13.
(090184550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Elgin Credit Plus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 106.440.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the 26 

th

 November.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette,

appeared:

Harry LIEDTKE and/or Marion FRITZ, Banker, residing professionally in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad

Adenauer (the "Proxyholder"),

acting as a special proxy of Stichting Elgin Credit Plus, a
foundation (Stichting) organized under the laws of The Netherlands, having its statutory office in The Netherlands at

Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam (the "Principal"),

by virtue of a proxy under private seal, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the

undersigned notary, will be registered with this minute.

The Proxy holder declared the following and requested the notary to act:
I. Elgin Credit Plus S.A. (the "Company"), having its registered office in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad

Adenauer, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 106440, has
been incorporated by deed of notary Henri HELLINCKX, notary residing in Mersch, on 7 March 2005 published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 4 July 2005, number 647.

II. The Principal is the owner of one three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100)

each representing the entire outstanding share capital of the Company.

III. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company.
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company.
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive

all assets of the Company and the Principal acknowledges that he will assume all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution, and the Principal declares that consequently the liquidation of the Company is completed.

VI. The Company authorises the Principal and any authorised officers of the Principal to sign such other documents

and deeds that may be required to dissolve the Company.

VII. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate

up to this date.

VIII. The shares of the Company shall be cancelled.
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered

office of the Company at L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
After the document had been read, the aforementioned Proxy holder signed the present original deed with me, the

undersigned notary.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-six novembre.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

a comparu:

Harry LIEDTKE et/ou Marion FRITZ, banquier, demeurant professionnellement L-1115 Luxembourg, 2, boulevard

Konrad Adenauer (le "Mandataire"),

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Stichting Elgin Credit Plus, une fondation (Stichting) de droit hollandais

et ayant son siège social à Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam (Pays-Bas) (le "Mandant");

119540

en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le

notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:
I. Que Elgin Credit Plus S.A. ("la Société"), ayant son siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 106440, a été constituée
suivant acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 mars 2005 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 juillet 2005, numéro 647.

II. Que le Mandant est le propriétaire de trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100)

chacune, représentant l'entièreté du capital émis de la Société.

III. Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite

Société.

IV. Que le Mandant en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.
V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société

et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et le Mandant déclare en
conséquence que la liquidation de la Société doit être clôturée.

VI. Que la Société autorise le Mandant, ainsi que les délégués du Mandant dûment autorisés, à signer les documents

et actes pouvant être requis pour dissoudre la Société.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII. Qu'il sera procédé à l'annulation des actions de la Société.
IX. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social à L-1115

Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision

du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: H. Liedtke, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 novembre 2009. Relation: EAC/2009/14494. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 décembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009154076/83.
(090186953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

DP Investment (Holding) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.796.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 30 novembre 2009.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2009152083/10.
(090184542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Intel Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.509.

Les comptes annuels au 31 octobre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119541

INTEL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009152082/12.
(090184203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Cork Supply Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 149.498.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of November.
Before Us Maitre Marline SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean SECKLER,

notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original of the present
deed.

THERE APPEARED:

1) Mr Joachim MICHALSKI, company director, born on January 30, 1955 in Leuchtenburg, Germany, residing at Rua

Ricardo Espirito Santo Silva, no 359, 2750-175 Cascais, Portugal,

2) the company MACOR, LTD., with its registered office at Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM 11

Bermuda, recorded in the Bermuda Registrar of Companies under number 15302, and

3) the company FRELIV &amp; SONS, LTD., with its registered office at Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM

11 Bermuda, recorded in the Bermuda Registrar of Companies under number 15304,

represented by Mr Alain THILL, private employee, residing professionally at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg),
by virtue of three proxies given under private seal.
Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing parties are the sole shareholders of the company Cork Supply Group, Ltd., with its former regis-

tered office in Clarendon House 2,

Church Street, Hamilton HM 11 Bermuda, incorporated in Bermuda in 1990, recorded in the Bermuda Registrar of

Companies under the number 15303 and that the appearing parties have taken the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The appearing parties decide to transfer the registered office from Bermuda to Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg, and to have adopted by the company the Luxembourg nationality without change of the legal form which will
remain the form of a société à responsabilité limitée / private limited company (S.à r.l. / Ltd.) and without discontinuity
of the legal status of the company.

<i>Second resolution

The appearing parties decide to adopt the following corporate object:
"The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations

in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support,
loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of
the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes."

<i>Third resolution

The appearing parties decide to adopt the following signatory power of the managers:
"In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the

company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

119542

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint

signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B."

<i>Fourth resolution

The appearing parties decide to adopt the Euro as currency of the capital, to cancel the nominal value of the sharequotas

and to exchange the twelve thousand (12,000) existing sharequotas with a nominal value of one Dollar of the United
States (USD 1.-) each against twelve thousand (12,000) sharequotas without nominal value.

<i>Ascertainment

The appearing parties ascertain that pursuant to the balance sheet as of August 31, 2009, the company's net assets

amount to twenty million six hundred three thousand one hundred and eighty-six Dollar of the United States (USD
20,603,186.-), converted according to the exchange rate of one Dollar of the United States (USD 1.-) equal to zero point
six nine nine three nine Euro (EUR 0.69939) into fourteen million four hundred nine thousand six hundred and sixty-two
Euro and twenty-six Cent (EUR 14,409,662.26): twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) representing the
capital and fourteen million three hundred ninety-seven thousand one hundred and sixty-two Euro and twenty-six Cent
(EUR 14,397,162.26) being allocated to a free reserve.

<i>Fifth resolution

The appearing parties decide to adopt the name Cork Supply Group S.á r.l. and the following articles of association of

a Luxembourg private limited company:

Art. 1. There exists a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which is governed by the laws in

force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is Cork Supply Group S.à r.l..

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-

pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city of Luxembourg by simple decision of the manager

or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution

of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand (12,000) sharequotas without nominal value.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the

amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota.

If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has

119543

been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders is free and the transfer of sharequotas inter vivos

to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter
of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional
upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital
belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their

participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.

Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders

make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an

additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end

to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets

and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting

deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the

company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint

signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a

meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any
other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who

are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of
attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

119544

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the

management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure."

<i>Sixth resolution

The appearing parties decide to appoint the following persons as managers of the category A for an unlimited duration:
- Mr Miguel DE MELO MARDEL CORREIA, company director, born on February 14, 1957 in Santos-O-Velho, Lisbon

(Portugal) residing at 2750-175 Cascais (Portugal), Rua João de Santarém, 22.

-  Mr  Joachim  MICHALSKI,  company  director,  born  on  January  30,  1955  in  Leuchtenburg  (Germany),  residing  at

2750-175 Cascais (Portugal), Rua Ricardo Espirito Santo Silva, no 359.

<i>Seventh resolution

The appearing parties decide to appoint the following persons as managers of the category B for an unlimited duration:
- Mr Philippe TOUSSAINT, company director, born on September 2, 1975 in Arlon (Belgium), residing professionally

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Mr Eric MAGRINI, company director, born on April 20, 1963 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), residing

professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Mr Xavier SOULARD, company director, born on August 14, 1980 at Châteauroux (France), residing professionally

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Eighth resolution

The appearing parties decide to establish the registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

<i>Evaluation of the expenses

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present

deed are estimated to about five thousand five hundred Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the ap-

pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

119545

WHEREOF,  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  at  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and

residence, the attorney has signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le seize novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé
restera dépositaire du présent acte.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Joachim MICHALSKI, administrateur de sociétés, né le 30 janvier 1955 à Leuchtenburg, Allemagne, de-

meurant à Rua Ricardo Espirito Santo Silva, no 359, 2750-175 Cascais, Portugal,

2) la société MACOR, LTD., avec siège à Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM 11 Bermudes, enregistrée

au "Bermuda Registrar of Companies" sous le numéro 15302, et

3) la société FRELIV &amp; SONS, LTD., avec siège à Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM 11 Bermudes,

enregistrée au "Bermuda Registrar of Companies" sous le numéro 15304,

représentés par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché

de Luxembourg),

en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le notaire et le mandataire, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls associés de la société Cork Supply Group, Ltd., ayant son ancien siège social à

Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM 11 Bermudes, constituée aux Bermudes en 1990, enregistrée au "Ber-
muda Registrar of Companies" sous le numéro 15303 et que les comparants ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les comparants décident de transférer le siège social des Bermudes à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et

de faire adopter par la société la nationalité luxembourgeoise sans modification de la forme juridique, qui restera celle
d'une société à responsabilité limitée / private limited company (S. à r. 1. / Ltd.), et sans interruption de la personnalité
juridique de la société.

<i>Deuxième résolution

Les comparants décident d'adopter l'objet social suivant:
"La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière

que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés."

<i>Troisième résolution

Les comparants décident d'adopter le pouvoir de signature suivant des gérants:
"En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera

valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par les

signatures conjointes d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B."

119546

<i>Quatrième résolution

Les comparants décident d'adopter l'Euro comme devise du capital, de supprimer la valeur nominale des parts sociales

et d'échanger les douze mille (12.000) parts sociales existantes d'une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD
1,-) chacune contre douze mille (12.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Constatation

Les comparants constatent que selon le bilan au 31 août 2009, l'actif net de la société s'élève à vingt millions six cent

trois mille cent quatre-vingt-six Dollars des Etats-Unis (USD 20.603.186,-), convertis au taux de change d'un Dollar des
Etats-Unis (USD 1,-) égal à zéro virgule six neuf neuf trois neuf Euro (EUR 0,69939) en quatorze millions quatre cent neuf
mille six cent soixante-deux Euros et vingt-six Cents (EUR 14.409.662,26); douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-)
représentant le capital social et quatorze millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-deux Euros et vingt-
six Cents (EUR 14.397.162,26) étant transférés à un compte de réserve libre.

<i>Cinquième résolution

Les comparants décident d'adopter la dénomination de Cork Supply Group S.à r.l. et les statuts suivants d'une société

à responsabilité limitée luxembourgeoise:

 Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois en vigueur et notamment par celle

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de Cork Supply Group S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par simple décision du gérant ou,

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de

l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille (12.000)

parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

119547

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés

sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de

décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont

nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité

des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera

valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par les

signatures conjointes d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,

par  câble,  télégramme,  télex,  télécopie  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  similaire,  à  confirmer  par  écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,

qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la
procuration.

Art. 13.  Tout  gérant  ne  contracte,  à  raison  de  sa  fonction  aucune  obligation  personnelle  quant  aux  engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

119548

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile."

<i>Sixième résolution

Les comparants décident de nommer les personnes suivantes comme gérants de catégorie A pour une durée indé-

terminée:

- Monsieur Miguel DE MELO MARDEL CORREIA, administrateur de sociétés, né le 14 février 1957 à Santos-O-Velho,

Lisbonne (Portugal) demeurant à 2750-175 Cascais (Portugal), Rua Joâo de Santarém, 22.

- Monsieur Joachim MICHALSKI, administrateur de sociétés, né le 30 janvier 1955 à Leuchtenburg (Allemagne), de-

meurant à 2750-175 Cascais (Portugal), Rua Ricardo Espirito Santo Silva, no 359.

<i>Septième résolution

Les comparants décident de nommer les personnes suivantes comme gérants de catégorie B pour une durée indé-

terminée:

- Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né le 2 septembre 1975 à Arlon (Belgique), demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né le 20 avril 1963 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né le 14 août 1980 à Châteauroux (France), demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Huitième résolution

Les comparants décident de fixer le siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte s'élève approximativement à cinq mille cinq cents Euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des

comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure,

le mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL - M. SCHAEFFER
Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2009. Relation GRE/2009/4331. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119549

Junglinster, le 2 décembre 2009.

Référence de publication: 2009152326/422.
(090184424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Marroni Finances Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 21.180.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MARRONI FINANCES HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009152084/12.
(090184204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Head IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.830.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2009152085/10.
(090184541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Krokus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.357.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KROKUS S.A.
C. BITTERLICH / L. VETS
<i>Administrateur de catégorie B / Administrateur de catégorie A, Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009152086/12.
(090184205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Solar Generation Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 866.135,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 132.733.

In the year two thousand and nine, on the fifth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Impax Solar Investments S.à r.l., a private limited liability company established and existing under the laws of Luxem-

bourg, with registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 140.154 ("Impax Solar Investments S.à r.l."), and

Impax New Energy Investors S.C.A., a partnership limited by shares, incorporated and existing under the laws of

Luxembourg, with registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 110.337 ("Impax New Energy Investors S.C.A."),

both here represented by Gaelle Bernard, private employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg,

by virtue of two (2) proxies given on October 15, 2009.

119550

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company existing in Luxembourg under the

name of "Solar Generation Holdings S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.733, established pursuant
to  a  deed  of  the  undersigned  notary,  of  September  27,  2007,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations n° 2648 of November 20, 2007, whose bylaws have been last amended by a deed of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg of November 26, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 189 of January 28, 2009.

II. The Company's share capital is set at six hundred seven thousand five hundred and forty-seven Euro (€ 607,547.-)

represented by six hundred seven thousand five hundred and forty-seven (607,547) shares of one Euro (€ 1.-) each.

III. The shareholders resolved to increase the Company's share capital to the extent of two hundred fifty-eight thousand

five hundred and eighty-eight Euro (€ 258,588.-) to raise it from its present amount of six hundred seven thousand five
hundred and forty-seven Euro (€ 607,547.-) to eight hundred sixty-six thousand one hundred and thirty-five Euro (€
866,135.-) by creation and issue of two hundred fifty-eight thousand five hundred and eighty-eight (258,588) new shares
of one Euro (€ 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The shareholders resolve to subscribe for the new shares as follows:
- Impax New Energy Investors S.C.A. subscribes to fifty-one thousand seven hundred and eighteen (51,718) new shares,

and fully pays them up at their nominal value of one Euro (€ 1.-) each, for an aggregate amount of fifty-one thousand
seven hundred and eighteen Euro (€ 51,718.-) by contribution in kind consisting in the conversion of receivables held
towards the Company in the same total amount (altogether the "Receivable A").

Evidence of the contribution's existence and value
Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
* a balance sheet dated as of September 30, 2009 of the Company, certified 'true and correct' by the managers of the

Company;

* a contribution declaration of Impax New Energy Investors S.C.A. attesting that it is the unrestricted owner of the

Receivable A.

Effective implementation of the contribution
Impax New Energy Investors S.C.A., through its proxyholder, declares that:
* it is the sole unrestricted owner of the Receivable A and possesses the power to dispose of it, it being legally and

conventionally freely transferable;

* the Receivable A has consequently not been assigned and no legal or natural person other than Impax New Energy

Investors S.C.A. is entitled to receive payment of the Receivable A.

- Impax Solar Investments S.à r.l. subscribes to two hundred six thousand eight hundred and seventy (206,870) new

shares of one Euro (€ 1.-) each, and fully pays them up at their nominal value of one Euro (€ 1.-) each, for an aggregate
amount of two hundred six thousand eight hundred and seventy Euro (€ 206,870.-) by contribution in kind consisting in
the conversion of receivables held towards the Company in the same amount (altogether the "Receivable B").

Evidence of the contribution's existence and value
Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
* the minutes of the extraordinary general meeting of Impax Solar Investments S.à r.l. dated November 5, 2009, certified

by the undersigned notary;

* a contribution declaration of Impax Solar Investments S.à r.l. attesting that it is the unrestricted owner of the Re-

ceivable B.

Effective implementation of the contribution
Impax Solar Investments S.à r.l., through its proxyholder, declares that:
* it is the sole unrestricted owner of the Receivable B and possesses the power to dispose of it, it being legally and

conventionally freely transferable;

* the Receivable B has consequently not been assigned and no legal or natural person other than Impax Solar Invest-

ments S.à r.l. is entitled to receive payment of the Receivable B.

<i>Manager's intervention

The report of the managers of the Company, dated November 5, 2009, annexed to the present deed, attests that the

managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally
bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description,
with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

119551

IV. Pursuant to the above increase of capital, the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association

is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 6. First paragraph. The share capital is fixed at eight hundred sixty-six thousand one hundred and thirty-five Euro

(€ 866,135.-) represented by eight hundred sixty-six thousand one hundred and thirty-five (866,135) shares of one Euro
(€ 1.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (€ 2,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille neuf, le cinq novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Impax Solar Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et établie sous les lois du Luxembourg,

ayant son siège social au 67, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 140.154 ("Impax Solar Investments S.à r.l."), et

Impax New Energy Investors S.C.A., une société en commandite par actions constituée et établie sous les lois du

Luxembourg, ayant son siège social au 67, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.337 ("Impax New Energy Investors S.C.A."),

toutes les deux ici représentées par Gaelle Bernard, employée privée, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, en vertu de deux procurations données le 15 octobre 2009.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de "Solar Generation Holdings S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 67, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.733, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 septembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association n° 2648 du 20 novembre 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Association n° 189 du 28 janvier 2009.

II. Le capital social de la Société est fixé à six cent sept mille cinq cent quarante-sept Euros (€ 607,547.-) divisé en six

cent sept mille cinq cent quarante-sept (607,547) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1.-) chacune.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent cinquante-huit mille

cinq cent quatre-vingt-huit Euros (€ 258.588,-) afin de le porter de son montant actuel de six cent sept mille cinq cent
quarante-sept Euros (€ 607.547,-) à huit cent soixante-six mille cent trente-cinq Euros (€ 866.135,-) par la création et
l'émission de deux cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-huit (258.588) parts sociales nouvelles d'un Euro (€
1,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

Les associés décident de souscrire aux nouvelles parts sociales, comme suit:
- Impax New Energy Investors S.C.A. souscrit à cinquante et un mille sept cent dix-huit (51.718) nouvelles parts sociales

et les libère intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (€ 1,-) chacune pour un montant total de cinquante et un
mille sept cent dix-huit Euros (€ 51.718,-) par apport en nature consistant en la conversion de créances d'un même
montant total détenues à l'encontre de la Société (ensemble la "Créance A").

Preuve de l'existence et valeur de l'apport
Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:
* un bilan au 30 septembre 2009 de la Société certifié "sincère et véritable" par ses gérants;

119552

* une déclaration d'apport d'Impax New Energy Investors S.C.A. certifiant qu'elle est propriétaire sans restrictions de

la Créance A apportée.

Réalisation effective de l'apport
Impax New Energy Investors S.C.A., par son mandataire, déclare que:
* elle est seule propriétaire sans restrictions de la Créance A apportée et possède les pouvoirs d'en disposer, la

Créance A étant légalement et conventionnellement librement transmissible;

* toutes autres formalités exigées par les lois applicables sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation

de la Créance A, aux fins d'effectuer son transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

- Impax Solar Investments S.à r.l. souscrit à deux cent six mille huit cent soixante-dix (206,870) nouvelles parts sociales,

et les libère intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (€ 1.-) chacune pour un montant total de deux cent six mille
huit cent soixante-dix Euros (€ 206,870.-) par apport en nature consistant en la conversion de créances d'un même
montant détenues à l'encontre de la Société (ensemble la "Créance B").

Preuve de l'existence et valeur de l'apport
Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée au notaire soussigné par:
* les minutes de l'assemblée générale extraordinaire d'Impax Solar Investments S.à r.l. du 5 novembre 2009, certifiées

par le notaire instrumentant;

* une déclaration d'apport d'Impax Solar Investments S.à r.l. certifiant qu'elle est propriétaire sans restrictions de la

Créance B apportée.

Réalisation effective de l'apport
Impax Solar Investments S.à r.l., par son mandataire, déclare que:
* elle est seule propriétaire sans restrictions de la Créance B apportée et possède les pouvoirs d'en disposer, la Créance

B étant légalement et conventionnellement librement transmissible;

* toutes autres formalités exigées par les lois applicables sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation

de la Créance B, aux fins d'effectuer son transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

<i>Intervention des gérants

Le rapport des gérants de la Société en date du 5 novembre 2009, annexé aux présentes, atteste que les gérants de

la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagée en leur qualité
de gérants de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la
description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifié

pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 6. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à huit cent soixante-six mille cent trente-cinq Euros (€ 866.135,-)

représenté par huit cent soixante-six mille cent trente-cinq (866.135) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (€
1.-) chacune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents Euros (€ 2.500,-). Plus rien
n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: G. BERNARD, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47374. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 26 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009152245/182.
(090184914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119553

Wesley S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 124.416.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WESLEY S.A.R.L.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009152088/12.
(090184206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Tecanox Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 25.387.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TECANOX HOLDING S. A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009152093/12.
(090184209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Arno Glass Luxco, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.250.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009152094/13.
(090184210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

GSMP 3 Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 96.137.

Constituée par-devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Senningerberg,

en date du 22 août 2003, acte publié au Mémorial C n 

o

 1158 du 5 novembre 2003.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

en date du 28 novembre 2008 sous la référence L080175192.05 sont erronés.

Il convient donc de les remplacer par la présente version.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christophe Cahuzac
<i>Gérant

Référence de publication: 2009152272/17.
(090184291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119554

Birkdale Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.637.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/08 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/11/2009.

<i>Birkade Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2009152095/15.
(090184172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Levanter Real 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 133.767.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LEVANTER REAL 3 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009152097/13.
(090184174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Bucher Invest S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Bucher Invest Holding S.A.).

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 84.874.

In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh of October.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Bucher Invest Holding S.A.", a "société anonyme",

having its registered office at L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper, incorporated by deed dated on 4 

th

 December

2001, inscribed at Luxembourg trade register section B under number 84.874, published in Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, number 489 page 23.441 of 28 

th

 March 2002; and whose Articles of Association have been

amended for the last time by deed drawn up on 20 

th

 January 2003, published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés

et Associations, number 364 page 17.434 of 3 

rd

 April 2003.

The meeting is presided by Hubert JANSSEN, Jurist, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Rachel UHL, Jurist, with professional address

in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 5 015 500 (five million fifteen thousand and five hundred) shares, repre-

senting the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Change of the Company's name into Bucher Invest S.A.;

119555

2. Renunciation of the taxation system established by the Luxembourg law of July 31, 1929 on holding companies and

adoption of the statute of a financial participation company (Soparfi);

3. Reduction of the subscribed share capital of the Company by an amount of nine millions six hundred thirty-one

thousand Euros (EUR 9,631,000) to decrease from its current amount of ten millions thirty-one thousand Euros (EUR
10,031,000) to four hundred thousand Euros (EUR 400,000) by way of reimbursement to the shareholders proportionally
to their share holding and by cancellation of four millions eight hundred fifteen thousand and five hundred (4,815,500)
shares;

4. Reduction of the legal reserve of the Company by an amount of nine hundred sixty-three thousand one hundred

euros (EUR 963,100) to decrease from its current amount of one million three thousand and one hundred euros (EUR
1,003,100) to forty thousand euros (EUR 40,000) by way of reimbursement to the shareholders proportionally to their
share holding;

5. Amendment of the articles 1, 4 and 5 §1 of the Articles of Association of the Company in order to reflect the above

resolutions;

6. Distribution of a dividend amounting to EUR 6,955,000.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the company into "Bucher Invest S.A.".

<i>Second resolution

The meeting decides to renounce to the taxation system established by the Luxembourg law of July 31, 1929 on holding

companies and to adopt the statute of a financial participation company (Soparfi) and the provisions applicable to said
companies.

Further to the above, the corporate object of the Company has to be modified accordingly.

<i>Third resolution

The meeting decides to reduce the subscribed share capital of the Company by an amount of nine millions six hundred

thirty-one thousand Euros (EUR 9,631,000) to decrease from its current amount of ten millions thirty-one thousand
Euros (EUR 10,031,000) to four hundred thousand (EUR 400,000) by way of reimbursement to the shareholders pro-
portionally to their share holding and by cancellation of four millions eight hundred fifteen thousand and five hundred
(4,815,500) shares.

All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments,

to proceed to the cancellation of the reimbursed shares and to the shareholder's reimbursement.

<i>Reimbursement delay

The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial

companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to
the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the
present deed in the Luxembourg Mémorial C.

<i>Fourth resolution

Further to the above resolutions, the meeting decides to reduce the legal reserve of the Company by an amount of

nine hundred sixty-three thousand one hundred euros (EUR 963,100) to decrease from its current amount of one million
three thousand and one hundred euros (EUR 1,003,100) to forty thousand euros (EUR 40,000) by way of reimbursement
to the shareholders proportionally to their share holding.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend articles 1, 4 and 5 §1 of the Articles of

Association and to give them the following wording:

Art. 1. "Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of Bucher Invest S.A.".

Art. 4. "The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise

119556

money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 5. "The subscribed capital of the company is fixed at four hundred thousand Euros (EUR 400,000) divided into

two hundred thousand (200.000) shares with a par value of two Euros (EUR 2.-) each. The company may issue both
registered and bearer shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at five million Euro (EUR 5,000,000) to be divided

into two million and five hundred thousand (2,500,000) shares with a par value of two Euro (EUR 2) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increase or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years, to increase in one or several times

the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for
and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by
compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorpo-
ration of profits, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The  board  of  directors  is  especially  authorized  to  proceed  to  such  issues  without  reserving  to  the  then  existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued."

<i>Sixth resolution

The meeting decides, taking into account the net profit distributable amounting to six million nine hundred fifty-five

thousand seven hundred and twenty-nine euros (EUR 6,955,729) such as it results from the annual accounts of the
Company for the year ended December 31, 2008 and such as approved by the Annual General Meeting of Shareholders
of the Company on July 7, 2009, to pay a dividend to the shareholders, proportionally to their share holding, an amount
of six million nine hundred fifty-five thousand euros (EUR 6,955,000).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was draw up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the German text, the English version will prevail.

Follows the german translation

Im Jahre zweitausendneun, am siebenundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Joseph ELVINGER, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg.

Wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der société anonyme (Aktiengesellschaft) "Bucher In-

vest Holding S.A.", mit Sitz in L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stümper, abgehalten, gegründet gemäß einer Urkunde
vom 4. Dezember 2001, eingetragen im Luxemburger Handelsregister Abteilung B unter der Nummer 84.874, veröf-
fentlicht im Amtsblatt Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 489, Seite 23.441, vom 28. März
2002, und die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt mit einer am 20. Januar 2003 erstellten Urkunde, veröffentlicht im
Amtsblatt Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 364, Seite 17.434 vom 3. April 2003, ab-
geändert.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Hubert JANSSEN, Jurist, mit Berufswohnsitz in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Rachel UHL, Juristin, mit

Berufswohnsitz in Luxemburg.

Der Vorsitzende ersucht den Notar, wie folgt zu beurkunden, dass:
I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl der Aktien im Besitz eines jeden Aktionärs, auf der

Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Liste und die Vollmachten, die von den erschienenen Personen und dem Notar
unterzeichnet wurden, bleiben dieser Urkunde zum Zweck der Eintragung zusammen mit der Protokollniederschrift
beigebogen.

II.- Wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, sind die 5.015.500 (fünf Millionen und fünfzehntausendfünfhundert)

Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellen, vertreten, so dass die Versammlung gültig über alle Punkte
auf der Tagesordnung, über welche die Aktionäre im vorhinein informiert wurden, beschließen kann.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung ist die folgende:

119557

<i>Tagesordnung

1. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft in Bucher Invest S.A.;
2. Verzicht auf das Steuersystem gemäss dem Luxemburger Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften

und Annahme der Gesetzesbestimmung in bezug auf eine Finanzbeteiligungsgesellschaft (Soparfi);

3. Herabsetzung des gezeichneten Aktienkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von neun Millionen sechshunder-

teinunddreißigtausend Euro (EUR 9.631.000) um es von seinem gegenwärtigen Betrag von zehn Millionen einunddreißig-
tausend Euro (EUR 10.031.000) auf vierhunderttausend Euro (EUR 400.000) über eine Rückzahlung an die Aktionäre im
Verhältnis  zu  ihrem  Aktienbesitz  und  über  die  Löschung  von  vier  Millionen  achthundertfünfzehntausendfünfhundert
(4.815.500) Ak-tien zu bringen;

4. Verminderung der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft von einem Betrag von neunhundertdreiundsechzigtau-

sendeinhundert Euro (EUR 963.100), um die Rücklage von ihrem gegenwärtigen Betrag von einer Million dreitausendein-
hundert  Euro  (EUR  1.003.100)  auf  vierzigtausend  Euro  (EUR  40.000)  durch  eine  Rückzahlung  an  die  Aktionäre  im
Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz zu bringen;

5. Änderung der Artikel 1, 4 und 5 §1 der Satzung der Gesellschaft, um die vorgenannten Beschlüsse wiederzugeben;
6. Ausschüttung einer Dividende von EUR 6.955.000.
Nachdem den vorgenannten Punkten von der Versammlung zugestimmt wurde haben die Aktionäre einstimmig be-

schlossen wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Bezeichnung der Gesellschaft in "Bucher Invest S.A." umzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die  Versammlung  beschließt,  auf  das  Steuersystem  gemäss  dem  Luxemburger  Gesetz  vom  31.  Juli  1929  über  die

Holdinggesellschaften zu verzichten, und die Gesetzesbestimmung in bezug auf eine Finanzbeteiligungsgesellschaft (So-
parfi), sowie die auf solche Gesellschaften anwendbare Bestimmungen, zu übernehmen.

Zusätzlich zu Vorstehendem ist der Zweck der Gesellschaft dementsprechend zu ändern.

<i>Dritter Beschluss

Die  Versammlung  beschließt,  das  gezeichnete  Aktienkapital  der  Gesellschaft  um  einen  Betrag  von  neun  Millionen

sechshunderteinunddreißigtausend Euro (EUR 9.631.000) zu vermindern, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von
zehn Millionen einunddreißigtausend Euro (EUR 10.031.000) auf vierhunderttausend Euro (EUR 400.000) über eine Rück-
zahlung an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz und über Löschung von vier Millionen achthundertfünf-
zehntausendfünfhundert (4.815.500) Aktien zu bringen.

Alle Vollmachten werden an den Verwaltungsrat übertragen, damit dieser die notwendigen Änderungen in der Buch-

haltung ausführen, sowie die Annullierung der zurückgezahlten Aktien und die Rückzahlung an die Aktionäre veranlassen
kann.

<i>Verzögerung bei der Rückzahlung

Der unterzeichnete Notar hat die Versammlung darauf aufmerksam gemacht, dass die Bestimmungen von Artikel 69

des Gesetzes über die Handelsgesellschaften zu beachten sind, die eine gesetzliche Absicherung zugunsten von eventuellen
Gläubigern der Gesellschaft enthält, und dass daher die tatsächliche Rückzahlung an die Aktionäre nicht nach Belieben
und ohne ihren Regressanspruch vor 30 (dreißig) Tagen nach der Veröffentlichung gegenwärtiger Urkunde im Luxem-
burger Amtsblatt Mémorial C vorgenommen werden kann.

<i>Vierter Beschluss

Bezugnehmend auf die vorgenannten Beschlüsse entscheidet die Versammlung, die gesetzliche Rücklage der Gesell-

schaft durch einen Betrag von neunhundertdreiundsechzigtausendeinhundert Euro (EUR 963.100) zu vermindern, um die
Rücklage von ihrem gegenwärtigen Betrag von einer Million dreitausendeinhundert Euro (EUR 1.003.100) auf vierzigtau-
send Euro (EUR 40.000) durch eine Rückzahlung an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz zu bringen.

<i>Fünfter Beschluss

Als Folge der vorgenannten Beschlüsse entscheidet die Versammlung, die Artikel 1, 4 und 5 §1 der Satzung der Ge-

sellschaft abzuändern, und ihnen folgenden Inhalt zu geben:

Art. 1. "Zwischen den vorgenannten Personen und allen, die künftig Eigentümer von im Folgenden ausgegebenen Aktien

werden könnten, wird eine société anonyme (Aktiengesellschaft) unter der Bezeichnung Bucher Invest S.A. gegründet."

Art. 4. "Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen und Anteilen im Bereich Handel, Industrie,

Finanzen, oder sonst wie, in jeder Form an jeden Luxemburger oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb von Wert-
papieren und Rechten auf dem Wege von Beteiligung, Beitragsleistung, fester Übernahme oder Kaufoption, Handel oder
sonst wie, und insbesondere der Kauf von Patenten und Lizenzen und anderen Eigentümern, Eigentumsrechten und -

119558

anteilen, wie es die Gesellschaft für geeignet hält, und im allgemeinen diese ganz oder teilweise zu besitzen, verwalten,
fördern, verkaufen oder veräußern für eine Vergütung, welche die Gesellschaft für geeignet hält, und insbesondere für
Anteile oder Wertpapiere gleich welcher Gesellschaft, die diese Rechte erwirbt; Transaktionen im Bereich Finanzen,
Handel und sonst wie einzugehen, sie zu fördern oder daran teilzunehmen, und jeder Holdinggesellschaft, Tochtergesell-
schaft oder Schwestergesellschaft, oder jeder anderen Gesellschaft, die auf irgendwelche Weise mit der Gesellschaft
verbunden ist, oder der gesagten Holdinggesellschaft, Tochtergesellschaft oder Schwestergesellschaft, in der die Gesell-
schaft einen direkten oder indirekten finanziellen Anteil besitzt, jede Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Sicher-
heiten zu gewähren; Geldmittel auf jede Weise zu leihen und aufzunehmen und die Rückzahlung von allen aufgenommenen
Geldmitteln zu garantieren; schließlich jede Tätigkeit auszuüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck verbunden ist.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten im Bereich Handel, Technik und Finanzen ausüben, die direkt oder indirekt mit

allen vorgenannten Bereichen verbunden sind, mit dem Ziel, die Erfüllung ihres Zwecks zu erleichtern.".

Art. 5. "Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft ist auf vierhunderttausend Euro (EUR 400.000) festgelegt,

eingeteilt in zweihunderttausend Aktien mit einem Nennwert von je zwei Euro (EUR 2,-). Die Gesellschaft kann Na-
mensaktien und Inhaberaktien ausgeben.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Für den nachstehend angegebenen Zeitraum ist das genehmigte Kapital auf fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000) fest-

gelegt, eingeteilt in zwei Millionen und fünfhunderttausend (2.500.000) Aktien mit einem Nennwert von je zwei Euro
(EUR 2).

Das genehmigte und gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der

Aktionäre, die mit derselben beschlussfähigen Anzahl der Aktionäre abstimmt, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen
ist, erhöht oder vermindert werden.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren das gezeichnete Aktienkapital

einmalig oder mehrere Male im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhung kann durch Zeich-
nung und Ausgabe von Aktien mit oder ohne Emissionsprämie erfolgen und in bar, durch Sacheinlage, durch Ausgleichs-
zahlung von unbestrittenen, vorliegenden und unverzüglich geltend machenden Ansprüchen bei der Gesellschaft, oder
sogar durch Einverleibung von Gewinnen, verfügbaren Rücklagen oder Emissionsprämien, oder durch Umwandlung von
Anleihen in Aktien, wie nachstehend erwähnt, gezahlt werden.

Insbesondere ist der Verwaltungsrat ermächtigt, solche Ausgaben vorzunehmen, ohne dabei den bereits vorhandenen

Aktionären ein Vorzugsrecht für die Aktien, die ausgegeben werden, einzuräumen."

<i>Sechster Beschluss

"Die Versammlung beschließt, unter Berücksichtigung des ausschüttbaren Nettogewinnes, der sich auf sechs Millionen

neunhundertfünfundfünfzigtausendsiebenhundertneunundzwanzig Euro (EUR 6.955.729) beläuft, wie aus den Jahreskon-
ten der Gesellschaft für das Jahresende am 31. Dezember 2008 hervorgeht, und wie es sich aus einer Zustimmung der
jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 7. Juli 2009 ergibt, eine Dividende an die Aktionäre im
Verhältnis zu ihrem Anteilbesitz von einem Betrag von sechs Millionen neunhundertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR
6.955.000) auszuzahlen."

Da hiermit die Tagesordnung der Versammlung erschöpft ist, wurde letztere für geschlossen erklärt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde an die erschienenen Personen haben diese zusammen mit Uns, Notar, gegenwärtige

Originalurkunde unterschrieben.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist und sie spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag

der  vorgenannten  erschienen  Personen  gegenwärtige  Urkunde  in  englischer  Sprache  abgefasst  ist,  gefolgt  von  einer
Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Antrag derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen Text und dem deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend.

Signé: H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 octobre 2009. Relation: LAC/2009/45686. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009152119/242.
(090184930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119559

Levanter Real 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 128.681.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LEVANTER REAL 1 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009152099/13.
(090184176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Levanter Real 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 128.630.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LEVANTER REAL 2 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009152100/13.
(090184177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Pike Environment, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 67.819.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «PIKE

ENVIRONMENT S.à r.l.», en date du 26 Octobre 2009.

- que la société «PIKE ENVIRONMENT S.à r.l.» (la «Société»), société à responsabilité limitée, établie et ayant son

siège  social  au  7,  Val  Sainte  Croix,  L-1371  Luxembourg,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  et  à
Luxembourg, section B sous le numéro 67819,

constituée suivant acte notarié de M 

e

 Paul Frieders du 18 décembre 1998 et publié au Mémorial C numéro 174 du

16 mars 1999;

se trouve à partir de la date du 26 Octobre 2009 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 27 décembre 2007 aux termes de laquelle

la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l'occurrence au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009153412/28.
(090186410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

119560

Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA), Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.814.

In the year two thousand nine, on the sixteenth of September.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, residing in Luxembourg,
acting as representative of the Manager as unlimited Shareholder (actionnaire gérant commandité) of ORLANDO

ITALY SPECIAL SITUATIONS SICAR (SCA), a société d'investissement en capital à risque (SICAR) under the form of a
company limited by shares (société en commandite par actions - partnership limited by shares), having its registered office
at L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, trade register Luxembourg section B number 116.814
(hereafter "the partnership" or "the Company"), by virtue of the authority conferred on her by decisions of the General
Partner, taken at its meetings of the 6 

th

 of August 2009,

an extract of the minutes of the said meeting, signed "ne varietur" by the appearing person and the notary, shall remain

attached to the present deed with which it shall be formalised.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as

follows:

1.- The Company has been incorporated by deed on 24 

th

 May, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, number 1189 of 19 

th

 June, 2006 and its Articles of Association have been amended for the last time by

deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, who acted in replacement of the undersigned notary
on 6 August 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2.- The subscribed share capital (hereinafter, the "Subscribed Capital") of the SICAR is set at ONE MILLION TWO

HUNDRED  AND  NINETEEN  THOUSAND  SIX  HUNDRED  AND  NINETY-SEVEN  EUROS  AND  FORTY-EIGHT
CENTS (EUR 1,219,697.48) divided into 885,410 (eight hundred and eighty-five thousand four hundred and ten) Class A
Shares with a par value of EUR 1.24 (one Euro and twenty-four cents) each and 98,217 (ninety-eight thousand two hundred
and seventeen) Class B Shares with a par value of EUR 1.24 (one Euro and twenty-four cents) each, fully paid up.

3.- Pursuant to Article 5.4 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at EUR

220,000,000.20 (two hundred twenty million euros and twenty cents), consisting of 177,419,355 (one hundred seventy-
seven million four hundred nineteen thousand three hundred fifty-five) shares of a par value of EUR 1.24 (one euro and
twenty-four cents) each.

The Manager is authorised and instructed to increase the share capital, in whole or in part, from time to time, within

a period starting on June 19, 2006 and expiring on June 19, 2011, up to the overall amount of the authorised capital; in
doing so, the Manager shall decide to issue shares representing such whole or partial increase and shall accept subscriptions
for such shares.

4.- Through its resolutions dated September 14, 2009, the Manager has realized an increase of capital by the amount

of FOUR THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY-THREE EURO AND TWENTY CENTS (eur 4,253.20) so as to
raise the subscribed capital from its present amount of ONE MILLION TWO HUNDRED AND NINETEEN THOUSAND
SIX HUNDRED AND NINETY-SEVEN EUROS AND FORTY-EIGHT CENTS (EUR 1,219,697.48) up to ONE MILLION
TWO HUNDRED AND TWENTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY EURO AND SIXTY-EIGHT
CENTS (EUR 1,223,950.68) by the creation and issue of TWO THOUSAND FOUR HUNDRED AND SEVENTY-NINE
(2,479) new Class A Shares at an issue price of ONE THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY-SIX EURO AND FOUR-
TEEN CENTS (EUR 1,136.14) per share, making THREE THOUSAND SEVENTY-THREE EURO AND NINETY-SIX
EURO (3,073,96) for the capital and TWO MILLION SEVEN HUNDRED AND NINETY-SEVEN THOUSAND FIVE
HUNDRED AND SEVENTY-SIX EURO TWENTY-NINE CENTS (EUR 2,797,576.29) for the issue premium, and NINE
HUNDRED AND FIFTY-ONE (951) new Class B Shares at an issue price of ONE EURO AND TWENTY-FOUR CENTS
(EUR 1.24) per share making ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-NINE EURO AND TWENTY-FOUR
CENTS (EUR 1,179.24) for the capital.

5.- That still pursuant to the powers conferred to the General Partner, on terms of Article 5.4 of the Articles of

Incorporation, the General Partner has cancelled the preferential right of the then existing shareholders to subscribe and
has allowed to the subscription of the total new A shares and B shares the subscribers detailed on the list here annexed.

All the shares thus subscribed have been fully paid up by the subscribers by payment in cash, so that the amount of

TWO MILLION EIGHT HUNDRED ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND TWENTY-NINE EURO AND FOR-
TY-NINE CENTS (EUR 2,801,829.49) has been at the free disposal of the company as was certified to the undersigned
notary by presentation of the supporting documents for subscriptions and payments. The share premium of TWO MIL-
LION  SEVEN  HUNDRED  AND  NINETY-SEVEN  THOUSAND  FIVE  HUNDRED  AND  SEVENTY-SIX  EURO  AND

119561

TWENTY-NINE CENTS (EUR 2,797,576.29 is to be allocated to the Company's freely distributable share premium
account.

6.- As a consequence of this increase of capital, Article 5.3 of the Articles of Association of the Company is amended

and now reads as follows:

5.3. The subscribed share capital (hereinafter, the "Subscribed Capital") of the SICAR is set at ONE MILLION TWO

HUNDRED AND TWENTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY EURO AND SIXTY-EIGHT CENTS
(EUR  1,223,950.68)  divided  into  EIGHT  HUNDRED  AND  EIGHTY-SEVEN  THOUSAND  EIGHT  HUNDRED  AND
EIGHTY-NINE (887,889) Class A Shares with a par value of EUR 1.24 (one Euro and twenty-four cents) each and NINETY-
NINE THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY-EIGHT (99,168) Class B Shares with a par value of EUR 1.24 (one
Euro and twenty-four cents) each, fully paid up.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present increase of capital, are estimated at EUR 2,800.-.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le seize septembre.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire du Gérant en tant qu'Actionnaire Gérant commandité (le Gérant) de la société

d'investissement en capital à risque (SICAR) sous forme de société en commandite par actions ORLANDO ITALY SPE-
CIAL  SITUATIONS  SICAR  (SCA),  ayant  son  siège  social  à  L-1331  Luxembourg,  31,  Boulevard  Grande-Duchesse
Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 116.814 (la "Société"), en vertu d'un pouvoir conféré par décisions de
l'Associé Commandité, prises en sa réunion du 6 août 2009.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:
1.- La Société a été constituée suivant acte reçu le 24 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations, numéro 189 du 19 juin 2006 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître
Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, ayant agi en remplacement du notaire instrumentant, en date
du 6 août 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s'élève actuellement à UN MILLION DEUX CENT DIX-

NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTS (EUR 1.219.697,48), divisé
en HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENT DIX (885.410) Actions de Catégorie A d'une valeur
nominale de UN EURO VINGT-QUATRE CENTS (EUR 1,24) chacune et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DEUX
CENT DIX-SEPT (98.217) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale de UN EURO VINGT-QUATRE CENTS (EUR
1,24) chacune.

3.- Conformément à l'article 5.4 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à EUR 220.000.000,20 (deux cent

vingt millions d'euros et vingt cents), composé de 177.419.355 (cent soixante dix-sept millions quatre cent dix-neuf mille
trois cent cinquante-cinq) actions d'une valeur nominale chacune de EUR 1,24 (un euro et vingt-quatre cents).

Le Gérant est autorisé à et a la charge d'augmenter le capital social, en tout ou en partie, le cas échéant, au cours

d'une période ayant débuté le 19 juin 2005 et expirant le 19 juin 2011, jusqu'au montant total du capital autorisé; ce
faisant, le Gérant décidera d'émettre des actions représentant une telle augmentation totale ou partielle et acceptera des
souscriptions pour lesdites actions.

4.- Par sa résolution du 14 septembre 2009, le Gérant a réalisé une augmentation de capital à concurrence de QUATRE

MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET VINGT CENTS (EUR 4.253,20) en vue de porter le capital social
souscrit de son montant actuel de UN MILLION DEUX CENT DIX-NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-
SEPT EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTS (EUR 1.219.697,48) à UN MILLION DEUX CENT VINGT-TROIS MILLE
NEUF CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTS (EUR 1.223.950,68) par la création et l'émission de
DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF (2.479) actions nouvelles de Classe A à un prix d'émission de
MILLE CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUATORZE CENTS (EUR 1.136,14) par action, faisant TROIS MILLE SOIXANTE-
TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (EUR 3.073,96) pour le capital et DEUX MILLIONS SEPT CENT

119562

QUATRE-VINGT-DIX-SEPT  MILLE  CINQ  CENT  SOIXANTE-SEIZE  EUROS  ET  VINGT-NEUF  CENTS  (EUR
2.797.576,29) pour la prime d'émission, et de NEUF CENT CINQUANTE ET UNE (951) actions nouvelles de Classe B
à un prix d'émission de UN EURO VINGT-QUATRE CENTS (EUR 1,24) par action, faisant MILLE CENT SOIXANTE-
DIX-NEUF EUROS ET VINGT-QUATRE CENTS (EUR 1,179.24) pour le capital.

5.- Que le Gérant, autorisé par les dispositions de l'article 5.4 des statuts, après avoir supprimé l'exercice du droit

préférentiel de souscription des actionnaires existants, a accepté la souscription de la totalité des nouvelles actions A par
les souscripteurs apparaissant sur la liste en annexe.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire par les souscripteurs, de sorte que

la somme totale de DEUX MILLIONS HUIT CENT UN MILLE HUIT CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUARANTE-
NEUF  CENTS  (EUR  2.801.829,49)  a  été  mise  à  la  libre  disposition  de  la  Société  dont  il  a  été  justifié  au  notaire
instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération. La prime d'émission du montant
de  DEUX  MILLIONS  SEPT  CENT  QUATRE-VINGT-DIX-SEPT  MILLE  CINQ  CENT  SOIXANTE-SEIZE  EUROS  ET
VINGT-NEUF CENTS (EUR 2.797.576,29) est à allouer au compte de prime d'émission librement distribuable de la
Société.

6.- En conséquence d'une telle augmentation du capital, l'article 5.3 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir

désormais la teneur suivante:

5.3. Le capital social souscrit (ci-après "le Capital Souscrit") de la SICAR est fixé à UN MILLION DEUX CENT VINGT-

TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTS (EUR 1.223.950,68) divisé en HUIT
CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF (887.889) Actions de Catégorie A d'une
valeur nominale de EUR 1,24 (un euro et vingt-quatre centimes) chacune et QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CENT
SOIXANTE-HUIT (99.168) Actions de Catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1,24 (un euro et vingt-quatre cents)
chacune."

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ EUR 2.800,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. BEMTGEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 septembre 2009. Relation: LAC/2009/39378. Reçu soixante-quinze euros

(75€)

<i>Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009153422/152.
(090185996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Svelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 112.754.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S. A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009152118/15.
(090184396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119563

JMW Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 89.708.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009152102/10.
(090184180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

JMW Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 89.708.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009152103/10.
(090184182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Medine-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 140.259.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Matthijs Bogers
<i>Gérant

Référence de publication: 2009152106/13.
(090184524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Tribal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 73.677.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009152108/10.
(090184416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Logwin Road + Rail Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Thiel EuroLogistics Services S.à r.l.).

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 22.938.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, le 30 Novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009152107/11.
(090184515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119564

Levhold Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 118.226.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009152104/11.
(090184185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Bluegems Investments Sicar, S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'In-

vestissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 123.528.

Le Bilan au 31 Décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009152105/12.
(090184526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Trivox S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 74.466.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009152109/10.
(090184414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

ArcelorMittal Long Carbon Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 79.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009152110/10.
(090184411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

D &amp; G Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 131.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009152140/10.
(090184373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119565

Beda Regiebau Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 75.833.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009152111/15.
(090184407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Hôtel-Restaurant Chez Jean Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6661 Born, 28, Haapstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 95.757.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009152113/15.
(090184404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Ben Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 129.187.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152160/11.
(090184621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Ben Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 129.188.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152157/11.
(090184623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119566

Thinnes Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6739 Grevenmacher, 2A, Kahlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 19.050.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009152114/15.
(090184402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

STK Metall S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 19.976.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009152115/15.
(090184401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Sopawa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange.

R.C.S. Luxembourg B 73.260.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOPAWA S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009152150/12.
(090184341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Waru S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 73, rue des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 111.274.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WARU S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009152151/12.
(090184339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119567

Cetinblew Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 106.270.

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "CETINBLEW INVESTMENT S.A.", R.C.S. Luxembourg Numéro B 112146 ayant son siège social à
Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 23 février 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
596 du 21 juin 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée profes-

sionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
l.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Antonio SIMONE,

résident à Flat 1, Acol Court, Acol Road, GB-London NW6 3AE, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Sabella, C. Peyron, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2009. LAC/2009/50702. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Référence de publication: 2009152412/49.
(090184652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

119568


Document Outline

ArcelorMittal Long Carbon Europe

Arno Glass Luxco

Beda Regiebau Luxembourg S.à r.l.

Ben Luxembourg 1 S.à r.l.

Ben Luxembourg 2 S.à r.l.

Birkdale Holding S. à r.l.

Bluegems Investments Sicar, S.à r.l.

Bucher Invest Holding S.A.

Bucher Invest S.A.

Cetinblew Investment S.A.

Cirsa Funding Luxembourg S.A.

Cork Supply Group S.à r.l.

D &amp; G Lux S.à r.l.

DP Investment (Holding) S.A.

Elgin Credit Plus S.A.

FLE Finco S. à r.l.

FLE SICAV-FIS

G.A. - Fund -L

Gavilon Luxembourg HoldCo II S.à r.l.

Gavilon Luxembourg HoldCo S.à r.l.

GSI Holding S.A.

GSMP 3 Onshore S.à r.l.

Head IT S.A.

Hôtel-Restaurant Chez Jean Sàrl

IMP East Real Estate Investments S.A.

Intel Holding S.A.

JMW Holdings Luxembourg S.à r.l.

JMW Holdings Luxembourg S.à r.l.

Jog S.à r.l.

Krokus S.A.

Labmed S.A.

Laboratoire Dentaire Fleischhauer S.à r.l.

Levanter Real 1 S.à r.l.

Levanter Real 2 S.à r.l.

Levanter Real 3 S.à r.l.

Levhold Germany S.à r.l.

LFPI Property S.à r.l.

Libidama International S.A.

Logwin Road + Rail Luxemburg S.à r.l.

Marroni Finances Holding S.A.

Medine-Lux S.à r.l.

MW Unitexx S.A.

Nabi Biopharmaceuticals Luxembourg S.à r.l.

Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA)

Pike Environment

Property Finance France S.A.

QOA Holding

Rusta S.à r.l.

Solar Generation Holdings S.à r.l.

Sopawa S.à r.l.

STK Metall S.àr.l.

Svelux S.à r.l.

Tecanox Holding S.A.

Thiel EuroLogistics Services S.à r.l.

Thinnes Sàrl

Tribal S.à r.l.

Trivox S.à r.l.

Waru S.à r.l.

Wesley S. à r.l.