logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2472

19 décembre 2009

SOMMAIRE

ACGH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118639

Algodeal Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

118640

Arcavest Project s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

118628

Auto-Sud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118627

Axel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118614

BDPE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118656

Berin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118627

Breteuil Strategies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

118638

Calao Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118626

CDC - Construction S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

118651

Checkpoint Assurances S.à r.l.  . . . . . . . . . .

118637

Compagnie Agricole de l'Est S.A. . . . . . . . .

118653

Compagnie Arabe de Financement Inter-

national  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118627

Corporate Express Silver S.A.  . . . . . . . . . . .

118656

Diam International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

118640

Emotion Event Management S.A.  . . . . . . .

118637

FANFARE BOURGLINSTER, Association

sans but lucratif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118654

Faustini Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118625

Foothills and Towers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

118653

Frazil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118615

Garage Da Cunha S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

118628

Geram International Holding S.A.  . . . . . . .

118610

Hickory Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118626

Hill 27 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118615

I.P.I. International Participations Investors

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118618

ITX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118651

Japan Fund Management (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118623

Jocemi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118637

Julius Baer Multifund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118637

Konsbruck's British House S.A. . . . . . . . . . .

118628

Kuhn Immobilier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118618

Lairnisia Gestion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

118626

Laumar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118622

Lime Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118652

Liontrust International Funds (Luxem-

bourg) SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118626

Luxeme S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118625

Mastiff S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118623

MFountain Selected Fund Series . . . . . . . . .

118623

Mitte Holdings Management S.C.A. . . . . . .

118650

Nabors Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

118639

Nabors Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

118639

Officio International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

118651

Optique Himmes Pétange S.à.r.l.  . . . . . . . .

118652

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118615

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118619

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118610

Parish Capital Luxembourg Holdings II-B,

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118656

Perisound S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118625

Quintiles Luxembourg European Holding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118629

Riverside Europe Engineering Luxem-

bourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118628

Sammichele S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118621

Scofield Corporation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

118639

Sicily Investments S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

118622

Sonnie Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118638

Spring Multiple 2007 S.C.A.  . . . . . . . . . . . . .

118622

ST Maxime Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .

118627

Superga Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118618

Tishman Speyer Rentiers Holdings I S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118636

118609

Geram International Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 19.372.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 janvier 2010 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009155167/795/15.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

A GENERAL MEETING

of the holders of the warrants 2012 (the "Warrantholders"), registered under ISIN code: LU0234878881 (the "War-

rants 2012") as described under the prospectus issued by the Company at the occasion of the issue of € 50,272,605.30
bonds with redeemable warrants attached on November 18, 2005 dated November 14, 2005 (the "Prospectus") will be
held at the registered office of the Company, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg,
on <i>January 20, 2010 at 11.00 Central European time ("CET") (the "Meeting").

The quorum of at least 50% of the total number of the Warrants 2012 outstanding required for the deliberation by

the general meeting of the Warrantholders held on December 16, 2009 was not reached: the number of the Warrants
2012 represented at the meeting amounted to 4,648 Warrants 2012 out of a total of 21,161 Warrants 2012 which
represents 21,96% of the Warrants 2012 outstanding. The general meeting of Warrantholders is therefore re-convened
in order to deliberate on the same agenda, which is as follows:

<i>Agenda:

1. Approval of the amendment of the terms and conditions of the Warrants 2012 in particular the exercise price, the

exercise parity and the redemption conditions thereof.

2. Approval of the amendment of the payment conditions of the exercise price of Warrants 2012 by the sale of Bonds

2010.

<i>Proposed amendments

1. Amendment of the terms and conditions of the Warrants 2012 in particular the exercise price, the exercise parity

and the redemption conditions thereof.

As of the date of the Meeting, the current terms of the Warrants 2012 are the following:
(i) Exercise Price of the Warrants 2012:
As of the date of the Meeting, pursuant to section 4.2.1.7.1 of the Prospectus, and as a result of previous adjustments

made in accordance with the terms and conditions of the Warrants 2012, each Warrant 2012 entitles its holder to
subscribe to 1.03 new Share (as defined in the Prospectus, the "Exercise Parity") at the exercise price of €68.61 to be
paid in cash (the "Exercise Price").

(ii) The redemption of the Warrants 2012 at the Company's option:
As of the date of the Meeting, the first paragraph of the section 4.2.1.11.2.1 of the Prospectus provides that the

Company may redeem all or part of the outstanding Warrants 2012, at its sole discretion, at any time from November
19, 2007 until November 18, 2012 at a unit price of € 0.01 provided that the average price (weighted for the volume of
transactions of the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist market), of the ten stock exchange
trading sessions preceding the publication of the early redemption announcement, of the products (1) of the closing prices
of the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist Market and (2) of the Exercise Parity in force at
each of these sessions exceeds 96.05€ (the "Current Soft Call Price").

The Meeting is invited to resolve to amend the current terms of the Warrants 2012 as follows:
(i) New Exercise Price and New Exercise Parity
The Meeting is invited to resolve to amend the current terms of the Warrants 2012 under section 4.2.1.7.1 so as to

read as follows:

118610

"Without prejudice to the provisions of paragraph 4.2.2.4 "Adjustment rules applicable in the occurrence of an event

that has an effect on the underlying instrument", (i) until February 15, 2010, one Redeemable Share Subscription Warrant
shall carry the right to subscribe to 8.7 new shares in Orco Property Group (hereinafter the "Exercise Parity" applicable
until February 15, 2010) subject to the payment of an exercise price of € 60.90 (hereinafter the "Exercise Price" applicable
until February 15, 2009) to be paid in cash, simultaneously to the exercise of the Redeemable Share Subscription Warrants
and (ii) from February 16, 2010, one Redeemable Share Subscription Warrant shall carry the right to subscribe to 1.03
new share in Orco Property Group (hereinafter the "Exercise Parity" applicable from February 16, 2010) subject to the
payment of an exercise price of € 7.21 (hereinafter the "Exercise Price" applicable from February 16, 2010) to be paid in
cash, simultaneously to the exercise of the Redeemable Share Subscription Warrants.

(ii) The redemption of the Warrants 2012 at the Company's option:
The Meeting is invited to resolve to modify,
i) until February 15, 2010, the Current Soft Call Price to € 87.00 for a first tranche of the Warrants 2012 (one third

of the outstanding Warrants 2012), to € 130.50 for a second tranche of the Warrants 2012 (half of the outstanding
Warrants 2012) and € 174.00 for a third and last tranche of the Warrants 2012 (all of the outstanding Warrants 2012)
so as to allow the Company to redeem the outstanding Warrants 2012, at its sole discretion, at any time until February
15, 2010 at a unit price of € 0.01 provided that the average price (weighted for the volume of transactions of the Orco
Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist market), of the ten stock exchange trading sessions preceding
the publication of the early redemption announcement (as defined later in this paragraph), of the products (1) of the
closing prices of the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist Market and (2) of the Exercise Parity
in force at each of these sessions exceeds € 87.00 for the first tranche, € 130.50 for the second tranche and € 174.00
for the third and last tranche (the "New Soft Call Prices" applicable until February 15, 2010),

ii) as from February 16, 2010, the Current Soft Call Price to € 10.30 for a first tranche of the Warrants 2012 (one

third of the outstanding Warrants 2012), to € 15.45 for a second tranche of the Warrants 2012 (half of the outstanding
Warrants 2012) and € 20.60 for a third and last tranche of the Warrants 2012 (all of the outstanding Warrants 2012) so
as to allow the Company to redeem the outstanding Warrants 2012, at its sole discretion, at any time until November
18, 2012 at a unit price of € 0.01 provided that the average price (weighted for the volume of transactions of the Orco
Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist market), of the ten stock exchange trading sessions preceding
the publication of the early redemption announcement (as defined later in this paragraph), of the products (1) of the
closing prices of the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist Market and (2) of the Exercise Parity
in force at each of these sessions exceeds € 10.30 for the first tranche, € 15.45 for the second tranche and € 20.60 for
the third and last tranche (the "New Soft Call Prices" applicable from February 16, 2010).

To reflect the foregoing it is proposed that the section 4.2.1.11.2.1 of the Prospectus be deleted and replaced by the

following:

"On giving notice (which shall be irrevocable) to the Holders of Redeemable Share Subscription Warrants, the Issuer

may, at any time, until the end of the Exercise Period, redeem the outstanding Redeemable Share Subscription Warrants,
by tranches, at a price of € 0.01 per Redeemable Share Subscription Warrant.

The first tranche shall be made up of one third of the outstanding Redeemable Share Subscription Warrants as of the

date of the relevant notice of redemption to the Holders of Redeemable Share Subscription Warrants. The Issuer may
proceed with the redemption of this first tranche provided that the average price (weighted for the volume of transactions
of the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist market), of the ten stock exchange trading sessions
preceding the publication of the early redemption announcement (as defined later in this paragraph), of the products (1)
of the closing prices of the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist Market and (2) of the Exercise
Parity in force at each of these sessions exceeds € 87.00 until February 15, 2010 and €10.30 as from February 16, 2010.

The second tranche shall be made up of half of the outstanding Redeemable Share Subscription Warrants as of the

date of the relevant notice of redemption to the Holders of Redeemable Share Subscription Warrants. The Issuer may
proceed with the redemption of this second tranche provided that the average price (weighted for the volume of trans-
actions of the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist market), of the ten stock exchange trading
sessions preceding the publication of the early redemption announcement (as defined later in this paragraph), of the
products (1) of the closing prices of the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist Market and (2)
of the Exercise Parity in force at each of these sessions exceeds € 130.50 until February 15, 2010 and €15.45 as from
February 16, 2010.

The third tranche shall be made up of all of the outstanding Redeemable Share Subscription Warrants as of the date

of the relevant notice of redemption to the Holders of Redeemable Share Subscription Warrants. The Issuer may proceed
with the redemption of this third tranche provided that the average price (weighted for the volume of transactions of
the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist market), of the ten stock exchange trading sessions
preceding the publication of the early redemption announcement (as defined later in this paragraph), of the products (1)
of the closing prices of the Orco Property Group share on the Euronext Paris S.A. Eurolist Market and (2) of the Exercise
Parity in force at each of these sessions exceeds € 174.00 until February 15, 2010 and €20.60 as from February 16, 2010.

In the event that the Issuer redeems some of the Redeemable Share Subscription Warrants remaining in circulation,

the number of Redeemable Share Subscription Warrants to be redeemed (hereinafter "Number of Redeemable Share

118611

Subscription Warrants to be Redeemed") shall amount, for each tranche of redemption to the number rounded down
to the lowest whole number of Redeemable Share Subscription Warrants. One month prior to the partial early redemp-
tion date, the financial intermediaries shall establish the number of Redeemable Share Subscription Warrants which are
to be redeemed early by applying the ratio of the Number of Redeemable Share Subscription Warrants to be Redeemed
and the number of Redeemable Share Subscription Warrants remaining in circulation to the number of Redeemable Share
Subscription Warrants appearing in each account, rounding off the result thus obtained to the next lowest whole number.
Application will be made to admit these Redeemable Share Subscription Warrants to trading on the Euronext Paris S.A.
Eurolist Market under a new ISIN code until their redemption date. The number of Redeemable Share Subscription
Warrants which are not redeemed early shall be carried over, where applicable, to the third and last tranche.

A "Stock Exchange Day" shall mean a Working Day on which Euronext Paris S.A. provides quotation of shares other

than a day on which the quotations cease before the normal closing time.

For the purpose of this paragraph, a "Working Date" is a day (other than a Saturday or Sunday) when the banks in

Paris are open and when Euroclear France operates.

Announcement to holders of Redeemable Share Subscription Warrants of the redemption of Redeemable Share Sub-

scription Warrants

The Company's decision to redeem Redeemable Share Subscription Warrants early shall be published in advance at

least one month before the Redeemable Share Subscription Warrants redemption date in an announcement in a Luxem-
bourg daily newspaper, a French national financial newspaper and in a Euronext Paris S.A. announcement (hereinafter,
the "Early Redemption Announcement").

In the event that the Company redeems the Redeemable Share Subscription Warrants, Holders of the Redeemable

Share Subscription Warrants may avoid such redemption by exercising their Redeemable Share Subscription Warrants
until the date set for the redemption in accordance with the stipulations of Section 4.2.1.7.3. After this date, the Redee-
mable Share Subscription Warrants shall be redeemed by the Company and cancelled."

2. Amendment of the payment conditions of the exercise price of the Warrants 2012 by the sale of Bonds 2010.
As of the date of the Meeting, pursuant to section 4.2.1.7.1 of the Prospectus, and as a result of previous adjustments

made in accordance with the terms and conditions of the Warrants 2012, each Warrant 2012 entitles its holder to
subscribe to 1.03 new Share (as defined in the Prospectus, the "Exercise Parity") at the exercise price of €68.61 to be
paid in cash (the "Exercise Price"). However, for every 10 Warrants 2012 exercised, Warrantholders may pay for their
subscription of €686.10 (10 x €68.61) by the sale to the Company of one Bond 2010 (as defined below) with a nominal
value of €686.10 made due and payable to this effect at a price of €686.10.

The bonds issued by OPG and registered under ISIN code: FR0010249599 (the " Bonds 2010 ").
The Meeting is invited to resolve to amend the current terms of the Warrants 2012 as follows:
Subject to a general meeting of the holders of the Bonds 2010 approving the amendment of the Section 4.1.8.1.3.2 of

the Prospectus, such amendment pertaining to the terms and conditions of the Bonds 2010, and subject to the general
meeting of the holders of the Warrants 2012 having approved the above first resolution, the Meeting is invited to resolve
to amend the current terms of the Warrants 2012 under section 4.2.1.7.1 so as to read as follows:

"Without prejudice to the provisions of paragraph 4.2.2.4 "Adjustment rules applicable in the occurrence of an event

that has an effect on the underlying instrument", (i) until February 15, 2010, one Redeemable Share Subscription Warrant
shall carry the right to subscribe to 8.7 new shares in Orco Property Group (hereinafter the "Exercise Parity") subject
to the payment of an exercise price of 60.90 € to be paid in cash, simultaneously to the exercise of the Redeemable Share
Subscription Warrants, and (ii) as from February 16, 2010, one Redeemable Share Subscription Warrant shall carry the
right to subscribe to 1.03 new share in Orco Property Group (hereinafter the "Exercise Parity") subject to the payment
of an exercise price of 7.21 € to be paid in cash, simultaneously to the exercise of the Redeemable Share Subscription
Warrants.

However, for every N (as defined below) Redeemable Share Subscription Warrants exercised, bearers may pay for

their subscription of A € (as defined below) by (i) the sale to the Company of 1 Bond with an initial nominal value of
686.10 € (see Section 4.1.8.1.3.2 "Early redemption at the option of the bearers exercising the Redeemable Share Sub-
scription  Warrants  and  payment  by  offset  of  the  share  subscription  amount  by  exercise  of  the  Redeemable  Share
Subscription Warrants") made due and payable to this effect at a price equal to its outstanding principal amount as of the
date of the sale ("ONV") and (ii) the payment in cash of R € (as defined below),

Where
"N" means the number rounded up to the nearest whole number calculated by the following formula:

ONV / K;

"A" means the amount calculated by the following formula:

N x K ;

"K" means the applicable Exercise Price as of the date of the exercise of such Redeemable Share Subscription Warrants ;
"R" means the amount calculated by the following formula:

A - ONV. "

118612

Please refer to the company's website at www.orcogroup.com for further details pertaining to the proposed amend-

ments to the terms and conditions of the Warrants 2012 being subject to their approval by the Meeting.

There is now no required quorum for the General Meeting to validly deliberate on the agenda as the Meeting is a re-

convened general meeting.

Resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least seventy-five (75%) percent of the votes cast by the

Warrantholders present or represented.

Copies of the Prospectus, the articles of association of the Company and the proposed amendments to the terms and

conditions of the Warrants 2012 are available on the Company's website at www.orcogroup.com and at the registered
office of the Company upon request.

The board of directors of the Company would like to point out that for Warrantholders whose ownership is directly

or indirectly recorded in the warrant registry of the Company, the conditions for attendance or representation at the
Meeting are as follows:

1. Conditions for personal attendance
(i) Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company
Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company and who elect to

attend the Meeting in person must use their usual applicable contacting method for informing their financial intermediary,
with whom their Warrants 2012 are on deposit, accordingly. They must further request their financial intermediary, with
whom their Warrants 2012 are on deposit, to send a blocking certificate (the "blocking certificate") for their Warrants
2012 to the relevant central registration bank no later than 5 business days prior to the Meeting.

Such blocking certificate must indicate clearly the precise identity of the Warrantholder, the number of Warrants 2012

being blocked, the date such Warrants 2012 are being blocked, which must be no later than January 15, 2010, and a
statement that the relevant Warrants 2012 are registered in the local bank or brokers records in the holder's name and
shall be blocked until the close of the Meeting.

The Warrantholders must bring a copy of the blocking certificate to the Meeting.
The Warrantholders shall also announce their intention to participate at the Meeting by completing, signing, dating

and returning on no later than January 15, 2010, at the latest to the relevant central registration bank or to the Company
(C/O Orco Property Group, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, to the attention of Françoise de Jongh and
Ralph Limburg), the participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or
downloaded from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial interme-
diaries or the relevant central registration bank.

(ii) Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company
Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company, shall announce their

intention to participate to the Meeting by completing, signing, dating and returning on January 15, 2010, at the latest to
the relevant central registration bank or to the Company (C/O Orco Property Group, 40, Parc d'Activités Capellen,
L-8308 Capellen, to the attention of Françoise de Jongh and Ralph Limburg) the participation form that can be obtained
at  the  registered  office  of  the  Company  upon  request  or  downloaded  from  the  Company's  website  at
www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant central registration bank.

2. Conditions for proxy voting or grant a mandate
(i) Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company
Warrantholders whose ownership is indirectly recorded in the warrant registry of the Company and who are unable

to attend the Meeting in person, may give a voting instruction to a third party that the Warrantholder designates.

Prior to giving voting instructions to a proxy, this Warrantholder must a) have obtained and delivered to the relevant

central registration bank the blocking certificate described above (see "Conditions for personal attendance"), and b)
complete, sign and date the participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request
or downloaded from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial inter-
mediaries or the relevant central registration bank, indicating the name of the proxy.

The completed, signed and dated participation form must be returned to the relevant central registration bank or to

the Company (C/O Orco Property Group, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, to the attention of Françoise
de Jongh and Ralph Limburg) no later than January 15, 2010, at the latest, in order to have that name recorded on the
registration list of the Meeting.

If a Warrantholder wishes to be represented by a proxy other than the Chairman of the Meeting, then this holder

must (a) have obtained and delivered to the relevant central registration bank the blocking certificate described above
(see "Conditions for personal attendance"), and (b) complete, sign and date the participation form that can be obtained
at  the  registered  office  of  the  Company  upon  request  or  downloaded  from  the  Company's  website  at
www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant central registration bank,
indicating the name of the proxy. The completed, signed and dated participation form must be returned to the relevant
central registration bank or to the Company (C/O Orco Property Group, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen,

118613

to the attention of Françoise de Jongh and Ralph Limburg) no later than January 15, 2010 at the latest, in order to have
that name recorded on the registration list of the Meeting.

Warrantholders, who have obtained the blocking certificate and have executed a participation form but who wish to

revoke such proxy may do so at any time by timely delivering a properly executed, later dated participation form no later
than January 15, 2010, at the latest, or by properly attending and voting in person at the Meeting.

Simply attending the Meeting without voting will not revoke the proxy.
(ii) Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company.
Warrantholders whose ownership is directly recorded in the warrant registry of the Company must complete, sign

and date the participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or downloaded
from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial intermediaries or the
relevant central registration bank.

The completed, signed and dated participation form must be returned to the relevant central registration bank or to

the Company (C/O Orco Property Group, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, to the attention of Françoise
de Jongh and Ralph Limburg) no later than January 15, 2010, at the latest.

3. Request for information and central registration banks
Warrantholders looking for more information can do so by:
(i) contacting directly the Company's services:
At the registered office of the Company- Legal Department
Tel.: +352 26 47 67 24
Fax.: +352 26 47 67 67
(ii) contacting one of the central registration banks :

CACEIS
14, rue Rouget de Lisle F - 92189 Issy les Moulineaux
Tel.: +33 157783479
Fax: +33 149080582 or +33 1 49080583

Paris, December 17, 2009.

<i>For the board of directors of the Company
Jean-François Ott
<i>Director

Référence de publication: 2009155133/1273/247.

Axel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 60.136.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>6 janvier 2010 à 11.00 heures au siège social, 19-21 Boulevard du Prince

Henri, 1724 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre suite à la résiliation par le domiciliataire de la convention de domiciliation et de gestion comp-

table;

2. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
3. Présentation des comptes annuels clos au 31 décembre 2008 ainsi que du rapport de gestion du conseil d'admi-

nistration et du rapport de la personne chargée du contrôle des comptes;

4. Approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2008 et affectation du résultat de l'exercice;
5. Décharge aux organes de la société;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Les actionnaires désirant assister à l'assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l'assemblée

générale auprès de la Société Européenne de Banque, 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009155169/755/23.

118614

Hill 27 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 56.448.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

Reportée qui aura lieu le <i>7 janvier 2010 à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

sur les sociétés commerciales

5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009155168/795/17.

Frazil S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 34.908.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>30 décembre 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs

remplaçants

2. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1 

er

 juillet 2009 à la

date de la présente Assemblée

3. Transfert du siège social
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009151425/795/17.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

A GENERAL MEETING

of the holders of the bonds registered under ISIN code: XS0291838992 and XS0291840626 (the "Bonds 2014") as

described in the prospectus issued by the Company in relation to the issue on March 28, 2007 of € 175.000.461,60, 2.5
per cent bonds with redeemable warrants attached due March 28, 2014 at an issue price: 97,10 per cent, represented by
119.544 bonds of € 1421,45 each dated March 22, 2007 (the "Prospectus"), will be held at the registered office of the
Company, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand-Duchy of Luxembourg, on <i>January 13, 2008 at 14.30
Central European time ("CET") (the "Meeting").

The Meeting is being held further to the adjournment by four weeks of the initial meeting held on December 16, 2009,

pursuant to a decision of the board of directors of the Company, taken at the request made by bondholders representing
at least one fifth of the Bonds 2014 on the basis of article 94-1 and article 67(5) of the Luxembourg law on commercial
companies, as amended.

The Meeting will be held in order to consider the following agenda:

<i>Agenda:

• Approval of the amendment of the section 4.1.8.1.2.2 of the Bonds 2014 terms and conditions as stated in the

Prospectus.

118615

<i>Proposed amendment of the section 4.1.8.1.2.2 of the prospectus

As of the date of the Meeting, the current terms of the Bonds 2014 under section 4.1.8.1.2.2 of the terms and conditions

of the Bonds 2014 are the following:

"4.1.8.1.2.2. Early redemption at the option of the Bondholders exercising the Warrants and prepayment of the Bonds

by way of setoff against the amount due by them to the Company as a result of the Shares subscription by exercise of
the Warrants.

For every 10 Warrants exercised (see Section 4.2.1.7.1), Bondholders may pay for the subscription of their Shares of

€1,463.90 (10 x €146.39) by the sale to the Company of 1 Bond with a nominal value of €1463.90 made due and payable
to this effect at a price of €1,463.90."

Subject to a general meeting of the holders of the warrants registered under ISIN code: XS0290764728 (the "Warrants

2014") approving the amendment of the Section 4.2.1.7.1 of the terms and conditions of the Warrants 2014 the Meeting
is invited to resolve to amend the current terms of the Bonds 2014 under section 4.1.8.1.2.2 of the terms and conditions
of the Bonds 2014 so as to read as follows:

"4.1.8.1.2.2. Early redemption at the option of the Bondholders exercising the Warrants and prepayment of the Bonds

by way of setoff against the amount due by them to the Company as a result of the Shares subscription by exercise of
the Warrants.

For every N (as defined below) Warrants exercised (see Section 4.2.1.7.1), Bondholders may pay for the subscription

of their Shares of €A (as defined below) by (i) the sale to the Company of 1 Bond with an initial nominal value of €1,463.90
made due and payable to this effect at a price equal to its outstanding principal amount as of the date of the sale ("ONV")
and (ii) the payment in cash of R € (as defined below).

Where
"N" means the number rounded up to the nearest whole number calculated by the following formula:

ONV / K ;

"A" means the amount calculated by the following formula:

N x K ;

"K" means the applicable Exercise Price (as defined pursuant to section 4.2.1.7.1 of the Prospectus) as of the date of

the exercise of such Warrants;

"R" means the amount calculated by the following formula:

A - ONV. "

Please refer to the Company's website at www.orcogroup.com for further details pertaining to the proposed amend-

ments to the terms and conditions of the Bonds 2014 being subject to the approval by the Meeting.

The voting certificate, hereinafter mentioned, necessary to be represented and participate at the Meeting shall be at

the disposal of the holders of Bonds 2014 from December 18, 2009 (or as soon as possible thereafter) either with the
Company on www.orcogroup.com, or on request with the Bondholders Representative by email at lleroi@pt.lu.

Copies of the Prospectus and the articles of association of the Company are available on the Company's website at

http://www.orcogroup.com and at the registered office of the Company upon request.

The Bondholder's representative would like to point out that for holders of Bonds 2014 of the Company, the conditions

for attendance or representation at the Meeting are as follows:

1. Authorization to participate
As mentioned in the Prospectus, holders of Bonds 2014 ("Bondholders"), and proxies showing a voting certificate and

register of voting certificates issued by the Paying Agent (Bank of New York Mellon, Brussels Branch, One Canada Square,
London, E14 5AL) can attend and vote at the Meeting. The Company and its legal advisors, as well as its respective financial
advisors and such other persons as may be accepted by the Meeting, may attend and speak at the Meeting.

2. Participation in and Voting at the Meeting
In accordance with Article 94-1, Article 67(5), Article 94-2 and 94-3 of the law of 10th August, 1915 on commercial

companies as amended and in accordance with the terms and conditions of the Bonds 2014, the quorum at the general
meeting remains 50% of the outstanding Bonds 2014. The resolutions will be passed by 2/3 of the votes cast by the
Bondholders present or represented at the Meeting.

The attention of Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take valid resolutions that will

validly bind all the Bondholders (even those not represented at the Meeting). In addition, Article 94-5 of the law of 10th
August, 1915 on commercial companies as amended provides that when a Bondholder representative has been appointed
in accordance with the provisions of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended, Bondholders
may no longer exercise their rights individually.

As is customary for securities such as the Bonds 2014, the Bonds 2014 are generally held through banks or other

financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems, Euroclear Bank
S.A./N.V., as operator of the Euroclear System ("Euroclear") and Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream,
Luxembourg"), through which transactions in the Bonds 2014 are effected.

118616

All of the Bonds 2014 are represented by a bearer global bond (the "Global Bond"). The Global Bond is presently held

by a common depositary for Euroclear and Clearstream Luxembourg.

Each person (a "Beneficial Owner") who is the owner of a particular principal amount of the Bonds 2014, through

Euroclear, Clearstream Luxembourg or their respective account holders with Euroclear or Clearstream Luxembourg
(the "Accountholders"), should be entitled to attend and vote at the Meeting in accordance with the procedures set out
below.

Voting instructions may be delivered only through direct Accountholders with the type of vote: in favour of / against /

abstain from the proposed resolutions and by stating the Principal Amount of Bonds 2014. A splitting of the resolutions
is not accepted.

In order to obtain a voting certificate or instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting

in accordance with a Bondholder's instructions, an Accountholder must procure delivery of an electronic voting instruc-
tion, in accordance with the procedures of Euroclear or Clearstream Luxembourg, to the relevant Paying Agent prior to
the Expiration Time on the Expiration Date all of them as defined below.

If a Bondholder is not wishing to attend and vote at the Meeting in person, he can instruct the Paying Agent to appoint

a proxy to attend and vote at the Meeting on his behalf with the type of vote: in favour of / against / abstain from the
proposed resolutions. A splitting of the resolutions is not accepted.

Bondholders may also allow their voting right in the Meeting to be exercised by an authorized representative, e.g.

allow another person of their choice to act as proxy. The authorizations must be issued in writing.

Beneficial Owners who are not Accountholders must arrange through their broker, dealer, commercial bank, custo-

dian, trust company or other nominee to contact the Accountholder through which they hold their Bond(s) 2014 in order
to procure delivery of their voting instructions via Euroclear or Clearstream, Luxembourg to the relevant Paying Agent
prior to the Expiration Time on the Expiration Date.

The expiration time shall be at 12.00 pm CET (the "Expiration Time") of January 8, 2010 (the "Expiration Date"). The

Company has the right to postpone the Expiration Date; in that case, notice of such postponement shall be given to the
Bondholders.

Once the Paying Agent has issued a voting certificate for a meeting in respect of a Bonds 2014, it shall not release the

Bond 2014 until either (i) the meeting has been concluded or (ii) the voting certificate has been surrendered to the Paying
Agent. A vote cast in accordance with a block voting instruction may not be revoked or altered during the 48 hours
before the time fixed for the meeting.

Beneficial Owners should note that they must allow sufficient time for compliance with the standard operating pro-

cedures of Euroclear and Clearstream Luxembourg and, if applicable, such Accountholder in order to ensure delivery of
their voting instructions to the Paying Agent in accordance with the time-frame set out in this Notice. Beneficial Owners
are urged to contact any such person promptly to ensure timely delivery of such voting instructions.

Once instructions to participate in the meeting or to vote by proxy have been given, the Beneficial Owner's interest

in the Bonds 2014 will be blocked until the conclusion of the meeting. This means that it may not be possible to sell such
Bonds 2014 until the conclusion of the meeting.

For the purposes of the present Notice, "48 hours" and "24 hours" shall mean a period of 48 hours or 24 hours,

respectively, including all or part of a day upon which banks are open for business in both the place where the relevant
meeting is to be held and in each of the places where the Paying Agent have their specified offices (disregarding for this
purpose the day upon which such meeting is to be held) and such period shall be extended by one period or, to the
extent necessary, more periods of 24 hours or 48 hours until there is included as aforesaid all or part of a day upon which
banks are open for business as aforesaid.

The period to give instructions is scheduled from December 18, 2009 to January 8, 2010.
Last deadline to receive the Electronic Voting Instruction is January 8, 2010.
Last deadline for revocation, for cancellation or changes is January 8, 2010.

3. Contact
The Paying Agent
Bank of New York Mellon,
One Canada Square, London, E14 5AL
Tel: + 44 (0)20.7964.8889
Email: latoya.austin@bnymellon.com

The Company
ORCO PROPERTY GROUP, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Att. M. Ralf Limburg

Tel: +352 26 47 67 24
Fax: +352 26 47 67 67

118617

Email: rlimburg@orcogroup.com

ORCO PROPERTY GROUP, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Att. Ms. Françoise de Jongh

Tel: +352 26 47 67 31
Fax: +352 26 47 67 67
Email: fdejongh@orcogroup.com

Paris, December 17, 2009.

<i>For the board of directors of the Company
Mr. Jean-François Ott
<i>Director

Référence de publication: 2009155134/1273/144.

Kuhn Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 5, rue de la Boucherie.

R.C.S. Luxembourg B 99.772.

Il y lieu de rayer Monsieur Marc Conter, décédé, comme membre du conseil d'administration.

Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2009150436/11.
(090182106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Superga Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.322.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTÉE

qui aura lieu le <i>30 décembre 2009 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009151426/795/15.

I.P.I. International Participations Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 53.215.

<i>Extrait procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 23 novembre 2009

Il résulte dudit procès verbal que:
les mandats de CARDALE OVERSEAS INC., KELWOOD INVESTMENTS LTD et TASWELL INVESTMENTS LTD,

tous ayant son siège social à Road Town, BVI-Tortola, en tant qu'administrateurs ainsi que celui de BENOY KARTHEISER
MANAGEMENT S.A.R.L., ayant son siège social à 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, en tant que commissaire
aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2015.

Luxembourg, le 23 novembre 2009.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2009150438/15.
(090181824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

118618

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

A GENERAL MEETING

of the holders of the bonds registered under ISIN code: FR0010249599 (the "Bonds 2010") as described in the pros-

pectus issued by the Company in relation to the issue on November 18, 2005 of €50,272,605.30 bonds with redeemable
share subscription warrants attached due November 18, 2010 dated November 14, 2005 (the "Prospectus"), will be held
at the registered office of the Company, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg,
on <i>January 13, 2010 at 13.30 Central European time ("CET") (the "Meeting").

The Meeting is being held further to the adjournment by four weeks of the initial meeting held on December 16, 2009,

pursuant to a decision of the board of directors of the Company, taken at the request made by bondholders representing
at least one fifth of the Bonds 2010 on the basis of article 94-1 and article 67(5) of the Luxembourg law on commercial
companies, as amended.

The Meeting will be held in order to consider the following agenda:

<i>Agenda:

• Approval of the amendment of the section 4.1.8.1.3.2 of the Bonds 2010 terms and conditions as stated in the

Prospectus.

<i>Proposed amendment of the section 4.1.8.1.3.2 of the prospectus

As of the date of the Meeting, the current terms of the Bonds 2010 under section 4.1.8.1.3.2 of the terms and conditions

of the Bonds 2010 are the following:

"4.1.8.1.3.2. Early redemption at the option of the bearers exercising the Redeemable Share Subscription Warrants

and payment by offset of the amount of the share subscription by exercise of the Redeemable Share Subscription War-
rants.

For every 10 Redeemable Share Subscription Warrants exercised (see Section 4.2.1.7.1 "Exercise Price of the Redee-

mable Share Subscription Warrants and number of shares of Orco Property Group received through the exercise of the
Redeemable Share Subscription Warrants"), the bearers of the Redeemable Share Subscription Warrants may request
early redemption of one Bond at a price of 686,10 €, including accrued interest. However, this amount shall only be
payable by offset against the amount of the subscription corresponding to the exercise of the 10 Redeemable Share
Subscription Warrants."

Subject to a general meeting of the holders of the warrants registered under ISIN code: LU0234878881 (the "Warrants

2012") approving the second resolution of the agenda of the convening notice of the general meeting of the warrantholders
to be held on January 20, 2010, relative to the amendment of the payment conditions of the exercise price of the Warrants
2012 by the sale of Bonds 2010 as defined in Section 4.2.1.7.1 of the terms and conditions of the Bonds 2010, the Meeting
is invited to resolve to amend the current terms of the Bonds 2010 under Section 4.1.8.1.3.2 of the terms and conditions
of the Bonds 2010 so as to read as follows:

"4.1.8.1.3.2. Early redemption at the option of the bearers exercising the Redeemable Share Subscription Warrants

and payment by offset of the amount of the share subscription by exercise of the Redeemable Share Subscription War-
rants.

For every N (as defined below) Redeemable Share Subscription Warrants exercised, bearers may pay for their sub-

scription of A € (as defined below) by (i) the sale to the Company of 1 Bond with an initial nominal value of 686.10 €
(see Section 4.1.8.1.3.2 "Early redemption at the option of the bearers exercising the Redeemable Share Subscription
Warrants and payment by offset of the share subscription amount by exercise of the Redeemable Share Subscription
Warrants") made due and payable to this effect at a price equal to its outstanding principal amount as of the date of the
sale ("ONV") and (ii) the payment in cash of R € (as defined below),

Where
"N" means the number rounded up to the nearest whole number calculated by the following formula:

ONV / K ;

"A" means the amount calculated by the following formula:

N x K ;

"K" means the applicable Exercise Price as of the date of the exercise of such Redeemable Share Subscription Warrants ;
"R" means the amount calculated by the following formula:

A - ONV. "

Please refer to the Company's website at www.orcogroup.com for further details pertaining to the proposed amend-

ments to the terms and conditions of the Bonds 2010 being subject to the approval by the Meeting.

118619

The voting certificate, hereinafter mentioned, necessary to be represented and participate at the Meeting shall be at

the disposal of the holders of Bonds 2010 from December 18, 2009 (or as soon as possible thereafter) either with the
Company on www.orcogroup.com, or on request with the Bondholders Representative by email at lleroi@pt.lu.

Copies of the Prospectus and the articles of association of the Company are available on the Company's website at

http://www.orcogroup.com. and at the registered office of the Company upon request.

The Bondholder's representative would like to point out that for holders of Bonds 2010 of the Company, the conditions

for attendance or representation at the Meeting are as follows:

1. Authorization to participate
As mentioned in the Prospectus, holders of Bonds 2010 ("Bondholders"), and proxies showing a voting certificate and

register of voting certificates issued by the Paying Agent (CACEIS, 14 rue Rouget de Lisle 92189 ISSY LES MOULINEAUX)
can attend and vote at the Meeting. The Company and its legal advisors, as well as its financial advisors and such other
persons as may be accepted by the Meeting, may attend and speak at the Meeting.

2. Participation in and Voting at the Meeting
In accordance with Article 94-1, article 67(5), Article 94-2 and 94-3 of the law of 10th August, 1915 on commercial

companies as amended and in accordance with the terms and conditions of the Bonds 2010, the quorum at the Meeting
remains 50% of the outstanding Bonds 2010. The resolutions will be passed by 2/3 of the votes cast by the Bondholders
present or represented at the Meeting.

The attention of Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take valid resolutions that will

validly bind all the Bondholders (even those not represented at the Meeting).

In addition, Article 94-5 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended provides that when a

Bondholder representative has been appointed in accordance with the provisions of the law of 10th August, 1915 on
commercial companies as amended, Bondholders may no longer exercise their rights individually.

As is customary for securities such as the Bonds 2010, the Bonds 2010 are generally held through banks or other

financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems, Euroclear France
("Euroclear"), through which transactions in the Bonds 2010 are effected.

All of the Bonds 2010 are represented by a bearer global bond (the "Global Bond"). The Global Bond is presently held

by Euroclear France.

Each person (a "Beneficial Owner") who is the owner of a particular principal amount of the Bonds 2010, through

Euroclear France or its respective account holders (the "Accountholders"), should be entitled to attend and vote at the
Meeting in accordance with the procedures set out below.

Voting instructions may be delivered only through direct Accountholders with the type of vote: in favour of / against /

abstain from the proposed resolutions and by stating the Principal Amount of Bonds 2010. A splitting of the resolutions
is not accepted.

In order to obtain a voting certificate or instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting

in accordance with a Bondholder's instructions, an Accountholder must procure delivery of an electronic voting instruc-
tion, in accordance with the procedures of Euroclear France, to the relevant Paying Agent prior to the Expiration Time
on the Expiration Date all of them as defined below.

If a Bondholder is not wishing to attend and vote at the Meeting in person, he can instruct the Paying Agent to appoint

a proxy to attend and vote at the Meeting on his behalf with the type of vote: in favour of / against / abstain from the
proposed resolutions. A splitting of the resolutions is not accepted.

Bondholders may also allow their voting right in the Meeting to be exercised by an authorized representative, e.g.

allow another person of their choice to act as proxy. The authorizations must be issued in writing.

Beneficial Owners who are not Accountholders must arrange through their broker, dealer, commercial bank, custo-

dian, trust company or other nominee to contact the Accountholder through which they hold their Bond(s) 2010 in order
to procure delivery of their voting instructions via Euroclear France to the relevant Paying Agent prior to the Expiration
Time on the Expiration Date.

The expiration time shall be at 12.00 pm CET (the "Expiration Time") of January 8, 2010 (the "Expiration Date"). The

Company has the right to postpone the Expiration Date; in that case, notice of such postponement shall be given to the
Bondholders.

Once the Paying Agent has issued a voting certificate for a meeting in respect of a Bonds 2010, it shall not release the

Bond 2010 until either (i) the meeting has been concluded or (ii) the voting certificate has been surrendered to the Paying
Agent. A vote cast in accordance with a block voting instruction may not be revoked or altered during the 48 hours
before the time fixed for the meeting.

Beneficial Owners should note that they must allow sufficient time for compliance with the standard operating pro-

cedures of Euroclear France and, if applicable, such Accountholder in order to ensure delivery of their voting instructions
to the Paying Agent in accordance with the time-frame set out in the present Notice. Beneficial Owners are urged to
contact any such person promptly to ensure timely delivery of such voting instructions.

118620

Once instructions to participate in the Meeting or to vote by proxy have been given, the Beneficial Owner's interest

in the Bonds 2010 will be blocked until the conclusion of the Meeting. This means that it may not be possible to sell such
Bonds 2010 until the conclusion of the Meeting.

For the purposes of the present Notice, "48 hours" and "24 hours" shall mean a period of 48 hours or 24 hours,

respectively, including all or part of a day upon which banks are open for business in both the place where the relevant
meeting is to be held and in each of the places where the Paying Agent have their specified offices (disregarding for this
purpose the day upon which such meeting is to be held) and such period shall be extended by one period or, to the
extent necessary, more periods of 24 hours or 48 hours until there is included as aforesaid all or part of a day upon which
banks are open for business as aforesaid.

The period to give instructions is scheduled from December 18, 2010 to January 8, 2010 at 12.00 pm.
Last deadline to receive the Electronic Voting Instruction is January 8, 2010 at 12.00 pm.
Last deadline for revocation, for cancellation or changes is January 8, 2010 at 12.00 pm.

3. Contact
The Paying Agent
CACEIS Corporate Trust
Service assemblées
14 rue du Rouget de Lisle F-92889 Issy les Moulineaux
Fax: +33 1.49.08.05.82
Email: gisele.gresle@caceis.com

The Company
ORCO PROPERTY GROUP, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Att. M. Ralf Limburg

Tel: +352 26 47 67 24
Fax: +352 26 47 67 67
Email: rlimburg@orcogroup.com

ORCO PROPERTY GROUP, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Att. Ms. Françoise de Jongh

Tel: +352 26 47 67 31
Fax: +352 26 47 67 67
Email: fdejongh@orcogroup.com

Paris, December 17, 2009.

<i>For the board of directors of the Company
Mr. Jean-François Ott
<i>Director

Référence de publication: 2009155135/1273/148.

Sammichele S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4580 Differdange, 66, rue de Hussigny.

R.C.S. Luxembourg B 47.814.

<i>Cession de parts

En vertu d'une cession de parts sous seing privé signée à Luxembourg, le 25 novembre 2009 les parts sociales sont

désormais reparties comme suit:

Monsieur Dionisio SICOLI, demeurant à L-4240 Esch-sur-Alzette, 21, rue Emile Mayrisch . . . . . . . . . . . 100 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

<i>Décision de l'associé unique

En ce jour, 25 novembre 2009, l'associé unique décide de révoquer Monsieur Michele CAPURSO de ses fonctions de

gérant et d'accorder le pouvoir de signature individuelle à Monsieur Dionisio SICOLI, gérant unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009150521/16.
(090182706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

118621

Sicily Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 124.425.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale tenue en date du 23 novembre 2009

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Mr Giovanni Nannelli, de son poste de Gérant B de la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée nomme Mr Thomas Rivolta, résidant professionnellement au Royal Damcenter, Dam 7f, 1012 JS Ams-

terdam, The Netherlands, au poste de Gérant B de la société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009150204/17.
(090182155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Laumar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 41.988.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>28 décembre 2009 à 11.00 heures au siège social, 19-21 Boulevard du Prince

Henri, 1724 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels clos au 30 juin 2009 ainsi que du rapport de gestion du conseil d'administration

et du rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes ;

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats de l'exercice ;
3. Décharge aux organes de la société ;
4. Divers.
Les actionnaires désirant assister à l'assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l'assemblée

générale auprès de la Société Européenne de Banque, 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009152008/755/19.

Spring Multiple 2007 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 116.416.

Le Gérant Commandité a l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

tenant lieu d'Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu le <i>28 décembre 2009 à 11.00 heures au siège social, avec

l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 août 2008 et au 31 août 2009, et affectation des

résultats.

3. Décharge à donner au Gérant Commandité, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d'Entreprises pour l'exercice

de leur mandat au 31 août 2009.

4. Divers.

118622

SPRING MULTIPLE Sàrl
<i>Gérant Commandité

Référence de publication: 2009152012/1023/19.

MFountain Selected Fund Series, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 129.619.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 novembre 2009 que:
1. Monsieur Kazunobu UCHIYAMA a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 18 novembre 2009.
2. Monsieur Takeshi KOZU, Directeur de "Mizuho Trust &amp; Banking (Luxembourg) S.A.", demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg au 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach est nommé Administrateur avec effet au 18 novembre
2009.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés

au 31 décembre 2009.

Munsbach, le 18 novembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009154754/19.
(090192926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2009.

Japan Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 46.632.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 novembre 2009 que:
1. Monsieur Kazunobu Uchiyama a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 18 novembre 2009.
2. Monsieur Takeshi Kozu, Vice-Président Executif de "Mizuho Trust &amp; Banking (Luxembourg) S.A.", demeurant pro-

fessionnellement au 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach est nommé Administrateur avec effet au 18 novembre
2009.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés

au 31 décembre 2009.

Munsbach, le 14 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Kiyoshi KOGA / Junichi JSHII
<i>Director / <i>Director

Référence de publication: 2009154755/19.
(090192921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2009.

Mastiff S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.307.

DISSOLUTION

In the year two thousand six, on the thirtieth of November.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr. Jean-Martin STOFFEL, employee, with professional address in Luxembourg;
"the proxy"
acting as a special proxy of Asterix Worldwide Limited, having its registered office in the British Virgin Islands, Road

Town, Tortola;

"the mandator"

118623

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société anonyme "Mastiff S.A.", having its head office at L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 105.307,
has been incorporated by deed enacted on the 20 

th

 day of December 2004 published in the Mémorial C number 361 of

the April 21 

st

 , 2005.

II.- That the subscribed share capital of the société anonyme Mastiff S.A. amounts currently to two hundred thousand

euros, represented by two thousand shares having a par value of one hundred euros each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of Mastiff

S.A..

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares

explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts, with the exception of debts against the shareholder and the

former shareholders have been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments, known or unknown of
the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up

to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the

English text will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte

anglais fait foi.

L'an deux mille neuf, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Jean-Martin STOFFEL, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Asterix Worldwide Limited, ayant son siège social aux Iles Vierges

Britanniques, Road Town, Tortola;

"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme Mastiff S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 105.307, a été
constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 361 du 21 avril 2005.

II.- Que le capital social de la société anonyme Mastiff S.A., prédésignée, s'élève actuellement à deux cent mille euros,

représenté par deux mille actions de cent euros chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

Mastiff S.A..

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge la liquidation du passif et les engagements financiers,

connus ou inconnus, de la société, qui devra être terminée avant toute appropriation de quelque manière que ce soit des
actifs de la société en tant qu'actionnaire unique.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs

de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

118624

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.-M. STOFFEL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2009. Relation: LAC/2009/51679. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009154756/81.
(090192083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Faustini Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 105.672.

<i>Extrait de la résolution prise

<i>par le conseil d'administration en date du 17 juin 2009

Est nommée réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes consolidés au 31 décembre 2007:

- HRT Révision S.A., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009150454/14.
(090181939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Luxeme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 113.919.

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 5 novembre 2009 le point suivant:
Rachat par Shareholder and Directorship Services Ltd., une société de droit de la République des Seychelles, enregistrée

sous le numéro IBC 045085 et ayant son siège social Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Str., Victoria,
MAHE, Republic of Seychelles des 150 parts sociales détenues par la société Dillon Ltd dans la société LUXEME S.à.r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Référence de publication: 2009150437/13.
(090182097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Perisound S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 47.005.

Les comptes annuels au 15.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26.11.2009.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2009150703/12.
(090182076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

118625

Hickory Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 98.127.

Les comptes annuels au 31.03.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2009.

<i>Pour: HICKORY HOLDING S.A.
Société anonyme holding
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009150712/15.
(090182477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Calao Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 84.101.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 octobre 2009 que le siège

social de la société a été transféré au L-1461 Luxembourg, rue d'Eich, 27 avec effet au 8 octobre 2009.

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009150750/13.
(090181979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.574.

Le Conseil d'Administration a décidé avec effet au 15 Novembre 2009 de transférer le siège social de la société du

16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 Novembre 2009.

State Street Bank Luxembourg S.A.
Signature
<i>Un administrateur domiciliataire

Référence de publication: 2009150765/14.
(090182223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Lairnisia Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 59.348.

<i>Décision du gérant unique prise en date du 15/10/2008

Le Gérant décide de transférer le siège social de LAIRNISIA GESTION SARL au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg

Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2009150763/12.
(090182580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

118626

ST Maxime Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 186.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 106.080.

Madame Géraldine SCHMIT, Gérante de la Société ST MAXIME INVESTMENTS S.à r.l.,
atteste par la présente que le trustee de l'associé Ashley Grandchildren's 2003 Settlement est désormais James &amp;

Cowper Trustees Limited, ayant son adresse au 3 Wesley Gate, Queens Road, Reading, Berkshire, RG1 4AP, Royaume
Uni, enregistré au Registre des sociétés sous le numéro 4117467.

Pour extrait
Géraldine SCHMIT
<i>Gérante

Référence de publication: 2009150205/15.
(090182129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

CAFI, Compagnie Arabe de Financement International, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 13.541.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2008

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Ahmed Bahaa El Din Youssef Mohamed, Deputy General Manager of Treasury, demeurant professionnel-

lement au 1191 Cornish El-Nile, Caire, Egypte, en remplacement de Monsieur Tarek Fayed, administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Référence de publication: 2009150433/14.
(090182184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Berin Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 58.617.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 octobre 2009 que le siège

social de la société a été transféré au L-1461 Luxembourg, rue d'Eich 27 avec effet au 8 octobre 2009.

Luxembourg, le 8 octobre 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009150764/13.
(090181978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Auto-Sud, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3932 Mondercange, 11, rue de Limpach.

R.C.S. Luxembourg B 11.553.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009150815/12.
(090182787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

118627

Konsbruck's British House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 11, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 25.377.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009150808/12.
(090182799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Riverside Europe Engineering Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.772.

<i>Extrait de la résolution prise par le conseil de gérance en date du 30 octobre 2009

Avec effet au 2 novembre 2009, le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

Luxembourg, le 27 NOV. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Riverside Europe Engineering Luxembourg S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009150793/15.
(090182449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Arcavest Project s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 66.711.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21.12.1998.

EXTRAIT

L'adresse du siège social de la société est au 32, rue du Fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette.

Luxembourg, le 26 novembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009150780/13.
(090181971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Garage Da Cunha S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4664 Niedercorn, 44, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 129.924.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2009151001/14.
(090182774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

118628

Quintiles Luxembourg European Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 149.428.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of November,
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg,

There appeared:

Quintiles Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated

and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6C, Parc d'Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 242,135,778 and registered with the Lu-
xembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 115.379,

Here represented by M. Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:

Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by

Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").

Art. 2. Name. The Company's name is Quintiles Luxembourg European Holding.

Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-

soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents, trademarks and licenses or other property
as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole
or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity

that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance,
loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as
borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand

Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality of Schuttrange by means of a
resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance
with these Articles or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Title II - Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Great Britain Pounds)

divided into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of GBP 1 (one Great Britain Pound) each,
fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-

mensurate to such shareholder's ownership of shares.

118629

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only

one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the

Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning com-

mercial companies, as amended from time to time (the "Law").

Art. 10. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient

distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

Title III - Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where

more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or

in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the
share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint

signature of two managers.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among

its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another

manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means, initiated from the Grand Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear
each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3)
managers in which case the quorum shall be all the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers

of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken
together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies

or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly

made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of
the Company.

118630

Title IV - Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in

accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of

managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as

such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at
a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote
and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand

Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1 and ends on December 31, with the

exception of the first financial year that shall start today and end on December 31,2009.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as

the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder,
or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute
it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the

case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement
of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be

entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several
statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%)

of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of

118631

shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of
shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register

as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality

of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the

sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets
of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders
proportionally to the shares they hold.

<i>Subscription - Payment

All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the entire share capital of the Company, have been

entirely subscribed by Quintiles Luxembourg S.à r.l. named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of GBP
12,500 (twelve thousand five hundred Great Britain Pounds) is as now at the disposal of the Company, proof of which
has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred and fifty
Euros (1,350.- Euro).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) Justin A. Van Gennep, born on October 19, 1956, in Amsterdam, residing professionally at 10 Siriusdreef, Hoofddorp,

2132 WT, Netherlands; and

- Olivier Dorier, born on September 25, 1968, in Saint-Rémy, France, residing professionally at 6C, Parc d'Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;

are appointed as managers for an undetermined duration.
2) The registered office of the Company shall be established at 6C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le seize novembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Quintiles Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C,

Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 242.135.778 GBP et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.379,

Ici représentée par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée sous seing privé.

118632

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte aux fins d'enregistrement.

La dite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)

d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I 

er

 - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois

ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est Quintiles Luxembourg European Holding.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des
participations,  des  apports,  achats,  options  ou  de  toute  autre  manière,  tous  titres,  sûretés,  droits,  intérêts,  brevets,
marques et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir,
gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, d'accorder à

toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec
la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre
forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir
les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de
garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement

à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Schuttrange par décision du gérant unique ou en cas de pluralité
de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand Duché de
Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des
associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II - Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 12.500 GBP (douze mille cinq cents Livres Sterling), divisé en 12.500 (douze

mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling) chacune et sont chacune entièrement
libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote

proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire

par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque la Société a un

associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 10. Rachat des parts. La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves

distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

Titre III - Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où

plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en

cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

118633

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé

unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du
conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

de deux gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses

membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,

l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication approprié, s'ils sont initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant
à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation
est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de

gérants de la Société est présente ou représentée, à moins que le conseil de gérance ne soit composé de moins de trois
(3) gérants auquel cas le quorum sera de tous les gérants.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par

un vote de la majorité des gérants présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par l'ensemble des gérants ont le même effet que les résolutions prises

lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux
constituant un original et tous réunis constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.

Titre IV - Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés con-

formément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la

Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,

le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut,
elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

118634

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par
tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-
ment à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au

Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant
si ce jour est férié.

Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à

l'exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2009.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas

échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l'ensemble  de  ces  documents  constituant  les  comptes  annuels  sera  soumis  à  l'associé  unique  ou  en  cas  de  pluralité
d'associés à l'assemblé générale des associés.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à
entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,

peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un

commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)

du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée
générale des associés peut cependant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par

l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé

unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera leurs pouvoirs  et rémunérations.  Au  moment  de  la  clôture  de liquidation,  les  avoirs de  la  Société seront
attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils
détiennent.

118635

<i>Souscription - Paiement

L'intégralité des 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société

a été entièrement souscrite par Quintiles Luxembourg S.à r.l. prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire.
Le montant de 12.500 GBP (douze mille cinq cents Livres Sterling) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage de fonds.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à mille trois cent cinquante Euros
(1.350.- Euro).

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1) - Justin A. Van Gennep, né le 19 octobre 1956, à Amsterdam, résidant professionnellement à 10 Siriusdreef, Hoofd-

dorp, 2132 WT, Pays-Bas; et

- Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968, à Saint-Rémy, France résidant professionnellement au 6C, Parc d'Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg;

sont nommés gérants pour une période indéterminée.
2) Le siège social de la Société est établi au 6C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 18 novembre 2009, Relation: LAC/2009/48615. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009150887/411.
(090182851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Tishman Speyer Rentiers Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.675.225,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 115.236.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 novembre 2009 que le siège social de l'associé

unique de la Société nommé Tishman Speyer Rentiers Holdings II Sarl a été transféré du 1B Heienhaff L-1736 Sennin-
gerberg au 34-38 Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009150208/20.
(090182120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

118636

Jocemi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 59, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 103.481.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2M CONSULTANT SARL
Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch / Alzette
Signature

Référence de publication: 2009150936/14.
(090183047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Checkpoint Assurances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1723 Luxembourg, 13, rue Jean-Pierre-David Heldenstein.

R.C.S. Luxembourg B 140.291.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2M CONSULTANT SARL
Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch / Alzette
Signature

Référence de publication: 2009150939/14.
(090183044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Emotion Event Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 13, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 92.120.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/11/2009.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009150943/13.
(090183037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Julius Baer Multifund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 80.161.

AUFLÖSUNG

SWISS &amp; GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD. (vormals, bis 1. Oktober 2009, JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS

SERVICES LTD.),

mit Gesellschaftssitz an der Hohlstrasse 602, CH-8010 Zürich, Schweiz;
die mittels eines notariellen Akts vom 7. September 2009, beglaubigt durch Maître Henri Hellinckx, Notar in Luxem-

burg, als einzige Aktionärin der Gesellschaft JULIUS BAER MULTIFUND festgestellt wurde, einer société d'investissement
à capital variable, mit verbleibendem Gesellschaftskapital von EUR 100.- (nominell), gegründet am 12. Januar 2001 mittels
eines notariellen Akts von Maitre Edmond Schroeder, damals Notar in Mersch, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter Abschnitt B-80.161, mit Gesellschaftssitz an der route d'Esch, 69, L-1470 Luxemburg,

118637

Grossherzogtum Luxemburg (die "Gesellschaft") und deren Satzung im Mémorial C Nr. 178 vom 7. März 2001 veröf-
fentlicht worden war;

die bis zum Zeitpunkt der Liquidation der Gesellschaft deren gesamtes Gesellschaftskapital von EUR 100.- (nominell)

hielt;

die mittels des oben erwähnten notariellen Akts vom 7. September 2009 beschloss, die Gesellschaft aufzulösen;
die mittels des oben erwähnten notariellen Akts vom 7. September 2009 die SWISS &amp; GLOBAL ASSET MANAGE-

MENT (Luxembourg) S.A. (vormals, bis 1. Oktober 2009, JULIUS BAER (Luxembourg) S.A.) mit Gesellschaftssitz an der
Grand-rue 25, L-1661 Luxemburg, zum Liquidator der Gesellschaft bestellte;

hat mittels eines Beschlusses des einzigen Aktionärs vom 9. November 2009 beschlossen, die Auflösung der Gesell-

schaft abzuschliessen und hiermit folgendes mitzuteilen:

1. Alle Schulden der Gesellschaft sind beglichen, alle Aktiva sind an die SWISS &amp; GLOBAL ASSET MANAGEMENT

LTD. übertragen worden, so dass die Gesellschaft als liquidiert angesehen muss, ungeachtet der Tatsache, dass SWISS &amp;
GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD. persönlich für alle Verbindlichkeiten und andere Passiva haftet, welche derzeit
nicht bekannt sind.

2. SWISS &amp; GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD. hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft, deren

Wirtschaftsprüfer und deren Liquidator für die Ausübung ihrer jeweiligen Ämter Entlastung gewährt.

3. RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, wurden damit betraut,

die Buchhaltungsdokumente, Bücher, Register und anderen Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von 5
Jahren, endend am 9. November 2014, zu verwahren.

Der Liquidator SWISS &amp; GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009150945/37.
(090183268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Sonnie Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.988.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hille-Paul Schut
<i>Gérant

Référence de publication: 2009150946/12.
(090183226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Breteuil Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 100.652.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,

<i>le 11 mai 2009 à 16.30 heures

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuilllier en

tant  qu'Administrateurs  et  Fiduciaire  Simmer  &amp;  Lereboulet  S.A.  en  tant  que  Commissaire  aux  Comptes,  demeurant
professionnellement au 18B, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen et inscrit au RCS Luxembourg sous le numéro B73.846,
pour une durée de six ans. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2009151224/18.
(090182934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

118638

Scofield Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.000.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hille-Paul Schut
<i>Gérant

Référence de publication: 2009150947/12.
(090183228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Nabors Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.838.

Le bilan corrigé au 31 DECEMBRE 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
et remplace le bilan au 31 décembre 2004 précédemment déposé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés

sous la référence L090077121.04 en date du 28/05/2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009150948/13.
(090183230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Nabors Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.838.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009150951/11.
(090183234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

ACGH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 78.314.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2009

La démission de Monsieur Tom STENDAHL comme administrateur de la société est acceptée avec effet au 21 octobre

2009.

La démission de Monsieur Hugues Marc LAMOTTE comme administrateur de la société est acceptée avec effet au 4

novembre 2009.

Est nommé administrateur de la société avec effet au 4 novembre 2009 Monsieur Timothy FRASER-SMITH, né le 29

juin  1949  à  Tanga,  Tanzanie,  demeurant  professionnellement  à  Deltec  House,  Lyford  Cay,  PO  Box  N-3229  Nassau,
Bahamas, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2009151233/17.
(090182926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

118639

Diam International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.000.000,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 131.153.

L'adresse de l'associé Louis Dupere a changé et se trouve à présent au 15, Gate House Lane, 10513 Mamaroneck,

New York, Etats-Unis

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009151203/12.
(090183419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Algodeal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 149.447.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at 32A, rue Zenon Bernard, L-4031 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy

of Luxembourg, undersigned.

Appears:

A) Azur Investments Holding S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having

its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Company Register of Luxembourg
under number B 98.391.

B) Benjamin Filippi, residing at 38, rue Jeanne Jugan, 06130 Grasse, France.
C) Atom Lux Invest S.A. a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its

registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Company Register of Luxembourg under
number B 147.283.

D) Jean-Christophe Allemand, residing at 10, rue d'Alsace, 92300 Levallois-Perret, France.
E) Edoine Holding S.p.r.l., a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at 147, avenue

Brugmann, 1190 Bruxelles, Belgium, registered with the Company Register of Belgium under number 0893692276.

F) David Gageot, residing at 16, Cité de Trévise, 75009 Paris, France.
G) Thierry d'Espalungue, residing at 30, rue Sambre et Meuse, 75010 Paris, France.
H) Mounthagen S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered

office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Company Register of Luxembourg under number
B 145.520.

All duly represented by Mr Jean-Christophe Allemand, residing at 10, rue d'Alsace, 92300 Levallois-Perret, France, by

virtue of proxies given under private seal.

The before said proxies, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties in the capacity of which they act have requested the notary to draw up the following articles

of incorporation (the «Articles») of a «société à responsabilité limitée» which such parties declare to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company»), go-

verned by the present Articles and by current Luxembourg laws (the «Law»), in particular the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on «sociétés
à responsabilité limitée».

Art. 2. The Company's name is Algodeal Luxembourg S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities. In addition, the company
may undertake, in Luxembourg and abroad, financing operations by granting loans and contributing equity to corporations
belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans shall be refinanced inter alia but not
limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans.

118640

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the deve-
lopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support, loans,
advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its
purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board

of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Statutes.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at Eur 12 500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 100 000

(hundred thousand) shares with a nominal value of Eur 0,125.- (zero point one hundred and twenty-five Euros) each.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting

of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment
of the Statutes.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share

holding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter

of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of

the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Statutes.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price. Such
redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

118641

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or

the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of one or several category
A manager(s) and one or several category B manager(s).

The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager, category B manager, and his/their remune-

ration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or
of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken
at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,

remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).

In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and in case of plurality of managers, by (i) the

sole signature of any manager for any payment not exceeding EUR 5,000.- (five thousand Euros); (ii) the joint signature
of one category A manager and one category B manager for any payment equal or greater than EUR 5,000.- (five thousand
Euros).

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers

for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers or the sole manager (as the case may be) will determine powers, duties and remuneration (if

any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. In case a plurality of managers is required, the decisions of the managers are taken by meeting of the board

of managers.

The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting

vote. The Chairman shall be a category A manager. It may also appoint a secretary, who needs not be a manager, who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may
be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, electronic means or by any

other suitable communication means.

The notice may be waived by consent, in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication

means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager at his proxy.

A manager may represent more than one manager.
The  managers  may  participate  in  a  board  of  managers  meeting  by  phone,  videoconference,  or  any  other  suitable

telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,

including at least one category A manager and one category B manager.

Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly

represented thereto provided that at least one category A manager and one category B manager approved these reso-
lutions.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman,

one category A manager and one category B manager or the sole manager. Any transcript of or excerpt from these
minutes shall be signed by the chairman, one category A manager and one category B manager or the sole manager.

118642

Resolutions  in  writing  approved  and  signed  by  all  managers  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  passed  at  a

managers' meeting. In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate
documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

Art. 14. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in
compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the sha-

reholders. In such a case, one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, or the sole manager (as the case

may be), failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, electronic means or by any other

suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders are valid in so far as they are adopted by shareholders representing more

than the half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a

second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital

may be represented.

However, resolutions to amend the Statutes shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded in minutes or evidenced in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1st October and closes on 30 September.

Art. 18. Each year, as of 30 September, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up

the balance sheet which will contain a record of all assets and liabilities of the Company together with a profit and loss
account and notes to the account in accordance with legal requirements.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-

ceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the Company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one

or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Where the thresholds of article 35 of the Law on the commercial companies are met, the Company shall have its

annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of
shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entre-
prises».

118643

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital as

decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the legal reserve falls below such one
tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case

may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders of the Company,

or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Statutes.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as

the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 24. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which shall determine their powers and
remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the

shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Statutes.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on September 30, 2010.

<i>Subscription - Payment

All the 100 000 (hundred thousand) shares have been subscribed by the shareholders as follow, and fully paid up in

cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary:

- Azur Investments Holding S.A. subscribed for a number of 44 590 (forty-four thousand, five hundred ninety) shares

amounting to EUR 5 573,75 (five thousand, five hundred seventy-three point seventy-five Euros)

-  Benjamin  Filippi,  subscribed  for  a  number  of  24  970  (twenty-four  thousand,  nine  hundred  and  seventy)  shares

amounting to EUR 3 121,25 (three-thousand, one hundred twenty-one point twenty-five Euros)

- Atom Lux Invest S.A. subscribed for a number of 14 714 (fourteen thousand, seven hundred and fourteen) shares

amounting to EUR 1 839,25 (one thousand, eight hundred thirty-nine point twenty-five Euros)

- Jean-Christophe Allemand, subscribed for a number of 8 820 (eight thousand, eight hundred and twenty) shares

amounting to EUR 1 102,5 (one thousand, one hundred and two point five Euros)

- Edoine Holding Sprl subscribed for a number of 4 905 (four thousand, nine hundred and five) shares amounting to

EUR 613,125 (six hundred, thirteen point one hundred twenty-five Euros)

- David Gageot, subscribed for a number of 1 000 (one thousand) shares amounting to EUR 125 (one hundred, twenty-

five Euros)

- Thierry d'Espalungue, subscribed for a number of 1 000 (one thousand) shares amounting to EUR 125 (one hundred,

twenty-five Euros)

- Mounthagen S.A. subscribed for a number of 1 (one) share amounting to EUR 0,125 (zero point one hundred twenty-

five Euros)

118644

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about EUR 1 200.-.

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders have passed the following resolutions:
1. The number of managers is fixed at 2 (two).
2. The following person is appointed as category A manager of the Company for an indefinite period:
- Jean-Christophe Allemand, born on October 26, 1969 in Sedan, France and residing at 10, rue d'Alsace, 92300

Levallois-Perret, France.

The following company is appointed as category B manager of the Company for an indefinite period:
- Dominique Jones, born on April 24, 1957 in Shrewsbury, United-Kingdom, and residing at 9 rue Nina et Julien Lefèvre,

L-1952 Luxembourg

3. The registered office of the Company is set at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned

appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg City, on the date at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence demeurant 32A, rue Zenon Bernard, L-4031 Esch-sur-

Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

A) Azur Investments Holding S.A., une société constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social sis 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 98.391.

B) Benjamin Filippi, domicilié au 38, rue Jeanne Jugan, 06130 Grasse, France.
C) Atom Lux Invest S.A., une société constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social

sis 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 147.283.

D) Jean-Christophe Allemand, domicilié au 10, rue d'Alsace, 92300 Levallois-Perret, France.
E) Edoine Holding S.p.r.l., une société constituée selon le droit de Belgique, ayant son siège social sis 147, avenue

Brugmann,  1190  Bruxelles,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Belgique,  sous  le  numéro
0893692276.

F) David Gageot, domicilié au 16, Cité de Trévise, 75009 Paris, France.
G) Thierry d'Espalungue, domicilié au 30, rue Sambre et Meuse, 75010 Paris, France.
H) Mounthagen S.A., une société constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis

at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 145.520.

Les fondateurs sont ici représentés par Mr Jean-Christophe Allemand, domicilié au 10, rue d'Alsace, 92300 Levallois-

Perret, France, en vertu de procurations sous seing privé à lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparante, agissant en cette qualité, ont requit du notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés
à responsabilité limitée.

Art. 2. La dénomination de la société sera Algodeal Luxembourg S.à r.l.

118645

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de
toute autre manière tous titres. De plus, la Société peut entreprendre, au Luxembourg et à l'étranger, des opérations
financières consistant en l'octroi de prêts et l'apport de capitaux à des sociétés appartenant au même groupe international
que la Société. Lesdits prêts feront l'objet d'un refinancement notamment par l'intermédiaire de moyens et d'instruments
financiers tels que des prêts d'actionnaires ou de sociétés du groupe ou encore des prêts bancaires.

De plus, la société pourra effectuer toutes transactions en rapport direct ou indirect avec l'acquisition de participations

dans toute société sous n'importe quelle forme, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations.

La Société peut, notamment, affecter ses liquidités à la mise en place, la gestion, le développement ou la cession d'un

portefeuille, se composant de tous titres et brevets de toute origine. La Société peut participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise généralement quelconque. La Société peut acquérir, par voie d'apport, de
souscription, de garantie ou d'option d'achat et de tout autre moyen, tout type de titres et de brevets. La Société peut
procéder à la réalisation de ces derniers par vente, transfert, échange ou par tout autre moyen. La Société peut faire
développer ces titres et brevets et accorder aux sociétés dans laquelle elle a une participation toute forme de soutien
ainsi que des prêts, des avances et des garanties.

De manière générale, la Société peut aussi réaliser toutes opérations financière, commerciale, industrielle, personnelle,

ou immobilière, prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de ses droits, et effectuer des opérations en
relation directe ou indirecte avec l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance

ou du gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement  le  siège  social  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas).

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 12 500,- EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 000 (cent mille) parts

sociales d'une valeur nominale de 0,125- EUR (zéro virgule cent vingt-cinq euros) chacune.

Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des associés

ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un

nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.

118646

Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l'associé unique

(selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eut égard au surplus du prix de rachat. Les
parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par une résolution de l'associé unique

ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) peut/peuvent ne
pas être associé(s) de la Société. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance composé d'un
ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) en qualité de gérant de catégorie A ou en qualité de gérant de catégorie

B et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix
exprimées ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par
résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqués à tout moment, par une résolution de l'assemblée générale des associés

ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas)

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour

agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par (i) la seule

signature de tout gérant pour tout paiement n'excédant pas EUR 5.000,- (cinq mille Euros); (ii) la signature conjointe d'un
gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B pour tout paiement égal ou supérieur à EUR 5.000,- (cinq mille Euros).

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés ou gérants de la
Société.

Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de

ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, aura une voix prépon-

dérante. Le président sera un gérant de catégorie A. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessaire-
ment gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de
l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 jours

avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la
réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, moyens électroniques ou par

tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, moyens électroniques ou par tout autre

moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou

représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé

précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Les gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette
réunion de communiquer à une même moment. Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée
équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité des gérants est présente ou re-

présentée, ce qui comprend au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

118647

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, pourvu

qu'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B approuvent ces résolutions.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président, par un

gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B ou par le gérant unique. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal
devra être signé par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B ou par le gérant unique.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents

ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques

ou tout autre moyen de communication approprié.

Art. 14. Un ou plusieurs gérant(s) (selon le cas) ne contracte(nt) en raison de ses (leurs) fonctions, aucune obligation

personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société; simple mandataire, il n'est (ne
sont) responsable(s) que de l'exécution de son (leurs) mandat(s).

Assemblée Générale des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par
écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas, une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé
dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou par le gérant unique

(selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, moyens

électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée générale sera immé-

diatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée générale, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle

que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale

extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé

unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 octobre et se termine le 30 septembre.

Art. 18. Chaque année, à partir du 30 septembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le

bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de
tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la société.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours

précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la Société

Art. 20.  Si  le  nombre  des  associés  excède  vingt-cinq,  la  surveillance  de  la  Société  sera  confiée  à  un  ou  plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

118648

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa

nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Lorsque les seuils de l'article 35 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou

plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique
(selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être

nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

que augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10%.

Les associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après

déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article vingt et un, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé

unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi ou le cas échéant

l'associé unique doivent donner leur accord à la dissolution et la liquidation de la Société ainsi qu'aux conditions de celle-
ci.

Art. 24. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique (selon le cas) qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le

capital de la Société.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera à la date d'incorporation pour finir le 30 septembre 2010.

<i>Libération - Apports

Toutes les 100 000 (cent mille) parts ont été souscrites et entièrement libérées par apport en numéraire, preuve en

ayant été donnée au notaire, par:

- Azur Investments Holding S.A. pour 44 590 (quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix) parts pour un montant

de EUR 5 573,75 (cinq mille cinq cent soixante-treize virgule soixante-quinze Euros)

- Benjamin Filippi, pour 24 970 (vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix) parts pour un montant de EUR 3 121,25

(trois mille cent vingt et un virgule vingt-cinq Euros)

- Atom Lux Invest S.A. pour 14 714 (quatorze mille sept cent quatorze) parts pour un montant de EUR 1 839,25 (mille

huit cent trente-neuf virgule vingt-cinq Euros)

- Jean-Christophe Allemand pour 8 820 (huit mille huit cent vingt) parts pour un montant de EUR 1 102,5 (mille cent

deux virgule cinq Euros)

- Edoine Holding SPRL pour 4 905 (quatre mille neuf cent cinq) parts pour un montant de EUR 613,125 (six cent treize

virgule cent vingt-cinq Euros)

- David Gageot pour 1 000 (mille) parts pour un montant de EUR 125 (cent vingt-cinq Euros)

118649

- Thierry d'Espalungue pour 1 000 (mille) parts pour un montant de EUR 125 (cent vingt-cinq Euros)
- Mounthagen S.A. pour 1 (une) part pour un montant de EUR 0,125 (zéro virgule cent vingt-cinq Euros)

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à EUR 1.200.-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1 100,- (mille cent Euros).

<i>Résolutions des associés

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social ont adopté les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à 2 (deux).
2. La personne suivante est nommée gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:
- Jean-Christophe Allemand, né le 26 octobre 1969 à Sedan, France et domicilié au 10, rue d'Alsace, 92300 Levallois-

Perret, France.

La société suivante est nommée gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:
- Dominique Jones, né le 24 avril 1957, à Shrewsbury, Royaume-Uni, et domicilié à 9, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952

Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi à 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le  notaire  soussigné  qui  comprend  et  parle  l'anglais  constate  par  le  présent  acte  qu'à  la  requête  de  la  personne

comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: J.-C.Allemand, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 novembre 2009, Relation: EAC/2009/14288. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009150870/558.
(090183096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Mitte Holdings Management S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.612.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 18 novembre 2009, enregistré à Luxembourg AC, le 23 novembre 2009., LAC/2009/49613, aux droits de soixante-
quinze euros (75.- €), que la société Mitte Holdings Management S.C.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9A,
boulevard du Prince Henri, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 78.612, constituée suivant un acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire alors de résidence à Remich, en date du 9
novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 334, le 8 mai 2001, dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentaire, en date du 31 juillet 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2,633 en date du 17 novembre 2007,

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la liquidation de la Société, au

9A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembreévrier 2009.

Référence de publication: 2009150757/22.
(090182007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

118650

CDC - Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 16.861.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 30 octobre 2009 que la personne suivante a été nommée

administrateur-délégué avec effet immédiat pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société:

- Jean-Marc Kieffer, né le 27 août 1972 à Luxembourg, demeurant à 1 Rue Mathias Goergen L-8028 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009150210/19.
(090182115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

ITX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 54.057.

<i>Extrait du Procès-verbal de la décision

<i>de l'Actionnaire Unique prise au siège social le 22 octobre 2009

<i>5 

<i>ème

<i> Résolution:

L'Actionnaire Unique décide de révoquer de sa fonction d'Administrateur, la société Lerou Robrecht &amp; Partner, avec

effet au 24 avril 2008 et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'Actionnaire Unique décide de nommer à la fonction d'Administrateur Unique, Monsieur François LEROU, Admi-

nistrateur  de  sociétés,  demeurant  professionnellement  au  Quedlinburger  Str.,  11,  D-10589  Berlin,  Allemagne,  en
remplacement de Lerou Robrecht &amp; Partner, avec effet au 24 avril 2008. Monsieur François LEROU terminera le mandat
de son prédécesseur. Le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2013.

Signature.

Référence de publication: 2009150468/17.
(090181862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Officio International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.763.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la Société en date du 16 novembre 2009 que les

actionnaires ont pris les décisions suivantes:

Prolongation des mandats des administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015:
- Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem, Belgique et demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Marcus Jacobus Dijkerman né le 5 novembre 1962 à Schiedam, Pays-Bas et demeurant professionnellement au 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Officio International S.A.
Marcus Jacobus Dijkerman
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009150459/18.
(090181918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

118651

Lime Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 101.147.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 octobre 2009, les actionnaires ont pris la décision de

nommer Hugues Judong, avec adresse au 69, Rue Adolphe Dumont, 4051 Chaudfontaine, Belgique, au mandat d'admi-
nistrateur, avec effet immédiat et pour une pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009150218/13.
(090181853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Optique Himmes Pétange S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 2, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.216.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mil neuf, le 27 novembre 2009 novembre
Au siège social de la société,

Ont comparu:

1° la société VISUEL Sàrl, établie et ayant son siège social à L-5887 HESPERANGE, 393, route de Thionville, inscrite

au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 100.106, ici représentée par son gérant unique, Monsieur Andréas
HIMMES, Opticien, né à MERZIG (Allemagne), le 22 août 1971, demeurant à L-5447 SCHWEBSANGE, 4, Cité Robi
Goldschmit,

2° Monsieur Daniel HOFFMANN, opticien, né à Luxembourg, le 6 avril 1972, demeurant à L-4955 BASCHARAGE,

11, rue des Roses,

Seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination "OPTIQUE HIMMES

PETANGE Sàrl.", avec siège social à L-4760 PETANGE, 2, route de Luxembourg,

constituée suivant acte, reçu par le notaire Aloyse BIEL, de résidence à ESCH-SUR-ALZETTE, en date du 29 mai 2008,
3° la société CROWNLUX S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Lake Building, Second

Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 31.16, Road Town, Tortola, constituée et inscrite au registre des sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 265316, ici représenté par Monsieur Richard STURM, juriste, demeurant profes-
sionnellement à L-2610 Luxembourg, 160, roule de Thionville,

Agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 14 septembre 1998,

laquelle procurations est restée annexée à un acte de dépôt de procuration reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence
à Niederanven, en date du 20 janvier 1999, portant le numéro 3.960 de son répertoire, enregistré à Luxembourg le 3
février 1999, volume 906B, folio 75, case 11.

Lesquels comparants actent ce qui suit:
- la société VISUEL Sàrl, prédite, déclare céder et transporter sous les garanties ordinaires de droit, à la société

CROWNLUX S.A., prédite, ici présent et ce acceptant: deux cent cinquante (250) PARTS SOCIALES, à prendre sur les
quatre cent cinquante (450) PARTS SOCIALES, appartenant à la société VISUEL Sàrl, prédite, dans la prédite société.

- La société VISUEL Sàrl, prédite, déclare céder et transporter sous les garanties ordinaires de droit, à Monsieur Daniel

HOFFMANN prédite, ici présent et ce acceptant: deux cents (200) PARTS SOCIALES, à prendre sur les quatre cent
cinquante (450) PARTS SOCIALES, appartenant la société VISUEL Sàrl, prédite, dans la prédite société.

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
Les cessionnaires sont propriétaires à compter de ce jour des parts cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices

dont elles seront productives à partir de cette date.

Ils seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n'a été délivré aux cessionnaires, prédits, aucun titre ni certificat des parts cédées.
Ensuite, l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Observations:

Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement exprès de tous les associés.

118652

Pour les besoins de l'enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de TRENTE MILLE

EUROS (30.000,00 EUR), en vertu de l'acte de constitution, ci-avant cité, reçu par le notaire Aloyse BIEL, en date du 9
mai 2008.

Par la suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s'établit comme suit:

1° CROWNLUX S.A.. prédite, 250 PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
2° Daniel HOFFMANN. Prédit, 250 PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
TOTAL: CINQ CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

Ensuite, les comparants, es qualités qu'ils agissent, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, laquelle réu-

nissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement telle qu'elle est constituée,
sur les objets portés à l'ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Andreas HIMMES en sa qualité de gérant technique.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

comme suit:

<i>Première résolution:

La démission de Monsieur Andreas HIMMES est acceptée avec effet au 27 novembre 2009.

Fait et passé à PETANGE, date qu'en tête.

- / CROWNLUX SA / VISUEL Sàrl
Daniel HOFFMANN / Richard STURM / Andreas HIMMES

Référence de publication: 2009150370/62.
(090182055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

CADELEST, Compagnie Agricole de l'Est S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 83.406.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009150760/10.
(090182438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Foothills and Towers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 55.626.

<i>Extraits du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 9 octobre 2009

<i>et du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire au siège social le 9 novembre 2009

<i>3 

<i>ème

<i> Résolution du Conseil d'Administration:

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Christophe BLONDEAU, demeurant professionnellement

au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration. Il occupera cette fonction
pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur de la société, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire
qui se tiendra en 2010.

<i>5 

<i>ème

<i> Résolution de l'Assemblée Générale:

L'Assemblée Générale décide de révoquer de sa fonction d'Administrateur, Monsieur Pierre Hoffmann, avec effet

immédiat.

L'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à son remplacement et décide de diminuer le nombre de postes

d'administrateurs de quatre à trois.

<i>Pour Foothills and Towers S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2009150465/22.
(090181878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

118653

FANFARE BOURGLINSTER, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6161 Bourglinster, 4, rue de Gonderange.

R.C.S. Luxembourg F 8.160.

STATUTS

Art. 1 

er

 .

1.1 Il est constitué entre les personnes soussignées une Association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928

sur les associations sans but lucratif. Cette association prend la dénomination de «FANFARE BOURGLINSTER, Asso-
ciation sans but lucratif». Dans la communication externe et interne, l'association sera en droit d'utiliser et d'afficher le
nom «Bierger Musëk».

1.2 Le siège de l'association est à Bourglinster.
1.3 L'association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. L'association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique musicale et la formation musicale, ainsi

que par extension toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socioculturelle. L'association est politiquement
et confessionnellement neutre.

Art. 3.
3.1.1 Sont membres actifs de l'association tous les musiciens, directeur de musique, membres du conseil d'adminis-

tration, portes drapeaux, vérificateurs de comptes ainsi que les membres du comité d'honneur.

3.1.2 Seuls peuvent devenir membres actifs de l'association sans but lucratif les personnes ayant atteint l'âge de 14 ans.

En ce qui concerne les enfants de moins de 14 ans, ils ont un statut d'étudiant de la société de musique.

3.2 Le nombre des membres de l'association est illimité. Il ne pourra cependant être inférieur à 10 membres actifs.
3.3  Les  personnes  qui  désirent  devenir  membres  actifs  de  l'association  sans  but  lucratif  présentent  une  demande

d'admission au conseil d'administration qui statue sur le bien-fondé de cette demande.

Art. 4.
4.1 La cotisation annuelle à verser par les membres actifs ne pourra pas excéder 20 Euros.
4.2 L'assemblée générale fixe annuellement le montant de la cotisation à payer par les membres actifs de l'association.

Art. 5. La qualité de membre actif se perd:
a) par la démission volontaire du membre actif;
b) en cas de non-paiement de la cotisation annuelle, trois mois après une sommation de payer dûment notifiée par

lettre recommandée;

c) par exclusion. Cette exclusion ne pourra avoir lieu que si les agissements du membre portent préjudice aux intérêts

et à l'honneur de l'association et/ou si le membre ne se conforme pas aux statuts ainsi qu'aux résolutions adoptées par
l'assemblée générale des membres actifs.

Les membres ainsi que tout membre démissionnaire ou exclu n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent pas

réclamer le remboursement des cotisations qu'ils ont versées.

Art. 6.
6.1 L'ensemble des membres actifs forme l'assemblée générale de l'association.
6.2 L'assemblée générale a notamment pour mission d'arrêter les règlements pris en exécution des statuts, de nommer

et de révoquer les membres du conseil d'administration et les vérificateurs de comptes, d'approuver les comptes annuels
de l'association, de fixer le montant de la cotisation annuelle à payer par les membres actifs, d'arrêter le budget des
recettes et dépenses, d'arrêter le programme des activités de l'association et de nommer les membres du comité d'hon-
neur. L'assemblée générale décide également de la liquidation de l'association ainsi que de l'exclusion des membres.
L'assemblée générale peut adopter un règlement interne conformément à l'article 8 ci-après.

6.3 L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
6.4 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut convoquer

une assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Une assemblée générale
extraordinaire doit être convoquée si un cinquième des membres actifs en fait la demande, tout en indiquant l'ordre du
jour.

6.5 La convocation à l'assemblée générale se fera par lettre simple au moins quatorze jours à l'avance. La convocation

indiquera le lieu et la date de l'assemblée générale. La convocation contiendra l'ordre du jour tel qu'il sera fixé par le
conseil d'administration. Toute proposition signée d'un nombre de membres actifs égal au vingtième de la dernière liste
annuelle, réceptionnée par le président du conseil d'administration au moins huit jours francs avant la date de la tenue
de l'assemblée, doit être portée à l'ordre du jour.

6.6 Le président, assisté des autres membres du conseil d'administration préside l'assemblée générale.

118654

6.7 Tous les membres actifs de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont

prises à la majorité des voix présentes ou représentées sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les présents
statuts ou la loi sur les associations sans but lucratif.

6.8 Il est permis à chaque membre de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre moyennant

une procuration écrite, sans qu'il soit cependant permis de représenter plus d'un membre.

6.9 L'exclusion d'un membre de l'association, y compris pour motif de non paiement de la cotisation annuelle, ne peut

se faire qu'à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

6.10 Toutes les décisions de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire

du conseil d'administration. Les procès-verbaux de l'association seront conservés par le secrétaire au siège social où tous
les membres ainsi que les tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 7.
7.1 L'association est gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres actifs au moins et de quinze

membres au plus. Les membres du conseil d'administration doivent être majeurs.

7.2 Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale. La durée de leur mandat est de un an

renouvelable sans limitation dans le temps. Ils peuvent toujours être révoqués par décision de l'assemblée générale.

7.3 Le conseil d'administration choisit en son sein après sa nomination par l'assemblée, un président, un vice-président,

un secrétaire ainsi qu'un trésorier.

7.4 Le conseil d'administration gère les affaires de l'association. Il dispose dans le cadre de cette gestion des pouvoirs

les plus étendus.

7.5 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au moins une fois

par trimestre. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Le conseil d'admi-
nistration ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente. Il est permis à chaque membre de se faire
représenter lors des réunions du conseil d'administration par un autre membre moyennant une procuration écrite, sans
qu'il soit cependant permis de représenter plus d'un membre.

7.6 Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas d'égalité

des voix, celle du président de la séance du conseil est prépondérante.

7.7  Le  conseil  peut  déléguer  sous  sa  responsabilité  ses  pouvoirs  pour  des  affaires  déterminées  à  un  ou  plusieurs

mandataires de son choix.

7.8 A l'égard des tiers, l'association est engagée en toute circonstance par les signatures conjointes de trois adminis-

trateurs. Pour les quittances, la signature d'un seul administrateur est suffisante.

Art. 8. Le conseil d'administration peut élaborer un règlement interne régissant notamment le fonctionnent de la

société de musique, la participation aux répétitions et manifestations de l'association, l'attribution et le retrait d'un ins-
trument ou de tout bien appartenant à l'association. Ce règlement devra être approuvé par l'assemblée générale des
membres actifs.

Art. 9.
9.1 Les comptes de l'association sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l'association, de

la comptabilisation des recettes et des dépenses et de l'établissement du décompte annuel à la clôture de l'exercice qui
est fixée au 31 décembre.

9.2 La gestion du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs de comptes majeurs. Les vérificateurs de comptes ne

peuvent pas faire partie du conseil d'administration.

Art. 10. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de l'année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 11. En cas de dissolution de l'association sans but lucratif, l'assemblée générale détermine la destination des biens

sociaux en leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vertu duquel l'association avait
été créée.

Art. 12. Tous les points non visés par les présents statuts sont régis par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif.

Bourglinster, le 29 mai 2008.

Georges Gudenburg / Raymond Nilles / Schmitz Eliane
<i>Administrateur-Président / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009150867/106.
(090183473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

118655

Parish Capital Luxembourg Holdings II-B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 145.398.

<i>Extrait des Résolutions

<i>de l'Associé Unique du 16 novembre 2009

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Willem-Arnoud van Rooyen, en tant que Gérant de catégorie B, et ce avec effet le 11

novembre 2009;

- de nommer Frederik Kuiper, né le 9 novembre 1974 à Utrecht, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg, Gérant de catégorie B, et ce avec effet le 11 novembre 2009.

Luxembourg, le 24 novembre 2009.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009150489/18.
(090181847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

BDPE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 98.017.

<i>Extrait des résolutions prises par le Gérant Unique en date du 14 août 2009:

Le Gérant Unique décide de transférer le siège social de la société au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg avec effet

immédiat.

D'autre part nous vous prions de bien vouloir prendre note des changements d'adresses du gérant unique et des

associés.

- Monsieur Jean Roger LEMAIRE, résidant professionnellement au 12A, rue Randlingen, L-8366 Hagen.
- SUMMIT RE TWO GMBH, ayant son siège social au 25/27, Groninger Str., D-13347 Berlin, Allemagne.
- SUMMIT REAL ESTATE GOLD GMBH, ayant son siège social au 6, Bürknerstr., D-12047 Berlin, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BDPE S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009150212/19.
(090182093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Corporate Express Silver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 75.881.

Par résolutions circulaires signées en date du 1 

er

 octobre 2009, les administrateurs ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Rudi Merckx, avec adresse au 24, Velpestraat (OVP), 3360 Bierbeek, Belgique, de

son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

2. Cooptation de Gino Hoornaert, avec adresse au 21, Regenbooglaan, 9800 Deinze, Belgique, au mandat d'adminis-

trateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 25 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009150216/15.
(090181856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

118656


Document Outline

ACGH S.A.

Algodeal Luxembourg S.à r.l.

Arcavest Project s.à r.l.

Auto-Sud

Axel S.A.

BDPE S.à r.l.

Berin Holding S.A.

Breteuil Strategies S.A.

Calao Holding S.A.

CDC - Construction S.A.

Checkpoint Assurances S.à r.l.

Compagnie Agricole de l'Est S.A.

Compagnie Arabe de Financement International

Corporate Express Silver S.A.

Diam International S.à r.l.

Emotion Event Management S.A.

FANFARE BOURGLINSTER, Association sans but lucratif

Faustini Europe S.A.

Foothills and Towers S.A.

Frazil S.A.

Garage Da Cunha S. à r.l.

Geram International Holding S.A.

Hickory Holding S.A.

Hill 27 S.A.

I.P.I. International Participations Investors S.A.

ITX S.A.

Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.

Jocemi S.à r.l.

Julius Baer Multifund

Konsbruck's British House S.A.

Kuhn Immobilier S.A.

Lairnisia Gestion S.à r.l.

Laumar S.A.

Lime Invest

Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV

Luxeme S.à r.l.

Mastiff S.A.

MFountain Selected Fund Series

Mitte Holdings Management S.C.A.

Nabors Luxembourg S.à r.l.

Nabors Luxembourg S.à r.l.

Officio International S.A.

Optique Himmes Pétange S.à.r.l.

Orco Property Group

Orco Property Group

Orco Property Group

Parish Capital Luxembourg Holdings II-B, S.à r.l.

Perisound S.à r.l.

Quintiles Luxembourg European Holding

Riverside Europe Engineering Luxembourg S.à r.l.

Sammichele S.à r.l.

Scofield Corporation S.à r.l.

Sicily Investments S.à.r.l.

Sonnie Holding S.à r.l.

Spring Multiple 2007 S.C.A.

ST Maxime Investments S.à r.l.

Superga Lux S.A.

Tishman Speyer Rentiers Holdings I S.à r.l.