This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2426
14 décembre 2009
SOMMAIRE
3P (L) Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116445
Adnan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116418
Aisch Zenter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116432
Balanced Portfolio A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116448
Balanced Portfolio D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116448
Banister Investissements SA . . . . . . . . . . . .
116431
BCG Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . .
116446
Bois Parren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116447
Bouche Minerals Equipments S.à r.l. . . . . .
116431
Cable & Wireless Global Card Services
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116419
CBK Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116427
Choron Finance (Luxembourg) S.A. . . . . .
116446
Commerzbank GS Fund Sicav . . . . . . . . . . .
116427
Constantine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116447
Doca Deal S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116442
Domus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116419
Falken Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116448
Fiduciaire Expert Comptable Whitecourt-
Kornerup Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116419
Fiduciaire Whitecourt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116419
First Global Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
116432
Front Tiza S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116436
Galactique S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116448
GPT Europe Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
116424
Grands Magasins Monopol . . . . . . . . . . . . . .
116445
Graros S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116445
Hansa Transport International S.à.r.l. . . . .
116444
Holzgestaltung Irsch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
116446
HSBC Trinkaus Lingohr . . . . . . . . . . . . . . . .
116435
ICAP US Holdings No. 2 Ltd - Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116435
Invista European Real Estate Trust SICAF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116402
Invista European Real Estate Trust SICAF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116411
Jolyco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116410
J.P.C. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116446
Kisling Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116409
La Languette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116431
Logica Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
116424
Luxdeftec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116430
LuxEnvironnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116445
Microshop S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116435
MSF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116427
Niederfeelen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116434
Nord-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116447
Ostara Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116444
Patrimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116410
PEH Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116443
Petrofond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116447
PHI Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116436
Satisfactory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116410
Sirius Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116420
Skyfield Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
116421
SPC Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116418
Speedquest Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116447
Standard Chartered Financial Services
(Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116443
Tradimex Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116435
Valode & Pistre Management S.A. . . . . . . .
116443
Van Gansewinkel Luxembourg S.A. . . . . . .
116430
VCapital S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . .
116446
Victoria Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116431
Victoria Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116431
XL-arch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116430
Yield Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116421
116401
Invista European Real Estate Trust SICAF, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investisse-
ment à Capital Fixe.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.461.
At the occasion of a first extraordinary general meeting (the "First Extraordinary General Meeting") of the shareholders
of Invista European Real Estate Trust SICAF, a société d'investissement à capital fixe organised under the form of a société
anonyme (public limited liability company) with registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and re-
gistered with the Luxembourg trade and companies register under number B 108.461 (the "Company"), which was held
before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 24 November 2009,
[o] % of the share capital of the Company was present or represented. The quorum required by article 67-1 (2) of the
Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Law") was therefore not reached
at such meeting.
NOTICE IS HEREBY GIVEN to the shareholders of the Company of a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(the "Second Extraordinary General Meeting"), in accordance with article 67-1 (2) of the Law, to be held on <i>29i>
<i>December 2009i>
at 10.00 a.m. CET at the office of Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.: 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to consider and pass resolutions on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Item 1.
To acknowledge and approve that all the resolutions under items 2 to 19 below will, given their reciprocal interde-
pendence, be conditional upon each of such resolutions being approved by a two thirds majority of the votes cast at the
Extraordinary General Meeting and that, if, for any reason, any of the resolutions under items 2 to 19 below is not
approved at the two thirds majority requirement, all resolutions (even those that would have previously been approved
at the required majority) will not become effective and the Extraordinary General Meeting will not proceed to the vote
on any further point on the agenda.
Item 2.
To determine to no longer attribute an express par value to the shares of the Company (the "Shares", each a "Share")
in the articles of association of the Company (the "Articles"). Pursuant to Luxembourg law, this will result in the accounting
par value of the Shares being automatically equal to the amount of the share capital divided by the number of Shares in
issue at that time.
Item 3.
To reduce the Company's share capital from its current amount of € 142,829,093.75 to € 11,426,327.5 (the "Share
Capital Reduction") without the cancellation of Shares (so that the number of Shares will remain unchanged) and without
any reimbursement or repayment to the Shareholders as follows:
(i) firstly, by absorbing the (non consolidated) losses of the Company as at 30 September 2008 in an amount of €
13,089,270 (the "Losses") as evidenced by the audited annual accounts of the Company as of 30 September 2008 drawn
up by the board of directors of the Company (the "Board"), which will result in the share capital of the Company being
reduced to € 129,739,823.75; and
(ii) secondly, by creating a non-distributable reserve of an amount of € 118,313,496.25 (the "Non-Distributable Re-
serve"), which can exclusively be used to absorb losses incurred or to increase the share capital of the Company through
the capitalisation of the Non-Distributable Reserve;
so that, after the Share Capital Reduction, each Share shall have an accounting par value of 10 eurocents (€ 0.1).
Item 4.
To acknowledge that the Share Capital Reduction by way of the creation of the Non-Distributable Reserve as per item
3. above will allow creditors of the Company to apply for the posting of collateral to the Luxembourg district court within
30 days from the publication of the notarial deed recording the minutes of the Extraordinary General Meeting in the
Luxembourg official gazette in accordance with article 69 of the Luxembourg act of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the Company Act).
Item 5.
To amend paragraph 1. of article 6 of the Articles to reflect the Share Capital Reduction as per item 3. above, to
convert all existing Shares into ordinary shares of the Company (the "Ordinary Shares") without amending their rights
and obligations and to reflect item 2. above so as to read as follows:
"The Company has an issued share capital of EUR 11,426,327.5 (eleven million four hundred and twenty-six thousand
three hundred and twenty-seven euro and fifty eurocents) consisting of one hundred and fourteen million two hundred
116402
and sixty-three thousand two hundred and seventy-five (114,263,275) Ordinary Shares without indication of nominal
value, all of which have been fully paid-up."
Item 6.
To approve the special report prepared by the Board in accordance with article 32-3 paragraph 5 of the Company
Act with respect to the proposed elimination or limitation of the preferential subscription right of the Shareholders
pursuant to items 9. to 14. below.
Item 7.
To re-set the Company's authorised capital from its current amount of € 938,463,133.75 to an amount of €
938,463,133 represented by 9,355,494,196 Ordinary Shares and 29,137,134 Preference Shares (as defined below).
Item 8.
To amend paragraph 3. of article 6 of the Articles to reflect item 7. above and the reduction of accounting par value
of the Shares as per item 2. above as follows:
"The Company shall have an authorised capital of nine hundred and thirty-eight million four hundred and sixty-three
thousand one hundred and thirty-three euro (EUR 938,463,133) represented by nine billion three hundred and fifty-five
million four hundred and ninety-four thousand one hundred and ninety-six (9,355,494,196) Ordinary Shares and twenty-
nine million one hundred and thirty-seven thousand one hundred and thirty-four (29,137,134) Preference Shares without
indication of nominal value (the Authorised Capital)."
Item 9.
To authorise the Board to issue, within the authorised capital of the Company and during a period starting as of the
date on which the Shareholders will validly vote on and approve this item and expiring on the date that is forty five
calendar days thereafter (the "Special Offering Period") the following securities with the following specific features with
the right to eliminate or limit the existing Shareholders' preferential subscription right to subscribe for these securities:
(i) up to 145,685,674 Ordinary Shares at a price that is not less than their accounting par value that will be redeemed
by the Company upon request of the Shareholders holding the relevant Ordinary Shares at a price of 0.20 pence per
Ordinary Share (i.e., at their issue price) if such Ordinary Shares are not admitted to the official list of the United Kingdom
Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange on or before 8 January 2010 provided that this redemption
right can only be exercised as from and including 8 January 2010 until and including 15 January 2010;
(ii) up to 29,137,134 non-voting preference shares (the "Preference Shares", each a "Preference Share") conferring:
(A) in accordance with article 44 of the Company Act:
I. a preferential cumulative dividend (the "Preference Dividend") corresponding to the higher of (a) 50 per cent. per
annum of their accounting par value of € 0.10 (the "Par Value") and (b) the relevant percentage per annum of the Par
Value, as will, when converted on each payment date at the spot rate of exchange between Sterling and Euro (or Euro
and Sterling) chosen by the Board for the purposes of such conversion (the "Prevailing Exchange Rate"), enable the
Company to pay to each Preference Share holder an amount in Sterling equal to 9.0 per cent. per annum of the preference
share issue price (i.e., one (1) Sterling, the "Preference Share Issue Price") (such 9 per cent. per annum amount being the
"Preferred Dividend Sterling Equivalent"); and
II. a preferential right to the reimbursement of an amount equal to (i) the higher of (a) the Preference Share Issue Price
at the Prevailing Exchange Rate and (b) the amount received by the Company for the subscription of the Preference
Shares issued during the Special Offering Period following conversion of the aggregate Preference Share Issue Price of
such Preference Shares into Euro at the Prevailing Exchange Rate on the date of issue increased by (ii) any accrued but
unpaid Preference Dividend (the "Repayment Amount");
being acknowledged that after payment of the Preference Dividend and the Repayment Amount in case of liquidation
of the Company to the Preference Shares holders, any amount remaining available for distribution shall be available for
distribution only to the holders of other shares of the Company;
(B) voting rights as per articles 44 to 46(1) of the Company Act; and
(C) voting rights in the same manner as other Shareholders at all meetings, in case, despite the existence of profits
available for that purpose, the Preference Dividend is not paid in its entirety for any reason whatsoever for a period of
one financial year until such time as all cumulative Preference Dividend shall have been paid in full,
that will be redeemed by the Company in the following circumstances, in accordance with the terms of, and subject
to the conditions set out in, article 49-8 of the Company Act:
(A) upon request of the holders of such Preference Shares, Preference Shares issued during the Special Offering Period
will be redeemed by the Company at the Preference Share Issue Price if such Preference Shares are not admitted to the
official list of the United Kingdom Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange on or before 8 January
2010 provided that this redemption right can only be exercised as from and including 8 January 2010 until and including
15 January 2010 and it is acknowledged that, in these circumstances, the Warrants issued with any Preference Shares so
redeemed will be redeemed by the Company for no consideration;
116403
(B) at any time, subject to such Preference Shares having been redeemed by the Company through the facilities of the
London Stock Exchange at market price; or
(C) upon a change of control of the Company (defined as the acquisition by a single person or persons acting in concert
of more than 50% of the voting rights attached to the Ordinary Shares), at the request of any Preference Share holders,
at a price equal to the higher of (i) the Repayment Amount, or (ii) the average mid-market closing price over the 5 business
days prior to the announcement of the offer which results in the change of control; or
(D) if more than 75% of the Preference Shares have been redeemed before the expiration of the 7-year period referred
to under item (E) below, by way of a mandatory redemption programme launched by the Company at its sole discretion,
at a price equal to the higher of (i) the Repayment Amount, or (ii) the average mid-market closing price over the 5 business
days prior to the announcement of the launch of such programme; or
(E) if not redeemed earlier pursuant to items (A) to (D) above, on a date that is seven years after their issue at a price
equal to the Repayment Amount;
(iii) up to 29,137,134 warrants (the "Warrants", each a "Warrant"), each Warrant entitling its holder to subscribe for
one new Ordinary Share upon exercise of the Warrant, being exercisable on a semi-annual basis during a maximum period
of four years as from the Warrant's issue in accordance with and subject to such terms and conditions as will be deter-
mined by the Board provided that the exercise price of the Warrants shall be not less than the accounting par value of
the Ordinary Shares. Upon exercise of the Warrants, the Board is authorised to issue the relevant Ordinary Shares.
Item 10.
To approve that one Warrant shall be issued with each Preference Share to the subscriber of that Preference Share
without consideration and to authorise the Board to issue the Warrants for free at a ratio of one Warrant per Preference
Share issued as per item 9. above.
Item 11.
To:
(i) approve that the issue price of the Preference Shares and Ordinary Shares and the exercise price of the Warrants
that can be issued during the Special Offering Period as per item 9. above by the Board within the limits of the authorised
share capital can be below the latest published net asset value of the Ordinary Shares ("NAV") as at their date of issue
or exercise; and
(ii) expressly authorise the Board to issue the Preference Shares, the Ordinary Shares and the Warrants at a (issue
or exercise) price that is or can be below the latest published NAV of the Ordinary Shares during the Special Offering
Period.
Item 12.
To amend articles 8 and 9 of the Articles to reflect items 9. to 11. above, to authorise the Board to issue Ordinary
Shares (and, as the case may be, additional warrants if and when required to comply with adjustment mechanisms provided
for in the terms and conditions of the Warrants) within the limits of the Authorised Capital from a period starting as of
end of the Special Offering Period and expiring on fifth anniversary of the date on which the shareholders of the Company
will validly vote on this item (the "Ordinary Offering Period"), to authorise the Board to carry out/decide increases of
the share capital within the Authorised Capital by way of the incorporation of reserves, and to introduce other cosmetic
or minor amendments so that articles 8 and 9 of the Articles shall read as follows, it being understood that the information
between square brackets shall be confirmed at the occasion of the extraordinary general meeting:
"8. ISSUE AND SALE OF SHARES - RIGHTS OFFERINGS - WARRANTS
<i>Ordinary Shares
i>Within a period starting as of [date on which the shareholders of the Company will validly vote on this item 12.], and
expiring on the date that is forty five calendar days thereafter (the "Special Offering Period"), the Board is authorised, if
it determines it to be in the best interests of the Company, to issue from time to time and within the limits of the
Authorised Capital up to one hundred and forty-five million six hundred and eighty-five thousand six hundred and seventy-
four (145,685,674) Ordinary Shares at a price that is not less than their accounting par value with the right to eliminate
or limit the existing holders of Ordinary Shares' preferential subscription right to subscribe for these Ordinary Shares.
Within a period starting as of the end of the Special Offering Period and expiring on [the fifth anniversary of the date
on which the shareholders of the Company will validly vote on this item 12.] (the "Ordinary Offering Period"), the Board
is authorised to issue from time to time additional Ordinary Shares up to the total amount of the Authorised Capital.
During the Ordinary Offering Period, the Board is authorised to issue within the limits of the Authorised Capital Ordinary
Shares for subscription by way of contributions in cash with the right to eliminate or limit the existing Shareholders'
preferential right to subscribe to these Ordinary Shares if these Ordinary Shares are issued at or above the latest published
Net Asset Value per Ordinary Share (the "Fair Price"). If, during the Ordinary Offering Period, the Board offers Ordinary
Shares for subscription by contribution in cash at a price per Ordinary Share which is below the Fair Price, issuance of
such Ordinary Shares must be made by reserving for existing holders of Ordinary Shares the right to subscribe to these
new Ordinary Shares or to Ordinary Shares previously redeemed by the Company on a preferential and rateable basis
116404
in compliance with the provisions of the following paragraph ("Rights Offering"). Ordinary Shares may not be issued at a
price which is less than their accounting par value.
Where the Board determines it to be in the best interests of the Company to issue during the Ordinary Offering
Period Ordinary Shares at a price below the Fair Price by way of Rights Offerings: (i) the rights to subscribe to such
Ordinary Shares shall be reserved for existing holders of Ordinary Shares on a preferential and rateable basis, (ii) such
offering shall be on such terms and conditions as the Board determines are fair and reasonable to the existing holders of
Ordinary Shares and customary for such offerings and (iii) the Board shall use its reasonable efforts to ensure that any
existing holders of Ordinary Shares electing not to subscribe to Ordinary Shares pursuant to the Rights Offerings receive
value for such rights, at market prices, by a method which the Board determines to be appropriate in compliance with
applicable law and to be in the best interest of the relevant Shareholders.
The Board will determine the conditions of any issue of Ordinary Shares (whether during the Special Offering Period
or the Ordinary Offering Period) including (i) whether such Ordinary Shares will be issued against contributions in cash,
contributions in kind or by capitalisation of reserves, in whole or in part and (ii) in relation to Ordinary Shares to be
issued against contributions in cash or in kind, the price per Ordinary Share and payment terms and terms of delivery,
respectively.
Any contributions in kind have to be compatible with the investment policy of the Company. Furthermore, such
contributions have to be made in accordance with Article 26-1 of the Company Act, and thus are subject to a valuation
report being drawn-up by the auditor of the Company.
The Board may impose restrictions on the frequency at which Ordinary Shares shall be issued; the Board may, in
particular, decide that Ordinary Shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other frequency
as provided for in the Prospectus, decide to discontinue temporarily, cease permanently or limit the issue of Ordinary
Shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain particular countries and territories.
The Board may reject in its absolute discretion any application for Ordinary Shares. No Ordinary Shares will be issued
during any period when the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to the provisions of Article 12.
Any application for subscription shall be irrevocable, except in the event of a suspension of the calculation of the Net
Asset Value. If, during the offering period for any particular offering, there is a suspension of the calculation of the Net
Asset Value, any application for subscription made prior to such suspension may be revoked by the subscriber.
<i>Preference Shares - Warrants
i>The Board is authorised, if it determines it to be in the best interests of the Company, to issue during the Special
Offering Period and within the limits of the Authorised Capital the following securities with the following specific features
with the right to eliminate or limit the existing holders of Ordinary Shares' preferential subscription right to subscribe
for these securities:
(a) up to twenty-nine million one hundred and thirty-seven thousand one hundred and thirty-four (29,137,134) non-
voting preference shares (the "Preference Shares", each a "Preference Share") conferring:
(i) in accordance with article 44 of the Company Act, a preferential cumulative dividend (the "Preference Dividend")
corresponding to the higher of (a) 50 per cent. per annum of their accounting par value of € 0.10 (the "Par Value") and
(b) the relevant percentage per annum of the Par Value, as will, when converted on each payment date at the spot rate
of exchange between Sterling and Euro (or Euro and Sterling) chosen by the Board for the purposes of such conversion
(the "Prevailing Exchange Rate"), enable the Company to pay to each Preference Share holder an amount in Sterling equal
to 9.0 per cent. per annum of the preference share issue price (i.e., one (1) Sterling, the "Preference Share Issue Price")
(such 9 per cent. per annum amount being the "Preferred Dividend Sterling Equivalent") and a preferential right to the
reimbursement of an amount equal to (i) the higher of (a) the Preference Share Issue Price at the Prevailing Exchange
Rate and (b) the amount received by the Company for the subscription of the Preference Shares issued during the Special
Offering Period following conversion of the aggregate Preference Share Issue Price of such Preference Shares into Euro
at the Prevailing Exchange Rate on the date of issue increased by (ii) any accrued but unpaid Preference Dividend (the
"Repayment Amount"), being acknowledged that after payment of the Preference Dividend and the Repayment Amount
in case of liquidation of the Company to the Preference Shares holders, any amount remaining available for distribution
shall be available for distribution only to the holders of other shares of the Company;
(ii) voting rights as per articles 44 to 46(1) of the Company Act; and
(iii) voting rights in the same manner as other Shareholders at all meetings, in case, despite the existence of profits
available for that purpose, the Preference Dividend is not paid in its entirety for any reason whatsoever for a period of
one financial year until such time as all cumulative Preference Dividend shall have been paid in full,
that will be redeemed in accordance with article 9 below;
(b) up to twenty-nine million one hundred and thirty-seven thousand one hundred and thirty-four (29,137,134) war-
rants (the "Warrants", each a "Warrant"), each Warrant entitling its holder to subscribe for one new Ordinary Share
upon exercise of the Warrant, being exercisable on a semi-annual basis during a maximum period of four years as from
the Warrant's issue in accordance with and subject to such terms and conditions as will be determined by the Board
provided that the exercise price of the Warrants shall be not less than the accounting par value of the Shares. The
116405
Warrants shall be issued for free at a ratio of one Warrant per issued Preference Share. Upon exercise of the Warrants,
the Board is authorised to issue the relevant Ordinary Shares.
The Board is further authorised, if and when required under the terms and conditions of the Warrants, to issue during
the Ordinary Offering Period and within the limits of the Authorised Capital such additional number of warrants as is
necessary to comply with adjustment mechanisms provided for in the terms and conditions of the Warrants, with specific
features similar to those of the warrants, and with the right to eliminate or limit the existing holders of Ordinary Shares'
preferential subscription right to subscribe for these additional warrants.
<i>General
i>The price per Share at which the Company offers Shares for subscription or sale may be increased by an amount
representing a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds
of the offering and/or by an amount representing applicable sales commissions and fees and expense reimbursement as
determined from time to time by the Board, as its discretion. The price so determined shall be payable within a period
as determined by the Board and disclosed in the Prospectus. The Company may decide, at the discretion of the Board,
to pay such costs and expenses, commissions and fees and expense reimbursement out of the assets of the Company. If
the consideration payable to the Company for the newly issued Shares exceeds the accounting par value of the Shares,
the excess is to be treated as share premium in respect of the Shares in the books of the Company.
The Board may delegate to any Director, manager, officer, or any other agent of the Company the power to accept
subscriptions and to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to deliver them.
The Board is authorised to make an application for admission of each Class of Shares and of the Warrants to the
official list of any major stock exchange as the Board may determine.
9. REDEMPTION OF SHARES
<i>Ordinary Shares
i>The Company is a closed-ended undertaking for collective investment. Consequently, Ordinary Shares in the Company
shall not be redeemable at the request of a Shareholder. All the Ordinary Shares of the Company are redeemable shares
within the meaning of article 49-8 of the Company Act and the Company may proceed at its own initiative or upon
request of Shareholders with a redemption of Ordinary Shares whenever the Board considers this to be in the best
interest of the Company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
the Company Act and these Articles.
Ordinary Shares shall be redeemed at the Fair Price as at the date specified by the Board at its discretion, less an
amount, if any, equal to any duties and charges which will be incurred upon the disposal of the Company's investments
as at the date of redemption in order to fund such a redemption, which duties and charges shall be equal (in percentage
terms) with respect to all Ordinary Shares, subject to the provisions of Article 10 hereof. Notwithstanding the above,
the Board may redeem Ordinary Shares at a price which is below the Fair Price if (i) the Shares are admitted to the official
list of a major stock exchange, (ii) the redemption price is not more than 5 per cent. above the average of the middle
market quotations for the Ordinary Shares for the five business days before the redemption occurs or, if higher, the
higher of (a) the latest independent trade and (b) the current highest independent bid and (iii) the Board considers that
such redemption will enhance Shareholder value.
Notwithstanding anything to the contrary herein, upon the request of the Shareholders holding such Ordinary Shares,
Ordinary Shares issued during the Special Offering Period will be redeemed by the Company at a price of 0.20 pence per
Ordinary Share (i.e., at their issue price) if such Ordinary Shares are not admitted to the official list of the United Kingdom
Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange on or before 8 January 2010 provided that this redemption
right can only be exercised as from and including 8 January 2010 until and including 15 January 2010.
The redemption price per Ordinary Share shall be paid within a period as determined by the Board which shall not
exceed thirty Luxembourg Banking Days from the date fixed for redemption, provided that the Share certificates, if any,
and the transfer documents have been received by the Company, subject to the provisions of Article 12 hereof.
<i>Preference Shares
i>The Preference Shares shall be redeemed by the Company in the following circumstances, in accordance with the
terms of, and subject to the conditions set out in, article 49-8 of the Company Act:
(i) upon request of the holders of such Preference Shares, Preference Shares issued during the Special Offering Period
will be redeemed by the Company at the Preference Share Issue Price if such Preference Shares are not admitted to the
official list of the United Kingdom Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange on or before 8 January
2010 provided that this redemption right can only be exercised as from and including 8 January 2010 until and including
15 January 2010 and it is acknowledged that, in these circumstances, the Warrants issued with any Preference Shares so
redeemed will be redeemed by the Company for no consideration;
(ii) at any time, subject to such Preference Shares having been redeemed by the Company through the facilities of the
London Stock Exchange at market price; or
(iii) upon a change of control of the Company (defined as the acquisition by a single person or persons acting in concert
of more than 50% of the voting rights attached to the Ordinary Shares), at the request of any Preference Share holders,
116406
at a price equal to the higher of (i) the Repayment Amount, or (ii) the average mid-market closing price over the 5 business
days prior to the announcement of the offer which results in the change of control; or
(iv) if more than 75% of the Preference Shares have been redeemed before the expiration of the 7-year period referred
to under item (v) below, by way of a mandatory redemption programme launched by the Company at its sole discretion,
at a price equal to the higher of (i) the Repayment Amount, or (ii) the average mid-market closing price over the 5 business
days prior to the announcement of the launch of such programme; or
(v) if not redeemed earlier pursuant to items (i) to (iv) above, on a date that is seven years after their issue at a price
equal to the Repayment Amount.
<i>General
i>Shares redeemed by the Company shall remain in existence as treasury shares held by the Company but shall not have
any voting rights or any right to participate in any dividends declared by the Company or in any distribution paid upon
the liquidation or winding-up of the Company and shall be disregarded for purposes of determining net asset value per
Share, in each case, for so long as such Shares are held by the Company. An amount equal to the accounting par value of
all the shares redeemed shall be included in a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the
event of a reduction in the subscribed capital or where the proceeds of a new issue of Shares is made with a view to
carry out such redemption.
Where Shares are redeemed by the Company upon its initiative, a notice of redemption will be published in the Journal
Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C.
Shares may be redeemed at the initiative of the Company, e.g., (i) if the value of the assets of the Company has decreased
to an amount determined by the Board to be below the minimum level for the Company to be operated in an economically
efficient manner, (ii) if there has been an adverse change in the economic or political situation of the region on which the
Company focuses, (iii) in order to distribute to the Shareholders upon the disposal of an investment asset by the Company
the net proceeds of such investment, notwithstanding any distribution pursuant to Article 28 hereof or (iv) in the cir-
cumstances, and in the manner, described in Article 10 hereof. Except as otherwise provided in these Articles, Shares
will be redeemed on a pro rata basis among Shareholders."
Item 13.
To amend article 28 of the Articles by (i) deleting from Article 28 sub-item (d) of paragraph 4. and (ii) including a new
paragraph 5. in Article 28 to reflect that Preference Shares that can be issued as per item 9. above will have the right to
the Preference Dividend and the a preferential right to the reimbursement of the Repayment Amount which shall read
as follows:
"Any distribution shall be made in accordance with, and subject to, the right of Preference Shares to receive the
Preference Dividend as set out in Article 8 and to the reimbursement of the Repayment Amount by preference to
Ordinary Shares, in accordance with article 44 of the Company Act. If cash distribution on any Preference Share is unpaid
and accruing, no cash distribution will be made in respect of any Ordinary Share in issue until all such unpaid amount have
been paid."
Item 14.
To amend paragraph 2. of article 26 of the Articles to reflect that the Board is authorised to issue the Preference
Shares as per item 9. above as follows:
"Each whole Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A Shareholder may act
at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax
message. Notwithstanding the preceding sentence, Preference Shares shall not have the right to vote except in circums-
tances as set out in article 8 above."
Item 15.
To amend paragraph 1. of article 11 of the Articles so as to reflect the (possible) existence of several classes of Shares
(i.e., Ordinary Shares and Preference Shares) and the calculation of a separate net asset value per Share in respect of each
such class as follows:
"The Net Asset Value per Share of each Class shall be expressed in euro. The Net Asset Value per Class shall be
determined as of any valuation day as set forth in the Prospectus (a "Valuation Day") as follows: each Class participates
in the Company according to the distribution and capital reimbursement entitlements (including, for the avoidance of
doubt, liability to pay preferred dividends or other preferential rights to receive distributions attached to a particular
Class) attributable to each such Class. The value of the total distribution and capital reimbursement entitlements attributed
to a particular Class on a given Valuation Day adjusted with the liabilities relating to that Class on that Valuation Day
represents the total Net Asset Value attributable to that Class on that Valuation Day. A separate Net Asset Value per
Share, which may differ as a consequence of these variable factors, will be calculated for each Class as follows: the Net
Asset Value of that Class on that Valuation Day divided by the total number of Shares of that Class then outstanding on
that Valuation Day."
Item 16.
116407
To restate the Articles in their entirety so as to reflect items 2. to 15. above and to make further cosmetic and minor
changes (including changes designed to update the provisions dealing with U.S. Persons and Prohibited Persons, as these
terms are defined in the Articles) thereto.
Item 17.
To approve that Invista Real Estate Investment Management Holdings plc ("Invista Holdings"), the parent company of
the investment manager of the Company, has committed to subscribe to up to an aggregate number of 21,492,315
Ordinary Shares during the Special Offering Period and that Invista Holdings will be paid a commission of 3% of two-
thirds of the total amount of its commitment.
Item 18.
To satisfy the requirement set out in Listing Rule 9.5.10 of the UK Listing Authority (made under section 74 of the
UK Financial Services and Markets Act 2000), to:
(i) approve that the issue price of the Ordinary Shares and the exercise price of the Warrants that can be issued by
the Board within the limits of the authorised share capital can be at a discount of more than 10 per cent. to the middle
market price of the existing Ordinary Shares at the time of announcing the terms of an offer in a circular issued by the
Company on 16 November 2009; and
(ii) expressly authorise the Board to issue the Ordinary Shares and the Warrants at a (issue or exercise) price that is
or can be at a discount of more than 10 per cent. to the middle market price of the existing Ordinary Shares at the time
of announcing the terms of an offer in a circular issued by the Company on 16 November 2009.
Item 19.
To acknowledge and approve that the contemplated issue of the Ordinary Shares, Preference Shares and Warrants
in accordance with the terms of the offer made in the circular (the "Circular") and the public offer prospectus (the
"Prospectus") (to be) issued by the Company on or around 16 November 2009 will have a partial dilutive effect on the
shareholding and voting interest of the current shareholders of the Company and that such dilutive effect will further
increase to the extent by which the current shareholders of the Company do not subscribe to the contemplated share
capital increase in accordance with their rights to do so as described in the Circular and the Prospectus.
<i>Notesi>
(a) Shareholders that hold their Shares directly and not though CREST on the Record Date (as defined below) ("Qua-
lifying Shareholders") who plan to attend the Second Extraordinary General Meeting referred to above, should complete
the relevant attendance form and date, sign and return a copy by fax and the original by mail before 5.00 p.m. CET on 23
December 2009 to the attention of Ms. Marta Kozinska, Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 20 rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, fax number +352 47 24 73.
(b) Qualifying Shareholders who will not be able to attend the Extraordinary General Meeting may complete the
relevant form of proxy (the "Form of Proxy") and date, sign and return a copy by fax and the original by mail before 5.00
p.m. CET on 23 December 2009 to the attention of Ms. Marta Kozinska, Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg, fax number +352 47 24 73.
Please note that any Forms of Proxy received after 5.00 p.m. CET on 23 December 2009 or incomplete Forms of
Proxy will not be taken into account for the calculation of the vote in respect of the Second Extraordinary General
Meeting of 29 December 2009.
Qualifying Shareholders are informed that any completed Form of Proxy which was returned for attendance at the
First Extraordinary General Meeting held on 24 November 2009 (even, for the avoidance of doubt, after the deadline set
for return of the same in respect of the First Extraordinary General Meeting) will remain valid for the Second Extraordinary
General Meeting, provided that the Qualifying Shareholders having submitted their Forms of Proxy in respect of the First
Extraordinary General Meeting have not notified the Company in writing of the revocation of their Form of Proxy in
respect of the First Extraordinary General Meeting, at the time on which the deadline for posting of Forms of Proxy in
respect of the Second Extraordinary General Meeting expires (it being understood that a completed Form of Proxy
returned on time for the Second Extraordinary General Meeting shall be deemed to constitute a revocation of any Form
of Proxy returned with respect to the First Extraordinary General Meeting) and that the relevant Form of Proxy shall be
valid only for the (remaining) number of Shares that each of the relevant Shareholder holds at 6.00 p.m. CET on the date
which is two days prior to the Second Extraordinary General Meeting.
(c) Holders of the dematerialised depositary interests in respect of shares of the Company issued and to be issued
(the "Depositary Interests") by Capita IRG Trustees Limited (the "Depositary") ("DI Holders") should therefore complete
the relevant voting direction forms and date, sign and return a copy by fax and the original by mail before 6.00 p.m. on
21 December 2009 to the attention of Capita IRG Trustees Limited, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham,
Kent BR3 4TU, fax: +44(0)2986392180. Once Capita IRG Trustees Limited has collated responses from DI Holders, it
will lodge with Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. a Form of Proxy representing in aggregate the instructions of DI
Holders.
116408
Please note that any voting direction forms received after 6.00 p.m. on 21 December 2009 or incomplete voting
direction forms will not be taken into account for the calculation of the vote in respect of the Second Extraordinary
General Meeting of 29 December 2009.
DI Holders are informed that any completed voting direction forms which was returned in respect of the First Ex-
traordinary General Meeting held on 24 November 2009 (even, for the avoidance of doubt, after the deadline set for
return of the same in respect of the First Extraordinary General Meeting) will remain a valid voting direction for the
Second Extraordinary General Meeting, provided that the DI Holders having submitted their voting direction forms in
respect of the First Extraordinary General Meeting have not notified the Company in writing of the revocation of their
voting direction form in respect of the First Extraordinary General Meeting at the time on which the deadline for posting
of voting direction forms in respect of the Second Extraordinary General Meeting expires (it being understood that a
completed voting direction from returned on time for the Second Extraordinary General Meeting shall be deemed to
constitute a revocation of any voting direction form returned with respect to the First Extraordinary General Meeting)
are still holders of Depositary Interests and that the relevant voting direction forms shall be valid only for the (remaining)
number of Depositary Interests that each of the relevant holder of Depositary Interests holds at 6.00 p.m. on 21 December
2009.
(d) Only Qualifying Shareholders entitled to vote at 6.00 p.m. CET on the date which is two days prior to the Second
Extraordinary General Meeting will be entitled to vote. Only DI Holders entered on the register of DI Holders at 6.00
p.m. (Luxembourg time) on 21 December 2009 shall be entitled to attend and vote at the Second Extraordinary General
Meeting of 29 December 2009 (or any adjournment thereof).
Changes to entries on the register of Shareholders (or, in respect of Depositary Interest(s), in the register of Depositary
Interests held by Capita IRG Trustees Limited) after the above times shall be disregarded in determining the rights of
persons to vote (and the number of votes they may cast) at the Second Extraordinary General Meeting.
(e) Qualifying Shareholders and DI Holders are advised that no quorum is required for the Second Extraordinary
General Meeting to validly deliberate and vote upon items of its agenda and that resolutions to be adopted at the Second
Extraordinary General Meeting require a two-thirds majority of the votes validly cast, abstentions, invalid and blank votes
not being taken into account. Each Share is entitled to one vote.
(f) The full text of the proposed revised Articles of the Company (together with a version that shows the changes
against the current version of the Articles) is available for inspection, and the attendance form, the Form of Proxy, and
the voting direction forms for the Second Extraordinary General Meeting are available, at the offices of Herbert Smith
LLP, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HS, the registered office of the Company and on http://
www.ieret.eu/.
Référence de publication: 2009144501/430.
Kisling Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.029.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>31 décembre 2009i> à 8.30 heures à Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2008 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société
par ses actionnaires;
7. Discussion concernant le refinancement de la société aux fins d'apporter le soutien financier nécessaire pour clô-
turer la liquidation de la filiale EKO srl;
8. Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au
bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009152556/693/23.
116409
Patrimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 28.307.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une
ASSEMBLEE GENERALE
qui aura lieu lundi, le <i>11 janvier 2010i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16, Allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des Comptes Annuels au 30.06.2008 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibérations conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009153111/1004/16.
Satisfactory, Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 41.603.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du <i>23 décembre 2009i> à 10.00 heures avec
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2008;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Questions de la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2009148967/18.
Jolyco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 132.095.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du <i>22 décembre 2009i> à 10.00 heures avec
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2008;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2009148475/17.
116410
Invista European Real Estate Trust SICAF, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investisse-
ment à Capital Fixe.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.461.
At the occasion of a first extraordinary general meeting (the "First Extraordinary General Meeting") of the shareholders
of Invista European Real Estate Trust SICAF, a société d'investissement à capital fixe organised under the form of a société
anonyme (public limited liability company) with registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and re-
gistered with the Luxembourg trade and companies register under number B 108.461 (the "Company"), which was held
before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 24 November 2009,
9.017 % of the share capital of the Company was present or represented. The quorum required by article 67-1 (2) of the
Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Law") was therefore not reached
at such meeting.
NOTICE IS HEREBY GIVEN to the shareholders of the Company of a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(the "Second Extraordinary General Meeting"), in accordance with article 67-1 (2) of the Law, to be held on <i>29i>
<i>December 2009i>
at 10.00 a.m. CET at the office of Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.: 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to consider and pass resolutions on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Item 1.
To acknowledge and approve that all the resolutions under items 2 to 19 below will, given their reciprocal interde-
pendence, be conditional upon each of such resolutions being approved by a two thirds majority of the votes cast at the
Extraordinary General Meeting and that, if, for any reason, any of the resolutions under items 2 to 19 below is not
approved at the two thirds majority requirement, all resolutions (even those that would have previously been approved
at the required majority) will not become effective and the Extraordinary General Meeting will not proceed to the vote
on any further point on the agenda.
Item 2.
To determine to no longer attribute an express par value to the shares of the Company (the "Shares", each a "Share")
in the articles of association of the Company (the "Articles"). Pursuant to Luxembourg law, this will result in the accounting
par value of the Shares being automatically equal to the amount of the share capital divided by the number of Shares in
issue at that time.
Item 3.
To reduce the Company's share capital from its current amount of € 142,829,093.75 to € 11,426,327.5 (the "Share
Capital Reduction") without the cancellation of Shares (so that the number of Shares will remain unchanged) and without
any reimbursement or repayment to the Shareholders as follows:
(i) firstly, by absorbing the (non consolidated) losses of the Company as at 30 September 2008 in an amount of €
13,089,270 (the "Losses") as evidenced by the audited annual accounts of the Company as of 30 September 2008 drawn
up by the board of directors of the Company (the "Board"), which will result in the share capital of the Company being
reduced to € 129,739,823.75; and
(ii) secondly, by creating a non-distributable reserve of an amount of € 118,313,496.25 (the "Non-Distributable Re-
serve"), which can exclusively be used to absorb losses incurred or to increase the share capital of the Company through
the capitalisation of the Non-Distributable Reserve;
so that, after the Share Capital Reduction, each Share shall have an accounting par value of 10 eurocents (€ 0.1).
Item 4.
To acknowledge that the Share Capital Reduction by way of the creation of the Non-Distributable Reserve as per item
3. above will allow creditors of the Company to apply for the posting of collateral to the Luxembourg district court within
30 days from the publication of the notarial deed recording the minutes of the Extraordinary General Meeting in the
Luxembourg official gazette in accordance with article 69 of the Luxembourg act of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the Company Act).
Item 5.
To amend paragraph 1. of article 6 of the Articles to reflect the Share Capital Reduction as per item 3. above, to
convert all existing Shares into ordinary shares of the Company (the "Ordinary Shares") without amending their rights
and obligations and to reflect item 2. above so as to read as follows:
"The Company has an issued share capital of EUR 11,426,327.5 (eleven million four hundred and twenty-six thousand
three hundred and twenty-seven euro and fifty eurocents) consisting of one hundred and fourteen million two hundred
116411
and sixty-three thousand two hundred and seventy-five (114,263,275) Ordinary Shares without indication of nominal
value, all of which have been fully paid-up."
Item 6.
To approve the special report prepared by the Board in accordance with article 32-3 paragraph 5 of the Company
Act with respect to the proposed elimination or limitation of the preferential subscription right of the Shareholders
pursuant to items 9. to 14. below.
Item 7.
To re-set the Company's authorised capital from its current amount of € 938,463,133.75 to an amount of €
938,463,133 represented by 9,355,494,196 Ordinary Shares and 29,137,134 Preference Shares (as defined below).
Item 8.
To amend paragraph 3. of article 6 of the Articles to reflect item 7. above and the reduction of accounting par value
of the Shares as per item 2. above as follows:
"The Company shall have an authorised capital of nine hundred and thirty-eight million four hundred and sixty-three
thousand one hundred and thirty-three euro (EUR 938,463,133) represented by nine billion three hundred and fifty-five
million four hundred and ninety-four thousand one hundred and ninety-six (9,355,494,196) Ordinary Shares and twenty-
nine million one hundred and thirty-seven thousand one hundred and thirty-four (29,137,134) Preference Shares without
indication of nominal value (the Authorised Capital)."
Item 9.
To authorise the Board to issue, within the authorised capital of the Company and during a period starting as of the
date on which the Shareholders will validly vote on and approve this item and expiring on the date that is forty five
calendar days thereafter (the "Special Offering Period") the following securities with the following specific features with
the right to eliminate or limit the existing Shareholders' preferential subscription right to subscribe for these securities:
(i) up to 145,685,674 Ordinary Shares at a price that is not less than their accounting par value that will be redeemed
by the Company upon request of the Shareholders holding the relevant Ordinary Shares at a price of 0.20 pence per
Ordinary Share (i.e., at their issue price) if such Ordinary Shares are not admitted to the official list of the United Kingdom
Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange on or before 8 January 2010 provided that this redemption
right can only be exercised as from and including 8 January 2010 until and including 15 January 2010;
(ii) up to 29,137,134 non-voting preference shares (the "Preference Shares", each a "Preference Share") conferring:
(A) in accordance with article 44 of the Company Act:
I. a preferential cumulative dividend (the "Preference Dividend") corresponding to the higher of (a) 50 per cent. per
annum of their accounting par value of € 0.10 (the "Par Value") and (b) the relevant percentage per annum of the Par
Value, as will, when converted on each payment date at the spot rate of exchange between Sterling and Euro (or Euro
and Sterling) chosen by the Board for the purposes of such conversion (the "Prevailing Exchange Rate"), enable the
Company to pay to each Preference Share holder an amount in Sterling equal to 9.0 per cent. per annum of the preference
share issue price (i.e., one (1) Sterling, the "Preference Share Issue Price") (such 9 per cent. per annum amount being the
"Preferred Dividend Sterling Equivalent"); and
II. a preferential right to the reimbursement of an amount equal to (i) the higher of (a) the Preference Share Issue Price
at the Prevailing Exchange Rate and (b) the amount received by the Company for the subscription of the Preference
Shares issued during the Special Offering Period following conversion of the aggregate Preference Share Issue Price of
such Preference Shares into Euro at the Prevailing Exchange Rate on the date of issue increased by (ii) any accrued but
unpaid Preference Dividend (the "Repayment Amount");
being acknowledged that after payment of the Preference Dividend and the Repayment Amount in case of liquidation
of the Company to the Preference Shares holders, any amount remaining available for distribution shall be available for
distribution only to the holders of other shares of the Company;
(B) voting rights as per articles 44 to 46(1) of the Company Act; and
(C) voting rights in the same manner as other Shareholders at all meetings, in case, despite the existence of profits
available for that purpose, the Preference Dividend is not paid in its entirety for any reason whatsoever for a period of
one financial year until such time as all cumulative Preference Dividend shall have been paid in full,
that will be redeemed by the Company in the following circumstances, in accordance with the terms of, and subject
to the conditions set out in, article 49-8 of the Company Act:
(A) upon request of the holders of such Preference Shares, Preference Shares issued during the Special Offering Period
will be redeemed by the Company at the Preference Share Issue Price if such Preference Shares are not admitted to the
official list of the United Kingdom Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange on or before 8 January
2010 provided that this redemption right can only be exercised as from and including 8 January 2010 until and including
15 January 2010 and it is acknowledged that, in these circumstances, the Warrants issued with any Preference Shares so
redeemed will be redeemed by the Company for no consideration;
116412
(B) at any time, subject to such Preference Shares having been redeemed by the Company through the facilities of the
London Stock Exchange at market price; or
(C) upon a change of control of the Company (defined as the acquisition by a single person or persons acting in concert
of more than 50% of the voting rights attached to the Ordinary Shares), at the request of any Preference Share holders,
at a price equal to the higher of (i) the Repayment Amount, or (ii) the average mid-market closing price over the 5 business
days prior to the announcement of the offer which results in the change of control; or
(D) if more than 75% of the Preference Shares have been redeemed before the expiration of the 7-year period referred
to under item (E) below, by way of a mandatory redemption programme launched by the Company at its sole discretion,
at a price equal to the higher of (i) the Repayment Amount, or (ii) the average mid-market closing price over the 5 business
days prior to the announcement of the launch of such programme; or
(E) if not redeemed earlier pursuant to items (A) to (D) above, on a date that is seven years after their issue at a price
equal to the Repayment Amount;
(iii) up to 29,137,134 warrants (the "Warrants", each a "Warrant"), each Warrant entitling its holder to subscribe for
one new Ordinary Share upon exercise of the Warrant, being exercisable on a semi-annual basis during a maximum period
of four years as from the Warrant's issue in accordance with and subject to such terms and conditions as will be deter-
mined by the Board provided that the exercise price of the Warrants shall be not less than the accounting par value of
the Ordinary Shares. Upon exercise of the Warrants, the Board is authorised to issue the relevant Ordinary Shares.
Item 10.
To approve that one Warrant shall be issued with each Preference Share to the subscriber of that Preference Share
without consideration and to authorise the Board to issue the Warrants for free at a ratio of one Warrant per Preference
Share issued as per item 9. above.
Item 11. To:
(i) approve that the issue price of the Preference Shares and Ordinary Shares and the exercise price of the Warrants
that can be issued during the Special Offering Period as per item 9. above by the Board within the limits of the authorised
share capital can be below the latest published net asset value of the Ordinary Shares ("NAV") as at their date of issue
or exercise; and
(ii) expressly authorise the Board to issue the Preference Shares, the Ordinary Shares and the Warrants at a (issue
or exercise) price that is or can be below the latest published NAV of the Ordinary Shares during the Special Offering
Period.
Item 12.
To amend articles 8 and 9 of the Articles to reflect items 9. to 11. above, to authorise the Board to issue Ordinary
Shares (and, as the case may be, additional warrants if and when required to comply with adjustment mechanisms provided
for in the terms and conditions of the Warrants) within the limits of the Authorised Capital from a period starting as of
end of the Special Offering Period and expiring on fifth anniversary of the date on which the shareholders of the Company
will validly vote on this item (the "Ordinary Offering Period"), to authorise the Board to carry out/decide increases of
the share capital within the Authorised Capital by way of the incorporation of reserves, and to introduce other cosmetic
or minor amendments so that articles 8 and 9 of the Articles shall read as follows, it being understood that the information
between square brackets shall be confirmed at the occasion of the extraordinary general meeting:
"8. ISSUE AND SALE OF SHARES - RIGHTS OFFERINGS - WARRANTS
<i>Ordinary Shares
i>Within a period starting as of [date on which the shareholders of the Company will validly vote on this item 12.], and
expiring on the date that is forty five calendar days thereafter (the "Special Offering Period"), the Board is authorised, if
it determines it to be in the best interests of the Company, to issue from time to time and within the limits of the
Authorised Capital up to one hundred and forty-five million six hundred and eighty-five thousand six hundred and seventy-
four (145,685,674) Ordinary Shares at a price that is not less than their accounting par value with the right to eliminate
or limit the existing holders of Ordinary Shares' preferential subscription right to subscribe for these Ordinary Shares.
Within a period starting as of the end of the Special Offering Period and expiring on [the fifth anniversary of the date
on which the shareholders of the Company will validly vote on this item 12.] (the "Ordinary Offering Period"), the Board
is authorised to issue from time to time additional Ordinary Shares up to the total amount of the Authorised Capital.
During the Ordinary Offering Period, the Board is authorised to issue within the limits of the Authorised Capital Ordinary
Shares for subscription by way of contributions in cash with the right to eliminate or limit the existing Shareholders'
preferential right to subscribe to these Ordinary Shares if these Ordinary Shares are issued at or above the latest published
Net Asset Value per Ordinary Share (the "Fair Price"). If, during the Ordinary Offering Period, the Board offers Ordinary
Shares for subscription by contribution in cash at a price per Ordinary Share which is below the Fair Price, issuance of
such Ordinary Shares must be made by reserving for existing holders of Ordinary Shares the right to subscribe to these
new Ordinary Shares or to Ordinary Shares previously redeemed by the Company on a preferential and rateable basis
in compliance with the provisions of the following paragraph ("Rights Offering"). Ordinary Shares may not be issued at a
price which is less than their accounting par value.
116413
Where the Board determines it to be in the best interests of the Company to issue during the Ordinary Offering
Period Ordinary Shares at a price below the Fair Price by way of Rights Offerings: (i) the rights to subscribe to such
Ordinary Shares shall be reserved for existing holders of Ordinary Shares on a preferential and rateable basis, (ii) such
offering shall be on such terms and conditions as the Board determines are fair and reasonable to the existing holders of
Ordinary Shares and customary for such offerings and (iii) the Board shall use its reasonable efforts to ensure that any
existing holders of Ordinary Shares electing not to subscribe to Ordinary Shares pursuant to the Rights Offerings receive
value for such rights, at market prices, by a method which the Board determines to be appropriate in compliance with
applicable law and to be in the best interest of the relevant Shareholders.
The Board will determine the conditions of any issue of Ordinary Shares (whether during the Special Offering Period
or the Ordinary Offering Period) including (i) whether such Ordinary Shares will be issued against contributions in cash,
contributions in kind or by capitalisation of reserves, in whole or in part and (ii) in relation to Ordinary Shares to be
issued against contributions in cash or in kind, the price per Ordinary Share and payment terms and terms of delivery,
respectively.
Any contributions in kind have to be compatible with the investment policy of the Company. Furthermore, such
contributions have to be made in accordance with Article 26-1 of the Company Act, and thus are subject to a valuation
report being drawn-up by the auditor of the Company.
The Board may impose restrictions on the frequency at which Ordinary Shares shall be issued; the Board may, in
particular, decide that Ordinary Shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other frequency
as provided for in the Prospectus, decide to discontinue temporarily, cease permanently or limit the issue of Ordinary
Shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain particular countries and territories.
The Board may reject in its absolute discretion any application for Ordinary Shares. No Ordinary Shares will be issued
during any period when the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to the provisions of Article 12.
Any application for subscription shall be irrevocable, except in the event of a suspension of the calculation of the Net
Asset Value. If, during the offering period for any particular offering, there is a suspension of the calculation of the Net
Asset Value, any application for subscription made prior to such suspension may be revoked by the subscriber.
<i>Preference Shares - Warrants
i>The Board is authorised, if it determines it to be in the best interests of the Company, to issue during the Special
Offering Period and within the limits of the Authorised Capital the following securities with the following specific features
with the right to eliminate or limit the existing holders of Ordinary Shares' preferential subscription right to subscribe
for these securities:
(a) up to twenty-nine million one hundred and thirty-seven thousand one hundred and thirty-four (29,137,134) non-
voting preference shares (the "Preference Shares", each a "Preference Share") conferring:
(i) in accordance with article 44 of the Company Act, a preferential cumulative dividend (the "Preference Dividend")
corresponding to the higher of (a) 50 per cent. per annum of their accounting par value of €0.10 (the "Par Value") and
(b) the relevant percentage per annum of the Par Value, as will, when converted on each payment date at the spot rate
of exchange between Sterling and Euro (or Euro and Sterling) chosen by the Board for the purposes of such conversion
(the "Prevailing Exchange Rate"), enable the Company to pay to each Preference Share holder an amount in Sterling equal
to 9.0 per cent. per annum of the preference share issue price (i.e., one (1) Sterling, the "Preference Share Issue Price")
(such 9 per cent. per annum amount being the "Preferred Dividend Sterling Equivalent") and a preferential right to the
reimbursement of an amount equal to (i) the higher of (a) the Preference Share Issue Price at the Prevailing Exchange
Rate and (b) the amount received by the Company for the subscription of the Preference Shares issued during the Special
Offering Period following conversion of the aggregate Preference Share Issue Price of such Preference Shares into Euro
at the Prevailing Exchange Rate on the date of issue increased by (ii) any accrued but unpaid Preference Dividend (the
"Repayment Amount"), being acknowledged that after payment of the Preference Dividend and the Repayment Amount
in case of liquidation of the Company to the Preference Shares holders, any amount remaining available for distribution
shall be available for distribution only to the holders of other shares of the Company;
(ii) voting rights as per articles 44 to 46(1) of the Company Act; and
(iii) voting rights in the same manner as other Shareholders at all meetings, in case, despite the existence of profits
available for that purpose, the Preference Dividend is not paid in its entirety for any reason whatsoever for a period of
one financial year until such time as all cumulative Preference Dividend shall have been paid in full,
that will be redeemed in accordance with article 9 below;
(b) up to twenty-nine million one hundred and thirty-seven thousand one hundred and thirty-four (29,137,134) war-
rants (the "Warrants", each a "Warrant"), each Warrant entitling its holder to subscribe for one new Ordinary Share
upon exercise of the Warrant, being exercisable on a semi-annual basis during a maximum period of four years as from
the Warrant's issue in accordance with and subject to such terms and conditions as will be determined by the Board
provided that the exercise price of the Warrants shall be not less than the accounting par value of the Shares. The
Warrants shall be issued for free at a ratio of one Warrant per issued Preference Share. Upon exercise of the Warrants,
the Board is authorised to issue the relevant Ordinary Shares.
116414
The Board is further authorised, if and when required under the terms and conditions of the Warrants, to issue during
the Ordinary Offering Period and within the limits of the Authorised Capital such additional number of warrants as is
necessary to comply with adjustment mechanisms provided for in the terms and conditions of the Warrants, with specific
features similar to those of the warrants, and with the right to eliminate or limit the existing holders of Ordinary Shares'
preferential subscription right to subscribe for these additional warrants.
<i>General
i>The price per Share at which the Company offers Shares for subscription or sale may be increased by an amount
representing a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds
of the offering and/or by an amount representing applicable sales commissions and fees and expense reimbursement as
determined from time to time by the Board, as its discretion. The price so determined shall be payable within a period
as determined by the Board and disclosed in the Prospectus. The Company may decide, at the discretion of the Board,
to pay such costs and expenses, commissions and fees and expense reimbursement out of the assets of the Company. If
the consideration payable to the Company for the newly issued Shares exceeds the accounting par value of the Shares,
the excess is to be treated as share premium in respect of the Shares in the books of the Company.
The Board may delegate to any Director, manager, officer, or any other agent of the Company the power to accept
subscriptions and to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to deliver them.
The Board is authorised to make an application for admission of each Class of Shares and of the Warrants to the
official list of any major stock exchange as the Board may determine.
9. REDEMPTION OF SHARES
<i>Ordinary Shares
i>The Company is a closed-ended undertaking for collective investment. Consequently, Ordinary Shares in the Company
shall not be redeemable at the request of a Shareholder. All the Ordinary Shares of the Company are redeemable shares
within the meaning of article 49-8 of the Company Act and the Company may proceed at its own initiative or upon
request of Shareholders with a redemption of Ordinary Shares whenever the Board considers this to be in the best
interest of the Company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
the Company Act and these Articles.
Ordinary Shares shall be redeemed at the Fair Price as at the date specified by the Board at its discretion, less an
amount, if any, equal to any duties and charges which will be incurred upon the disposal of the Company's investments
as at the date of redemption in order to fund such a redemption, which duties and charges shall be equal (in percentage
terms) with respect to all Ordinary Shares, subject to the provisions of Article 10 hereof. Notwithstanding the above,
the Board may redeem Ordinary Shares at a price which is below the Fair Price if (i) the Shares are admitted to the official
list of a major stock exchange, (ii) the redemption price is not more than 5 per cent. above the average of the middle
market quotations for the Ordinary Shares for the five business days before the redemption occurs or, if higher, the
higher of (a) the latest independent trade and (b) the current highest independent bid and (iii) the Board considers that
such redemption will enhance Shareholder value.
Notwithstanding anything to the contrary herein, upon the request of the Shareholders holding such Ordinary Shares,
Ordinary Shares issued during the Special Offering Period will be redeemed by the Company at a price of 0.20 pence per
Ordinary Share (i.e., at their issue price) if such Ordinary Shares are not admitted to the official list of the United Kingdom
Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange on or before 8 January 2010 provided that this redemption
right can only be exercised as from and including 8 January 2010 until and including 15 January 2010.
The redemption price per Ordinary Share shall be paid within a period as determined by the Board which shall not
exceed thirty Luxembourg Banking Days from the date fixed for redemption, provided that the Share certificates, if any,
and the transfer documents have been received by the Company, subject to the provisions of Article 12 hereof.
<i>Preference Shares
i>The Preference Shares shall be redeemed by the Company in the following circumstances, in accordance with the
terms of, and subject to the conditions set out in, article 49-8 of the Company Act:
(i) upon request of the holders of such Preference Shares, Preference Shares issued during the Special Offering Period
will be redeemed by the Company at the Preference Share Issue Price if such Preference Shares are not admitted to the
official list of the United Kingdom Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange on or before 8 January
2010 provided that this redemption right can only be exercised as from and including 8 January 2010 until and including
15 January 2010 and it is acknowledged that, in these circumstances, the Warrants issued with any Preference Shares so
redeemed will be redeemed by the Company for no consideration;
(ii) at any time, subject to such Preference Shares having been redeemed by the Company through the facilities of the
London Stock Exchange at market price; or
(iii) upon a change of control of the Company (defined as the acquisition by a single person or persons acting in concert
of more than 50% of the voting rights attached to the Ordinary Shares), at the request of any Preference Share holders,
at a price equal to the higher of (i) the Repayment Amount, or (ii) the average mid-market closing price over the 5 business
days prior to the announcement of the offer which results in the change of control; or
116415
(iv) if more than 75% of the Preference Shares have been redeemed before the expiration of the 7-year period referred
to under item (v) below, by way of a mandatory redemption programme launched by the Company at its sole discretion,
at a price equal to the higher of (i) the Repayment Amount, or (ii) the average mid-market closing price over the 5 business
days prior to the announcement of the launch of such programme; or
(v) if not redeemed earlier pursuant to items (i) to (iv) above, on a date that is seven years after their issue at a price
equal to the Repayment Amount.
<i>General
i>Shares redeemed by the Company shall remain in existence as treasury shares held by the Company but shall not have
any voting rights or any right to participate in any dividends declared by the Company or in any distribution paid upon
the liquidation or winding-up of the Company and shall be disregarded for purposes of determining net asset value per
Share, in each case, for so long as such Shares are held by the Company. An amount equal to the accounting par value of
all the shares redeemed shall be included in a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the
event of a reduction in the subscribed capital or where the proceeds of a new issue of Shares is made with a view to
carry out such redemption.
Where Shares are redeemed by the Company upon its initiative, a notice of redemption will be published in the Journal
Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C.
Shares may be redeemed at the initiative of the Company, e.g., (i) if the value of the assets of the Company has decreased
to an amount determined by the Board to be below the minimum level for the Company to be operated in an economically
efficient manner, (ii) if there has been an adverse change in the economic or political situation of the region on which the
Company focuses, (iii) in order to distribute to the Shareholders upon the disposal of an investment asset by the Company
the net proceeds of such investment, notwithstanding any distribution pursuant to Article 28 hereof or (iv) in the cir-
cumstances, and in the manner, described in Article 10 hereof. Except as otherwise provided in these Articles, Shares
will be redeemed on a pro rata basis among Shareholders."
Item 13.
To amend article 28 of the Articles by (i) deleting from Article 28 sub-item (d) of paragraph 4. and (ii) including a new
paragraph 5. in Article 28 to reflect that Preference Shares that can be issued as per item 9. above will have the right to
the Preference Dividend and the a preferential right to the reimbursement of the Repayment Amount which shall read
as follows:
"Any distribution shall be made in accordance with, and subject to, the right of Preference Shares to receive the
Preference Dividend as set out in Article 8 and to the reimbursement of the Repayment Amount by preference to
Ordinary Shares, in accordance with article 44 of the Company Act. If cash distribution on any Preference Share is unpaid
and accruing, no cash distribution will be made in respect of any Ordinary Share in issue until all such unpaid amount have
been paid."
Item 14.
To amend paragraph 2. of article 26 of the Articles to reflect that the Board is authorised to issue the Preference
Shares as per item 9. above as follows:
"Each whole Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A Shareholder may act
at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax
message. Notwithstanding the preceding sentence, Preference Shares shall not have the right to vote except in circums-
tances as set out in article 8 above."
Item 15.
To amend paragraph 1. of article 11 of the Articles so as to reflect the (possible) existence of several classes of Shares
(i.e., Ordinary Shares and Preference Shares) and the calculation of a separate net asset value per Share in respect of each
such class as follows:
"The Net Asset Value per Share of each Class shall be expressed in euro. The Net Asset Value per Class shall be
determined as of any valuation day as set forth in the Prospectus (a "Valuation Day") as follows: each Class participates
in the Company according to the distribution and capital reimbursement entitlements (including, for the avoidance of
doubt, liability to pay preferred dividends or other preferential rights to receive distributions attached to a particular
Class) attributable to each such Class. The value of the total distribution and capital reimbursement entitlements attributed
to a particular Class on a given Valuation Day adjusted with the liabilities relating to that Class on that Valuation Day
represents the total Net Asset Value attributable to that Class on that Valuation Day. A separate Net Asset Value per
Share, which may differ as a consequence of these variable factors, will be calculated for each Class as follows: the Net
Asset Value of that Class on that Valuation Day divided by the total number of Shares of that Class then outstanding on
that Valuation Day."
Item 16.
To restate the Articles in their entirety so as to reflect items 2. to 15. above and to make further cosmetic and minor
changes (including changes designed to update the provisions dealing with U.S. Persons and Prohibited Persons, as these
terms are defined in the Articles) thereto.
116416
Item 17.
To approve that Invista Real Estate Investment Management Holdings plc ("Invista Holdings"), the parent company of
the investment manager of the Company, has committed to subscribe to up to an aggregate number of 21,492,315
Ordinary Shares during the Special Offering Period and that Invista Holdings will be paid a commission of 3% of two-
thirds of the total amount of its commitment.
Item 18.
To satisfy the requirement set out in Listing Rule 9.5.10 of the UK Listing Authority (made under section 74 of the
UK Financial Services and Markets Act 2000), to:
(i) approve that the issue price of the Ordinary Shares and the exercise price of the Warrants that can be issued by
the Board within the limits of the authorised share capital can be at a discount of more than 10 per cent. to the middle
market price of the existing Ordinary Shares at the time of announcing the terms of an offer in a circular issued by the
Company on 16 November 2009; and
(ii) expressly authorise the Board to issue the Ordinary Shares and the Warrants at a (issue or exercise) price that is
or can be at a discount of more than 10 per cent. to the middle market price of the existing Ordinary Shares at the time
of announcing the terms of an offer in a circular issued by the Company on 16 November 2009.
Item 19.
To acknowledge and approve that the contemplated issue of the Ordinary Shares, Preference Shares and Warrants
in accordance with the terms of the offer made in the circular (the "Circular") and the public offer prospectus (the
"Prospectus") (to be) issued by the Company on or around 16 November 2009 will have a partial dilutive effect on the
shareholding and voting interest of the current shareholders of the Company and that such dilutive effect will further
increase to the extent by which the current shareholders of the Company do not subscribe to the contemplated share
capital increase in accordance with their rights to do so as described in the Circular and the Prospectus.
<i>Notesi>
(a) Shareholders that hold their Shares directly and not though CREST on the Record Date (as defined below) ("Qua-
lifying Shareholders") who plan to attend the Second Extraordinary General Meeting referred to above, should complete
the relevant attendance form and date, sign and return a copy by fax and the original by mail before 5.00 p.m. CET on 23
December 2009 to the attention of Ms Marta Kozinska, Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 20 rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, fax number +352 47 24 73.
(b) Qualifying Shareholders who will not be able to attend the Extraordinary General Meeting may complete the
relevant form of proxy (the "Form of Proxy") and date, sign and return a copy by fax and the original by mail before 5.00
p.m. CET on 23 December 2009 to the attention of Ms Marta Kozinska, Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 20 rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg, fax number +352 47 24 73.
Please note that any Forms of Proxy received after 5.00 p.m. CET on 23 December 2009 or incomplete Forms of
Proxy will not be taken into account for the calculation of the vote in respect of the Second Extraordinary General
Meeting of 29 December 2009.
Qualifying Shareholders are informed that any completed Form of Proxy which was returned for attendance at the
First Extraordinary General Meeting held on 24 November 2009 (even, for the avoidance of doubt, after the deadline set
for return of the same in respect of the First Extraordinary General Meeting) will remain valid for the Second Extraordinary
General Meeting, provided that the Qualifying Shareholders having submitted their Forms of Proxy in respect of the First
Extraordinary General Meeting have not notified the Company in writing of the revocation of their Form of Proxy in
respect of the First Extraordinary General Meeting, at the time on which the deadline for posting of Forms of Proxy in
respect of the Second Extraordinary General Meeting expires (it being understood that a completed Form of Proxy
returned on time for the Second Extraordinary General Meeting shall be deemed to constitute a revocation of any Form
of Proxy returned with respect to the First Extraordinary General Meeting) and that the relevant Form of Proxy shall be
valid only for the (remaining) number of Shares that each of the relevant Shareholder holds at 6.00 p.m. CET on the date
which is two days prior to the Second Extraordinary General Meeting.
(c) Holders of the dematerialised depositary interests in respect of shares of the Company issued and to be issued
(the "Depositary Interests") by Capita IRG Trustees Limited (the "Depositary") ("DI Holders") should therefore complete
the relevant voting direction forms and date, sign and return a copy by fax and the original by mail before 6.00 p.m. on
21 December 2009 to the attention of Capita IRG Trustees Limited, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham,
Kent BR3 4TU, fax: +44(0)2986392180. Once Capita IRG Trustees Limited has collated responses from DI Holders, it
will lodge with Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. a Form of Proxy representing in aggregate the instructions of DI
Holders.
Please note that any voting direction forms received after 6.00 p.m. on 21 December 2009 or incomplete voting
direction forms will not be taken into account for the calculation of the vote in respect of the Second Extraordinary
General Meeting of 29 December 2009.
DI Holders are informed that any completed voting direction forms which was returned in respect of the First Ex-
traordinary General Meeting held on 24 November 2009 (even, for the avoidance of doubt, after the deadline set for
116417
return of the same in respect of the First Extraordinary General Meeting) will remain a valid voting direction for the
Second Extraordinary General Meeting, provided that the DI Holders having submitted their voting direction forms in
respect of the First Extraordinary General Meeting have not notified the Company in writing of the revocation of their
voting direction form in respect of the First Extraordinary General Meeting at the time on which the deadline for posting
of voting direction forms in respect of the Second Extraordinary General Meeting expires (it being understood that a
completed voting direction from returned on time for the Second Extraordinary General Meeting shall be deemed to
constitute a revocation of any voting direction form returned with respect to the First Extraordinary General Meeting)
are still holders of Depositary Interests and that the relevant voting direction forms shall be valid only for the (remaining)
number of Depositary Interests that each of the relevant holder of Depositary Interests holds at 6.00 p.m. on 21 December
2009.
(d) Only Qualifying Shareholders entitled to vote at 6.00 p.m. CET on the date which is two days prior to the Second
Extraordinary General Meeting will be entitled to vote. Only DI Holders entered on the register of DI Holders at 6.00
p.m. (Luxembourg time) on 21 December 2009 shall be entitled to attend and vote at the Second Extraordinary General
Meeting of 29 December 2009 (or any adjournment thereof).
Changes to entries on the register of Shareholders (or, in respect of Depositary Interest(s), in the register of Depositary
Interests held by Capita IRG Trustees Limited) after the above times shall be disregarded in determining the rights of
persons to vote (and the number of votes they may cast) at the Second Extraordinary General Meeting.
(e) Qualifying Shareholders and DI Holders are advised that no quorum is required for the Second Extraordinary
General Meeting to validly deliberate and vote upon items of its agenda and that resolutions to be adopted at the Second
Extraordinary General Meeting require a two-thirds majority of the votes validly cast, abstentions, invalid and blank votes
not being taken into account. Each Share is entitled to one vote.
(f) The full text of the proposed revised Articles of the Company (together with a version that shows the changes
against the current version of the Articles) is available for inspection, and the attendance form, the Form of Proxy, and
the voting direction forms for the Second Extraordinary General Meeting are available, at the offices of Herbert Smith
LLP, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HS, the registered office of the Company and on http://
www.ieret.eu/.
Référence de publication: 2009147416/755/429.
Adnan S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 17.192.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une
ASSEMBLEE GENERALE
qui aura lieu le <i>lundi 14 janvier 2010i> à 14.00 heures à Luxembourg, 16, Allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des Comptes Annuels au 31.12.2008 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009153113/1004/15.
SPC Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 33.235.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, le <i>22 décembre 2009i> à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation pour faute grave de Monsieur Lennart Stenke de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
2. Divers.
<i>Deux administrateurs
i>Le Commissaire
Référence de publication: 2009148964/263/14.
116418
Domus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 21, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 21.263.
Les actionnaires sont convoqués par la présente à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société qui aura lieu le <i>23 décembre 2009i> à 14.30 heures à l'étude de Maître Carlo Wersandt, notaire à L-1466
Luxembourg, 12, rue Jean Engling, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision quant à la dissolution de la société et la nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs.
2. Transfert du siège social.
3. Divers.
<i>Pour le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2009148086/503/15.
Cable & Wireless Global Card Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 63.924.
<i>Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale annuelle de la société en date du 6 juillet 2009i>
1. Le mandat des administrateurs de la Société est renouvelé jusqu'à la tenue de l'assemblée générale de la Société
approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2010:
- Monsieur Geert SCHELLEMANS, demeurant 22, Begijnenland, B-2260 Westerlo, administrateur et Président du
conseil d'administration,
- Monsieur David RICKETT, demeurant 54, Ridgway, GB-SM2 5JU Sutton, Surrey, administrateur,
- Monsieur Gilles ROLANDO, demeurant 1C, rue Georges Clemenceau, Apt 21, F-54192 Villerupt, administrateur.
2. Le mandat du commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Ian GIBSON, demeurant 3, Siverdale Road, Burgess
Hill, GB-RH15 OED West Sussex est renouvelé jusqu'à tenue de l'assemblée générale de la Société approuvant les
comptes de l'exercice clos au 31 mars 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009099750/19.
(090119292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.
Fiduciaire Expert Comptable Whitecourt-Kornerup Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Fiduciaire Whitecourt).
Siège social: L-2267 Luxembourg, 18, rue d'Orange.
R.C.S. Luxembourg B 101.081.
L'an deux mille neuf, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Ian WHITECOURT, réviseur d'entreprises, né à Londres, (Royaume-Uni), le 4 mai 1946, demeurant au
L-2551 Luxembourg, 115, avenue du X Septembre.
2.- Madame Birghitte KORNERUP, juriste, née à Copenhague (Danemark), le 14 août 1969, demeurant au L-5368
Schuttrange, 27, rue de Neuhaeusgen.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "Fiduciaire Whitecourt", ayant son siège social à L-2267 Luxembourg, 18, rue
d'Orange. (R.C.S. Luxembourg section B numéro 101.081), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 25 mai 2004, publié au Mémorial C numéro 792 du 3 août 2004.
- Que les comparants, sont les seules et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils ont pris sur ordre du jour
conforme, les résolutions suivantes:
116419
<i>Première résolutioni>
L'assemblée constate que suite à des cessions de parts sociales, dûment acceptées par la société conformément à
l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois, le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR),
représenté par cinq cents (500) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, lesquelles
sont détenues comme suit:
1) deux cent cinquante-cinq (255) parts sociales par Monsieur Ian WHITECOURT, réviseur d'entreprises, né à Londres,
(Royaume-Uni), le 4 mai 1946, demeurant au L-2551 Luxembourg, 115, avenue du X Septembre, et
2) deux cent quarante-cinq (245) parts sociales par Madame Birghitte KORNERUP, juriste, née à Copenhague (Da-
nemark), le 14 août 1969, demeurant au L-5368 Schuttrange, 27, rue de Neuhaeusgen.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts comme suit:
"Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) pans sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
La répartition du bénéfice en ce compris le boni de liquidation se fera suivant les conventions particulières intervenues
entre les associés."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en "FIDUCIAIRE EXPERT COMPTABLE WHITECOURT-
KORNERUP Sàrl" et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts comme suit:
" Art. 1
er
. La Société prend la dénomination de "FIDUCIAIRE EXPERT COMPTABLE WHITECOURT-KORNERUP
Sàrl"."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à neuf cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: WHITECOURT; KORNERUP; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2009. Relation GRE 2009/2616. Reçu soixante-quinze euros 75 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 29 juillet 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009100315/53.
(090120726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.
Sirius Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.655.
<i>Extrait portant à publication des décisions du Conseil d'Administration tenu en date du 7 juillet 2009 au siège social de la sociétéi>
En date du 7 juillet 2009, le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité:
De nommer Monsieur Eric VANDERKERKEN comme Président du Conseil d'Administration de la société pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009102099/14.
(090122195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.
116420
Skyfield Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 55.137.
Yield Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 143.957.
In the year two thousand and nine, on the thirtieth of November.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) The Absorbing Company, Skyfield Luxembourg S.A., incorporated as a société anonyme and has its registered office
at 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg commercial register under number B
55.137.
here represented by Mr Sibrand van Roijen, residing in Luxembourg, pursuant to a resolution of the Board of Directors,
taken on November 27, 2009;
2) The Absorbed Company, Yield Holding SA, which will be merged by absorption into the Absorbing Company,
incorporated as a société anonyme and has its registered office at 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered
with the Luxembourg commercial register under number B 143.957.
here represented by Mr Sibrand van Roijen, residing in Luxembourg, pursuant to a resolution of the Board of Managers,
taken on November 27, 2009;
copies of which resolutions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary
will be attached to the present deed.
The appearing persons requested the undersigned notary to record the merger project of the Absorbing Company
and the Absorbed Company as more fully specified hereafter:
MERGER PROJECT
1) The Companies:
The Absorbing Company, Skyfield Luxembourg SA, is incorporated as a société anonyme and has its registered office
at 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg commercial register under number B
55.137.
The Absorbed Company, Yield Holding SA, which will be merged by absorption into the Absorbing Company, is
incorporated as a société anonyme and has its registered office at 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered
with the Luxembourg commercial register under number B 143.957.
All the shares issued in the Absorbing Company and all the shares issued in the Absorbed Company are currently held
by the same single Shareholder (the Shareholder).
The board of directors of the respective Merging Companies have decided at their respective meetings of November
27, 2009, to approve the merger of the companies (the Merger) to be carried out by the absorption into the Absorbing
Company Skyfield Luxembourg SA of the Absorbed Company, Yield Holding SA.
2) The General Meeting of the Shareholders of the Companies:
It is proposed to submit to the approval of the general meeting of the shareholders of each of the Merging Companies
the proposed Merger, whereby in the context of its dissolution without liquidation the Absorbed Company will transfer
to the Absorbing Company all of its assets and liabilities, in accordance with article 274 of the Law on commercial
companies. In this context, each board of directors of both Merging Companies shall present the Merger Project to the
approval of the Sole Shareholder to be recorded by a Luxembourg notary public at the earliest one (1) month following
the publication in the Mémorial C of the present Merger Project.
The Merger will be effective upon its approval by the Sole Shareholder of each of the Merging Company which cannot
occur prior to the expiry of one (1) month after publication of this draft terms of Merger in the Mémorial C (the Merger
Date) and will automatically and simultaneously have the effects provided for in 274 of the Law.
3) Terms of the share exchange:
As a result of the Merger, the Absorbing Company will not issue new shares and the existing shares in the Absorbed
Company will be cancelled and the Absorbed Company will cease to exist.
4) The date from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for both fiscal and accounting
purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.
For both fiscal and accounting purposes the operations of the Absorbed Company shall be treated as being carried
out on behalf of the Absorbing Company as from 1 January 2010.
116421
5) The rights conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to the holders of securities
other than shares, or the measures proposed concerning them.
The sole shareholder does not have any special rights in the Absorbed Company
6) Any special advantages granted to the auditors, to the members of the board of directors and to the statutory
auditors.
No special advantages will be granted to the auditors, to the members of the board of directors and to the statutory
auditor.
7) Effects of the Merger:
The Merger shall entail automatically, as form the Merger Date, the universal transmission, both as between the Merging
Companies and vis-à-vis third parties, of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.
The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company
with all securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall from the Merger Date carry
out all obligations of whatever kind of the Absorbed Company such as these obligations exist on the Merger Date and
in particular carry out all claims existing with the creditors of the Absorbed Company and shall be subrogated to all rights
and obligations from such claims.
8) The books and documents of the Absorbed Company shall be kept for five years at the registered office of the
Absorbing Company.
9) The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescibed by law,
which are necessary or useful to give effect to the Merger. Insofar as required by law or deemed necessary or useful,
appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets and
liabilities transferred by the Absorbed Company to the Absorbing Company.
10) The Absorbing Company shall at the date of the general meeting approving the merger be transformed from a
"société anonyme" into a "société à responsabilité limitée" pursuant to a set of Articles submitted to the sole shareholder
and agreed by him.
This articles shall remain annexed to the present merger plan and are at the disposal of the sole shareholder at the
registered office of the Absorbing Company.
The undersigned notary certifies the legality of this merger proposal according to article 271(2) of the law on com-
mercial companies.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille neuf, le trente novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La Société Absorbante Skyfield Luxembourg SA, constituée sous la forme d'une société anonyme et ayant son siège
social au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscripte auprès du registre de commerce et des sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro B 55.137.
ici représentée par Mr Sibrand van Roijen, demeurant à Luxembourg, suivant résolution du conseil de gérance prise
le 27 novembre 2009;
2) La Société Absorbée Yield Holding SA, qui sera absorbée par fusion dans la Société Absorbante, constituée sous la
forme d'une société anonyme et ayant son siège social au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscripte auprès
du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 143.957.
ici représentée par Mr Sibrand van Roijen, demeurant à Luxembourg, suivant résolution du conseil de gérance prise
le 27 novembre 2009;
copies des dites décisions, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire soussigné resteront
annexées aux présentes.
Les comparants ont requis le notaire d'acter le projet de fusion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée
suivant les termes et conditions suivantes:
PROJET DE FUSION
1) Les Sociétés:
116422
La Société Absorbante, Skyfield Luxembourg SA, est constituée sous la forme d'une société anonyme et son siège
social est sis au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscripte auprès du registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg sous le numéro B 55.137.
La Société Absorbée, Yield Holding SA, est constituée sous la forme d'une société anonyme et son siège social est sis
au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscripte auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Lu-
xembourg sous le numéro B 143.957.
Toutes les actions émises par la Société Absorbante et toutes les actions émises par la Société Absorbée sont actuel-
lement détenues par le même actionnaire unique ("l'Actionnaire unique").
Les conseils d'administration respectifs des Sociétés Fusionnantes ont décidé à l'occasion de leurs réunions respectives
du 27 novembre 2009 d'approuver la fusion des Sociétés Fusionnantes ("la Fusion") par voie d'absorption par la Société
Absorbante Skyfield Luxembourg S.A. de la société Absorbée Yield Holding SA.
2) Assemblées Générales des Actionnaires des Sociétés:
Il est proposé de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de chacune des Sociétés Fusion-
nantes le projet de fusion, par lequel la Société Absorbée transférera, conformément à l'article 274 de la Loi, dans le
cadre de la dissolution sans liquidation, l'ensemble de ses actifs et passifs à la Société Absorbante. Dans ce contexte, le
conseil d'administration de chacune des Sociétés Fusionnantes se doit de soumettre le présent projet de fusion à l'ap-
probation de l'actionnaire unique. Cette approbation sera actée par devant un notaire luxembourgeois au plutôt un mois
après la publication du projet de fusion présent au Mémorial C.
La fusion prendra effet au moment de l'approbation par l'actionnaire unique de chacune des Sociétés Fusionnantes.
Cette approbation aura lieu au plutôt après l'écoulement d'un délai d'un (1) mois après la publication du présent projet
de fusion au Mémorial C (la "Date de Fusion") et produira automatiquement et simultanément les effets prévus à l'article
274 de la Loi.
3) Conditions de l'échange des actions:
Suite à la fusion, la Société Absorbante n'émettra pas de nouvelles actions. Les actions émises par l'actuelle Société
Absorbée seront annulées et la Société Absorbée cessera d'exister.
4) Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable et
fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
D'un point de vue comptable et fiscal, les opérations de la Société Absorbée seront considérés comme accomplies
pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1
er
janvier 2010.
5) Les droits conférés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres
autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard.
L'Actionnaire Unique ne dispose pas de droits spéciaux dans la Société Absorbée.
6) Tous avantages particuliers attribués aux réviseurs d'entreprises, aux membres du conseil d'administration ainsi
qu'aux commissaires aux comptes.
Aucun avantage spécial ne sera attribué aux réviseurs d'entreprises, aux membres du conseil d'administration ainsi
qu'aux commissaires aux comptes des sociétés fusionnantes.
7) Effets de la fusion:
La fusion entraînera automatiquement, à partir de la date de fusion, le transfert universel, tant entre les Sociétés
Fusionnantes qu'à l'égard des tiers, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante. Les droits
de créances compris dans les actifs de la Société Absorbée seront transmis à la Société Absorbante ainsi que toutes les
sûretés, in rem ou personnelles qui leur sont attachés. La Société Absorbante exécutera à partir de la date de fusion
toutes les obligations de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée telles qu'elles existent à la date de la fusion
et en particulier toutes les prétentions existantes des créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée dans les droits
et obligations résultant de ces prétentions.
8) Les livres et documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant cinq ans au siège de la Société
Absorbante.
9) La Société Absorbante doit accomplir toutes les formalités, y compris les annonces prévues par la loi, qui sont
nécessaires ou utiles à la prise d'effet de la fusion. Pour autant que prévu par la loi ou considéré nécessaire ou utile, les
instruments de transfert appropriés devront être exécutés par les Sociétés Fusionnantes pour effectuer le transfert des
actifs et des passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.
10) La Société Absorbante sera, à la date approuvant la fusion, transformée d'une société anonyme en une société à
responsabilité limitée suivant un projet de statuts soumis au seul actionnaire et approuvé par lui.
Ces statuts resteront annexés au présent projet de fusion et sont à la disposition du seul actionnaire au siège social
de la Société Absorbante.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article
271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
116423
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. van Roijen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2009. LAC/2009/52010. Reçu douze euros (12.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009152431/179.
(090189607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2009.
Logica Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.477.800,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 35.212.
En date du 9 juillet 2009, les associés de la Société réunis en Assemblée générale ont pris la résolution portant sur la
direction de l'entreprise suivante:
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Jorge DEL RIO, né le 12 mai 1971 en Californie (Etats-Unis),
demeurant 28, rue Marguerite de Brabant, L-1254 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à la tenue
de l'assemblée ordinaire approuvant les comptes annuels de 2011 qui se tiendra en 2012.
Sébastien GENESCA
<i>Managing Directori>
Référence de publication: 2009103506/15.
(090124187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2009.
GPT Europe Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 117.100.
In the year two thousand nine, on the fourteenth of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing at Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of "GPT Europe Finance S.A.", a public
limited company (société anonyme), incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 117.100, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on June 7
th
, 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1558 on August 16
th
, 2006. The articles of
association have not yet been amended since.
The Meeting was presided by Mister Jorrit Crompvoets, private employee, residing professionally at 12, rue Léon
Thyes, L-2636 Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appointed as secretary Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxem-
bourg, 74, avenue Victor Hugo.
The Meeting elected as scrutineer Mr. Erwin Vande Cruys, private employee, residing professionally at L-1750 Lu-
xembourg, 74, avenue Victor Hugo.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman states and asks the notary to act the following
that:
I.- The shareholders present or represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the proxyholder of the
represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the Meeting.
The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed
to the present deed.
116424
II.- According to the attendance list, all the shareholders, representing the aggregate share capital subscribed, are
present or represented at the present Meeting, which can vote on all the points of the agenda.
III.- The present Meeting has the following agenda:
1. Increase of the share capital of the Company by sixty thousand euro (EUR 60,000) in order to bring the share capital
from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000), up to ninety-one thousand euro (EUR 91,000) by
way of issuance of forty-eight thousand (48,000) new shares having a par value of one euro and twenty-five cents (EUR
1.25) each;
2. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1;
3. Amendment of Article 5 of the Company's articles of association in order to reflect the foregoing resolution; and
4. Miscellaneous.
The General Meeting of the shareholders, having approved the statements of the Chairman, and considering itself as
duly constituted, has deliberated and decided unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to increase the share capital by an amount of sixty thousand euro (EUR 60,000) in order to bring
the share capital from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000), up to ninety-one thousand euro
(EUR 91,000) by way of issuance of forty-eight thousand (48,000) new shares having a par value of one euro and twenty-
five cents (EUR 1.25) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Waiver is given by GPT MALTAC01 LIMITED, having its registered office at 259, St. Paul Street, Valletta VLT 1213,
Malta, and registered with the Registry of Companies in Malta under number C 36453, hereby represented by Mister
Jorrit Crompvoets, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Valletta, Malta
on July 10
th
, 2009, of its preferential subscription right.
The total of the new shares are then subscribed, by:
GPT MALTAC02 LIMITED, a company incorporated under the laws of Malta, having its registered office at 259, St.
Paul Street, Valletta VLT 1213, Malta, and registered with the Registry of Companies in Malta under number C 36453,
hereby represented by Mister Jorrit Crompvoets, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of
a proxy given in Valletta, Malta on July 10
th
, 2009, which declares to subscribe the forty-eight thousand (48,000) newly
issued shares and to pay up these shares by contribution in cash amounting to sixty thousand euro (EUR 60,000).
All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of sixty thousand euro (EUR 60,000) is from now at
the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the previous resolutions the Meeting decides to amend Article 5 of the articles of association to
read as follows:
" Art. 5. The subscribed capital is set at ninety-one thousand euro (EUR 91,000), divided into seventy-two thousand
eight hundred (72,800) shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, fully paid up."
There being no further business before the Meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Declarationi>
The undersigned notary states in compliance with Article 32-1 of the law of August 10, 1915, on commercial companies,
as amended (the Law), that the conditions of Article 26 of this Law have been observed.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the proxyholder signed together with
the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mil neuf, le quatorze juillet.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de "GPT Europe Finance S.A.", une
société anonyme, constituée et organisée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
117.100, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 juin 2006, publié au
116425
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1558 du 16 août 2006. Les statuts n'ont pas encore été modifies
depuis.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jorrit Crompvoets, employé privé, demeurant profession-
nellement au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg (le Président).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabel Dias, employée privée, demeurant professionnellement au
L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Erwin Vande Cruys, employé privé, demeurant professionnellement
au L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le
mandataire des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne
varietur" par les comparants.
II.- Au vu de la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social, sont présents ou
représentés à la présente Assemblée, qui peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés
à l'ordre du jour.
III.- Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante mille euros (60.000,- EUR) en vue de porter
son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre-vingt-onze mille euros (91.000,- EUR) par la
création et l'émission de quarante-huit mille (48.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq
cents (1,25 EUR) chacune;
2. Souscription et paiement en espèces de l'augmentation de capital social spécifiée au point 1;
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente; et
4. Divers.
L'Assemblée Générale des actionnaires, après avoir approuvé les déclarations du Président, et s'être considéré comme
valablement constituée, a délibéré et a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de soixante mille euros (60.000,- EUR)
en vue de porter son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre-vingt-onze mille euros (91.000,-
EUR) par la création et l'émission de quarante-huit mille (48.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un euro
vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, bénéficiant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Renonciation est donnée par GPT MALTAC01 LIMITED, une société constituée sous le droit maltais, ayant son siège
social au 259, St. Paul Street, Valletta VLT 1213, Malte, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Malte sous le
numéro C 36453, ici représentée par Monsieur Jorrit Cromvoets, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée à Valletta, Malte le 10 juillet 2009, à son droit de souscription préférentiel.
Toutes les nouvelles actions sont souscrites à l'instant par:
GPT MALTAC02 LIMITED, une société constituée sous le droit maltais, ayant son siège social au 259, St. Paul Street,
Valletta VLT 1213, Malte, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Malte sous le numéro C 36453, ici repré-
sentée par Monsieur Jorrit Crompvoets, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Valletta, Malte le 10 juillet 2009, qui déclare souscrire les quarante-huit mille (48.000) actions
nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces s'élevant à soixante mille euros (60.000,- EUR).
Toutes les actions sont libérées en espèces de sorte que le montant de soixante mille euros (60.000,- EUR) est à la
disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ces précédentes résolutions, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
" Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt-onze mille euros (91.000,- EUR), divisé en soixante-douze
mille huit cents (72.800) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, lesquelles sont
entièrement libérées."
L'ordre du jour de la présente Assemblée étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'Assemblée.
116426
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues
à l'Article 26 de la Loi, ont été remplies.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des parties comparantes, ce dernier a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: J. Crompvoets, I. Dias, E. Vande Cruys et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 juillet 2009. LAC/2009/28469. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.
Luxembourg, le 31 juillet 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009103756/147.
(090125065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.
MSF, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion modifié coordonné au 1
er
novembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, décembre 2009.
MAS Luxinvest S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009148128/11.
(090179136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
CBK Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. Commerzbank GS Fund Sicav).
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 137.309.
In the year two thousand and nine, on the 2
nd
day of November.
Before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Extraordinary General Meeting") of Commerzbank
GS Fund SICAV, a Luxembourg public limited company qualifying as an investment company with variable share capital,
having its registered office at 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 137309, incorporated by a notarial deed, dated
18 March 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 935, on 16 April 2008, (the
"Company").
The Extraordinary General Meeting was presided over by Mr Mathias TURRA, private employee, residing professionally
in Luxembourg who appointed as secretary Mr Ronald KERR, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The Extraordinary General Meeting elected as scrutineer Mr Dietman KUSCH, private employee, residing professio-
nally in Luxembourg.
The bureau of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to state that:
I. The present extraordinary general meeting has been convened by convening notices sent by recorded mail on 21
st
October 2009 to all the shareholders of the Company. Copies of the convening notices have been made available by
the board of the meeting to the member of the meeting.
II. The shareholders represented (the "Shareholders") and the number of shares they hold are shown on the attendance
list, signed by the members of the bureau and the undersigned notary. This list, together with the proxies initialled ne
varietur by the members of the bureau of the Extraordinary General Meeting and the undersigned notary will remain
attached to this deed in order to be filed with the registration authorities.
116427
III. It appears from the attendance list that 24,156,259.80 (twenty-four million one hundred and fifty-six thousand two
hundred fifty-nine point eighty) of the 45,645,272.03 (forty-five million six hundred forty-five thousand two hundred
seventy-two point zero three) shares, representing the entirety of the share capital of the Company, are represented at
this Extraordinary General Meeting, so that the meeting can validly deliberate.
III. The agenda of the Extraordinary General Meeting is worded as follows:
1. Approval of the change of name of the Company from Commerzbank GS Fund SICAV to CBK SICAV and amending
article 1 of the Company's articles of incorporation (the "Articles") to read as follows:
"There exists among the subscribers and all those who may become holders of Shares, a company in the form of a
"société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of CBK SICAV (the "Com-
pany")".
2. Approval of the transfer of the registered office of the Company from 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg to 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg and amending
the first sentence of article 4 of the Company's articles of incorporation to read as follows:
"The registered office of the Company is established in the commune of Hesperange, in the Grand Duchy of Luxem-
bourg.".
3. Approval of the change of date for the annual general meeting of shareholders from 1 March in each year to 1 April
in each year and amending the first sentence of article 10 of the Company's articles of incorporation to read as follows:
"The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the
registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
every year on the 1st April at 11.00 a.m.".
4. Miscellaneous.
Then the general meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Extraordinary General Meeting APPROVES the change of name of the Company from Commerzbank GS Fund
SICAV to CBK SICAV and to amend article 1 of the Company's articles of incorporation (the "Articles") to read as follows:
"There exists among the subscribers and all those who may become holders of Shares, a company in the form of a
"société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of CBK SICAV (the "Com-
pany")".
<i>Second resolutioni>
The Extraordinary General Meeting APPROVES the transfer of the registered office of the Company from 25, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand
Duchy of Luxembourg and to amend the first sentence of article 4 of Company's articles of incorporation to read as
follows:
"The registered office of the Company is established in the commune of Hesperange, in the Grand Duchy of Luxem-
bourg".
<i>Third resolutioni>
The Extraordinary General Meeting APPROVES the change of date for the annual general meeting of shareholders
from 1 March in each year to 1
st
April in each year and to amend the first sentence of article 10 of the Company's articles
of incorporation to read as follows.
"The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the
registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
every year on the 1
st
April at 11.00 a.m.".
There being no further item on the agenda, the Extraordinary General Meeting was thereupon closed.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing the present
deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the German text, the English text will be binding.
The document having been read to the persons appearing, the members of the bureau of the Extraordinary General
Meeting signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausend und neun, den zweiten November.
Vor Notar Carlo Wersandt, mit Amssitz zu Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
116428
Sind die Aktionäre der Luxemburger Aktiengesellschaft in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital der
"Commerzbank GS Fund SICAV", mit Sitz in L-2540 Luxemburg, 25, rue Edward Steichen, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 137309, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen getreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet laut notarieller Urkunde vom 18. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 935 vom 16. April 2008 (die "Gesellschaft").
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Mathias TURRA, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Luxemburg
eröffnet, welcher zum Protokollführer Herrn Roland KERR, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Luxemburg, beruft.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Dietman KUSCH, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in
Luxemburg.
Nachdem das Versammlungsbüro konstituiert ist, erklärte der Vorsitzende folgendes und bat den Notar dieses zu
beurkunden:
I. Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung wurde einberufen durch Einladungsschreiben mit Ein-
schreiben am
an alle Aktionäre der Gesellschaft: Kopien dieser Einladungsschreiben wurden dem Versammlungsbüro von den Mit-
gliedern der Versammlung zur Verfügung gestellt.
II. Die vertretenen Aktionäre (die "Aktionäre") und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwe-
senheitsliste, unterschrieben von deren Bevollmächtigten, dem Versammlungsbüro und dem unterzeichneten Notar,
aufgeführt. Die Anwesenheitsliste und die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben ein-
registriert zu werden.
III. Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor das 24.156.259,80 (vierundzwanzig Millionen einhundert sechsundfünf-
zigtausend zweihundert neunundfünfzig komma achtzig) von insgesamt 45.645.272,03 (fünfundvierzig Millionen sechs-
hundert fünfundvierzigtausend zweihundert zweiundsiebzig komma null drei) Anteile, welche das gesamte Gesellschafts-
kapital darstellen, bei dieser außergewöhnlichen Generalversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung
abstimmungsfähig ist.
IV. Die Tagesordnung der außergewöhnlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Genehmigung der Namensänderung der Gesellschaft von Commerzbank GS Fund SICAV in CBK SICAV und Um-
änderung des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
"Es besteht zwischen den Unterzeichnenden und all denjenigen, die Anteilsinhaber werden, eine Gesellschaft in der
Form einer "Aktiengesellschaft" namens "CBK SICAV" (die "Gesellschaft") die sich als eine "Investmentgesellschaft mit
veränderlichem Kapital "qualifiziert."
2. Genehmigung der Verlegung des Gesellschaftssitzes von 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großher-
zogtum Luxemburg nach 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg, und Umänderung des
ersten Satzes des Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
"Der Geschäftssitz der Gesellschaft besteht in der Stadt Hesperange, im Großherzogtum Luxemburg."
3. Genehmigung der Umänderung des Datums der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre vom ersten März
jeden Jahres zum ersten April jeden Jahres und Umänderung des ersten Satzes von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft
wie folgt:
"Die jährliche Generalversammlung der Anteilseigner wird in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht am
Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung genannten Ort in Luxemburg abgehalten und findet
jedes Jahr am 1. April um 11.00 Uhr statt."
4. Verschiedenes.
Alsdann fasste die Außergewöhnliche Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Außergewöhnliche Generalversammlung beschließt die Namensänderung der Gesellschaft von Commerzbank GS
Fund SICAV in CBK SICAV und die Umänderung des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
"Es besteht zwischen den Unterzeichnenden und all denjenigen, die Anteilsinhaber werden, eine Gesellschaft in der
Form einer "Aktiengesellschaft" namens "CBK SICAV" (die "Gesellschaft") die sich als eine "Investmentgesellschaft mit
veränderlichem Kapital "qualifiziert".
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Außergewöhnliche Generalversammlung beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes von 25, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg nach 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großher-
zogtum Luxemburg, und die Umänderung des ersten Satzes des Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
"Der Geschäftssitz der Gesellschaft besteht in der Stadt Hesperange, im Großherzogtum Luxemburg."
Verlegung des Gesellschaftssitzes von 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg nach
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg, und Umänderung des ersten Satzes des Artikel
4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
116429
"Der Geschäftssitz der Gesellschaft besteht in der Stadt Hesperange, im Großherzogtum Luxemburg."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Außergewöhnliche Generalversammlung beschließt die Umänderung des Datums der jährlichen Generalversamm-
lung der Aktionäre vom ersten März jeden Jahres zum ersten April jeden Jahres und die Umänderung des ersten Satzes
von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
"Die jährliche Generalversammlung der Anteilseigner wird in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht am
Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung genannten Ort in Luxemburg abgehalten und findet
jedes Jahr am 1. April um 11.00 Uhr statt."
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird daraufhin die außergewöhnliche Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Tag wie eingangs erwähnt.
Der unterschriebene Notar, welcher Englisch versteht, erklärt hiermit das auf Anfrage der erschienen Personen, diese
Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Begehren dergleichen Personen, und im
Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der englische Text maßgebend.
Und nach Vorlesung an die erschienen Personen, haben die Mitglieder des Versammlungsbüro mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Turra, Kerr, Kusch, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2009. LAC/2009/46515. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Carlo WERSANDT.
Référence de publication: 2009151720/158.
(090188022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.
XL-arch S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 12, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 75.863.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour XL-ARCH S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2009148489/12.
(090180176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Van Gansewinkel Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4501 Differdange, Z.A. Gadderscheier.
R.C.S. Luxembourg B 64.008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VAN GANSEWINCKEL LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signature
Référence de publication: 2009148490/12.
(090180174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Luxdeftec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 38, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 110.692.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
116430
<i>Pour LUXDEFTEC S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2009148493/12.
(090180168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Victoria Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 101.716.
Les comptes annuels au 31 janvier 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009148561/10.
(090179787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Victoria Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 101.716.
Les comptes consolidés au 31 janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009148562/10.
(090179783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Banister Investissements SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 88.804.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009148563/9.
(090179813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Bouche Minerals Equipments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 118.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009148564/10.
(090179853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
La Languette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7333 Steinsel, 71, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 129.295.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
116431
Itzig, le 23 novembre 2009.
<i>Pour LA LANGUETTE S.A R.L.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L.
Signature
Référence de publication: 2009148585/13.
(090180198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Aisch Zenter S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 38, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 124.116.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 23 novembre 2009.
<i>Pour AISCH ZENTER S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Signature
Référence de publication: 2009148587/13.
(090180197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
First Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 11.540.000,00.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 146.924.
In the year two thousand and nine, on the fourth day of the month of December.
Before Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared.
Rothschild Trust Corporation Limited of New Court St. Swithin's Lane, London EC4P 4DU, England, and Rothschild
Trust New Zealand Limited of Level 3, 280 Parnell Road, Parnell, Auckland, New Zealand, as trustees of the Factor Trust,
a trust set up under the laws of England and Wales, being the sole member (the "Sole Member") of First Global Holdings
S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, (the "Com-
pany"), having a share capital of EUR 11,540,000 and with registered office at 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 146924. The Company was
incorporated under the laws of the Republic of Panama on 28 December 1988 and was formerly established at Salduba
Building, 53, East Street, Panama, Republic of Panama, 7284, Panama 5 and was registered into the Company Registrar
under number 217148. The Company transferred its registered office to Luxembourg and was reinstated as a société à
responsabilité limitée by deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg
on 30 June 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number C 1380 of 17 July 2009. The
articles of association have been restated by the same deed.
The appearing party was represented by Mr Max Becker residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy
dated 1
st
December 2009.
The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The entire issued share capital of the Company represented by one hundred fifteen thousand four hundred (115,400)
shares is held by the Sole Member.
2. The Sole Member is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this
extraordinary decision of the Sole Member and the decisions can be validly taken on all items of the agenda.
3. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Decision to dissolve the Company and to put it into liquidation.
2. Appointment of Mr Gerhard Greidanus, Mr Jean Hoss and Mr Freddy Martell, being the members of the board of
Managers of the Company, as Board of liquidators of the Company and determination of the powers of the liquidators
granting the liquidators the largest powers provided for by law.
The above being approved, the Sole Member took the following resolutions:
116432
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation. The Sole Member noted that the
Company subsists for the sole purpose of its liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Sole Member appointed Mr Gerhard Greidanus residing at Stadhouders-kade 14 H, 1054 ES Amsterdam, The
Netherlands, Mr Jean Hoss residing at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg and Mr Freddy Martell residing
at 30, Rue du Rhône, 1204 Geneve, Switzerland, as Board of liquidators of the Company (the "Liquidators") with full
power of subdelegation to any of the Liquidators or to third parties.
The largest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10th August, 1915 on
commercial companies, as amended, are granted to the Liquidators by the meeting. The Sole Member authorises the
Liquidators to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law, to repay outstanding
liabilities in cash or in kind and at a fair and reasonable value, to do any other payments as the Liquidators deem fit, in
cash or in kind, without any special authorisation from the meeting, if such authorisation is required by law.
The Sole Member dispenses the Liquidators from drawing up an inventory and agrees that the Liquidators may refer
to the books of the Company.
The Liquidators may delegate, under their responsibility, all or part of their powers to one or more of the Liquidators
or third parties with respect to specific acts or deeds.
The Liquidators are authorised, to the extent required, to proceed to any interim liquidation payments as the Liqui-
dators deems fit.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at three thousand Euro (EUR 3,000).
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg-City, on the day indicated at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed
by a French translation; at the request of the appearing person, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.
This document having been read to the appearing person, the said person signed together this original deed with us,
the notary.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le quatrième jour du mois de décembre.
Par-devant nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Rothschild Trust Corporation Limited de New Court St. Swithin's Lane, London EC4P 4DU, England, et Rothschild
Trust New Zealand Limited de Level 3, 280 Parnell Road, Parnell, Auckland, New Zealand, agissant en tant que trustees
du Factor Trust, un trust établi sous les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, et étant l'associé unique (l'"Associé Unique")
de First Global Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous le droit du Grand-Duché de Lu-
xembourg (la "Société"), ayant un capital social de EUR 11.540.000 et avec siège social à 3, rue des Bains, L-1212
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 146924. La Société était constituée sous
les lois de la République du Panama le 28 décembre 1988 et était anciennement établie à Salduba Building, 53, East Street,
Panama, Republic of Panama, 7284, Panama 5 et immatriculée auprès du Registre des Sociétés sous le numéro 217148.
La Société a transféré son siège social au Luxembourg et a été ré-établie en tant que société à responsabilité limitée par
acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg, le 30 juin
2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 1380 du 17 juillet 2009. Les statuts ont été
reformulés par le même acte.
Le comparant a été représenté par M. Max Becker demeurant professionnellement à Luxembourg, conformément à
une procuration datée du 1
er
décembre 2009.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1. L'entièreté du capital social émis de la Société, représenté par cent quinze mille quatre cents (115.400) parts sociales,
est détenue par l'Associé Unique.
2. L'Associé Unique est représenté par une procuration, de sorte que toutes les parts sociales émises de la Société
sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et des décisions peuvent être valablement prises
sur tous les points portés à l'ordre du jour.
3. Les points sur lesquels des résolutions seront prises sont les suivants:
1. Décision de la dissolution de la Société et de sa mise en liquidation.
116433
2. Nomination de M. Gerhard Greidanus, M. Jean Hoss et M. Freddy Martell, qui sont les membres du conseil de
gérance de la Société, en tant que conseil de liquidation de la Société et détermination des pouvoirs des liquidateurs,
conférant aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus prévus par la Loi.
Après avoir approuvé ce qui précède, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation. L'Associé Unique a noté que la Société
existe pour les seuls besoins de sa liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a nommé M. Gerhard Greidanus demeurant à Stadhouderskade 14 H, 1054 ES Amsterdam, Pays-
Bas, M. Jean Hoss demeurant à 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg et M. Freddy Martell demeurant à 30,
rue du Rhône, CH-1204 Genève, en tant que conseil de liquidation de la Société (les "Liquidateurs") avec plein pouvoir
de sous-délégation à chacun des Liquidateurs ou à des parties tierces.
Les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, sont conférés aux Liquidateurs par l'assemblée. L'Associé Unique autorise les
Liquidateurs à accomplir les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi, de rembourser les dettes
restants dues en espèces ou en nature et à une valeur juste et raisonnable, de faire tous autres paiements que les Liqui-
dateurs estiment opportuns, en espèces ou en nature, sans autorisation spéciale de l'assemblée, dans le cas où celle-ci
est requise par la loi.
Les Liquidateurs sont dispensés par l'Associé Unique de dresser un inventaire et peuvent se référer aux écritures de
la Société.
Les Liquidateurs peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tous ou parties de leurs pouvoirs à un ou plusieurs des
Liquidateurs ou à des parties tierces, pour des actes ou contrats spécifiques.
Les Liquidateurs sont autorisés, dans la mesure requise, de procéder à tous paiements de liquidation intérimaires, tels
que les Liquidateurs estiment opportuns.
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de n'importe quelle forme à charge de la Société sont estimés à trois
mille euros (EUR 3.000).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et
est suivi d'une version française; à la requête de la personne comparante, la version anglaise fera foi en cas de divergences
entre les deux versions.
Après lecture faite à la personne comparante, cette dernière a signé, avec le notaire, l'original du présent procès-
verbal.
Signé: M. BECKER, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 2009. Relation: GRE/2009/4511. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Grevenmacher, le 8 décembre 2009.
Joseph GLODEN.
Référence de publication: 2009151722/130.
(090188149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.
Niederfeelen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Mac Adam.
R.C.S. Luxembourg B 118.642.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 23 novembre 2009.
<i>Pour NIEDERFEELEN S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Signature
Référence de publication: 2009148588/13.
(090180195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
116434
Microshop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 117.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 23 novembre 2009.
<i>Pour MICROSHOP S.A R.L.
i>Signature
Référence de publication: 2009148589/12.
(090180193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
ICAP US Holdings No. 2 Ltd - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 118.498.
Les Comptes Annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2009.
<i>Pour ICAP US Holdings No. 2 Ltd - Luxembourg Branch
i>Signature
Référence de publication: 2009148590/12.
(090179864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
HSBC Trinkaus Lingohr, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.
R.C.S. Luxembourg B 141.002.
Les comptes annuels au 31.08.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009148591/10.
(090180102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Tradimex Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7317 Steinsel, 1, rue Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 133.659.
L'an deux mille neuf, le neuf novembre.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
1. Biljana ANGELOSKA, employée privée, demeurant à L-5868 Alzingen, 10a, rue Jean Steichen.
2. Antonio BARBONE, étudiant, demeurant à L-1880 Luxembourg, 144, rue Pierre Krier.
3. Elena BARBONE, étudiante, demeurant à L-1880 Luxembourg, 144, rue Pierre Krier,
tous les trois (3) ici représentés par Michèle BARBONE, ci-après qualifié,
agissant en vertu de trois (3) procurations lui délivrées sous seing privé en date du 6 octobre 2009,
lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le notaire instrumentant et par les comparants,
resteront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
4. Michèle BARBONE, employé privé, demeurant à L-5868 Alzingen, 10a, rue Jean Steichen,
associés de la société TRADIMEX SARL, établie et ayant son siège à L-5868 Alzingen, 10A, rue Jean Steichen, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B133.659, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 9 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2913
du 14 décembre 2007.
Les comparants, représentés comme il est dit, prennent les résolutions suivantes:
116435
<i>Première résolutioni>
Ils décident de transférer le siège social d'Alzingen à Steinsel et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts
comme suit:
" Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinsel."
<i>Deuxième résolutioni>
Ils fixent l'adresse à L-7317 Steinsel, 1, rue Paul Eyschen.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: BARBONE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 17 novembre 2009. REM 2009/ 1500. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Mondorf-les-Bains, le 26 novembre 2009.
Roger ARRENSDORFF.
Référence de publication: 2009150192/38.
(090181797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.
PHI Capital, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.918.
<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 novembre 2009i>
L'Assemblée Générale a pris note de la démission des personnes suivantes:
- M. Jean-François de CLERMONT-TONNERRE, Président du Conseil d'Administration et Administrateur;
- M. Fabien GAGLIO, Administrateur;
- M. Laurent VERNADAT, Administrateur.
Sous réserve de l'accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l'Assemblée Générale a par ailleurs
nommé Administrateur les personnes suivantes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à délibérer sur
l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010:
- M. Patrick MOCHKOVITCH (résidant à F-13760 Saint Cannat, 3, avenue Paul Lafargue),
- M. François BEUZELIN (résidant à F-75008 Paris, 19, rue de Marignan).
L'Assemblée Générale a par ailleurs noté que Monsieur Alexandre IGNACE (résidant professionnellement à F-92200
Neuilly sur Seine, 52 bis, rue Jacques Dulud) exercera désormais la fonction de Président du Conseil d'Administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2009.
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2009148357/25.
(090179456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Front Tiza S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 149.695.
STATUTS
L'an deux mille neuf, le trois décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Civile Particulière Monégasque "Société
Civile Immobilière FRONT TIZA", établie et avec siège social à Monte Carlo, Monaco-Condamine, 25, boulevard Albert
116436
1
er
, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Monaco sous le numéro 06SC12044. La Société a été constituée
par acte reçu par Me REY, notaire de résidence à Monaco. Les statuts ont été modifiés une seule fois par acte sous seing
privé reçu en date du 27 novembre 2009, acte qui est actuellement en cours d'enregistrement à Monaco.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude GEIBEN, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle
à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent ALLENO, avocat, avec adresse professionnelle à
L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
L'assemblée élit comme scrutateurs Monsieur Clément VILLAUME, maître en droit, et Monsieur José DOS REIS
SANTOS, employé privé, les deux avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 100 (en toutes
lettres: cent) parts sociales d'une valeur nominale de 20,- EUR (vingt euros) chacune, représentant le capital total émis
de la Société de 2.000,- EUR (deux mille euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-
après reproduit, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen
de l'ordre du jour. Tous les associés ont par ailleurs renoncé à des convocations spéciales et préalables.
II.- qu'en date du 27 novembre 2009 tous les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à Monaco, dont le procès-verbal a été acté comme dit ci-dessus, et que lors de cette assemblée souveraine, statuant à
l'unanimité, il a été décidé entre autres de:
(1) changer la nationalité de la Société, par abandon de la nationalité monégasque et adoption concomitante de la
nationalité luxembourgeoise;
(2) transférer le siège social de la Société de Monaco à Luxembourg, sans dissolution ni liquidation, avec tous les actifs
et passifs de la Société, tout compris et rien excepté.
III.- que le droit monégasque, ainsi que les statuts actuels de la Société permettent le transfert de son siège social en
dehors de Monaco pour être enregistré à Luxembourg, avec abandon de la nationalité monégasque et adoption de celle
du pays d'accueil, et ceci sans dissolution ni liquidation de la société transférée, et avec tous les actifs et tous les passifs
tout compris et rien d'excepté.
IV. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Nomination des nouveaux gérants, respectivement membres du conseil de gérance de la Société à Luxembourg;
détermination de leurs pouvoirs et fixation de la durée de leurs mandats;
2.- Transformation de la Société en société à responsabilité limitée;
3.- Augmentation du capital social de son montant actuel jusqu'à concurrence de 12.500,- EUR, par incorporation de
réserves libres;
4.- Confirmation du transfert du siège social de la Société à Luxembourg et confirmation du changement de la nationalité
de la Société actuellement de nationalité du monégasque en société de nationalité luxembourgeoise;
5.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les
actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité monégasque, tout compris et rien excepté, restant la
propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le passif et tous les
engagements de la Société auparavant de nationalité monégasque;
6.- Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxem-
bourg sous la dénomination de FRONT TIZA S.à.r.l. et sous la forme d'une "société à responsabilité limitée";
7.- Confirmation de l'établissement du siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.
8.- Divers.
Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée,
l'assemblée a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer comme futurs gérants de la Société et membres du conseil de gérance, selon
les statuts nouvellement adoptés ci-après:
(1) Monsieur Fernand HEIM, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, administrateur de sociétés, avec adresse profes-
sionnelle à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, et
(2) Monsieur Enrico FERABOLI, né le 13 juillet 1970 à San Remo (Italie), administrateur de sociétés, avec adresse
professionnelle à MONACO, 5bis, avenue Princesse Alice, et
(3) Monsieur Marc FAGGIONATO, né le 11 mars 1959 à Monaco, administrateur de sociétés, avec adresse profes-
sionnelle à MONACO, 25, boulevard Albert 1
er
.
L'assemblée générale décide de nommer l'ensemble des gérants ci-avant pour une durée indéterminée, leurs pouvoirs,
et notamment leurs pouvoirs de signature au nom et pour compte de la Société étant déterminés comme il est dit ci-
après dans les nouveaux statuts.
116437
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide la transformation de la Société de société civile en société à responsabilité limitée sous
les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 10.500,- EUR (dix mille cinq
cents euros), pour le porter de son montant actuel de 2.000,- EUR (deux mille euros) à 12.500,- EUR (douze mille cinq
cents euros), par incorporation de réserves libres suffisantes à la disposition de la Société, et qui résultent du bilan
intermédiaire joint au présent acte, et dont l'approbation va suivre. L'assemblée générale décide qu'après cette augmen-
tation de capital le nombre et la répartition des parts sociales restent inchangés.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide le transfert du siège social au Grand-Duché de Luxembourg et le changement de la
nationalité de la Société, actuellement de nationalité du monégasque, en une société de nationalité luxembourgeoise,
comme l'Assemblée Générale décide d'abandonner dorénavant la nationalité monégasque.
L'Assemblée Générale prend expressément acte que la décision de transférer le siège social de la Société au Grand-
Duché de Luxembourg est considérée par la loi monégasque et par la loi luxembourgeoise comme une continuation de
la Société et qu'elle est dès lors mise en exécution sans dissolution ni liquidation de la Société, et sans création d'une
nouvelle personne morale.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indi-
quant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société de Monaco, tel qu'établi à la
date du 15 novembre 2009 et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité de
Monaco, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembourgeoise qui continue
à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité
monégasque, étant spécifié que les actifs de la Société comprennent principalement (1) la détention, propriété et pleine
jouissance de 9.800 (en toutes lettres: neuf mille huit cents) parts sociales, représentant 98% (quatre-vingt dix-huit pour-
cent) du capital social de 200.000,- EUR (deux cent mille euros) de la société civile particulière de droit monégasque du
nom de Société civile immobilière TIZA, établie et ayant son siège social à Monaco-Condamine, 25, boulevard Albert 1
er
, Monte-Carlo (Principauté de Monaco), et (2) la détention, propriété et pleine jouissance de 1.000 (en toutes lettres:
mille) parts sociales, représentant 1% (un pour cent) du capital social de 150.000,- EUR (cent cinquante mille euros) de
la société civile particulière de droit monégasque du nom de Société civile immobilière LES OLIVIERS, établie et ayant
son siège social à Monaco-Condamine, 25, boulevard Albert 1
er
, Monte-Carlo (Principauté de Monaco).
Ledit état financier, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexé
aux présentes pour être enregistré avec lui en même temps, en même temps.
L'assemblée générale décide par ailleurs de déléguer à Maître Claude GEIBEN, préqualifié, tous pouvoirs nécessaires
pour procéder à toutes les formalités et inscriptions requises au Grand-Duché de Luxembourg en vue du transfert du
siège et de l'établissement de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, et entre autres de procéder à toutes démarches
administratives et formalités, incluant les transcriptions et les enregistrements, nécessaires ou simplement utiles, au
Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une "société à responsabilité limitée" sous la dé-
nomination de FRONT TIZA S.àr.l. et d'adopter les statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de manière à les
rendre conformes à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il existe entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la
suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a principalement pour objet l'acquisition, la vente, l'échange, la construction de tout objet immobilier,
soit directement et en son nom, soit par l'entremise de sociétés ou autres entités luxembourgeoises ou étrangères
poursuivant ce même objet ou un objet similaire. Dans ces derniers cas, la Société peut prendre des participations ou
des intérêts qui ne doivent pas être nécessairement majoritaires ou déterminants en ce qui concerne leur gestion. Dans
ces contextes la Société peut également donner des objets immobiliers en location, sous quelque forme que ce soit, ou
les prendre en location, les concéder en sous location ou les mettre autrement en valeur.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
116438
Dans l'exercice de toutes ses activités, la Société pourra également établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de FRONT TIZA S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-ville. Il peut être transféré en toute autre lieu de la commune du siège
social en vertu d'une décision du gérant ou du conseil de gérance, selon le cas. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,- EUR) représenté par 100
(cent) parts sociales, d'une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés
que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant. Toute cession, disposition ou transfert de parts sociales,
que ce soit par acte entre vifs, ou à cause de mort, ne pourront avoir lieu que moyennant autorisation expresse et
préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts de tous les associés. Toute cession de parts
opérée en l'absence d'une telle autorisation par l'assemblée générale n'est pas valable et ne doit pas être reconnue par
la Société, ni être enregistrée dans le registre des associés. Au cas où l'assemblée générale se refuse toutefois à donner
son agrément à un transfert de parts sociales à cause de mort, la Société doit suivre les dispositions impératives de l'article
189 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, étant entendu que dans ce cas précis, lorsqu'il y a projet de
rachat de ces parts par un tiers ou par un associé, les autres associés jouissent d'un droit de préemption, sous les
conditions et d'après les proportions et modalités comme dit dans les présents statuts.
Pareillement toute constitution de gage ou d'autres garanties conventionnelles ou réelles sur des parts sociales de la
Société, en tout ou en partie, par un associé ne seront valables et ne doivent être reconnues et inscrites par la Société
qu'après avoir été expressément autorisée par une assemblés générale des associés statuant aux conditions de majorité
et de quorum telles que légalement prévues pour une modification des statuts.
En toute hypothèse où un associé aurait l'intention de transférer, par acte entre vifs, tout ou une partie de ses parts
sociales à un tiers, les autres associés existants ont un droit de préemption proportionnel à leur part dans le capital.
L'offre de préemption contenant l'indication du nombre de parts cédées, du nom du tiers ou associé acheteur, du prix,
ainsi que des modalités de paiement, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) gérant(s)
de la Société qui en informera(ont) les associés existants à leurs adresses respectives.
L'offre pourra être valablement retirée avant que soit convoquée l'assemblée générale en vue de se prononcer sur
ledit acte de transfert.
Les associés intéressés par l'achat doivent signaler leur intention par lettre recommandée avec accusé de réception
au(x) gérant(s) au plus tard dans les 60 (soixante) jours à partir de la réception de l'offre de vente. Le(s) gérants en
informera(ont) l'associé désireux de céder ses parts.
Les associés intéressés par l'achat peuvent accepter le prix indiqué dans l'offre ou bien déclarer qu'ils entendent
entamer une procédure de détermination du prix par un collège d'experts.
Dans ce dernier cas, le prix est déterminé par un collège d'experts composé de trois membres, dont un membre est
nommé par la partie intéressée à la cession dans un délai de 15 (quinze) jours à partir de l'exercice du droit de préemption,
tandis que l'autre membre est nommé, dans les 15 (quinze) jours suivant la nomination du premier expert par l'associé
intéressé, ou conjointement par les associés intéressés à L'achat. Le troisième membre, qui a la fonction de président du
collège d'experts, est désigné par les deux experts déjà nommés, dans les 15 (quinze) jours à partir de la nomination du
deuxième expert. Au cas où l'une des parties ne procédera pas à la nomination d'un expert ainsi qu'en cas de désaccord
sur la nomination du troisième expert, celui-ci est nommé par le président du tribunal d'arrondissement comme il est
prévu par le Nouveau code de procédure civile en matière d'arbitrage.
Le collège d'experts détermine le juste prix des parts, objet de la cession, à la date de l'exercice du droit de préemption,
sur base des principes exprimés à l'article 189 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, et de tous les éléments
que les parties auront droit de lui soumettre ainsi que sur base des principes et règles comptables internationaux géné-
116439
ralement reconnus en matière de détermination de la valeur des parts sociales, en prenant notamment en considération
les bénéfices réalisés pendant les trois dernières années, ainsi que les primes, bonus ou rémunérations non périodiques
de la même période .
Le collège d'experts rend son évaluation au plus tard dans les 90 (quatre-vingt dix) jours à partir de la nomination du
troisième expert.
L'évaluation lie définitivement les parties sans qu'un recours en appel ne soit possible.
La partie ayant préempté pourra néanmoins renoncer à son droit de préemption sans indication de motifs, par noti-
fication écrite à l'associé désireux de vendre. Cette notification devra, pour être valable, intervenir endéans un délai de
10 (dix) jours à partir de la réception de l'évaluation définitive par le collège d'experts.
Tous les frais du collège et de procédure sont pour moitié à charge du vendeur et pour moitié à charge de l'acquéreur
ou des acquéreurs proportionnellement aux parts sociales achetées.
Le paiement du prix a lieu au moment de la cession des parts, à condition que l'assemblée générale des associés ait
marqué son accord formel au transfert.
Si les associés existants n'ont pas exercé le droit de préemption dans les délais établis ci-dessus, l'associé intéressé à
la vente a le droit de céder les actions à l'associé ou au tiers indiqué et aux conditions communiquées au conseil d'ad-
ministration conformément aux dispositions ci-dessus, à condition que l'assemblée générale des associés ait marqué son
accord formel au transfert.
Si le droit de préemption est exercé par plus d'un associé il sera réputé exercé par les associés acquéreurs propor-
tionnellement au nombre de leurs parts et aux droits dont chaque associé est titulaire, sous condition bien entendu que
toutes les parts soient achetées.
Les associés qui ont préempté peuvent déclarer leur disposition à se porter acquéreurs des parts sociales non pré-
emptées dans la proportion des parts qu'ils détiennent.
Tous les associés peuvent convenir par écrit que l'évaluation des parts que l'un des associés est désireux de céder, ne
sera effectuée que par un expert unique, à charger sous signature conjointe de tous les associés, accompagné d'un lettre
déterminant sa mission.
Les dispositions du présent article concernant Ia vente et cession des parts sont applicables à la constitution et à la
cession des droits réels, de jouissance et de garantie, ainsi qu'aux droits préférentiels.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance - Surveillance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants,
par les signatures conjointes de tous les gérants.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Le conseil de gérance est investi des
pouvoirs les plus larges pour gérer les affaires de Société, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent
à l'assemblée générale, comme cela résulte notamment des dispositions de l'article 19 des présents statuts. Il pourra
également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
116440
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
L'assemblée générale a le pouvoir de faire et de ratifier tous les actes qui concernent les affaires et intérêts de la
Société.
L'approbation de l'assemblée générale requise pour tous les actes de disposition et de transfert de la propriété ou
d'autres droits que la Société détient dans des titres participatifs d'autres sociétés ou de toutes propriétés immobilières
à Luxembourg ou à l'étranger. Ces décisions ne sont valablement adoptés que si elles sont adoptées par des associés
représentant au moins 70% (soixante-dix pour cent) du capital.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition - Assemblée annuelle
Art. 21. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
116441
Art. 24. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 10.00 heures du
matin au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 26. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 27. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée Générale confirme l'établissement du siège social de la Société au no231, Val des Bons-Malades, à L-2121
Luxembourg-Kirchberg avec effet immédiat.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par exception aux dispositions des articles 21 et 22 des statuts, le premier exercice social qui commence aujourd'hui
lors de la continuation de la Société à Luxembourg, se terminera le 31 décembre 2010.
2) La première assemblée générale annuelle sous régime légal luxembourgeois se tiendra en 2011.
<i>Constati>
L'assemblée générale constate, aux fins d'inscription dans le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
que la répartition du capital social et de ses parts est comme suit:
(1) SHORINVEST HOLDING S.A., siège social à c/o Markus AFFOLTER-HACK,
Rossweidstrasse, 7, DAVOS (Suisse) registre de commerce n° CH-350.3.004.911-5 . . . . . . .
67 parts sociales
(n
os
33 à 99)
(2) Madame Tiziana SAVINELLI, photographe, domiciliée à Monaco, 17, boulevard du
Larvotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 parts sociales
(n
os
1 à 32 et 100)
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts sociales.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: C. Geiben, V. Alleno, C. Villaume, J. Dos Reis Santos et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2009. LAC/2009/52387. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009151724/325.
(090188716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2009.
Doca Deal S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5540 Remich, 29, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 112.155.
<i>Assemblée générale extraordinaire tenue à Remich le 14 octobre 2009 à 15.00 heuresi>
L'assemblée se compose de:
1. Monsieur DO CARMO RODRIGO Antonio, cuisinier, né à Sabroso/Vreia de Bornes (Portugal), le 31 mars 1962,
demeurant à L-7370 LORENTZWEILER, 14, rue St. Laurent.
Lequel associé, a pris, sur ordre du jour, les résolutions suivantes:
Monsieur DO CARMO RODRIGO Antonio, prénommé, déclare céder soixante-deux (62) parts sociales à Madame
JANEIRO LAGARTO Ana Paula, née le 16 mars 1969 à Salvada / Beja (P), demeurant L-5540 REMICH, 29, rue de la Gare,
et soixante-trois (63) parts sociales à Madame CANICO DAMIAO Tania Andreia, née le 30 novembre 1980 à Torres
Vedras, demeurant L-5530 REMICH, 7, rue de l'Eglise, au prix nominal.
116442
Suite à la cession de parts sociales qui précède les parts sociales sont réparties comme suit:
1. Madame CANICO DAMIAO Tania Andreia, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 PARTS SOCIALES
2. Madame JANEIRO LAGARTO Ana Paula, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 PARTS SOCIALES
TOTAL: CENT VINGT-CINQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 PARTS SOCIALES
L'assemblée accepte la démission de Monsieur DO CARMO RODRIGO Antonio, associé/gérant technique, demeurant
à 14, rue St. Laurent, 7370 LORENTZWEILER, de sa fonction de gérant technique et gérant administratif,
L'assemblée nomme gérante technique pour une durée indéterminée, Madame CANICO DAMIAO Tania Andreia,
associée/gérante technique, demeurant à 7, rue de l'Eglise, 5530 REMICH,
L'assemblée nomme gérante administrative pour une durée indéterminée, Madame JANEIRO LAGARTO Ana Paula,
associée/gérante administrative, demeurant à 29, rue de la Gare, 5540 REMICH,
La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 15.30 heures.
DO CARMO RODRIGO Antonio / CANICO DAMIAO Tania Andreia / JANEIRO LAGARTO Ana Paula.
Référence de publication: 2009150036/29.
(090181433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2009.
Standard Chartered Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 10.515.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 27 avril 2009i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
1- Les mandats d'administrateurs de M. Eric JULLIEN, M. Graeme T. HAIG, M. Norman R. GILCHRIST et M. Frank
Di MAIO ont été renouvelés. Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes
de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009.
2- Le mandat d'administrateur de M. Brendon HOPKINS n'a pas été renouvelé.
Luxembourg, le 19 novembre 2009.
Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009148376/17.
(090179168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Valode & Pistre Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 101.183.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue à Luxembourg, eni>
<i>date du 4 novembre 2009 à 10.00 heuresi>
1. Démission de Monsieur Patrick CHATANAY demeurant au 2, rue des Vieilles Boucheries, 78000, Saint-Germain-
En-Laye de son poste d'administrateur avec effet au 1
er
décembre 2009.
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 4 novembre 2009.
<i>Pour la société
i>Denis Valode
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2009148383/16.
(090179501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
PEH Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.128.
<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 novembre 2009i>
L'Assemblée Generale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un
nouveau terme d'un an.
116443
<i>Composition du Conseil d'Administrationi>
Stefan MAYERHOFER, Président
(résidant professionnellement à D-80333 München, 8, Max-Joseph Strasse)
Thomas AMEND
(résidant professionnellement à L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall)
Roman MERTES
(résidant professionnellement à L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall)
<i>Réviseur d'Entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
(ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 400, route d'Esch)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2009.
BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2009148387/25.
(090179446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Hansa Transport International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 100.750.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2009148524/13.
(090180264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Ostara Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 128.921.
Il résulte de deux cessions avec effet au 29 octobre 2009 que:
- M. Rolf ELGETI, domicilié à 4, Carlingford Road, GB-NW3 1RX Londres, a transféré la propriété de 99 parts sociales
de la société à responsabilité limitée Ostara Holdings S.à r.l. avec siège social à 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,
à la société Ashdown Funding Limited avec siège social à 26, Park House, North End Road, GB-NW11 7PT Londres;
- M. Rolf ELGETI, domicilié à 4, Carlingford Road, GB-NW3 1RX Londres, a transféré la propriété de 66 parts sociales
de la société à responsabilité limitée Ostara Holdings S.à r.l. avec siège social à 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,
à M. Jonathan CHENEVIX-TRENCH, domicilié à 4 Albert Place, GB-W8 5PD Londres.
Le capital de la société est dorénavant réparti comme suit:
- Ashdown Funding Limited, 26, Park House, North End Road, GB - NW11 7PT Londres . . . 14 999 parts sociales
- Jonathan CHENEVIX-TRENCH, 4, Albert Place, GB - W8 5PD Londres . . . . . . . . . . . . . . . 10 001 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 parts sociales
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Ostara Holdings S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009148459/23.
(090179008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
116444
3P (L) Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 134.768.
<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 novembre 2009i>
L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat du Réviseur d'Entreprises, PricewaterhouseCoopers S.à
r.l., pour un nouveau terme d'un an.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2009.
BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2009148388/16.
(090179442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Grands Magasins Monopol, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 4.274.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution circulaire du conseil d'administration de la Société prise en date du 12 novembre 2009, que
le conseil d'administration de la Société a décidé de révoquer Monsieur Wolfgang Ehrhardt en sa qualité de délégué à la
gestion journalière de la Société, ceci avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009148395/15.
(090179239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
LuxEnvironnement, Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 41, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.933.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009148503/10.
(090180149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Graros S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 112.157.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2009148528/12.
(090180254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
116445
BCG Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 95.258.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56651 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009148756/12.
(090180278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
J.P.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 54.058.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009148757/10.
(090179848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Holzgestaltung Irsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R.C.S. Luxembourg B 86.122.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009148758/10.
(090179845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Choron Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 102.190.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009148759/10.
(090179843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
VCapital S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investisse-
ment en Capital à Risque.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
R.C.S. Luxembourg B 128.151.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009148765/11.
(090179719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
116446
Constantine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 114.294.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Constantine S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009148751/12.
(090179694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Speedquest Finance, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 134.340.
Le bilan au 30/11/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009148752/11.
(090179693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Nord-Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 37.445.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009148753/10.
(090179859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Petrofond, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 128.809.
Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009148755/10.
(090179852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Bois Parren S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 18.082.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BOIS PARREN S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2009148501/12.
(090180155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
116447
Balanced Portfolio D, Fonds Commun de Placement.
Die Verwaltungsgesellschaft des Luxemburger Investmentfonds BALANCED PORTFOLIO D (ISIN-Code:
LU0103599451) hat am 16. November 2009 beschlossen, den Investmentfonds aufzulösen und zum 23. November 2009
zu liquidieren. Der Liquidationserlös wurde den Anteilinhabern ab dem 25. November 2009 von ihrer Depotbank aus-
gezahlt.
Luxemburg, im Dezember 2009.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Référence de publication: 2009153115/1999/12.
Falken Fonds, Fonds Commun de Placement.
<i>Liquidationsbekanntmachungi>
Wir möchten hiermit darüber informieren, dass das Sondervermögen Falken Fonds (FCP) mit dem Teilfonds "Falken
Fonds - Cash & Value" mit Wirkung zum 2. Dezember 2009 liquidiert wurde.
Das Allgemeine Verwaltungsreglement des Fonds sowie das Sonderreglement des Teilfonds traten mit Wirkung zum
2. Dezember 2009 außer Kraft.
Luxemburg, im Dezember 2009.
Axxion SA
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2009153116/6206/12.
Balanced Portfolio A, Fonds Commun de Placement.
Die Verwaltungsgesellschaft des Luxemburger Investmentfonds BALANCED PORTFOLIO A (ISIN-Code:
LU0084565851) hat am 16. November 2009 beschlossen, den Investmentfonds aufzulösen und zum 23. November 2009
zu liquidieren. Der Liquidationserlös wurde den Anteilinhabern ab dem 25. November 2009 von ihrer Depotbank aus-
gezahlt.
Luxemburg, im Dezember 2009.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Référence de publication: 2009153117/1999/12.
Galactique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 138.636.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg:
Le siège social de AIM Services S.àr .l. est désormais le suivant: 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 Novembre 2009.
S G G S.A.
<i>Un Mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009148686/17.
(090180275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
116448
3P (L) Fund
Adnan S.A.
Aisch Zenter S.A.
Balanced Portfolio A
Balanced Portfolio D
Banister Investissements SA
BCG Luxembourg Holding S.à r.l.
Bois Parren S.A.
Bouche Minerals Equipments S.à r.l.
Cable & Wireless Global Card Services S.A.
CBK Sicav
Choron Finance (Luxembourg) S.A.
Commerzbank GS Fund Sicav
Constantine S.à r.l.
Doca Deal S. à r.l.
Domus S.A.
Falken Fonds
Fiduciaire Expert Comptable Whitecourt-Kornerup Sàrl
Fiduciaire Whitecourt
First Global Holdings S.à r.l.
Front Tiza S.àr.l.
Galactique S.à r.l.
GPT Europe Finance S.A.
Grands Magasins Monopol
Graros S.A.
Hansa Transport International S.à.r.l.
Holzgestaltung Irsch S.à r.l.
HSBC Trinkaus Lingohr
ICAP US Holdings No. 2 Ltd - Luxembourg Branch
Invista European Real Estate Trust SICAF
Invista European Real Estate Trust SICAF
Jolyco S.A.
J.P.C. S.A.
Kisling Investment S.A.
La Languette S.à r.l.
Logica Luxembourg S.A.
Luxdeftec S.A.
LuxEnvironnement
Microshop S.à r.l.
MSF
Niederfeelen S.A.
Nord-Finance
Ostara Holdings S.à r.l.
Patrimmo S.A.
PEH Sicav
Petrofond
PHI Capital
Satisfactory
Sirius Finance S.A.
Skyfield Luxembourg S.A.
SPC Holding S.A.
Speedquest Finance
Standard Chartered Financial Services (Luxembourg) S.A.
Tradimex Sàrl
Valode & Pistre Management S.A.
Van Gansewinkel Luxembourg S.A.
VCapital S.C.A., SICAR
Victoria Holding S.à r.l.
Victoria Holding S.à r.l.
XL-arch S.A.
Yield Holding S.A.