This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2411
11 décembre 2009
SOMMAIRE
Adviser I Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115684
Adviser II Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115682
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 6 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115695
A.R.I. Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115726
Athena Investments Limited S.A. . . . . . . . .
115726
Athena Paint Investments S.A. . . . . . . . . . .
115726
Athena Paint Investments S.A. . . . . . . . . . .
115726
Aurealux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115726
B & B Bepuvo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
115688
BDM Technologies Holding S.A. . . . . . . . . .
115687
Capital Street S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115725
China Corn Oil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115688
Covam Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115728
El Boustan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115727
Elektra Finanzierung A.G. . . . . . . . . . . . . . .
115688
Elite Relocation Service S.à r.l. . . . . . . . . . .
115727
Gabefi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115725
Gemplus International S.A. . . . . . . . . . . . . .
115722
GFA - HAIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115695
GFA - HAIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115702
Global Garden Products C S.à r.l. . . . . . . .
115727
Helios Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
115718
Holdess Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115722
IMC Asset Management Funds . . . . . . . . . .
115725
International Chemical Investors S.A. . . . .
115715
KBC Institutional Cash . . . . . . . . . . . . . . . . .
115682
K-Erlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115720
K-Erlen Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115720
KP Interiors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115705
Laumar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115682
Liontrust International Funds (Luxem-
bourg) SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115703
Liontrust International Funds (Luxem-
bourg) SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115705
LP One Halbergmoos Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
115727
LP Three Darmstadt Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
115728
Pamplona PE Holdco 4 S.A. . . . . . . . . . . . . .
115725
Spring Multiple 2007 S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
115686
Transworld Fertilizers Holding S.A. . . . . .
115690
UBP Multifunds II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115686
UBS (Lux) Exposure Sicav . . . . . . . . . . . . . .
115689
UBS (Lux) Structured Sicav . . . . . . . . . . . . .
115689
UBS (Lux) Structured Sicav 2 . . . . . . . . . . .
115690
Valauchan Caisse Auchan Italie S.C.A. . . .
115686
Vega Business Aviation S.à r.l. . . . . . . . . . . .
115708
Yannick S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115728
115681
Laumar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 41.988.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>28 décembre 2009i> à 11.00 heures au siège social, 19-21 Boulevard du Prince
Henri, 1724 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels clos au 30 juin 2009 ainsi que du rapport de gestion du conseil d'administration
et du rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes ;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats de l'exercice ;
3. Décharge aux organes de la société ;
4. Divers.
Les actionnaires désirant assister à l'assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l'assemblée
générale auprès de la Société Européenne de Banque, 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2009152008/755/19.
KBC Institutional Cash, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 39.266.
Les Actionnaires sont invités à assister à la
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>12 janvier 2010i> à 15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2009 et de l'affectation des résultats
3. Décharge aux Administrateurs
4. Nominations Statutaires
5. Divers
Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles
au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 11 janvier
2010 au plus tard auprès de KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009152010/755/20.
Adviser II Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 116.177.
Adviser II Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds (LU0331735398)
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am <i>15.1.2010i> um 13.00 Uhr am Gesellschaftssitz in 1B, Parc d'Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, die
AUSSERORDENTLICHE und ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen, die zeitgleich abgehalten werden.
<i>Tagesordnung:i>
1. Beschluss über die Übertragung des Teilfonds "Adviser II Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds" unverändert und
insbesondere unter Beibehaltung der Wertpapierkennnummern und der ISIN-Codes auf die Société d'Investisse-
ment à Capital Variable "ADVISER I FUNDS" mit Sitz in 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Handelsre-
gisternummer RCS Luxemburg B 74.992 mit Wirkung zum 15. Februar 2010. (Der Stichtag der Übertragung ist auf
ein Datum nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen 30-Tagesfrist festgelegt, während der die Aktionäre Ihre
Aktien kostenlos zurückgeben können.)
115682
Die Axxion S.A. wird beauftragt, sämtliche Aufgaben, die in Zusammenhang mit der Einberufung der Durchführung
sowie der Nachbereitung der Generalversammlung stehen, abzuwickeln. Ebenfalls soll die Generalversammlung
von einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitarbeiter der Axxion S.A. eröffnet werden.
Die Banque de Luxembourg (nachfolgend "BDL" genannt) sowie deren technischer Dienstleister European Fund
Administration (nachfolgend "EFA" genannt) wird hiermit mit der administrativen und technischen Durchführung
des Übertrages betraut. KPMG wird als Wirtschaftsprüfer die Übertragung prüfen.
Es ergeben sich folgende wesentliche Änderungen in der Struktur der aufnehmenden Investmentgesellschaft "AD-
VISER I FUNDS":
Adviser I Funds, Sicav
(aufnehmende Struktur)
Albrech & Cie. Optiflex Fonds
Adviser II Funds, Sicav
(abgebende Struktur)
Albrech & Cie. Optiflex Fonds
Verwaltungsratsmitglieder
bis 14. Februar 2010:
Niki Ga-Yu Bat
Jan Ebberg
Thorsten Schwarting
Josef Zellner
ab 15. Februar 2010:
Stephan Albrech
Thomas Amend
Roman Mertes
Winfried Walter
Dr. Josef Zellner
Thorsten Schwarting
Niki Ga-Yu Bat
Jan Ebberg
Zahlstelle in Deutschland
DAB bank AG
(bis zum 14. Februar 2010*)
Landsberger Straße 300
D-80687 München
Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
D-20095 Hamburg
DAB bank AG
Landsberger Straße 300
D-80687 München
Vertriebsstelle
Albrech & Cie. Vermögensverwal-
tung AG
Breite Straße 161-167
D-50667 Köln
DAB bank AG
Landsberger Straße 300
D-80687 München
Albrech & Cie.
Vermögensverwaltung AG
Breite Straße 161-167
D-50667 Köln
Promotor
DAB bank AG (bis 14. Februar 2010)
Axxion SA und
PEH Wertpapier AG
(ab 15. Februar 2010)
DAB bank AG
Ziel ist die verwaltungsmäßige Zusammenführung der Produktpalette von Albrech & Cie. Vermögensverwaltung
AG und die damit einhergehenden Synergieeffekte.
Die übrigen Funktionsträger behalten ihre Funktion weiterhin inne.
2. Beschluss, die Kosten der Übertragung werden dem Teilfonds "Adviser II Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds"
belastet.
3. Beschluss, nach Übertrag des Teilfonds wie unter Pkt 1) beschrieben, die Adviser II Funds, SICAV zu liquidieren.
Alle Kosten des Liquidationsverfahrens werden dem Teilfonds "Adviser II Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds"
belastet.
4. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers.
5. Genehmigung des geprüften Jahresberichts zum 31. August 2009.
6. Ergebniszuweisung.
7. Entlastung des Verwaltungsrates.
8. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates.
9. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers.
10. Verschiedenes.
Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung zu den Tage-
sordnungspunkten 4., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden können.
Bezüglich der Punkte 1., 2. und 3. der Außerordentlichen Generalversammlung müssen die Beschlüsse, gleich welcher
Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist, mit mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre gefasst sein.
115683
Jeder Aktionär kann sich auf der Generalversammlung vertreten lassen.
Aktionäre, die teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten und ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank
unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung eine Depotbestandsbescheinigung, die bes-
tätigt, dass die Aktien bis nach der außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft
zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss fünf Arbeitstage vor der außerordentlichen Generalversammlung
am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Aktionäre, die an der Versammlung nicht teilnehmen können, werden gebeten,
das Stimmrechtsbevollmächtigungsformular auszufüllen und es vor 17.00 Uhr am Tag vor der Versammlung an den Sitz
der Gesellschaft zurückzusenden.
Für die zur ersten Versammlung gültig empfangenen Stimmrechtsvollmachten bezüglich der Punkte 1., 2. und 3. behalten
ihre Wirksamkeit für die zweite Versammlung der Aktionäre, die über die Punkte der ersten Versammlung abstimmt.
Aktionäre, die an dieser außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage
vor dieser außerordentlichen Generalversammlung anzumelden.
Nach der Generalversammlung haben die Aktionäre, die mit der jeweils für sie relevanten Übertragung eines der zuvor
erwähnten Teilfonds und den damit einhergehenden Änderungen nicht einverstanden sind, die Möglichkeit, innerhalb von
30 Tagen ihre Aktien kostenlos an den Fonds zurückzugeben. Der Stichtag der Übertragung ist der 15. Februar 2010.
Luxemburg, im Dezember 2009.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2009152014/6206/101.
Adviser I Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 74.992.
Da in der Außerordentlichen Generalversammlung, die am 1. Dezember 2009 stattgefunden hat, mangels Quorum
nicht gültig beraten werden konnte, werden Sie hiermit eingeladen, an einer 2. Außerordentlichen Generalversammlung
teilzunehmen, die am <i>15. Januar 2010i> um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz in 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
abgehalten wird.
Zeitgleich wird die jährliche Ordentliche Generalversammlung abgehalten, wozu der Verwaltungsrat die Aktionäre
hiermit ebenfalls einlädt.
AUßERORDENTLICHE UND ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
<i>Tagesordnung:i>
1. Beschluss über die Neuwahl des Verwaltungsrates mit folgenden neuen Mitgliedern:
Stephan Albrech
Thomas Amend
Roman Mertes
Winfried Walter
Der neue Verwaltungsrat übernimmt mit Wirkung ab dem 15. Februar 2010 seine Funktion.
2. Beschluss der jeweils abstimmungsberechtigten Aktionäre über die Übertragung der Teilfonds "Adviser I Funds -
Meridio Green Balance" und "Adviser I Funds - Meridio GlobalVision" unverändert und insbesondere unter
Beibehaltung der Wertpapierkennnummern und der ISIN-Codes auf die Société d'Investissement à Capital Variable
"MERIDIO FUNDS" mit Sitz in 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Handelsregisternummer RCS Luxem-
burg B 120.176 mit Wirkung zum 15. Februar 2010.
Es ergeben sich folgende wesentliche Änderungen in der Struktur der aufnehmenden Investmentgesellschaft "ME-
RIDIO FUNDS" für die Teilfonds "Meridio GlobalVision" und "Meridio Green Balance":
Adviser I Funds, Sicav
(abgebender Umbrellafonds)
(Teilfonds Meridio GlobalVision und
Teilfonds Meridio Green Balance)
MERIDIO FUNDS, Sicav
(aufnehmender Umbrellafonds)
(Teilfonds Meridio GlobalVision und
Teilfonds Meridio Green Balance)
Verwaltungsratsmitglieder
bis 14. Februar 2010:
Niki Ga-Yu Bat
Jan Ebberg
Thorsten Schwarting
Josef Zellner
ab 15. Februar 2010:
Stephan Albrech
Thomas Amend
Roman Mertes
Thomas Amend
Roman Mertes
Uwe Zimmer
115684
Winfried Walter
Rashad Khourshid
Zahlstelle in Deutschland
DAB bank AG (bis 14. Februar 2010)
Landsberger Straße 300
D-80687 München
Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
D-20095 Hamburg
Vertriebsstelle
Meridio Vermögensverwaltung AG
DAB bank AG, München
Meridio Vermögensverwaltung AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
D-50968 Köln
Steuerlicher Vertreter in Österreich
Ernst & Young
Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
m.b.H.
Wagramer Str. 19
A-1220 Wien
KPMG Audit
Alpen-Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Porzellangasse 51
A-1090 Wien
Zahlstelle in Österreich
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3
A-1010 Wien
Raiffeisen Zentralbank Österreich
Aktiengesellschaft
Am Stadtpark 9,
A-1030 Wien
Promotor
DAB bank AG (bis 14. Februar 2010)
Axxion S.A. und
PEH Wertpapier AG (ab 15. Februar
2010)
Axxion S.A. und PEH Wertpapier AG
Fondswährung
Teilfondswährung
Konsolidiert EUR
Konsolidiert EUR
Konsolidiert USD
Konsolidiert EUR
Ziel ist die verwaltungsmäßige Zusammenführung der Produktpalette der Meridio Vermögensverwaltung AG und
die damit einhergehenden Synergieeffekte.
Die übrigen Funktionsträger behalten ihre Funktion weiterhin inne.
3. Beschluss, die Kosten der Übertragung jeweils den Teilfonds "Adviser I Funds - Meridio Green Balance" und "Ad-
viser I Funds - Meridio GlobalVision" zu belasten.
4. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers.
5. Genehmigung des geprüften Jahresberichts zum 31. August 2009.
6. Ergebniszuweisung.
7. Entlastung des Verwaltungsrates.
8. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers.
9. Verschiedenes.
Die Axxion S.A. wird beauftragt, sämtliche Aufgaben, die in Zusammenhang mit der Einberufung der Durchführung
sowie der Nachbereitung der Generalversammlung stehen, abzuwickeln. Ebenfalls soll die Generalversammlung von einem
Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitarbeiter der Axxion S.A. eröffnet werden.
Die Banque de Luxembourg (nachfolgend "BDL" genannt) sowie deren technischer Dienstleister European Fund Ad-
ministration (nachfolgend "EFA" genannt) wird hiermit mit der administrativen und technischen Durchführung des
Übertrages betraut. KPMG wird als Wirtschaftsprüfer die Übertragung prüfen.
Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung zu den Tage-
sordnungspunkten 1., 4., 5., 6., 7., 8. und 9. ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden können.
Bezüglich der Punkte 2. und 3. der Außerordentlichen Generalversammlung müssen die Beschlüsse, gleich welcher
Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist, mit mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre gefasst sein.
Jeder Aktionär hat das Recht, an der Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.
Aktionäre, die teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten und ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank
unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die
bestätigt, dass die Aktien bis nach der außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesell-
schaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss fünf Arbeitstage vor der außerordentlichen Generalver-
sammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Aktionäre, die an der Versammlung nicht teilnehmen können,
werden gebeten, das Stimmrechtsbevollmächtigungsformular auszufüllen und es vor 17.00 Uhr am Tag vor der Ver-
sammlung an den Sitz der Gesellschaft zurückzusenden.
Die zur ersten Versammlung gültig empfangenen Stimmrechtsvollmachten behalten ihre Wirksamkeit bezüglich der
Punkte 1., 2. und 3. für die zweite außerordentliche Versammlung der Aktionäre. Aktionäre, die an dieser außerordent-
lichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor dieser außerordentlichen Gene-
ralversammlung anzumelden.
115685
Nach der Generalversammlung haben die Aktionäre, die mit der jeweils für sie relevanten Übertragung eines der zuvor
erwähnten Teilfonds und den damit einhergehenden Änderungen nicht einverstanden sind, die Möglichkeit, innerhalb von
30 Tagen ihre Aktien kostenlos an den Fonds zurückzugeben. Der Stichtag der Übertragung ist der 15. Februar 2010.
Luxemburg, im Dezember 2009.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2009152015/6206/111.
Spring Multiple 2007 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 116.416.
Le Gérant Commandité a l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
tenant lieu d'Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu le <i>28 décembre 2009i> à 11.00 heures au siège social, avec
l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 août 2008 et au 31 août 2009, et affectation des
résultats.
3. Décharge à donner au Gérant Commandité, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d'Entreprises pour l'exercice
de leur mandat au 31 août 2009.
4. Divers.
SPRING MULTIPLE Sàrl
<i>Gérant Commanditéi>
Référence de publication: 2009152012/1023/19.
UBP Multifunds II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 98.691.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société qui aura lieu le <i>29 décembre 2009i> à 9:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 10 pour enlever la mention que la première assemblée générale annuelle des actionnaires
se tient en 2005.
2. Modification de l'article 22 pour adapter et compléter la liste des circonstances dans lesquelles le calcul de la valeur
nette d'inventaire peut être suspendu.
3. Modification de l'article 23 pour adapter la méthodologie d'évaluation des avoirs de la Société.
4. Modification de l'article 26 pour enlever la mention que la première année sociale commence le jour de la consti-
tution et se termine le 31 décembre 2004.
5. Remplacement du terme 'Sous-Fonds' par le terme 'Compartiment'
6. Divers
Les décisions concernant les points à l'ordre du jour requièrent un quorum de 50%. Les décisions seront prises à la
majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires
au porteur sont priés de déposer leurs actions pour le 23 décembre 2009 au plus tard au siège de Union Bancaire Privée
(Luxembourg) S.A., 18 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
<i>Le Conseil d'Administration de UBP MULTIFUNDS IIi>
Référence de publication: 2009145651/755/24.
Valauchan Caisse Auchan Italie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 115.266.
Les actionnaires de la Société sont priés d'assister à:
115686
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la Société le lundi <i>28 décembre 2009i> à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Augmentation du montant du capital autorisé à concurrence d'un montant de QUARANTE MILLIONS D'EUROS
(EUR 40.000.000.-), lequel sera porté de la somme actuelle de QUARANTE MILLIONS D'EUROS (EUR
40.000.000.-) à la somme de QUATRE-VINGT MILLIONS D'EUROS (EUR 80.000.000.-), et modification subsé-
quente de l'article 5 des statuts de la Société;
b. Renouvellement, pour une période de 5 ans, de l'autorisation accordée à la Gérance en ce qui concerne l'émission
d'actions ordinaires nouvelles dans le cadre du capital autorisé, laquelle sera alors valable jusqu'en 2014, et modi-
fication subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
c. Augmentation en une fois par un apport en numéraire du capital social de la Société à concurrence d'un montant
de DIX MILLIONS SIX CENT TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS (EUR 10.638.730.-) pour porter
le capital social de son montant actuel de TRENTE-SEPT MILLIONS HUIT MILLE CINQ CENT VINGT EUROS
(EUR 37.008.520.-) à la somme de QUARANTE-SEPT MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX
CENT CINQUANTE EUROS (EUR 47.647.250.-) par l'émission D'UN MILLION SOIXANTE-TROIS MILLE HUIT
CENT SOIXANTE-TREIZE (1.063.873) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR
10.-) chacune, émises avec une prime d'émission de QUARANTE-SIX CENTIMES D'EUROS (EUR 0,46.-) par action,
soit une prime d'émission totale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-
VINGT-UN EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (EUR 489.381,58.-), et modification subséquente des
dispositions de l'article 5 des statuts de la Société;
d. Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires commanditaires de la Société quant à l'émission
des actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital envisagée au point (c) de
l'ordre du jour;
e. Admission de l'actionnaire commandité, CAISSE AUCHAN ITALIE, une société anonyme de droit belge, établie et
ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, rue des quatre bras, 6, immatriculée au Registre de Commerce de
Bruxelles sous le numéro 0879.996.173, à la souscription de la totalité des actions ordinaires nouvelles à émettre
dans le cadre de l'augmentation de capital envisagée au point (c) de l'ordre du jour;
f. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société laquelle sera désormais fixée
au deuxième vendredi du mois d'avril à 15.00 heures, et modification subséquente de l'article 15 des statuts de la
Société;
g. Attribution d'un pouvoir individuel à Monsieur Laurent Fisch et/ou Monsieur Michel Molitor et/ou Monsieur Olivier
Gaston-Braud et/ou Mademoiselle Stéphanie Juan, juristes, demeurant tous les quatre professionnellement à L-2673
Luxembourg, rue Sainte-Zithe, 8, chacun avec pouvoirs de substitution, aux fins de faire constater devant notaire
au nom et pour le compte des actionnaires de la Société l'ensemble des éléments indiqués ci-dessus, ainsi que pour
procéder aux modifications nécessaires des articles 5 et 15 des statuts de la Société;
h. Divers.
La présente convocation fait suite à une première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
convoquée et tenue le 20 novembre 2009 à 16.00 heures au siège social de la Société, à l'occasion de laquelle le quorum
de présence exigé par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
et fixé à 50% du capital social, n'a pas été atteint. En conséquence, il a été décidé de convoquer une seconde assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société.
<i>Le Gérant.i>
Référence de publication: 2009146039/321/49.
BDM Technologies Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 72.794.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 décembre 2009i> à 10.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2
ème
étage) avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2008 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
115687
6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société
par ses actionnaires;
7. Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au
bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009146195/693/22.
B & B Bepuvo Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 62.896.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 décembre 2009i> à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2
ème
étage) avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2008 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société
par ses actionnaires;
7. Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au
bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009146196/693/22.
China Corn Oil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 134.716.
All the shareholders of the company are convened to the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
that will be held at the registered office, on <i>December 22, 2009i> at 2.00 pm, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of a liquidator.
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and determination of the remuneration of the liquidator.
4. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor.
5. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009147859/565/16.
Elektra Finanzierung A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 41.610.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
115688
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 décembre 2009i> à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2009148477/29/16.
UBS (Lux) Exposure Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 116.032.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am Montag, <i>21. Dezember 2009,i> um 10:00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung statt-
finden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. August 2009.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schrift-
licher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 15. Dezember
2009, spätestens 16:00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der
Gesellschaft eingehen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2009149015/755/25.
UBS (Lux) Structured Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.286.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am Montag, den <i>21. Dezember 2009,i> um 10:00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung
stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. August 2009.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schrift-
licher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
115689
Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 15. Dezember
2009, spätestens 16:00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der
Gesellschaft eingehen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2009149016/755/25.
UBS (Lux) Structured Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 102.240.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am Montag, <i>21. Dezember 2009,i> um 11:00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung statt-
finden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. August 2009.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer
7. Diverses.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schrift-
licher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 15. Dezember
2009, spätestens 16:00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der
Gesellschaft eingehen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2009149017/755/25.
Transworld Fertilizers Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 60.745.
In the year two thousand and nine, on the ninth of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company "TRANSWORLD FERTILIZERS
HOLDING S.A.", a public limited liability company (Société anonyme) incorporated and existing under the laws of Lu-
xembourg, having its registered office at 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 60.745, incorporated pursuant
to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, dated August 28
th
, 1997, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 689 of December 9
th
, 1997 (the "Company").
The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Lecuit, notary
residing in Luxembourg, dated June 11
th
, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
923 of September 16
th
, 2004.
The meeting is chaired by Ms. Sophie Liberatore, employee with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg.
The chairman appointed as secretary Mr. Gauthier Mary, employee with professional address at 1B Heienhaff, L-1736
Senningerberg and
as scrutineer Mr. Fabrice Meeuwis, employee with professional address at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary
to state that:
115690
I. The shareholders represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list, signed by the proxies of the shareholders represented, the chairman, the secretary, the scrutineer and
the undersigned notary. The said list shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The proxies given by the represented shareholders, after having been initialed "ne varietur" by the chairman, the
secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the
registration authorities.
II. The chairman informed the meeting that the present extraordinary general meeting will validly deliberate only if at
least fifty percent (50%) of the issued share capital is present or represented and that resolutions will be validly adopted
if approved by at least two thirds (2/3) of the votes cast at the meeting with the exception of the resolution on item 2
of the agenda, which may be passed by a simple majority of the votes cast at the meeting without any quorum.
III. As it appears from the attendance list, out of the total of one thousand (1,000) shares representing the entire share
capital of the Company, one thousand (1,000) shares are represented at the present extraordinary general meeting
representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company. As the shares represented represent
more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, the meeting is thus validly constituted and can validly
deliberate and resolve on all the items of the agenda.
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. Approval of the merger whereby the Company shall merge into Eurofert Investments L.L.C., a limited liability
company organised under the laws of the State of Delaware, U.S.A., having its registered office in the State of Delaware
c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808,
registered with the Delaware Secretary of State under registration No. 4657323, by way of absorption by Eurofert
Investments L.L.C. of the Company and without liquidation of the Company (the "Merger"), as contemplated by: (i) the
merger proposal as filed, together with the applicable documents, with the Luxembourg Trade and Companies Register
and as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1949 of October 7
th
, 2009; and (ii)
the explanatory memorandum to the aforementioned merger proposal, which approval expressly includes an approval
to transfer all assets and liabilities of the Company to Eurofert Investments L.L.C. and the dissolution without liquidation
of the Company and which designates the effective date of the Merger;
2. Discharge to the directors and the auditor of the Company and determination of the place where the books and
records of the Company will be kept for a period of five (5) years.
V. The provisions of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10
th
, 1915, as amended (the "LSC"),
relating to mergers have been respected as follows:
1. Being under the simplified, cross-border merger legal regime, all the shareholders of the Company and the sole
member of Eurofert Investments L.L.C. have found out and decided that the Merger will be performed without the need
for having the joint merger proposal examined by an independent expert and without having a written report prepared
by an independent expert. All the shareholders of the Company have declared to agree to be allocated the respective
number of units in Eurofert Investments L.L.C. as expressly provided for in sections 1 and 6 of the Merger Proposal (as
defined hereafter).
2. The merger proposal as jointly drawn up by the board of directors of the Company and by the sole member of
Eurofert Investments L.L.C. (Eurofert Investments L.L.C. and the Company being hereafter referred to as the "Merging
Companies") and as signed on September 29
th
, 2009, has been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register
and has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 7
th
, 2009, at least one
month before the date of the written consent of the sole member of Eurofert Investments L.L.C. convened to resolve
upon the Merger and also before the date hereof (the "Merger Proposal").
It is to take notice that further to a clerical error, the family name of Mr Adnan CHABAN shall read everywhere in
the Merger Proposal as "CHABAN" and not "KEMALOGLU".
3. An explanatory memorandum has been jointly drawn up by the board of directors of the Company and by the sole
member of Eurofert Investments L.L.C., which has been approved on September 4
th
, 2009, describing the reasons for
the Merger, the exchange ratio and any legal, economic and social related implications of the Merger (the "Explanatory
Memorandum"). A copy of this Explanatory Memorandum, after having been signed "ne varietur" by the chairman, the
secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the
registration authorities.
4. The Explanatory Memorandum, together with the respective documents required pursuant to article 267 of the
LSC, have been deposited at the registered office or principal place of business of each of the Merging Companies for
inspection by the shareholders of the Company and by the sole member of Eurofert Investments L.L.C. on October 7
th
, 2009, at least one month prior to the date hereof and also prior to the date of the written consent of the sole member
of Eurofert Investments L.L.C.. An attestation from each of the Merging Companies certifying as to the availability of these
documents, after having been signed "ne varietur" by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned
notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
VI. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the shareholders, the chairman submitted to
the vote of the shareholders the following resolutions:
115691
<i>First resolutioni>
The shareholders, after having reviewed the Merger Proposal dated September 29
th
, 2009 and the Explanatory
Memorandum dated September 4
th
, 2009, both jointly drawn up by the board of directors of the Company and by the
sole member of Eurofert Investments L.L.C. in accordance with articles 261 and 265 of the LSC and with §18-209 of the
Delaware Limited Liability Company Act, approve the Merger with effect from the date hereof conditioned on the filing
of the certificate of merger by the authorised individual of Eurofert Investments L.L.C. in the office of the Delaware
Secretary of State (the "Effective Date"), as contemplated by the Merger Proposal and the Explanatory Memorandum.
The shareholders decide to transfer all the assets and liabilities of the Company to Eurofert Investments L.L.C. with
effect as of the Effective Date.
The units of membership interests to be issued by Eurofert Investments L.L.C. in consideration for the transfer by
operation of law of all the assets and liabilities of the Company to Eurofert Investments L.L.C. will be allocated on the
Effective Date directly to the shareholders of the Company in proportion to their holding in the Company, as follows:
one (1) new unit of membership interests of Eurofert Investments L.L.C. for ten (10) Company's shares to the holders
of the Company's shares existing at such time as contemplated by the Merger Proposal and the Explanatory Memorandum.
In payment of all liabilities owed by the Company to its shareholders, Eurofert Investments L.L.C. will further issue
one (1) unit of membership interest for approximately each US Dollar (USD 1,-) of payable toward the shareholders, as
contemplated and further specified in the Merger Proposal.
The shareholders further decide that the Company shall be dissolved without liquidation on the Effective Date, all the
assets and liabilities of the Company being transferred to Eurofert Investments L.L.C. on the Effective Date.
The shareholders finally state that the Merger and all other matters referred to in the present resolution shall be
effective on the date hereof, conditioned on the filing of the certificate of merger by the authorised individual of Eurofert
Investments L.L.C. in the office of the Delaware Secretary of State.
For: 1,000 votes
Against: 0 vote
Abstention: 0 vote
This resolution was thus adopted unanimously.
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to discharge the directors and the auditor of the Company from any liability resulting from
the performance of their duty up to the Effective Date and decide that the books and records of the Company shall be
kept for a period of five (5) years from the Effective Date at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.
The shareholders state that this resolution shall be effective on the date hereof, conditioned on the filing of the
certificate of merger by the authorised individual of Eurofert Investments L.L.C. in the office of the Delaware Secretary
of State.
For: 1,000 votes
Against: 0 vote
Abstention: 0 vote
This resolution was thus adopted unanimously.
<i>Declarationi>
In accordance with article 271 (2) of the LSC, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence
and validity of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to realise the Merger and the validity of
the Merger Proposal.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
A copy of the agenda and of the proposed resolutions has been remitted to each shareholder and each proxy holder
present before the beginning of the meeting.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French version, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the shareholders represented by their proxyholder, the members of the bureau,
known to the notary by their surnames, given names, civil status and residences, signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mil neuf, le neuf novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "TRANSWORLD FERTILIZERS HOLD-
ING S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
115692
bourg, section B, sous le numéro 60.745, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à
Niederanven, reçu le 28 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 689 du 9 dé-
cembre 1997 (la "Société").
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg, reçu le 11 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 923 du 16 sep-
tembre 2004.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sophie Liberatore, employée, ayant son adresse profes-
sionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Le président désigne comme secrétaire M. Gauthier Mary, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff,
L-1736 Senningerberg et
comme scrutateur M. Fabrice Meeuwis, employé, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469
Luxembourg.
Le bureau de la réunion étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire soussigné d'acter que:
I. Les actionnaires représentés, leurs mandataires et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont mentionnés
sur la liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés, le président, le secrétaire, le scrutateur
et le notaire soussigné. Ladite liste sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregis-
trement.
Les procurations accordées par les actionnaires représentés, après avoir été émargées "ne varietur" par le président,
le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
II. Le président a rappelé que la présente réunion de l'assemblée générale extraordinaire va délibérer valablement à
condition qu'au moins cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société soit présent ou représenté et que les
résolutions seront valablement prises si approuvées par au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées en réunion à
l'exception de la résolution sur le deuxième point de l'ordre du jour, qui pourrait être prise par une majorité simple des
voix exprimées en réunion sans quorum.
III. Tel qu'il résulte de la liste de présence, sur un total de mille (1.000) actions représentant la totalité du capital social
de la Société, mille (1.000) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire représentant cent
pour cent (100%) du capital social de la Société. Comme les actions représentées représentent plus de cinquante pour
cent (50%) du capital social de la Société, la réunion est ainsi valablement constituée et peut délibérer valablement et
prendre des résolutions sur tous les points de l'ordre du jour.
IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Approbation de la fusion par laquelle la Société va fusionner avec Eurofert Investments L.L.C., une société à res-
ponsabilité limitée (limited liability company) régie par le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son
siège social dans l'Etat du Delaware c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19808, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware sous le numéro 4657323,
par voie d'absorption de la Société par Eurofert Investments L.L.C. et sans liquidation de la Société (la "Fusion"), tel
qu'envisagé par: (i) le projet commun de fusion tel que déposé, ainsi que les documents applicables, auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1949 du 7 octobre 2009, et (ii) le mémorandum explicatif dudit projet de fusion, approbation qui comprend une
acceptation expresse du transfert de la totalité de l'actif et du passif de la Société à Eurofert Investments L.L.C. et de la
dissolution sans liquidation de la Société et qui désigne la date d'effet juridique et comptable de la Fusion;
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société et détermination de la place où les livres
de comptes et les dossiers de la Société seront gardés pour une période de cinq (5) années.
V. Les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la
"LSC"), concernant les fusions ont été respectées comme suit:
1. S'agissant d'une fusion transfrontalière simplifiée, tous les actionnaires de la Société et l'associé unique d'Eurofert
Investments L.L.C. ont établi et décidé que la Fusion serait faite sans qu'il soit besoin que le projet commun de fusion soit
examiné par un expert indépendant et sans avoir un rapport écrit concernant les conditions de la fusion rédigé par un
expert indépendant. Tous les actionnaires de la Société ont déclaré accepter l'émission à leur profit du nombre respectif
de parts d'Eurofert Investments L.L.C. établi expressément dans les articles 1 et 6 du Projet Commun de Fusion (tel que
défini ci-après).
2. Le projet commun de fusion tel que rédigé conjointement par le conseil d'administration de la Société et par l'associé
unique d'Eurofert Investments L.L.C. (Eurofert Investments L.L.C. et la Société étant ci-après dénommées les "Sociétés
Fusionnantes") et tel que signé le 29 septembre 2009, a été déposé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 7 octobre 2009, un mois au moins avant la
date de l'accord écrit de l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C. convoqué afin de décider de la Fusion et également
avant la date des présentes (le "Projet Commun de Fusion").
Il est à noter que suite à une erreur matérielle, le patronyme de M. Adnan CHABAN se lira partout dans le Projet
Commun de Fusion "CHABAN" au lieu de "KEMALOGLU".
115693
3. Un mémorandum explicatif a été rédigé conjointement par le conseil d'administration de la Société et par l'associé
unique d'Eurofert Investments L.L.C., qui a été approuvé le 4 septembre 2009, décrivant les raisons de la Fusion, le rapport
d'échange, et toute implication de nature juridique, économique et sociale de la Fusion (le "Mémorandum Explicatif").
Une copie de ce Mémorandum Explicatif, après avoir été signée "ne varietur" par le président, le secrétaire, le scrutateur
et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
4. Le Mémorandum Explicatif, ainsi que les documents requis conformément à l'article 267 de la LSC, ont été déposés
au siège social, respectivement au principal établissement de chaque Société Fusionnante, pour examen par les actionnaires
de la Société et par l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C. le 7 octobre 2009, un mois au moins avant la date des
présentes et avant la date de l'accord écrit de l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C.. Une attestation de la part
de chaque Société Fusionnante certifiant la disponibilité de ces documents, après avoir été signée "ne varietur" par le
président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui
aux formalités de l'enregistrement.
VI. Ceci ayant été exposé par le président et approuvé par les actionnaires, le président a soumis au vote des action-
naires les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires, après avoir revu le Projet de Fusion du 29 septembre 2009 et le Mémorandum Explicatif du 4 sep-
tembre 2009, tout deux rédigés conjointement par le conseil d'administration de la Société et par l'associé unique
d'Eurofert Investments L.L.C. conformément aux articles 261 et 265 de la LSC et §18-209 de la loi sur les sociétés à
responsabilité limitée du Delaware, approuvent la Fusion qui prend effet à compter de la date des présentes sous réserve
du dépôt d'un certificat de fusion par un représentant d'Eurofert Investments L.L.C. auprès du bureau du Secrétariat
d'État du Delaware (la "Date d'Effet"), tel qu'envisagé par le Projet de Fusion et par le Mémorandum Explicatif.
Les actionnaires décident de transférer la totalité de l'actif et du passif de la Société à Eurofert Investments L.L.C. avec
effet à la Date d'Effet de la Fusion.
Les parts émises par Eurofert Investments L.L.C. en considération de la transmission de plein droit de la totalité de
l'actif et du passif de la Société à Eurofert Investments L.L.C. seront distribuées à la Date d'Effet directement aux action-
naires de la Société proportionnellement à leur participation dans la Société, comme suit: une (1) part nouvelle d'Eurofert
Investments L.L.C. pour dix (10) parts de la Société aux titulaires d'actions de la Société existants, tel qu'envisagé par le
Projet de Fusion et le Mémorandum Explicatif.
En paiement de toutes les dettes que la Société a envers ses actionnaires, Eurofert Investments L.L.C. émettra en outre
une (1) part pour environ chaque Dollar Américain (USD 1,-) de dette due aux actionnaires, comme envisagé et décrit
plus en détails dans le Projet Commun de Fusion.
Les actionnaires décident ensuite que la Société sera dissoute sans liquidation à la Date d'Effet, la totalité de l'actif et
du passif de la Société étant transférée à Eurofert Investments L.L.C. à la Date d'Effet.
Enfin, les actionnaires exposent que la Fusion et tous les autres points mentionnés dans la présente résolution pren-
dront effet à la date des présentes, sous réserve du dépôt d'un certificat de fusion par un représentant d'Eurofert
Investments L.L.C. auprès du bureau du Secrétariat d'Etat du Delaware.
Pour: 1.000 voix
Contre: 0 voix
Abstention: 0 voix
Ainsi la présente résolution a été adoptée à l'unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exercice de leur mandat jusqu'à la Date d'Effet et décident que les livres de comptes et les dossiers de la Société seront
gardés pour une période de cinq (5) années à compter de la Date d'Effet au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.
Les actionnaires exposent que la présente résolution prendra effet à la date des présentes sous réserve du dépôt d'un
certificat de fusion par un représentant d'Eurofert Investments L.L.C. auprès du bureau du Secrétariat d'État du Delaware.
Pour: 1.000 voix
Contre: 0 voix
Abstention: 0 voix
Ainsi la présente résolution a été adoptée à l'unanimité.
<i>Déclarationi>
Conformément à l'article 271 (2) de la LSC, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et certifie l'existence et la validité
des actes et des formalités imposés à la Société pour réaliser la Fusion ainsi que celles du Projet Commun de Fusion.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Une copie de l'ordre du jour et des résolutions proposées a été remise à chaque mandataire présent avant le début
de la séance.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, constate par les présentes, qu'à la demande des personnes
comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes personnes et
en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
115694
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée au début de ce document.
Après lecture du document faite aux comparants, les membres du bureau, connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états civils et résidences, ont signé, ainsi que le notaire, le présent acte.
Signé: S. Liberatore, G. Mary, F. Meeuwis et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 novembre 2009. Relation: LAC/2009/48699. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009151311/262.
(090188085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.
GFA - HAIG, Fonds Commun de Placement.
<i>Sonderreglementi>
Das Sondervermögen GFA - HAIG wurde von der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. nach Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die
Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. De-
zember 1985.
Für den GFA - HAIG ist das allgemeine Verwaltungsreglement, das am 7. Dezember 2009 in Kraft trat, integraler
Bestandteil. Dieses Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxembourg hinterlegt, und
der diesbezügliche Hinterlegungsvermerk wurde am 11. Dezember 2009 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, veröffentlicht.
Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des Sonderreglements des GFA - HAIG, das am 7. Dezember
2009 in Kraft tritt und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.
Luxemburg, den 7. Dezember 2009.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009148125/19.
(090182117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.010.
VERSCHMELZUNGSPLAN
Verschmelzung durch Aufnahme der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 6
S.à r.l. in die deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH.
Die Geschäftsführung der Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 6 S.à r.l. (nachstehend: übertragende Gesellschaft)
und die Geschäftsführung der DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH (nachstehend: übernehmende Gesellschaft, ge-
meinsam mit der übertragenden Gesellschaft als die Gesellschaften bezeichnet) haben entschieden, den folgende
Verschmelzungsplan gemäß
(i) §§ 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (nachstehend: UmwG),
(ii) Artikel. 261 und 278 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden
Fassung (nachstehend: "Luxemburgisches Gesetz"),
(iii) der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (nachstehend: "Verschmelzungsrichtlinie")
aufzustellen und den Verschmelzungsplan ihren jeweiligen Gesellschafterversammlungen zu unterbreiten.
ERFORDERNISSE NACH LUXEMBURGISCHEM UND DEUTSCHEM RECHT:
I. Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften (Art. 5 a) der Verschmelzungsrichtlinie)
Die übernehmende Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB
83499. Die übernehmende Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde des Notars Dr. Thomas Engel, München, vom
115695
20. Mai 2008 errichtet. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,- und es ist vollständig erbracht. Gemäß dem Gesell-
schaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft ist deren Unternehmensgegenstand die Vermögensverwaltung, der
Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben und Hand-
lungen vornehmen, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft darf
andere Unternehmen übernehmen, sie darf sich an Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Ge-
sellschafterin. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma errichten.
Gemäß § 122b Abs. 1 UmwG i. V. m. Art. 4 Abs. 1 lit a) der Verschmelzungsrichtlinie ist die grenzüberschreitende
Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf eine andere Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu-
lässig, so dass die übernehmende Gesellschaft Teilnehmer einer grenzüberschreitenden Verschmelzung sein kann.
Die übertragende Gesellschaft ist eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, errichtet nach luxem-
burgischem Recht, mit Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg unter B 134.010, gegründet gemäß notarieller Urkunde des Maître Jean Seckler, Notar,
Junglinster (Großherzogtum von Luxemburg), vom 20. November 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations vom 28. Dezember 2007, Nr. 3013, S. 144600. Das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft beträgt
EUR 12.500,-. Die übernehmende Gesellschaft hält alle 500 (fünfhundert) Stammanteile mit einem Nennwert von EUR
25,- (fünfundzwanzig Euros) je Anteil am Stammkapital von insgesamt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euros) an
der übertragenden Gesellschaft, die von ihr übernommen und vollständig eingezahlt worden sind. Bei der übertragenden
Gesellschaft bestehen keine Sonderechte entsprechend § 23 UmwG. Nach dem geltenden innerstaatlichen luxemburgi-
schen Recht, insbesondere Art. 257 des Luxemburgischen Gesetzes, ist die Verschmelzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung auf eine andere Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig. Die übertragende Gesellschaft kann
daher gem. § 122b Abs. 1 UmwG i. V. m. Art. 4 Abs. 1 lit. a) der Verschmelzungsrichtlinie auch an einer grenzübers-
chreitenden Verschmelzung teilnehmen.
II. Verschmelzung
Die übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung
ohne Abwicklung auf die übernehmende Gesellschaft im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung mit einer
bestehenden Gesellschaft ohne die Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft (Verschmelzung durch
Aufnahme) gemäß § 122a UmwG und Art. 278 des Luxemburgischen Gesetzes, insbesondere Art. 274 Abs. 1 lit. a) des
Luxemburgischen Gesetzes, sowie in Übereinstimmung mit diesem Verschmelzungsplan (Verschmelzung).
Die Übertragung beinhaltet sämtliche (bekannten und unbekannten) Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der
übertragenden Gesellschaft zum Zeitpunkt der dieser Verschmelzung zustimmenden Gesellschafterversammlung. Mit
Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft ("rechtlicher Verschmelzungss-
tichtag") gehen sämtliche Aktiva und Passiva auf die übernehmende Gesellschaft von Rechts wegen im Innen- und
Außenverhältnis über.
Die übertragende Gesellschaft garantiert der übernehmenden Gesellschaft, dass die aufgrund der Verschmelzung
übertragenen Forderungen bestehen, garantiert jedoch nicht die Zahlungsfähigkeit der jeweiligen Schuldner.
Die übernehmende Gesellschaft übernimmt ab dem rechtlichen Verschmelzungsstichtag die Zahlung sämtlicher
Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und Versicherungsprämien, die hinsichtlich des Eigentums der übertragenen Ver-
mögenswerte fällig sind oder werden.
Ab dem rechtlichen Verschmelzungsstichtag erfüllt die übernehmende Gesellschaft sämtliche Vereinbarungen und
Verpflichtungen jeglicher Art, die von der übertragenden Gesellschaft eingegangen worden sind.
Die sich aus den Vermögenswerten der übertragenden Gesellschaft ergebenden Rechte und Ansprüche gehen auf die
übernehmende Gesellschaft mit sämtlichen dinglichen und schuldrechtlichen Sicherheiten über. Die übernehmende Ge-
sellschaft tritt somit ohne Forderungsübertragung in alle dinglichen und schuldrechtlichen Rechte aus sämtlichen Ver-
mögenswerten und im Verhältnis zu sämtlichen Schuldnern ohne Ausnahme ein.
Die übernehmende Gesellschaft übernimmt sämtliche Schulden und Verbindlichkeiten jeglicher Art der übertragenden
Gesellschaft. Insbesondere übernimmt sie die Zahlung von Kapital und Zinsen auf sämtliche Schulden und Verbindlich-
keiten jeglicher Art, die von der übertragenden Gesellschaft eingegangen worden sind.
Sämtliche Unterlagen der übertragenden Gesellschaft sind am Sitz der übernehmenden Gesellschaft in Übereinstim-
mung mit den dort geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufzubewahren.
Die Mandate der Mitglieder der Geschäftsführung sowie etwaiger Abschlussprüfer der übertragenden Gesellschaft
werden zum rechtlichen Verschmelzungsstichtag beendet. Den Mitgliedern der Geschäftsführung sowie den Abschluss-
prüfern wird für die Erfüllung ihres Mandats jeweils vollständige Entlastung erteilt.
III. Neue Anteile (Art. 5 lit. b), c) und e) der Verschmelzungsrichtlinie)
Da die übernehmende Gesellschaft alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, erfolgt keine Gewäh-
rung von Geschäftsanteilen an der übernehmenden Gesellschaft oder sonstige Gegenleistungen für die Übertragung des
Aktiv- und Passivvermögens gemäß § 122c Abs. 3 UmwG. Somit sind keine besonderen Angaben gemäß § 122c Abs. 2
Nr. 2, 3 und 5 UmwG, Art. 5 lit. b) c) und e) der Verschmelzungsrichtlinie erforderlich.
IV. Zustimmung der Gesellschafter
115696
Die Verschmelzung unterliegt der Zustimmung der Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft gemäß §§ 122g
Abs. 1 und 13 UmwG.
Weiterhin unterliegt die Verschmelzung der Zustimmung der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gemäß
Art. 263 des Luxemburgischen Gesetzes. Die Geschäftsführung der übertragenden Gesellschaft wird für die Zwecke des
Art. 263 des Luxemburgischen Gesetzes so schnell wie möglich nach Ablauf eines Monats nach Anmeldung und Veröf-
fentlichung des vorliegenden Verschmelzungsvorhabens gemäß Art. 9 und 262 des Luxemburgischen Gesetzes eine
außerordentliche Gesellschafterversammlung vor einem luxemburgischen Notar zur Erteilung der Zustimmung zu der
Verschmelzung gemäß des vorliegenden Verschmelzungsvorhabens einberufen.
Die Geschäftsführungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften haben der Verschmelzung jeweils bereits
zugestimmt.
V. Abfindungsangebot
Ein Abfindungsangebot gemäß § 122 i UmwG ist nicht erforderlich, da es sich bei der übernehmenden Gesellschaft (als
aufnehmendem Rechtsträger) um eine Gesellschaft nach deutschem Recht handelt. Ein Abfindungsangebot ist auch nicht
gemäß §§ 122a Abs. 2 und 29 Abs. 1 UmwG erforderlich, da sich sämtliche Geschäftsanteile der übertragenden Gesellschaft
(als übertragendem Rechtsträger) in der Hand der übernehmenden Gesellschaft (als aufnehmendem Rechtsträger) be-
finden. Die übernehmende Gesellschaft wird als Alleingesellschafter des übertragenden Gesellschafters in der über die
Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlung vorsorglich auf sämtliche Rechte bezüglich eines Abfindung-
sangebots verzichten.
VI. Verschmelzungsstichtag unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung (Art. 5 lit. f) der Verschmelzungsrichtlinie)
und verwendeten Bilanzstichtage (Art. 5 lit. l) der Verschmelzungsrichtlinie)
Mit Bezug auf die übernehmende Gesellschaft wird die Übernahme des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden
Gesellschaft mit Ablauf des 30. Juni 2009 (24.00 Uhr) wirksam. Ab dem 1. Juli 2009 (00.00 Uhr) gelten sämtliche Hand-
lungen der übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen ("Verschmel-
zungsstichtag" gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG, Art. 5 lit. f) der Verschmelzungsrichtlinie).
Der Verschmelzung wird eine Bilanz der übertragenden Gesellschaft zum 30. Juni 2009 (Schlussbilanz) zu Grunde
gelegt, aus der sich die Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft zum 30. Juni 2009
(Bilanzstichtag der übergehenden Gesellschaft) ergibt.
Der Bilanzstichtag der übernehmenden Gesellschaft ist der 31. Dezember 2009. Da jedoch im Verlauf der Versch-
melzung weder ein Austausch von Anteilen stattfindet noch eine sonstige Gegenleistung für die Übertragung des Aktiv-
und Passivvermögens erfolgt, ist der Jahresabschluss der übernehmenden Gesellschaft zur Bestimmung der Verhältnisse
der grenzüberschreitenden Verschmelzung im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 12 UmwG, Art. 5 lit. l) der Verschmelzungs-
richtlinie nicht erforderlich.
VII. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens (Art. 5 lit. k) der Verschmelzungsrichtlinie)
Das übertragene Aktiv- und Passivvermögen wird zu Buchwerten in der Bilanz der übernehmenden Gesellschaft wei-
tergeführt (§ 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG, Art. 5 lit. k) Verschmelzungsrichtlinie).
Da sich sämtliche Geschäftsanteile der übertragenden Gesellschaft in der Hand der übernehmenden Gesellschaft be-
finden, ist eine Verschmelzungsprüfung oder ein Prüfungsbericht nicht erforderlich (§§ 122f und 9 Abs. 2 UmwG; Art.
278 des Luxemburgischen Gesetzes).
VIII. Sonderrechte und besondere Vorteile (Art. 5 lit. g), h) der Verschmelzungsrichtlinie)
Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erklären, dass die übertragende Gesellschaft außer den von der
übernehmenden Gesellschaft an ihrem Stammkapital gehaltenen Geschäftsanteile keine Wertpapiere an andere Personen
ausgegeben hat. Es bestehen keine Sonderrechte betreffend die Gesellschaften und es werden den Gesellschaftern auch
keine Sonderrechte im Zusammenhang mit der Verschmelzung gewährt, zudem werden diesen Personen auch gemäß §
122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG, Art. 5 lit. g) h) der Verschmelzungsrichtlinie und Art. 261 (2) f) und g) des Luxemburgischen
Gesetzes keine Maßnahmen vorgeschlagen.
Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erklären, dass den Geschäftsführern oder sonstigen Personen
gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und Art. 261 Abs. 2 lit. g) des Luxemburgischen Gesetzes keine besonderen Vorteile
oder Leistungen gewährt werden.
IX. Auswirkung der Verschmelzung auf die Beschäftigung und die Arbeitnehmermitbestimmung (Art. 5 lit. d) und j)
der Verschmelzungsrichtlinie)
Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft beschäftigt Arbeitnehmer. Aus diesem
Grund können keine Angaben zu den voraussichtlichen Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die
Beschäftigung (§ 122c Abs. 2 Nr. 4 UmwG) gemacht werden.
Auch Angaben zu mitbestimmungsrechtlichen Fragen (§ 122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG) entfallen, weil bei den an der
Verschmelzung beteiligten Gesellschaften weder vor noch nach der grenzüberschreitenden Verschmelzung Mitbestim-
mungsrechte oder ein der Mitbestimmung unterliegendes Gremium bestehen oder einzurichten sind.
X. Einziehung der Anteile und Auflösung ohne Abwicklung der übertragenden Gesellschaft
115697
Mit Wirkung zum rechtlichen Verschmelzungsstichtag werden die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen
Anteile an der übertragenden Gesellschaft eingezogen und die Gesellschaft besteht nicht weiter fort.
XI. Zusätzliche Bestimmungen und Satzung der übernehmenden Gesellschaft (Art. 5 lit. i) der Verschmelzungsrichtlinie)
Die Kosten der Verschmelzung werden von der übernehmenden Gesellschaft getragen. Bezüglich etwaiger Grunder-
werbsteuern erklären die Parteien, dass die übertragende Gesellschaft keinen Grundbesitz hat.
Der Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft besteht nach der Verschmelzung unverändert fort und ist
als Anhang 1 beigefügt.
Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften verpflichten sich gegenseitig zur Mitwirkung bei der Durchführung
der Verschmelzung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und rechtlichen Erfordernissen beider Gesellschaften.
Die übernehmende Gesellschaft verpflichtet sich, sämtliche notwendigen formalen Erfordernisse für die Durchführung
der Verschmelzung sowie die Übertragung des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft auf die über-
nehmende Gesellschaft zu erfüllen.
Die Gesellschafter der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften sind jeweils berechtigt, am Sitz der Gesell-
schaften mindestens einen Monat vor der über die Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlung die
folgenden Unterlagen einzusehen: die Bedingungen der Verschmelzung, den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht
der Gesellschaften in den letzten drei Geschäftsjahren sowie ggf. eine buchhalterische Übersicht neueren Datums. Eine
Kopie dieser Unterlagen ist auf Anfrage erhältlich.
Das vorliegende Dokument wurde am 7. Dezember 2009 im Original in Luxemburg zum Zweck der (i) Eintragung im
Luxemburgischen Handelsregister der übertragenden Gesellschaft sowie zur Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations, (ii) zur Eintragung im deutschen Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft min-
destens einen Monat vor der über die Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlungen der an der Versch-
melzung beteiligten Gesellschaften gemäß Art. 262 des Luxemburgischen Gesetzes, § 122d UmwG und Art. 6 der
Verschmelzungsrichtlinie erstellt.
Es folgt die englische Übersetzung des vorangehenden Textes. Er soll bei der Beurkundung nicht verlesen werden,
sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Bei Abweichungen ist allein der deutsche Text maßgeblich.
MERGER PROPOSAL
Merger to be carried out by way of the absorption of the private limited liability company Allco Wind Energy (Lux-
embourg) No. 6 S.à r.l. by the German private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) DIF RE
Erneuerbare Energien 3 GmbH.
The Board of Managers of Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 6 S.à r.l. (the "Absorbed Company") and the Board
of Managers of DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH (the "Absorbing Company" and together with the Absorbed
Company, the "Companies") have decided to draw up the following merger proposal in accordance with:
(i) Sections 122a et seq. of the German Transformation Act (hereinafter: "UmwG"),
(ii) Articles 261 and 278 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter:
"Luxembourg Law"),
(iii) Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council as of October 26, 2005 on cross-border
mergers of limited liability companies (hereinafter: "Merger Directive").
and to present the merger proposal to their respective general meeting of shareholders.
REQUIREMENTS UNDER LUXEMBOURG AND GERMAN LAW:
I. The Companies (Art. 5 lit. a) of the Merger Directive)
The Absorbing Company is a private limited liability company existing under German laws, with registered seat in
Frankfurt am Main, Germany, registered in the Commercial Register of the local court of Frankfurt am Main, under No.
HRB 83499. The Absorbing Company was incorporated pursuant to a notarial deed of the Notary Dr. Thomas Engel,
residing in Munich, dated May 20, 2008. Its share capital is EUR 25,000.- and is fully paid in. According to its Articles of
Association, the object of the Absorbing Company's is the administration of property, the purchase, the holding and the
sale of shares. The company may do all business being in direct or indirect coherence with the aforesaid objects. The
company may acquire interest in other enterprises, may purchase or in-corporate enterprises especially as a personal
liable general partner. The Company is entitled to set up branch offices in Germany or abroad under the same or a similar
name. According to Section 122b (1) UmwG in conjunction with Art. 4 (1a) of the Merger Directive a cross-border
merger of a company with limited liability into another company with limited liability is permitted so that the Absorbing
Company may participate in a cross border merger.
The Absorbed Company is a Luxembourg private limited liability company, incorporated and organized under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg R.C.S. under number B 134.010, incorporated pursuant to a notarial deed
of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), of November 20, 2007, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of December 28, 2007, number 3013, page 144600. The share capital
of the Absorbed Company is EUR 12,500.-. The Absorbing Company is the owner of all 500 (five hundred) shares with
115698
a nominal value of EUR 25.00 (twenty five Euros) each, all subscribed and fully paid-up, in the Absorbed Company,
representing all the shares of the share capital of the Absorbed Company in an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand
five hundred Euros). The Absorbed Company has not granted any special rights similar to those defined in Section 23
UmwG. Under the laws applicable in Luxembourg, in particular article 257 of the Luxembourg Law a merger of a company
with limited liability into another company with limited liability is permitted. The Absorbed Company may therefore
participate in a cross-border merger in accordance with Section 122b (1) UmwG in conjunction with Art. 4 (1a) of the
Merger Directive.
II. Merger
The Absorbed Company transfers all of its assets and liabilities including all rights and obligations, on being dissolved
without going into liquidation, to the Absorbing Company by way of a cross-border merger with an existing company
without granting of shares in the Absorbing Company (absorption) according to Section 122a UmwG and article 278 of
the Luxembourg Law, in particular, article 274 (1) a) of the Luxembourg Law and this Merger Proposal (the Merger).
This transfer includes all the assets and liabilities belonging to the Absorbed Company (known or unknown) as of the
date of the shareholders meeting, approving the Merger. Upon entry of the merger into the commercial register of the
Absorbing Company ("Legal Effective Date") all the assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company
ipso jure between the Companies and vis-à-vis third parties.
The Absorbed Company guarantees to the Absorbing Company that the claims transferred as a result of the Merger
are certain and existing but does not guarantee the solvency of their respective debtors.
The Absorbing Company shall pay, as of the Legal Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance
premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been transferred.
As of the Legal Effective Date the Absorbing Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the
Absorbed Company.
The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company
with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be subrogated,
without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Company with respect to all assets and
against all debtors without any exception.
The Absorbing Company shall incur all debts and liabilities of any kind of the Absorbed Company. In particular, it shall
pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Absorbed Company.
All corporate documents of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company
for as long as prescribed by the competent jurisdiction.
The mandates of the members of the board of managers and of the statutory auditor(s) of the Absorbed Company (if
any) will be terminated on the Legal Effective Date. Full discharge will be given to the members of the board of managers
and to the statutory auditor(s) for the performance of their mandate.
III. New Shares (Art. 5 lit. b), c) and e) of the Merger Directive)
Since the Absorbing Company is the only shareholder of the Absorbed Company, there shall be no granting of shares
in the Absorbing Company or any other consideration in exchange for the transfer of the assets and liabilities pursuant
to Section 122c (3) UmwG. Therefore, any particular information pursuant to Section 122c (2) No. 2, 3 and 5 UmwG,
Art. 5 lit. b) c) and e) of the Merger Directive is not required.
IV. Shareholders' approval
The merger is subject to the approval of the shareholders of the Absorbing Company according to Sections 122g (1)
and 13 UmwG.
Further the merger is subject to the approval of the shareholders of the Absorbed Company according to article 263
of the Luxembourg Law. The board of managers of the Absorbing Company shall convene the shareholders to an ex-
traordinary general meeting of the shareholders to be held for the purpose of article 263 of the Luxembourg Law before
a Luxembourg notary as soon as practicable after one month has elapsed following the filing and publication of this Merger
Proposal in accordance with articles 9 and 262 of the Luxembourg Law, in order to approve the Merger in accordance
with this Merger Proposal.
The board of managers of each of the Companies have approved the Merger of the Companies.
V. Compensation offer
A compensation offer pursuant to Section 122i UmwG is not required, since the Absorbing Company as the acquiring
company is a company under German law. Neither is a compensation offer pursuant to Sections 122a (2) and 29 (1)
UmwG required, since the Absorbing Company as the acquiring company holds all shares in the Absorbed Company as
the transferring company. As a matter of precaution the Absorbing Company in its capacity as sole shareholder of the
Absorbed Company will also waive any rights for a compensation offer in the shareholder's meeting to decide upon the
merger.
VI. Effective date of the Merger from an accounting point of view (Art. 5 lit. f) of the Merger Directive) and date of
the merging companies` accounts (Art. 5 lit. l) of the Merger Directive)
115699
In relation to the Absorbing Company the takeover of the assets and liabilities of the Absorbed Company shall be
effective upon expiry of June 30, 2009 (midnight). As of July 1, 2009 (12 a.m.) all dealings and business transactions of the
Absorbed Company shall be deemed to be made for the account of the Absorbing Company ("Effective Date" pursuant
to Section 122c (2) No. 6 UmwG, Art. 5 lit. f) of the Merger Directive).
The Merger shall be based on the balance sheet of the Absorbed Company as of June 30, 2009 ("Closing Balance
Sheet"), which describes the evaluation of the assets and liabilities of the Absorbed Company as of June 30, 2009 (date
of the Absorbed company's accounts).
The date of the Absorbing Company's accounts is December 31, 2009. However, since there shall be no exchange of
shares or other consideration for the transfer of the assets and liabilities in the course of the merger, the accounts of
the Absorbing Company are not relevant to establish the conditions of the cross-border merger in the sense of Section
122c (2) No. 12 UmwG, Art. 5 lit. l) of the Merger Directive.
VII. Evaluation of assets and liabilities (Art. 5 lit. k) of the Merger Directive)
The transferred assets and liabilities shall be carried over at book values in the balance of the Absorbing Company
(Section 122c (2) No. 11 UmwG, Art. 5 lit. k) Merger Directive).
Since all shares of the transferring company are held by the Absorbing Company a merger audit or an audit report
will not be necessary (Sections 122f and 9 (2) UmwG; article 278 of the Luxembourg Law).
VIII. Special rights and special advantages (Art. 5 lit. g), h) of the Merger Directive)
The companies acknowledge that the Absorbed Company has not issued to any person any securities other than the
shares held by the Absorbing Company in the share capital of the Absorbed Company. No special rights concerning the
Companies exist and no special rights will be granted to any shareholder in connection with the merger, in addition no
measures concerning such persons will be proposed pursuant to Section 122c (2) No. 7 UmwG, Art. 5 lit. g) h) Merger
Directive and article 261 (2) f) and g) of the Luxembourg Law.
The Companies acknowledge that no special advantage or benefits will be granted to the managers of the Companies
or to any of the persons referred to in Section 122c (2) No. 8 UmwG and article 261 (2) lit. g) of the Luxembourg Law.
IX. Repercussions on employment and employee participation (Art. 5 lit. d) and j) of the Merger Directive)
Neither the Absorbed Company nor the Absorbing Company has any employees. Therefore no particular information
can be given regarding the repercussions of the cross-border merger on employment (Section 122c (2) No. 4 UmwG).
Information on any issues of employee participation (Section 122c (2) No. 10 UmwG) are not required either, because
no employee participation rights exist or will have to be established at the Absorbed Company or the Absorbing Company,
either before or after the cross-border merger.
X. Cancellation of the shares and dissolution without liquidation of the Absorbed Company
As from the Legal Effective Date, the shares held by the Absorbing Company in the Absorbed Company will be cancelled
and the Absorbed Company will cease to exist.
XI. Additional provisions and Statutes of the Absorbing Company (Art. 5 lit i) of the Merger Directive)
The cost of the merger will be incurred by the Absorbing Company. Regarding a potential real estate transfer tax
obligation the parties declare that the Absorbed Company does not own any real estate.
The statutes of the Absorbing Company shall remain unchanged after this merger and are attached to this deed as
Annex 1.
The Companies mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the merger in accordance
with the legal and statutory requirements of both companies.
The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the Merger as
well as the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.
The shareholders of each of the Companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered office
of the said companies, at least one month before the date of the general meeting of the shareholders called to decide on
the Merger: the merger plan, the merger report, annual accounts and annual reports of the Companies for the last three
financial years, if any, and, if necessary, a recent accounting statement. A copy of the above mentioned documents will
be obtainable upon request.
The present document has been drafted in Luxembourg on December 7, 2009, in original, in order (i) to be registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies of the Absorbed Company and to be published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, (ii) to be registered with the German Commercial Register of the
Absorbing Company at least one month prior to the date of the general meeting of the shareholder(s) of each Companies
called to decide on the terms of the merger, in accordance with article 262 of the Luxembourg Law, Section 122d UmwG
and Art. 6 of the Merger Directive.
The present document has been drafted in German, followed by an English version. The English text shall not be read
out aloud but shall serve exclusively for the purpose of information; in case of deviations, the German text shall be the
decisive text.
115700
Datum/Date: 7. Dezember 2009/December 7, 2009
<i>Manacor (Luxembourg) S.A.
i>Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 6 S.à r.l. / DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH
Signatures, Engel Koolhaas, Michel Steenbergen / Thomas Wiesenthal
Anhang 1
Annex 1
GESELLSCHAFTSVERTRAG
ARTICLES OF ASSOCIATION
der
of
DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH
DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH
§ 1
§ 1
Firma der Gesellschaft
Name of the Company
Die Firma der Gesellschaft lautet:
The name of the Company is as follows:
DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH
DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH
§ 2
§ 2
Sitz der Gesellschaft
Registered Office
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.
The Company has its registered office in Frankfurt am Main.
§ 3
§ 3
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr
Duration, Business Year
(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
(1) The Company is established for an unlimited period.
(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalender-
jahr.
(2) The business year of the Company is the calendar year.
§ 4
§ 4
Gegenstand des Unternehmens
Objects of the Company
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Vermögens-
verwaltung, der Erwerb, das Halten und die Veräußerung
von Beteiligungen.
(1) The objects of the Company are the administration of
property, the purchase, the holding and the sale of shares.
(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben und
Handlungen vornehmen, die geeignet sind, dem Gesell-
schaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen.
(2) The Company may do all business being in direct or
indirect coherence with the aforesaid objects.
(3) Die Gesellschaft darf andere Unternehmen überneh-
men, sie darf sich an Unternehmen beteiligen und zwar auch
als persönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft
darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen unter glei-
cher oder anderer Firma errichten.
(3) The Company may acquire interest in other enterprises,
may purchase or in-corporate enterprises especially as a
personal liable general partner. The Company is entitled to
set up branch offices in Germany or abroad under the same
or a similar name.
§ 5
§ 5
Stammkapital
Share Capital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR
25.000,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend). Das
Stammkapital ist voll eingezahlt.
The share capital of the Company is EUR 25,000.00 (in
words Euro twenty five thousand). The share capital is fully
paid in.
§ 6
§ 6
Geschäftsführung
Managing Directors
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts-
führer, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und
abberufen werden.
(1) The Company has one or more managing directors who
are appointed and removed by the shareholders' meeting.
(2) Die Geschäftsführer sind an Gesetz und Gesell-
schaftsvertrag sowie die Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlung gebunden. Sie haben die Gesellschaft mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu führen.
(2) The managing directors are bound to applicable laws
and these Articles of Association and any resolutions ad-
opted by the shareholders' meeting pertaining to them.
They shall conduct the affairs of the Company with the due
care of a prudent businessman.
§ 7
§ 7
Vertretung
Representation
(1) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bes-
tellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertreten.
(1) If only one managing director has been appointed, he or
she shall represent the Company alone. If several managing
directors have been appointed, the Company shall be re-
presented by two managing directors acting jointly or by
one managing director acting in conjunction with a Proku-
rist.
115701
(2) Die Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB erteilen. Ebenso kann einem oder
mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
auch dann erteilt werden, wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt sind.
(2) The shareholders' meeting may exempt one or more
managing directors from the restrictions set forth in Sec.
181 of the German Civil Code, so that they are authorized
to act on behalf of the Company in transactions with them-
selves or with themselves as representatives of a third
party. The shareholders' meeting may also accord individual
power of representation to one, several or all of the ma-
naging directors.
§ 8
§ 8
Bekanntmachungen
Publications of the Company
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im
elektronischen Bundesanzeiger.
The publications of the Company are only made in the
electronic Federal Gazette.
§ 9
§ 9
Gründungskosten
Expenses for Formation
Die Gesellschaft trägt den ihr oder ihrem Gründer so-
wohl bei der rechtlichen Gründung, als auch bei der so
genannten "wirtschaftlichen Neugründung" entstehenden
Gründungsaufwand (Rechtsanwalts-, Notar- und Gerichts-
kosten und Bankgebühren) bis zu insgesamt EUR 2.500,00.
The Company shall be liable for any expenses incurred by
it or by its founder in connection with both its legal for-
mation and any "economic new formation" which may have
occurred (lawyer's fees, notary's fees, fees of registration
and bank charges) up to a total amount of EUR 2,500.00.
§ 10
§ 10
Wettbewerbsverbot
Prohibition of Competition
Die Gesellschafter sind von jedwedem Wettbewerbs-
verbot befreit und schulden hierfür keine Vergütung.
The shareholders are released from any prohibitions of
competition whatsoever. They owe no compensation for
such release.
§ 11
§ 11
Salvatorische Klausel
Severability
Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags ganz
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt. Das gleiche gilt, falls sich herausstellt,
dass der Gesellschaftsvertrag eine Regelungslücke enthält.
Anstelle der unwirksamen Bestimmungen ist eine wirksame
Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Gesellschaf-
tern Gewollten am nächsten kommt; gleiches gilt im Fall
einer Lücke.
If any provisions of these Articles of Association should be
or become invalid or unenforceable, in whole or in part,
the remaining provisions hereof shall remain in full force
and effect. The same applies to any gaps herein. The parties
shall replace any invalid or unenforceable provision by such
a valid provision which is best suited to achieve the intent
of the shareholders; the same shall apply mutatis mutandis
in the event of any gap herein.
Référence de publication: 2009151785/413.
(090189128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2009.
GFA - HAIG, Fonds Commun de Placement.
<i>Allgemeines Verwaltungsreglementi>
Das Sondervermögen GFA - HAIG wurde von der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. nach Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die
Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. De-
zember 1985.
Für den Fonds gilt das allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 7. Dezember 2009 in Kraft trat und zwecks
Veröffentlichung am 11. Dezember 2009 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, beim Handels- und Ge-
sellschaftsregister hinterlegt wurde.
Luxemburg, den 7. Dezember 2009.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009148126/16.
(090182116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.
115702
Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 127.574.
In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Liontrust International Funds (Luxembourg) SI-
CAV", a Luxembourg public limited company qualifying as an investment company with variable share capital having its
registered office at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 127.574, incorporated pursuant to a notarial deed dated
11 May 2007, published in the Memorial C, number 1005, on 30 May 2007 (the "Company").
The extraordinary general meeting was opened at 03.00 p.m. and was presided by Mr Max Welbes, lawyer, residing
professionally in Luxembourg who appointed as secretary Mr Tobias Lochen, lawyer, residing professionally in Luxem-
bourg.
The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mr Christian Lennig, lawyer, residing professionally in Lu-
xembourg.
The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares they hold are shown on the attendance list,
signed by the members of the bureau and the undersigned notary. This list, together with the proxies initialled ne varietur
by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this deed in order to be filed with the
registration authorities.
II. It appears from the attendance list that 315,310.253 of a total of 316,296.641 shares are represented in this ex-
traordinary general meeting.
III. The agenda of the extraordinary general meeting is as follows:
1. Amendment of the first paragraph of article 11 of the Company's articles of incorporation (the "Articles") to read
as follows:
" Art. 11. Net asset value. The net asset value per share of each class of shares in each sub-fund of the Company shall
be determined at least twice per month by the Company (every such day for determination of the net asset value being
referred to herein as the "valuation day") on the basis of the last available prices, provided that such valuation day is any
full working day in Luxembourg when the banks are open for business."
IV. A convening notice reproducing the agenda of the present meeting was sent by registered mail to each of the
registered shareholders of the Company on 16 November 2009.
The present extraordinary general meeting is thus regularly constituted and can validly decide on the items of its
agenda.
The extraordinary general meeting deliberated and adopted the following resolution unanimously:
<i>Resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES to amend the first paragraph of article 11 of the Articles to read as
follows:
" Art. 11. Net asset value. The net asset value per share of each class of shares in each sub-fund of the Company shall
be determined at least twice per month by the Company (every such day for determination of the net asset value being
referred to herein as the "valuation day") on the basis of the last available prices, provided that such valuation day is any
full working day in Luxembourg when the banks are open for business."
There being no further item on the agenda, the extraordinary general meeting was thereupon closed at 3.30 p.m..
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil
status and residences, the members of the bureau of the extraordinary general meeting signed together with the notary
the present deed.
Follows the French translation of the preceding text:
L'an deux mille neuf, le vingt-sept novembre.
115703
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Liontrust International Funds (Luxembourg)
SICAV", une société anonyme luxembourgeoise sous forme d'une société d'investissement à capital variable, ayant son
siège social au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.574, constituée suivant acte du 11 mai 2007, publié au
Mémorial C numéro 1005, en date du 30 mai 2007 (la "Société").
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.00 heures, présidée par Me Max Welbes, avocat, demeurant
professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Me Tobias Lochen, avocat, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Me Christian Lennig, avocat, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée générale extraordinaire ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter
que:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent apparaissent dans la liste
de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence ainsi que les procurations
dûment paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Il apparaît de la liste de présence que 315,310.253 d'un total de 316,296.641 actions sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire.
III. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Modification du paragraphe premier de l'article 11 des statuts de la Société (les "Statuts"), qui est formulé comme
suit:
" Art. 11. Valeur Nette d'Inventaire. La valeur nette d'inventaire par action de chaque catégorie d'actions au sein de
chaque compartiment de la Société sera déterminée au moins deux fois par mois par la Société (chaque jour d'évaluation
de la valeur nette d'inventaire étant désigné ci-après comme le "jour d'évaluation"), sur la base des derniers prix dispo-
nibles, à condition qu'un tel jour d'évaluation soit un jour ouvrable entier au Luxembourg auquel les banques sont
ouvertes."
IV. Une convocation reproduisant l'ordre du jour de la présente assemblée a été envoyée par lettre recommandée à
chacun des actionnaires nominatifs le 16 novembre 2009.
L'assemblée générale extraordinaire est donc valablement constituée et peut valablement décider sur tous les points
de l'ordre du jour.
Après avoir délibéré, l'assemblée générale extraordinaire a adopté la résolution suivante à l'unanimité:
<i>Résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de modifier le paragraphe premier de l'article 11 des Statuts, qui est
formulé comme suit:
" Art. 11. Valeur Nette d'Inventaire. La valeur nette d'inventaire par action de chaque catégorie d'actions au sein de
chaque compartiment de la Société sera déterminée au moins deux fois par mois par la Société (chaque jour d'évaluation
de la valeur nette d'inventaire étant désigné ci-après comme le "jour d'évaluation"), sur la base des derniers prix dispo-
nibles, à condition qu'un tel jour d'évaluation soit un jour ouvrable entier au Luxembourg auquel les banques sont
ouvertes."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. WELBES, T. LOCHEN, C. LENNIG, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-AIzette A.C., le 1
er
décembre 2009. Relation: EAC/2009/14659. Reçu soixante-quinze Euros
(75,- EUR).
Le Receveur, signé: SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
115704
Belvaux, le 3 décembre 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009151061/111.
(090186577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.
Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 127.574.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 3 décembre 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009151062/10.
(090186578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.
KP Interiors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 102.528.
PROJET DE FUSION
In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of November.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
I.- Mr Raymond Thill, acting as special proxy of the board of managers of the company KP Interiors S.à r.l., organized
under Luxembourg law with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered at the Register
of Commerce and Companies of Luxembourg under the number B 102.528; under a resolution of the board of managers
of the company, taken by way of circular resolution on November 24, 2009;
Which circular resolution, after having been signed ne varietur by the mandatory acting on behalf of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
II.- Mr Raymond Thill, acting as special proxy of the board of managers of the company Key Plastics Switzerland S.à
r.l., organized under Luxembourg law with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in process of
registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register:
under a resolution of the board of managers of the company, taken by way of circular resolution on November 24,
2009;
Which circular resolution, after having been signed ne varietur by the mandatory acting on behalf of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The companies have requested the undersigned notary to record the terms and conditions of the proposed merger
between them, and as follows:
1. The company KP Interiors S.à r.l., having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 102.528, with a subscribed capital of EUR
12,500 (twelve thousand five hundred euro) divided into 125 (one hundred twenty-five) shares with a nominal value of
EUR 100 (one hundred euros) each, fully paid
holds the entire (100%) of shares representing the entire subscribed capital and voting rights of:
Key Plastics Switzerland S.à r.l., having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in process
of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register, with subscribed capital of EUR 330,000 (three
hundred and thirty thousand euros) divided into 3,300 (three thousand and three hundred) shares with a nominal value
of EUR 100 (one hundred euro) each, fully paid.
Any other manner of voting or giving special rights have not been issued by the aforementioned companies (also called
the "merging companies").
2. The company KP Interiors S.à r.l. ("KP Interiors") intends to merge in accordance with Articles 278 and 279 of the
Act of 10 August 1915 on commercial companies and the subsequent texts with the company Key Plastics Switzerland
S.à r.l. ("Key Plastics Switzerland") by way of absorption.
3. The date from which the transactions of Key Plastics Switzerland shall be treated for accounting purposes as having
been completed on behalf of KP Interiors shall be December 28, 2009.
4. No advantage is given to the managers of the merging companies.
115705
5. The merger takes effect between the parties one month after the publication of the merger project in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, in accordance with Article 9 of the Companies Act.
6. The partners of KP Interiors have the right, at least one month before the operation takes effect as between the
parties, to inspect at the registered office of KP Interiors, the documents specified in Article 267 (1) a) b) and c ) of the
Act on commercial companies and that they can obtain a copy without charge upon request.
7. One or several partners of KP Interiors, holding at least 5% (five percent) of the subscribed capital, are entitled
during the same period to require that a general meeting of the partners of KP Interiors S.à r.l. in order to decide whether
to approve the merger.
8. Failing to convene a meeting or rejecting the proposed merger by the latter, the merger becomes final as indicated
above in point 5) and lead to right the effects provided for in section 274 of the Act on commercial companies and in
particular in its paragraph a).
9. The merging companies shall comply with all legal provisions in force in respect of statements to be made for the
payment of any taxes or charges resulting from the achievement of contributions made pursuant to the merger, as
described below.
10. Full discharge is given to the managers of Key Plastics Switzerland.
11. The documents of Key Plastics Switzerland will be kept for the statutory period at the registered office of KP
Interiors.
12. Formalities - KP Interiors:
- carry out all the legal formalities relating to advertising contributions made pursuant to the merger;
- make his own statements and formalities necessary for all jurisdictions as appropriate to put his name to the assets
contributed;
- carry out all formalities in order to make effective against third parties the assets and rights made it.
13. Release of documents - During the final completion of the merger, Key Plastics Switzerland will deliver to KP
Interiors the originals of all its incorporation and amended deed, accounting books and other accounting documents, title
deeds or acts of ownership documents of all assets, evidence of transactions, securities and all contracts (loans, work,
trust ...), archives, documents and any other documents relating to the rights and made.
14. Fees - All fees, duties and fees payable under the merger will be paid by KP Interiors.
15. KP Interiors will pay, if any, taxes on capital or profit due by Key Plastics Switzerland for the years not yet taxed.
The undersigned notary states certify the legality of this proposed merger act, in accordance with the article 271 (2)
of the Act on commercial companies.
On the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille neuf, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
I.- Monsieur Raymond Thill, agissant en vertu d'un pouvoir donné par le conseil de gérance de la société KP Interiors
S.à r.l. , société de droit luxembourgeois avec siége social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 102.528; en vertu d'un pouvoir qui lui a été
conféré par décision du conseil de gérance, prise par résolution circulaire du 24 novembre 2009;
un exemplaire de la résolution circulaire, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
II.- Monsieur Raymond Thill, agissant en vertu d'un pouvoir donné par le conseil de gérance de la société Key Plastics
Switzerland S.à r.l., société de droit luxembourgeois avec siége social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg en cours; en vertu d'un pouvoir qui lui a été
conféré par décision du conseil de gérance, prise par résolution circulaire du 24 novembre 2009;
un exemplaire de la résolution circulaire, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes
et conditions du projet de fusion intervenu entre elles, et ce ainsi qu'il suit:
1. La société KP Interiors S.à r.l. avec siége social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 102.528, au capital social de EUR 12,500 (douze
115706
mille cinq cent euro) divisé en 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euro) chacune,
entièrement libérées,
détient l'intégralité (100%) des actions, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, de:
la société Key Plastics Switzerland S.à r.l., avec siége social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatri-
culation au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg en cours , au capital social de EUR 330.000 (trois cent
trente mille euros) divisé en 3.300 (trois mille trois cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros)
chacune, entièrement libérées,
Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées
(encore appelées sociétés fusionnantes).
2. La société KP Interiors S.à r.l. ("KP Interiors") entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et
279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec la société Key Plastics Swi-
tzerland S.à r.l. ("Key Plastics Switzerland") par absorption de cette dernière.
3. La date à partir de laquelle les opérations de Key Plastics Switzerland sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour compte de KP Interiors est fixée au 28 décembre 2009.
4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux gérants des sociétés qui fusionnent.
5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Les actionnaires de KP Interiors ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre les
parties, de prendre connaissance, au siège de KP Interiors, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi
sur les sociétés commerciales et peut en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.
7. Les actionnaires de KP Interiors, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des parts sociales du capital souscrit,
ont le droit de requérir, pendant le même délai, à la convocation d'une assemblée générale de KP Interiors appelée à se
prononcer sur l'approbation de la fusion.
8. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive
comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).
9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations
à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits
au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.
10. Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de Key Plastics Switzerland.
11. Les documents sociaux de Key Plastics Switzerland seront conservés pendant le délai légal au siège de KP Interiors.
12. Formalités - KP Interiors:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
13. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, Key Plastics Switzerland remettra à KP Interiors les
originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables,
les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées,
les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quel-
conques relatifs aux éléments et droits apportés.
14. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par KP Interiors.
15. KP Interiors acquittera, le cas échéant, les impôts dus par Key Plastics Switzerland sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article
271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/50929. Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
115707
Luxembourg, le 4 décembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009151318/158.
(090188062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.
Vega Business Aviation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 149.629.
STATUTES
In the year two thousand nine, on the twenty-seventh of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Navymar Shipping Company Limited, a private limited liability company incorporated under the laws of Cyprus, having
its registered office at having its registered office at 284 Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2
nd
Floor,
Limassol, Cyprus and registered with the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus under number 193683, here
represented by Sabrina Mahlous, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Limassol,
Cyprus on November 25
th
, 2009.
Said proxy, after having been initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Vega
Business Aviation S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.
The Company may (i) acquire, hold and dispose, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of aircrafts
and (ii) act by any means, whether directly or indirectly, as lessee and/or as lessor for aircrafts leases of any form and to
enter in any transactions related thereto and (iii) own, administrate, develop and manage a portfolio of assets, including,
but not limited to, aircrafts.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option,
securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.
The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the
obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, mortgage, transfer, encumber or otherwise create security over
some or all its assets.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 20,000 (twenty thousand US Dollars),
represented by 20,000 (twenty thousand) shares having a nominal value of USD 1 (one US Dollar) per share each.
115708
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company
to an end.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the by
the sole signature of any manager.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the
Company amongst any manager. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers
for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by
vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. The notice may be waived
by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission of each manager. No separate notice
is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board
of Managers.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers
jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been
115709
informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of January of each year and it shall
terminate on the 31
st
of December of the following year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
of December, the Company's accounts are established
and the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to
pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
115710
<i>Subscription and Paymenti>
The appearing party hereby declares that it subscribes to the 20,000 (twenty thousand) shares having a nominal value
of USD 1 (one US Dollar) each representing the total subscribed share capital of the Company.
All these shares have been fully paid up by means of a contribution in cash in an aggregate amount of USD 20,000
(twenty thousand US Dollars), so that the same sum is at the free disposal of the Company, evidence of which has been
given to the undersigned by means of a blocking certificate and the notary expressly acknowledges the availability of the
funds so paid.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
st
of December 2009.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,300 (one thousand three hundred euro).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
have herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers is set at one.
The meeting appoints Dana Claudia Glavan, jurist and economist, whose professional address is at Voluntari, Soseaua
Pipera - Tunari, nr. 97, corp cladire C9 - Birouri, Camera nr. 6, et. 1 - Ilfov Romania as sole manager of the Company for
an unlimited period of time.
2. The registered office is established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove
mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder(s) of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil neuf, le vingt-sept novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Navymar Shipping Company Limited, une société à responsabilité limitée de droit chypriote, ayant son siège social au
284 Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2
nd
Floor, Limassol, Chypre et enregistrée auprès du Registre
des Sociétés de la République de Chypre sous le numéro 193683, ici représenté par Sabrina Mahlous, Avocate, résidant
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Limassol, Chypre, le 25 novembre 2009.
Ladite procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter
ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.
Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de «Vega Business Aviation S.à
r.l.» (ci-après, la Société).
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme
que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut (i) acquérir, détenir et céder, sous toute forme, par tout moyen, que ce soit directement ou indirec-
tement, des avions et (ii) agir par tout moyen, que ce soit directement ou indirectement, en qualité de bailleur ou preneur
de bail pour des locations d'avions sous toute forme et prendre part à des transactions y relatives et (iii) posséder,
administrer, développer et gérer un portefeuille d'actifs, y compris mais sans être limité à, des avions.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer à la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'in-
115711
vestissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange
ou autrement et pour les développer.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts
et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité
à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, hypothéquer, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de
gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 20.000 USD (vingt mille dollars des Etats-
Unis d'Amérique) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar des Etats-
Unis d'Amérique) chacune.
Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.
Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées.
Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.
Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des Associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture
de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront
un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la
moitié du capital social.
L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer
le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société
en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.
115712
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le gérant qui délègue
déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de
représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
Un président du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de
gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents
ou représentés lors du conseil de gérance.
Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Il peut être renoncé à la convocation de
l'accord de chaque gérant donné par écrit, téléfax, télégramme, télex ou email. Aucune convocation spéciale n'est requise
pour des réunions tenues en des lieux et temps indiqués dans un document préalablement approuvé par une résolution
du Conseil de Gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par deux gérants conjointement. On pourra passer
outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été
informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se
tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Assemblées générales des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se
tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convo-
cation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 15. Droits de Vote des Associés, Quorum et Majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
115713
Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31
décembre de l'année suivante.
Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le
conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 18. Distribution des Bénéfices, Réserves Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou,
en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Commissaire aux Comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société
doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
La partie comparante déclare qu'elle souscrit les 20.000 (vingt mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1
USD (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de 20.000
USD (vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique), de façon à ce que ladite somme soit à la libre disposition de la Société,
preuve ayant été donnée au moyen d'un certificat de blocage. Le notaire confirme expressément la disponibilité des fonds
ainsi versés.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et prend fin le 31 décembre 2009.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement 1.300 EUR (mille trois cents euros).
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique représentant la totalité du capital souscrit a pris
les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à un.
L'assemblée nomme Dana Claudia Glavan, juriste et économiste, dont l'adresse professionnelle est au Voluntari, So-
seaua Pipera - Tunari, nr. 97, corp cladire C9 - Birouri, Camera nr. 6 et. 1 - Ilfov, Roumanie, en tant que gérant unique
de la Société pour une durée indéterminée.
2. Le siège social de la société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: S. Mahlous et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
décembre 2009, LAC/2009/51332. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.
Luxembourg, le 8 décembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009151319/380.
(090187720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.
115714
International Chemical Investors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 105.416.
Im Jahre zweitausendundneun, am zwölften November.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) ist
erschienen.
Herr Robert Langmantel, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1750 Luxemburg, 62, Avenue Victor Hugo, in seiner
Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied der luxemburgischen Gesellschaft "International Chemical Investors
S.A." mit Sitz in 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, gegründet mit Gesellschaftsvertrag vom 16. Dezember 2004,
beurkundet vor Notar Henri Hellinckx, mit damaligem Amtssitz in Mersch (Großherzogtum Luxemburg) und veröffentlich
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 396 vom 29. April 2005.
Die Satzung der Gesellschaft wurde letztens abgeändert gemäß einer Urkunde von Notarin Marthe Thyes-Walch, mit
damaligem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) vom 12. August 2005, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 96 vom 14. Januar 2006.
Das Gesellschaftskapital beträgt 300.000,00 EUR, eingeteilt in 3.000 Inhaberaktien zu je 100,00 EUR. Alle Anteile sind
voll eingezahlt.
Herr Robert Langmantel ist berechtigt und vom Verwaltungsrat bevollmächtigt, den Umwandlungsplan der Gesellschaft
"International Chemical Investors S.A." zwecks Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) vor einem Notar in
Luxemburg beurkunden zu lassen. Eine beglaubigte Kopie der Verwaltungsratssitzung vom 6. Oktober 2009 liegt diesem
Akt als Kopie bei.
Sodann wird folgendes beurkundet:
<i>Umwandlungsplan in eine Europäische Gesellschaft (SE)i>
1.) Der vorliegende Plan betrifft die Umwandlung der "International Chemical Investors S.A.", société anonyme, mit
einem gezeichneten Kapital von dreihunderttausend EUR (300.000,00 EUR), mit Sitz in 62, Avenue Victor Hugo, L-1750
Luxemburg, und eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 105.416.
Die Satzung der Gesellschaft wurde letztens abgeändert gemäß einer Generalversammlung vom 12. August 2005,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 4586 vom 14. Januar 2006.
2.) Die Gesellschaft hält an mehreren europäischen Gesellschaften dauerhafte Beteiligungen seit mehr als zwei Jahren,
so dass die Bedingungen laut Artikel 3 Paragraph 6 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
unter Berücksichtigung der Änderungen von Artikel 2 Paragraph 4 der EU-Verordnung N° 2157/2001 vom 8. Oktober
2001 über die Satzungen der Europäischen Gesellschaften (SE) zwecks Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine
Europäische Gesellschaft (SE) erfüllt sind.
Es handelt sich hierbei um folgende Gesellschaften:
International Chemical Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, An der Hauptwache 5. Kauf der
100 %igen Beteiligung am 22. Dezember 2004 mit der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einem
Kapital von 1.000.000,00 EUR (eine Millionen EUR). Die Gesellschaft wird im Handelsregister B des Amtsgerichts Frank-
furt am Main, Deutschland unter der Nummer HRB 73702 geführt.
International Chemical Investors II GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, An der Hauptwache 5. Kauf der
100 %igen Beteiligung am 28. September 2005 mit der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einem
Kapital von 25.000,00 EUR (fünfundzwanzigtausend EUR). Die Gesellschaft wird im Handelsregister B des Amtsgerichts
Frankfurt am Main, Deutschland unter der Nummer HRB 75508 geführt.
International Chemical Investors III GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, An der Hauptwache 5. Kauf der
100 %igen Beteiligung am 20. Dezember 2006 mit der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einem
Kapital von 25.000,00 EUR (fünfundzwanzigtausend EUR). Die Gesellschaft wird im Handelsregister B des Amtsgerichts
Frankfurt am Main, Deutschland unter der Nummer HRB 79779 geführt.
International Chemical Investors IV GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, An der Hauptwache 5. Kauf
der 100 %igen Beteiligung am 8. November 2007 mit der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und
einem Kapital von 25.000,00 EUR (fünfundzwanzigtausend EUR). Die Gesellschaft wird im Handelsregister B des Amts-
gerichts Frankfurt am Main, Deutschland unter der Nummer HRB 81385 geführt.
3.) Die Gesellschaft International Chemical Investors S.A. möchte die Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft
(SE) mit dem Namen "International Chemical Investors S.E." umwandeln. Das gezeichnete Kapital soll dreihunderttausend
EUR (300.000,00 EUR) betragen, eingeteilt in dreitausend (3.000) Inhaberaktien zu je hundert EUR (100,00 EUR). Die
Aktionäre der Gesellschaft erhalten nach der Umwandlung die gleiche Anzahl von Anteilen (Aktien) an der SE wie an
Stelle der vorherigen Gesellschaft. Alle Anteile sollen voll eingezahlt sein. Der Sitz der Gesellschaft soll nach der Um-
wandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) in 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg sein.
115715
4.) Die Gesellschaft gewährt den Aktionären weder vor der Umwandlung oder während der Umwandlung noch nach
der Umwandlung in eine SE keine Sonderrechte oder andere Vorteile.
5.) Es werden keine Sonderrechte oder andere Vorteile an die Verwaltungsräte oder an den Aufsichtskommissar
aufgrund der Umwandlung in eine SE erteilt.
6.) Der Verwaltungsrat hat als "Réviseur d'Entreprises" die Gesellschaft DEBELUX AUDIT S.A., mit Sitz in 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nr. B 37.592, unabhängige
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Mitglied im "Institut des Réviseurs d'Entreprises", beauftragt, um eine Überprüfung
des Nettovermögens durchzuführen, die mindestens die Höhe des SE-Kapitals zuzüglich der nicht ausschüttungsfähigen
Rücklagen erreichen muss. Es werden keine Sonderrechte oder andere Vorteile an den "Réviseur d'Entreprises" aufgrund
der Umwandlung in eine SE erteilt. Unberührt hiervon bleiben die Prüfungshonorare des "Réviseur d'Entreprises" in
berufsüblicher Höhe.
7.) Die letzten zwei Jahresabschlüsse, die von der Generalversammlung genehmigt wurden, sowie eine Zwischenbilanz
zum 30. September 2009, die von dem Verwaltungsrat vorbereitet wurde, liegen diesem Akt bei, zusammen mit dem
Bericht des Verwaltungsrates, aus der die Erklärung und Rechtfertigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten
für die Umwandlung hervorgehen.
8.) Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) muss von der Generalversammlung, die vor einem luxem-
burgischen Notar abgehalten werden muss, genehmigt werden und spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung
des Umwandlungsplans in eine Europäische Gesellschaft (SE) im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröf-
fentlicht werden.
9.) Als Umwandlungsstichtag wird der 1. Januar 2009 zugrunde gelegt. Zivilrechtlich ist die Änderung der Rechtsform
in eine Europäische Gesellschaft (SE) erst mit dem Datum der Eintragung in das luxemburgische Handelsregister gültig
und rechtskräftig.
10.) Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) hat keine Auswirkung oder Konsequenz auf die Rechte
der Aktionäre der Gesellschaft.
11.) Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) hat keine Auswirkung oder Konsequenz auf die Rechte
der Verwaltungsräte und der Angestellten der Gesellschaft.
12.) Die Satzung der Europäischen Gesellschaft soll nach der Umwandlung wie folgt lauten:
"International Chemical Investors S.E.
Europäische Gesellschaft
Gesellschaftssitz: L-1750 Luxemburg, 62, Avenue Victor Hugo
Satzung:
I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragschließenden und allen Dritten, die später das Eigentumsrecht an den nachstehend ge-
schaffenen und in der Folge noch zu schaffenden Aktien erwerben werden, besteht eine Europäische Aktiengesellschaft
("Societas Europaea") unter dem Namen INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E..
Die Gesellschaft unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäi-
schen Gesellschaft ("SE-VO") in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 25. August 2006.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates
an jeden Ort der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft ist zugleich der Ort ihrer General-
verwaltung. Der Gesellschaft ist gestattet, ihren Sitz und den Ort ihrer Generalverwaltung nach Maßgabe von Art. 8 SE-
VO innerhalb der EU zu verlegen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann vorzeitig aufgelöst werden durch einen Beschluss der
Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländi-
schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens
teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form
unterstützen.
Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.
Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-
Transaktionen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.
115716
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter,
allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tä-
tigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.
Art. 5. Das gezeichnete und eingezahlte Aktienkapital beträgt 300.000,- EUR (dreihunderttausend Euro), eingeteilt in
3.000 (dreitausend) Aktien mit einem Nominalwert von je 100,- EUR (einhundert Euro).
Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch
Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
II. - Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer von
maximal sechs Jahren ernannt. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschafts- angelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur
beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch
einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen
können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax
abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist,
ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Ebenfalls kann der Verwaltungsrat auch mittels Zirkularbeschlüsse vorgehen, wobei die Beschlussvorlagen im Ge-
samtwortlaut den Mitgliedern im Umlaufverfahren zur schriftlichen Genehmigung zugesandt werden müssen.
In besonders dringenden Fällen kann sie mit Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder auch telefonisch erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung an
einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.
Das erste geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied kann durch die Generalversammlung der Gesellschafter ernannt
werden.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch
die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 9. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat unterbreitet der Gesellschafterversammlung Vorschläge über die Verwendung und Ver-
teilung des Gewinnes, worüber ausschließlich die Gesellschafter bestimmen.
Von dem Reingewinn der Gesellschaft werden 5% der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Auflage erlischt sobald
die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht.
Falls die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, kann der Verwaltungsrat im Laufe des Jahres Vorauszahlungen auf kom-
mende Dividenden vornehmen.
Art. 11. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre
Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.
III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung
Art. 12. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht
notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.
Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in dem Einberufungss-
chreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am 3. Mittwoch des Monats Juni um 15.00 Uhr. Falls der vorgenannte
Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
115717
Art. 14. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungs-
fähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der
ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt.
Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie die an-
nullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die
Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.
IV. - Geschäftsjahr - Auflösung
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher abgeschlossen und es werden Jahresabschlüsse und
Berichte erstellt, unter der Verantwortung des Verwaltungsrates.
Die Jahresabschlüsse begreifen eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung und deren Anhang, welche die gesetzlich
vorgesehenen Angaben und Mitteilungen enthalten.
Die Jahresabschlüsse sind -zusammen mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dem Prüfungsbericht des Prü-
fungskommissars- der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen.
Der Jahresbericht des Verwaltungsrates gibt Rechenschaft über die Geschäftsführung und Aufschluss über die wich-
tigsten Begebenheiten seit dem Vorjahresabschluss.
Art. 17. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
V. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 18. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Aktionäre auf die Bestimmungen der Ve-
rordnung CE Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 der Satzung für die Europäische Gesellschaft gemäß dem Gesetz vom
25. August 2006 im Zusammenhang mit dem Gesetz vom 10. August 1915."
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund dieses Umwandlungsplans, werden auf eintausendsechshundert Euro (1.600,- EUR) geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienene, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 novembre 2009. Relation: LAC/2009/48146. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009151313/201.
(090188105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.
Helios Private Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 79.392.
L'an deux mille neuf, le vingt novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de «HELIOS PRIVATE EQUITY S.A.», R.C.S. LUXEMBOURG No 79.392 ayant son siège social à Lu-
xembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 501
du 4 juillet 2001.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 578 du 17 mars 2009.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au
18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
115718
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15,
Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, domicilié professionnellement au 15, Côte
d'Eich, L-1450 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre cent quatre-
vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,
représentant l'intégralité du capital social de quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR
4.988.330,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires
représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Réduction du capital social à concurrence d'un montant total de quatre millions six cent vingt-trois mille cinq cent
un euros et cinquante-sept cents (EUR 4.623.501,57) pour le porter de son montant actuel quatre millions neuf cent
quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330,-) représenté par quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille
huit cent trente-trois (498.833) actions sans valeur nominale, à trois cent soixante-quatre mille huit cent vingt-huit euros
et quarante-trois cents (EUR 364.828,43) par compensation des pertes existantes au 31 octobre 2009 d'un montant de
quatre millions six mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 4.006.547,95) et par rembour-
sement à l'actionnaire unique d'un montant de six cent seize mille neuf cent cinquante-trois euros et soixante-deux cents
(EUR 616.953,62).
3. Modification afférente de l'article 3 des statuts.
4. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de réduire le capital social de la société à concurrence d'un montant total de quatre millions six cent vingt-
trois mille cinq cent un euros et cinquante-sept cents (EUR 4.623.501,57) pour le porter de son montant actuel quatre
millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330,-) représenté par quatre cent quatre-
vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions sans valeur nominale, à trois cent soixante-quatre mille huit
cent vingt-huit euros et quarante-trois cents (EUR 364.828,43) par compensation des pertes existantes au 31 octobre
2009 d'un montant de quatre millions six mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR
4.006.547,95) et par remboursement à l'actionnaire unique d'un montant de six cent seize mille neuf cent cinquante-trois
euros et soixante-deux cents (EUR 616.953,62).
La réalité des pertes a été prouvée au notaire instrumentaire par une copie des comptes de la société au 31 octobre
2009, lesquels états financiers demeureront annexés à la présente.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent soixante-quatre mille huit cent vingt-huit euros et quarante-trois cents
(EUR 364.828,43) divisé en quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions sans valeur
nominale.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. KOEUNE, R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 novembre 2009. Relation: LAC/2009/49818. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
115719
Luxembourg, le 27 novembre 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009151428/73.
(090185367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.
K-Erlen, Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 500.000,00.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 135.368.
K-Erlen Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 1.000.000,00.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 135.367.
VERSCHMELZUNGSPLAN
Im Jahre zweitausendneun, den sechsundzwanzigsten November.
Vor mir, Notar Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in L-1750 Luxemburg, 62, avenue Victor
Hugo, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen
Rechts K-Erlen Holding, mit Sitz in L-1750 Luxemburg, 62, avenue Victor Hugo, eingetragen im Handelsregister Luxem-
burg unter der Nummer B 135.367;
2) Herr Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in L-1750 Luxemburg, 62, avenue Victor
Hugo, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen
Rechts K-Erlen, mit Sitz in L-1750 Luxemburg, 62, avenue Victor Hugo, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter
der Nummer B 135.368.
Die Erschienenen, handelnd wie vorerwähnt, ersuchen den unterzeichnenden Notar Folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts K-Erlen Holding, mit Sitz in L-1750 Luxemburg,
62, avenue Victor Hugo, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 135.637, wurde gegründet
durch Urkunde, aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph Wagner mit dem Amtssitz in Sanem, am 14. Januar 2008,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 384 vom 14. Februar 2008. Die Satzungen
wurden letztmalig abgeändert gemäß Urkunde des vorbenannten Notars vom 29. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1011 vom 24. April 2008. Sie hat ein Kapital von einer Million Schweizer
Franken (1.000.000,- CHF), eingeteilt in eine Million (1.000.000) Anteile zu je einem (1,- CHF) Schweizer Franken.
Die Gesellschaft K-Erlen Holding, hält die gesamten Anteile, d.h. 100% des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts K-Erlen, mit Sitz in L-1750 Luxemburg, 62, avenue Victor Hugo, einge-
tragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 135.638, welche gegründet wurde durch Urkunde, aufge-
nommen durch den Notar Jean-Joseph Wagner mit dem Amtssitz in Sanem, am 14. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 380 vom 14. Februar 2008. Die Satzungen wurden letztmalig abgeändert
gemäss Urkunde des vorbenannten Notars vom 29. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 1011 vom 24. April 2008. Sie hat ein Kapital von fünfhunderttausend Schweizer Franken (500.000,-
CHF), eingeteilt in fünfhunderttausend (500.000) Anteile zu je einem (1,- CHF) Schweizer Franken.
Die vorbezeichneten Gesellschaften haben keinerlei andere Titel ausgegeben, welche ein Stimmrecht oder besondere
Rechte einräumen würden.
1. K-Erlen (die aufnehmende Gesellschaft) beabsichtigt, gemäss Artikel 278 und 279 des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften, so wie abgeändert, mit der Gesellschaft K-Erlen Holding (die übertragende Gesellschaft)
zu verschmelzen durch Einverleibung der Letztgenannten.
2. Die Operationen der übertragenden Gesellschaft sind buchhaltungstechnisch für Rechnung der aufnehmenden Ge-
sellschaft zu betrachten ab dem 30. September 2009.
3. Den Geschäftsführern, Kommissaren oder Wirtschaftsprüfern der verschmelzenden Gesellschaften wird keinerlei
Vorteil gewährt.
4. Zwischen den Parteien ist die Verschmelzung wirksam ein Monat nach Veröffentlichung des Verschmelzungsplanes
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, gemäß Artikel 9 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
5. Während eines Monats ab Veröffentlichung des Verschmelzungsplanes im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, haben die Gesellschafter der aufnehmenden Gesellschaft das Recht, die in Artikel 267 (1) a) b) und c) des
Gesetzes über Handelsgesellschaften aufgezählten Dokumente am Sitz der Gesellschaft einzusehen und eine Kopie aller
Dokumente auf einfache Anfrage und zu ihren Kosten zu erhalten.
115720
6. Während des gleichen Zeitraumes haben ein oder mehrere Gesellschafter der aufnehmenden Gesellschaft, welche
mindestens 5% (fünf Prozent) des gezeichneten Gesellschaftskapitals darstellen, das Recht die Einberufung einer Gene-
ralversammlung zu verlangen, welche über die Genehmigung der Verschmelzung beschließt.
7. Die übertragende Gesellschaft besitzt keinerlei Immobilien.
8. Durch die Verschmelzung durch Einverleibung ändert sich nichts, weder am Kapital noch an der Anzahl der Anteile
der aufnehmenden Gesellschaft. Jedoch werden die Anteile pro rata an die bestehenden Gesellschafter der K-Erlen
Holding übertragen.
Das Kapital der übertragenden Gesellschaft wird komplett auf die aufnehmende Gesellschaft übertragen und in dessen
Reserven verbucht.
9. In Ermangelung der Einberufung einer Generalversammlung oder der Verwerfung des Verschmelzungsplanes durch
diese, wird die Fusion, wie vorerwähnt unter 4., endgültig und bringt die Rechtswirksamkeit gemäß Artikel 274 des
Gesetzes über Handelsgesellschaften mit sich, insbesondere unter Punkt a) besagten Artikels.
10. Die verschmelzenden Gesellschaften halten die gesetzlichen Vorschriften ein bezüglich der zu tätigenden Erklä-
rungen für die Begleichung jeglicher eventueller Abgaben oder Steuern, welche aus der endgültigen Verwirklichung der
Einbringung im Rahmen der Verschmelzung hervorgehen.
11. Den Organen der übertragenden Gesellschaft wird Entlast erteilt.
12. Sämtliche Unterlagen der übertragenden Gesellschaft bleiben während des gesetzlichen Zeitraumes am Sitz der
aufnehmenden Gesellschaft hinterlegt.
13. Formalitäten - Die aufnehmende Gesellschaft:
- führt alle gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten zur Bekanntmachung der Einbringungen im Rahmen der Fusion
aus;
- verpflichtet sich die nötigen Erklärungen und Formalitäten bei jeglichen betroffenen Verwaltungen zu tätigen um die
eingebrachten Elemente der Aktiva auf ihren Namen zu übernehmen;
- führt alle Formalitäten durch um die Übertragung der Güter und Rechte auf ihren Namen Dritten gegenüber wirksam
zu machen.
14. Übergabe der Titel - Bei endgültiger Verwirklichung der Verschmelzung wird die übertragende Gesellschaft der
aufnehmenden Gesellschaft die Originale aller ihrer Gründungs- und Abänderungstitel übergeben sowie die Buchhal-
tungsbücher und andere buchhalterische Unterlagen, die Eigentumstitel oder -belege aller Aktiva, die Belege zu den
verwirklichten Operationen, die Mobiliarwerte sowie alle Verträge (Darlehen, Arbeitsverträge, Treuhandverträge ...),
Archive, Schriftstücke und andere jegliche Unterlagen in Bezug auf die übertragenen Werte und Rechte.
15. Kosten und Gebühren - Alle Kosten, Gebühren und Honorare im Rahmen der Verschmelzung sind zu Lasten der
aufnehmenden Gesellschaft.
16. Die aufnehmende Gesellschaft übernimmt die gegebenenfalls durch die übertragende Gesellschaft geschuldeten
Steuern auf das Kapital und die Gewinne bezüglich der noch nicht definitiv besteuerten Geschäftsjahre.
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 271 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
Zwecks Einregistrierung erklären die Gesellschaften, dass die Einverleibung der Gesamtheit aller Aktiva und Passiva
der übertragenden Gesellschaft an die aufnehmende Gesellschaft, welche in der Europäischen Gemeinschaft bestehen,
unter Anwendung des Artikels 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, so wie dies abgeändert wurde, getätigt wird,
welcher die Freistellung von der Registrierungsgebühr auf Einbringungen vorsieht.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1
er
décembre 2009. Relation: LAC/2009/51326. Reçu douze euros (EUR
12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009151671/106.
(090188069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.
115721
Holdess Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2152 Luxembourg, 34, rue Van der Meulen.
R.C.S. Luxembourg B 73.631.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2382 du 7 décembre 2009, page 114313, de
l'extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2009:
au lieu de: «(...) 1) que le siège social de la société est transféré du 21, rue Vauban à L-2663 Luxembourg à la rue Van
der Meiden n° 34 à L-2152 Luxembourg à dater du 1
er
novembre 2009.»,
lire: «(...) 1) que le siège social de la société est transféré du 21, rue Vauban à L-2663 Luxembourg à la rue Van der
Meulen n° 34 à L-2152 Luxembourg à dater du 1
er
novembre 2009.»
Référence de publication: 2009151420/13.
Gemplus International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 73.145.
In the year two thousand and nine, on the first day of the month of December, at 4.15 p.m.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Gemalto N.V., a public limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, with corporate seat
in Amsterdam, the Netherlands whose address is Barbara Strozzilaan 382, 1083 HN Amsterdam, the Netherlands, re-
gistered with the Dutch trade register under number 27255026 (the "Sole Shareholder"),
represented by Me Valérie Kopéra, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 30 November
2009, being the Sole Shareholder of Gemplus International S.A. (the "Company"), a société anonyme incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 73.145, incorporated under the deno-
mination Mars Sun S.à r.l., by virtue of a deed of notary Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on 6
th
December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") n° 120 of 4
th
February 2000. The articles of association of the Company have been amended in order to change the legal form of the
Company from a société à responsabilité limitée to a société anonyme and to change the Company's name into Gemplus
International S.A., by virtue of a deed of notary Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on 1
st
February 2000,
published in the Mémorial n° 363 of 20
th
May 2000. The articles of association of the Company have subsequently been
amended from time to time and for the last time as a result of a deed of notary Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, on 25
th
August 2009, published in the Mémorial n° 1886 of 29
th
September 2009.
The appearing party declared and requested the notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all the outstanding shares in the Company (other than the shares held in treasury by the
Company), together representing 100% of the voting rights in the Company, so that decisions can validly be taken on all
items of the agenda.
II. The items on which resolution is to be passed is as follows:
1. Reduction of the share capital of the Company from its current amount of one hundred thirty-eight million two
hundred forty-one thousand six hundred forty point thirty Euros (EUR 138,241,640.30) to sixty-six million one hundred
thirteen thousand three hundred thirty-nine point forty-four Euros (EUR 66,113,339.44) for the purpose of, and by
cancellation of three hundred forty million two hundred fifty-nine thousand six hundred eighty-nine (340,259,689) shares
currently held in treasury; concurrent reduction of the undistributable reserve created pursuant to article 49-5 of the
Luxembourg Company Law that was created at the time of repurchase of such treasury shares; creation of an undistri-
butable reserve in an amount of seventy-two million one hundred twenty-eight thousand, three hundred point eighty-six
Euros (EUR 72,128,300.86) corresponding to the accounting par of the shares so cancelled pursuant to article 69-2 of
the Luxembourg Company Law.
2. Reduction of the share capital of the Company from its current amount of sixty-six million one hundred thirteen
thousand three hundred thirty-nine point forty-four Euros (EUR 66,113,339.44) to fifty-eight million seven hundred ninety
thousand seven hundred twenty-three point eleven Euros (EUR 58,790,723.11) for the purpose of, and by, cancellation
of thirty-four million five hundred forty-three thousand eight hundred seventy-seven (34,543,877) shares held by the Sole
Shareholder and reimbursement to the Sole Shareholder of the nominal amount of the shares so cancelled and the amount
put into the undistributable reserve pursuant to item 1 above in total being seventy-nine million four hundred fifty thousand
nine hundred seventeen point ten Euros (EUR 79,450,917.10), and payment of this amount to the Sole Shareholder after
30 days following publication in the Mémorial of the minutes recording this reduction of share capital.
115722
3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the foregoing resolution.
The appearing party requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to decrease the share capital of the Company from its current amount of one hundred thirty-eight million
two hundred forty-one thousand six hundred forty point thirty Euros (EUR 138,241,640.30) to sixty-six million one
hundred thirteen thousand three hundred thirty-nine point forty-four Euros (EUR 66,113,339.44) by cancellation of three
hundred forty million two hundred fifty-nine thousand six hundred eighty-nine (340,259,689) shares currently held in
treasury, concurrent reduction of the undistributable reserve created pursuant to article 49-5 of the Luxembourg Com-
pany Law, without any payment to the Sole Shareholder, and creation of an undistributable reserve of seventy-two million
one hundred twenty-eight thousand, three hundred point eighty-six Euros (EUR 72,128,300.86) corresponding to the
accounting par of the shares so cancelled pursuant to article 69-2 of the Luxembourg Company Law. Such reserve may
not be distributed to the Sole Shareholder except in the case of a reduction of share capital.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to decrease the share capital of the Company from its amount of sixty-six million one hundred thirteen
thousand three hundred thirty-nine point forty-four Euros (EUR 66,113,339.44) pursuant to the preceding resolution to
fifty-eight million seven hundred ninety thousand seven hundred twenty-three point eleven Euros (EUR 58,790,723.11)
and to dissolve the undistributable reserve created pursuant to the preceding resolution by cancellation of thirty-four
million five hundred forty-three thousand eight hundred seventy-seven (34,543,877) shares held by the Sole Shareholder
and reimbursement to the Sole Shareholder of the amount corresponding to the accounting par of the shares so cancelled
and the amount put into the undistributable reserve pursuant to the first resolution above in total being seventy-nine
million four hundred fifty thousand nine hundred seventeen point ten Euros (EUR 79,450,917.10) and payment of this
amount to the Sole Shareholder after 30 days following the publication in the Mémorial of these minutes.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above, the sub paragraph 5.1 of article 5 of the articles of association of the Company is amended so
as to read as follows:
" 5.1. The subscribed capital is set at fifty-eight million seven hundred ninety thousand seven hundred twenty-three
point eleven Euros (EUR 58,790,723.11) consisting of two hundred seventy-seven million three hundred forty thousand
six hundred ninety-six shares (277,340,696) in registered form without nominal value."
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this amendment of articles are estimated at EUR 3,200.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of discrepancies between the English and French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day beforementioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le premier jour du mois de décembre, à 16.15 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Gemalto N.V., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Pays-Bas, avec siège social à Amsterdam,
Pays-Bas, dont l'adresse est Barbara Strozzilaan 382, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas, inscrite auprès du registre de
commerce hollandais sous le numéro 27255026 (l'"Actionnaire Unique"),
représentée par Me Valérie Kopéra, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du
30 novembre 2009, étant l'Actionnaire Unique de Gemplus International S.A. (la "Société"), une société anonyme con-
stituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph
II, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.145, constituée sous
la dénomination Mars Sun S.à r.l., suivant acte du notaire Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, le 6
décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") n° 120 du 4 février 2000. Les
statuts de la Société ont été modifiés afin de changer la forme juridique de la Société d'une société à responsabilité limitée
en une société anonyme et de changer le nom de la Société en Gemplus International S.A., suivant acte du notaire Gérard
Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, le 1
er
février 2000, publié au Mémorial n° 363 du 20 mai 2000. Les
statuts de la Société ont ensuite été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte du notaire Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 25 août 2009, publié au Mémorial n° 1886 du 29 septembre 2009.
115723
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. L'Actionnaire Unique détient toutes les actions en circulation dans la Société (autres que les actions détenues en
trésorerie par la Société), représentant ensemble 100% des droits de vote dans la Société, de sorte que des décisions
peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de cent trente-huit millions deux cent quarante et
un mille six cent quarante euros et trente cents (EUR 138.241.640,30) pour le porter à soixante six millions cent treize
mille trois cent trente neuf euros et quarante-quatre cents (EUR 66.113.339,44) pour les besoins de, et par l'annulation
de trois cent quarante millions deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt neuf (340.259.689) actions actuelle-
ment détenues en trésorerie; réduction simultanée de la réserve indisponible créée conformément à l'article 49-5 de la
Loi sur les Sociétés Commerciales qui a été créée au moment du rachat de ces actions en trésorerie; création d'une
réserve indisponible d'un montant de soixante-douze millions cent vingt-huit mille trois cents euros et quatre-vingt six
cents (EUR 72.128.300,86) correspondant au pair comptable des actions ainsi annulées conformément à l'article 69-2 de
la Loi sur les Sociétés Commerciales.
2. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de soixante six millions cent treize mille trois cent
trente neuf euros et quarante-quatre cents (EUR 66.113.339,44 ) pour le porter à cinquante-huit millions sept cent quatre-
vingt-dix mille sept cent vingt-trois euros et onze cents (EUR 58.790.723,11) pour les besoins de, et par l'annulation de
trente-quatre millions cinq cent quarante-trois mille huit cent soixante-dix-sept (34.543.877) actions détenues par l'Ac-
tionnaire Unique et remboursement à l'Actionnaire Unique de la valeur nominale des actions ainsi annulées et du montant
alloué à la réserve indisponible conformément au point 1. ci-dessus d'un montant total de soixante-dix-neuf millions
quatre-cent cinquante mille neuf cent dix-sept euros et dix cents (EUR 79.450.917,10), et paiement de ce montant à
l'Actionnaire Unique après 30 jours suivant la publication au Mémorial du procès-verbal de la réduction du capital social.
2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions précédentes.
La partie comparante a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de cent trente-huit millions deux cent
quarante et un mille six cent quarante euros et trente cents (EUR 138.241.640,30) pour le porter à soixante six millions
cent treize mille trois cent trente neuf euros et quarante-quatre cents (EUR 66.113.339,44) par l'annulation de trois cent
quarante millions deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt neuf (340.259.689) actions actuellement détenues
en trésorerie, la réduction simultanée de la réserve indisponible créée conformément à l'article 49-5 de la Loi sur les
Sociétés Commerciales, sans paiement à l'Actionnaire Unique, et la création d'une réserve indisponible d'un montant de
soixante-douze millions cent vingt-huit mille trois cents euros et quatre-vingt six cents (EUR 72.128.300,86) correspon-
dant au pair comptable des actions ainsi annulées conformément à l'article 69-2 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Cette réserve ne peut pas être distribuée à l'Actionnaire Unique sauf en cas de réduction du capital social.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de soixante six millions cent treize mille
trois cent trente neuf euros et quarante-quatre cents (EUR 66.113.339,44) pour le porter à cinquante-huit millions sept
cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-trois euros et onze cents (EUR 58.790.723,11) en vertu de la résolution qui
précède et de supprimer la réserve non-distribuable créée en vertu de la résolution qui précède par l'annulation de trente-
quatre millions cinq cent quarante-trois mille huit cent soixante-dix-sept (34.543.877) actions détenues par l'Actionnaire
Unique et le remboursement à l'Actionnaire Unique du montant correspondant au pair comptable des actions ainsi
annulées et le montant alloué à la réserve indisponible conformément à la première résolution ci-dessus d'un montant
total de soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante mille neuf cent dix-sept euros et dix cents (EUR 79.450.917,10),
et paiement de ce montant à l'Actionnaire Unique après 30 jours suivant la publication au Mémorial du procès-verbal de
la réduction du capital social.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, il est décidé de modifier l'alinéa 5.1 de l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il
ait la teneur suivante:
" 5.1. Le capital souscrit est fixé à cinquante-huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-trois euros
et onze cents (EUR 58.790.723,11) consistant en deux cent soixante-dix-sept millions trois cent quarante mille six cent
quatre-vingt-seize (277.340.696) actions nominatives sans valeur nominale."
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges quelconques incombant à la Société du fait de la modification des statuts,
sont à évaluer à environ EUR 3.200,-.
115724
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, ce procès-
verbal rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version
française, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture de ce procès-verbal, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. KOPERA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 décembre 2009. Relation: LAC/2009/51997. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 décembre 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009151427/166.
(090188366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2009.
IMC Asset Management Funds, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
IMC Asset Management Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2009151389/9.
(090182848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.
Capital Street S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 84.873.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009147927/10.
(090178954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Pamplona PE Holdco 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 118.106.
Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009147926/10.
(090178955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Gabefi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 99.474.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009147925/10.
(090179357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
115725
Aurealux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2628 Luxembourg, 20, rue des Trévires.
R.C.S. Luxembourg B 99.975.
Le Bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Di Carlo Olivier
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2009147923/11.
(090179465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
A.R.I. Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 78.330.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009147928/12.
(090178953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Athena Investments Limited S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 17.854.
Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009147936/10.
(090178972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Athena Paint Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 18.723.
Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009147939/10.
(090178966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Athena Paint Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 18.723.
Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009147940/10.
(090178965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
115726
Elite Relocation Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 136.877.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009147941/10.
(090178964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
El Boustan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 75.191.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EL BOUSTAN SàRL
i>Société Anonyme à Responsabilité Limitée
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
<i>Agent prestataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009147934/14.
(090178956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Global Garden Products C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.803.900,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 96.507.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 11 novembre 2009i>
L'associé unique de Global Garden Products C S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter les démissions de Madame Valérie Cooke et de Monsieur Willem-Arnoud van Rooyen en tant que gérants
de la Société avec effet au 11 novembre 2009.
- de nommer Monsieur Frederik Kuiper, né le 9 novembre 1974 à Utrecht (Pays-Bas) et Monsieur Xavier De Cillia,
né le 11 avril 1978 à Nice (France), ayant leur adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en
tant que gérants de la Société avec effet au 11 novembre 2009 et ce, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, 16 novembre 2009.
Xavier De Cillia.
Référence de publication: 2009147017/16.
(090178125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.
LP One Halbergmoos Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 113.794.
Il résulte d'un contrat sous seing privé de cession de parts sociales qu'en date du 30 octobre 2009 l'associé Logic Park
Europe S.à r.l. a cédé 78 parts sociales de la Société à Logicreal Holding GmbH, avec siège social à: Philipp-Reis-Strasse
14, 63303 Dreieich, Germany.
Il résulte que les 1500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont dès lors détenues
comme suit:
- 1422 parts sociales: First Euro Industrial Properties II S.à r.l.
- 78 parts sociales: Logicreal Holding GmbH
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
115727
Luxembourg, le 16 novembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2009147021/20.
(090178113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.
LP Three Darmstadt Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 113.567.
Il résulte d'un contrat sous seing privé de cession de parts sociales qu'en date du 30 octobre 2009 l'associé Logic Park
Europe S.à r.l. a cédé 78 parts sociales de la Société à Logicreal Holding GmbH, avec siège social à: Philipp-Reis-Strasse
14, 63303 Dreieich, Germany.
Il résulte que les 1500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont dès lors détenues
comme suit:
- 1422 parts sociales: First Euro Industrial Properties II S.à r.l.
- 78 parts sociales: Logicreal Holding GmbH
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2009147023/20.
(090178107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.
Covam Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 64.602.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 06 mai 2009i>
Les mandats de Messieurs Roger CAURLA, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette (L) demeurant
au 19, rue des Champs à L-3912 Mondercange, Toby HERKRATH, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach (L)
demeurant au 19, rue de Kirchberg à L-1858 Luxembourg et Alain VASSEUR, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange
(L) demeurant au 3, rue de Mamer à L-8277 Holzem en tant qu'administrateurs, ainsi que le mandat de la société anonyme
Triple A Consulting, R.C.S. Luxembourg B 61417, ayant son siège social au 2, Millegässel à L-2156 Luxembourg en tant
que commissaire aux comptes sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire
de 2015.
Certifié sincère et conforme
COVAM HOLDING S.A.
Signature
Référence de publication: 2009147024/18.
(090178100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.
Yannick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 30, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 27.500.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009147596/9.
(090178849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
115728
Adviser I Funds
Adviser II Funds
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 6 S.à r.l.
A.R.I. Invest S.A.
Athena Investments Limited S.A.
Athena Paint Investments S.A.
Athena Paint Investments S.A.
Aurealux S.A.
B & B Bepuvo Holding S.A.
BDM Technologies Holding S.A.
Capital Street S.A.
China Corn Oil S.A.
Covam Holding S.A.
El Boustan S.à r.l.
Elektra Finanzierung A.G.
Elite Relocation Service S.à r.l.
Gabefi S.à r.l.
Gemplus International S.A.
GFA - HAIG
GFA - HAIG
Global Garden Products C S.à r.l.
Helios Private Equity S.A.
Holdess Holding S.A.
IMC Asset Management Funds
International Chemical Investors S.A.
KBC Institutional Cash
K-Erlen
K-Erlen Holding
KP Interiors S.à r.l.
Laumar S.A.
Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV
Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV
LP One Halbergmoos Sàrl
LP Three Darmstadt Sàrl
Pamplona PE Holdco 4 S.A.
Spring Multiple 2007 S.C.A.
Transworld Fertilizers Holding S.A.
UBP Multifunds II
UBS (Lux) Exposure Sicav
UBS (Lux) Structured Sicav
UBS (Lux) Structured Sicav 2
Valauchan Caisse Auchan Italie S.C.A.
Vega Business Aviation S.à r.l.
Yannick S.à r.l.