This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2337
1
er
décembre 2009
SOMMAIRE
Acres 1010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112174
Amberley S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112130
Areion Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112151
Baikal S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112170
Bemol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112173
Brighton Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
112175
BSkyB Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
112161
Central Shoe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112170
Citrix Systems Capital and Finance Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112163
Coaching International S.A. . . . . . . . . . . . . .
112171
Colonnade Holdco n°11 S.à r.l. . . . . . . . . . .
112176
Compagnie d'Investissement Eaton-Bel-
gravia S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112133
Cordell Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
112168
Economat S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112130
E.ON Asset Management S.à r.l. . . . . . . . .
112174
European Resorts S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112172
Ever Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112133
Fine Tobacco Flavours S.A. . . . . . . . . . . . . .
112160
Finsweet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112160
FPM Realty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112170
FPM Realty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112131
Gemalco S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112132
GR Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
112148
Harvey Weston International S.A. . . . . . . .
112173
Hirslanden Investments S.A. . . . . . . . . . . . .
112154
Immo 70's S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112163
Knockon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112171
Marine Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
112172
M. Bormann GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112151
Millicom International Cellular S.A. . . . . . .
112175
Mypa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112175
Netaxel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112171
Nidderkuerer Tuterten asbl . . . . . . . . . . . . .
112165
OVC Property Services Limited Société
Anonyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112132
Pimco Luxembourg II . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112131
Pimco Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
112131
Port Bay SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112132
Presta-Gaz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112162
Repco 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112169
Repco 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112169
SafeWorks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112176
School S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112154
Sigma Capital Investments S.A. . . . . . . . . .
112173
Skype Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112174
SL Software_Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
112162
Socipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112161
Summerwind S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112176
Theo Müller Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
112141
Theo Müller Group S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . .
112134
Unirec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112163
Vendest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112168
Yurger S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112168
Zeclat Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112154
112129
Amberley S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 78.952.
EXTRAIT
Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 15 octobre 2009 à 9.00 heures au siège social:
Madame Carine Agostini (employée privée, adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née
le 27.04.1977 à Villerupt (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur
Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se
tiendra en 2010.
Luxembourg, le 15.10.2009
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2009143234/16.
(090172949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Economat S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg E 1.391.
Anteilsverkauf und Übertragungsurkunde vom 14. Juni 2001
- Herr Alain van Kasteren, Inhaber einer Lizenz der Wirtschaftswissenschaften, wohnhaft in Remich (L)
- Herr Joachim Mittermüller, Kaufmann, wohnhaft in Remeldorff (F)
Verkaufen hiermit insgesamt 750 Interessenanteile, die nicht belastet und frei verfügbar sind, der Bürgerlichrechtlichen
Immobiliengesellschaft ECONOMAT an:
Den
Comptoir Luxembourgeois des Charbonnages d'Eschweiler S.à r.l.
50, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Hier vertreten durch:
- Herr Norbert Theisen, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in Dommeldange (L)
- Herr Wilhelm Bayartz, Diplom Betriebswirt, wohnhaft in Aachen (D)
a) 375 Anteile von Herrn van Kasteren
b) 375 Anteile von Herr Joachim Mittermüller
Der vorliegende Anteilverkauf erfolgte zum Gesamtpreis von 8.597.811,- (achtmillionenfünfhundersiebenundneunzig-
tausendachthunderteinundachtzig) LUF. Der Kaufpreis ist am Tage der Beurkundung fällig und auf das nachstehend
bezeichnete Konto des Notars d'Huart Georges zu überweisen: Kontonummer 30-110576-30 bei der Banque Générale
du Luxembourg.
Die bisherigen Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten die bis zum heutigen Tage entstanden sind, unabhängig
davon, ob sie in der Bilanz vom 15.05.201 aufgeführt sind oder nicht.
Nach diesem Verkauf ist jetzt die neue Interessenanteilverteilung wie folgt:
Comptoir Luxembourgeois des Charbonnages d'Eschweiler S.à r.l.
50, rue Goethe
L-1637 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Anteile
M. Joachim Mittermüller
Kaufmann, wohnhaft in Remeldorff (F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
M. Alain van Kasteren
Inhaber einer Licence der Wirtschaftswissenschaften
wohnhaft in Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009143280/38.
(090173182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
112130
Pimco Luxembourg II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 112.824.
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2009, les actionnaires de la société 'PIMCO Luxembourg II' ont
pris les résolutions suivantes:
- Approbation de la cooptation de Jeffrey Michael Sargent, ayant son adresse professionnelle au Seidlstrasse 24-24a,
Munich, D-80335 Allemagne, avec effet au 30 avril 2009 en remplacement de Ernest Lee Schmider, administrateur dé-
missionnaire;
- Réélection des membres du conseil d'administration de la société. Désormais, le conseil d'administration de la société
est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2010:
* Craig Dawson
* Joseph Vincent McDevitt
* Jeffrey Michael Sargent
- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en leur fonction de réviseurs d'entreprise de la société pour
une durée d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature
Référence de publication: 2009143279/22.
(090173054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Pimco Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 86.327.
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2009, les actionnaires de la société 'PIMCO Luxembourg S.A.'
ont pris les résolutions suivantes:
- Approbation de la cooptation de Jeffrey Michael Sargent, ayant son adresse professionnelle au Seidlstrasse 24-24a,
Munich, D-80335 Allemagne, avec effet au 30 avril 2009 en remplacement de Ernest Lee Schmider, administrateur dé-
missionnaire;
- Réélection des membres du conseil d'administration de la société. Désormais, le conseil d'administration de la société
est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2010:
* Craig Dawson
* Joseph Vincent McDevitt
* Jeffrey Michael Sargent
- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en leur fonction de réviseurs d'entreprise de la société pour
une durée d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature
Référence de publication: 2009143278/22.
(090173050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
FPM Realty S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 117.790.
Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009143810/10.
(090173632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
112131
OVC Property Services Limited Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.201.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009143811/10.
(090173655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Gemalco S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 37.394.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre
2009, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2009, LAC/2009/44086.
Qu'a été prononcée la clôture de la liquidation de la société anonyme holding "GEMALCO S.A.H.", ayant son siège
social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, constituée suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire alors
de résidence à Esch/AIzette, le 26 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 5 de
1992.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,
le 25 février 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 905 du 29 avril 2009.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du 14 octobre
2009, à l'ancien siège social L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009143778/21.
(090173875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Port Bay SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 80.908.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 4 septembre 2009
que:
1. Sont réélus administrateurs pour la durée d'une année, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale qui
statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013:
- Monsieur Levon DEDEGIAN, administrateur type «A»;
- Monsieur Patrick MOINET, administrateur type «B»;
- Monsieur Gabriele BROGGINI, administrateur type «B».
2. Le mandat de la société «BF CONSULTING S.à r.l.» n'étant pas renouvelé.
Est élu en tant que commissaire de la société son mandat prendra fin le 31 décembre 2013:
- La société «REVICONSULT S.à r.l.» inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 139.013 et ayant son siège social au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2009.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2009143367/23.
(090173225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
112132
Compagnie d'Investissement Eaton-Belgravia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 96.759.
Pursuant to a share transfer agreement dated 22 July 2009 between Foncière CG & Associés, a public limited liability
company (société anonyme), under Luxembourg Law, having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 101.813, and Ms Olimpia Ciardi,
born on 25
th
July 1959 in Roma (Italy), and residing at 27 Chester Square, London SW1W 9HT (United Kingdom)
- six (6) shares of the Company issued and outstanding as of the date of the agreement, have been transferred from
Foncière CG & Associés to Ms Olimpia Ciardi
Consequently, the subscribed capital of the Company is fixed as follows:
- Foncière CG & Associés S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 shares
- Ms Olimpia Ciardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 shares
Traduction pour les besoins de l'Enregistrement
Conformément à un contrat de transfert de parts sociales en date du 22 juillet 2009 entre Foncière CG & Associés,
société anonyme de droit luxembourgeois, domiciliée 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, et enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 101.813, et Mme Olimpia Ciardi, née le 25 juillet 1959 à Rome
(Italie) et résidant à 27 Chester Square, London, SW1W 9HT (United Kingdom)
- six (6) parts sociales de la Société, émises et en circulation à la date du contrat, ont été transférées par Foncière CG
& Associés S.A. à Mme Olimpia Ciardi.
Par conséquent, le capital social de la société est réparti comme suit:
- Foncière CG & Associés S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 parts
- Ms Olimpia Ciardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009143371/28.
(090173256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Ever Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 136.262.
Pursuant to a share transfer agreement dated 7
th
October 2009 between
PARK PLACE CAPITAL S.A., a public limited liability company (société anonyme), under Luxembourg Law, having its
registered office at 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 131.673, duly represented by Mrs. Sylvie Lexa, its managing director,
and
Mr. Olivier Corchia, born in Paris (France), on January 20
th
, 1974 and residing at 123, boulevard Pereire, F-75017
Paris, France,
ninety (90) shares of the Company issued and outstanding as of the date of the agreement, have been transferred from
Mr Olivier Corchia to Park Place Capital SA.
Consequently, the subscribed capital of the Company is fixed as follows:
- Park Place Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 shares
- Mr Bruno RUBINSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 shares
- Mr Olivier CORCHIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 shares
Traduction pour les besoins de l'Enregistrement
Conformément à un contrat de transfert de parts sociales en date du 7 octobre 2009 entre
PARK PLACE CAPITAL S.A., une société anonyme, sous la Loi Luxembourgeoise, ayant son siège social au 22, rue
Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 131.673, dûment représentée par Madame Sylvie Lexa, administrateur-délégué
et
Mr Olivier Corchia, né à Paris (France), le 20 janvier 1974 et résidant 123, boulevard Pereire, F-75017 Paris, France,
112133
quatre-vingt-dix (90) parts sociales de la Société, émises et en circulation à la date du contrat, ont été transférées par
Monsieur Olivier Corchia à Park Place Capital S.A.
Par conséquent, le capital social de la société est réparti comme suit:
- Park Place Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 parts sociales
- Mr Bruno RUBINSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 parts sociales
- Mr Olivier CORCHIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009143369/36.
(090173255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Theo Müller Group S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 149.104.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the third day of November.
Before the undersigned Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri
Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
There appeared:
1) Theo Müller Group S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register and having a share capital of EUR 12,500,
(general partner),
here represented by Olivier Too, lawyer, professionally residing at 33, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, by
virtue of a power of attorney, given in Zurich, Switzerland on 23 October 2009;
2) Theo Müller Commanditaire S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register and having a share capital of EUR 12,500
(limited partner),
here represented by Olivier Too, lawyer, professionally residing at 33, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, by
virtue of a power of attorney, given in Zurich, Switzerland on 23 October 2009; and
3) Theo Müller, Unternehmer, born on 29 January 1940 in Aretsried / Fischach, residing at Holzwiesstrasse 49, CH
8703 Erlenbach, Switzerland,
(limited partner),
here represented by Olivier Too, lawyer, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by
virtue of a power of attorney, given in Zurich, Switzerland on 23 October 2009.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following articles of association
of a société en commandite simple, which they declare organised among themselves as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société en commandite simple, under the name of "Theo Müller Group S.e.c.s.".
Art. 2. The company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the company is the incorporation and the acquisition of Luxembourg and foreign companies as
well as participations in Luxembourg and foreign companies, of any legal form whatsoever, the sale of companies and
participations thereof, the management and development of the group and its member companies, the provision of central
services within the group as well as the management of the participations in companies and the creation of branches.
The company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option,
securities, and any intellectual property rights and real estate, to realise them by way of sale, transfer, exchange or
otherwise and to develop them. The company may receive or grant licenses on intellectual property rights.
112134
The company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.
The company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obli-
gations of companies in which the company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form
part of the same group of companies as the company and it may grant any assistance to such companies, including, but
not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assis-
tance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its
assets.
The company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly
or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City.
Within the same municipality, the registered office of the company may be transferred by resolution of the managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the managers.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The share capital is set at one million Euro (EUR 1,000,000.-) consisting of one (1) class A share with a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and thirty-nine thousand nine hundred ninety nine (39,999) class B shares with a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote with regard to the general meetings of the partners.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by decision of the general meeting of the partners.
Art. 7. The company will recognize only one single holder per share. The joint holders have to appoint a sole repre-
sentative towards the company.
Art. 8. Shares are freely transferable among partners. Transfers to non-partners can be made only with the agreement
of all partners. The transfer of shares will not cause the dissolution of the company.
Art. 9. In accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code, a transfer of shares shall be binding on the
company only after the company has been notified of such transfer or has accepted it.
Art. 10. The general partners are severally and jointly liable for all liabilities of the company.
The limited partners are only liable to the extent of their contributions to the company.
Art. 11. Neither creditors nor heirs of the partners may, for any reason, seal the assets of the company.
C. Management
Art. 12. The company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting
of the partners, adopted by partners owning more than half of the share capital.
The general meeting of the partners may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the partners
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
joint signature of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate his or their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
112135
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the company. The decisions of the board of managers
will be recorded in minutes to be held at the registered office of the company and to be signed by any managers attending
the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the company.
D. General meetings - Decision of the Partners
Art. 14. Once a year, on the 3rd Wednesday in June at 2 p.m., the partners shall meet at the company's registered
office or at any other place contained in the convening notice or pass a written resolution having on its agenda the approval
of the balance sheet, of the profit and loss accounts, of the report of the management and of the independent auditor,
the decision on the allocation of the results and the discharge to be granted to the management.
Art. 15. Collective decisions are taken in general meetings or, if all the partners so agree, by way of written vote.
The meeting shall be convened by the management pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered
mail to all partners at least eight days prior to the meeting.
Other general meetings of partners must also be convened if requested by partners holding 20% or more of the
company's issued shares.
Such convened general meetings of partners may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg and at
such times as may be specified in the respective notices of meeting.
General meetings of the partners can deliberate or act validly only if at least 50 % of the shares of the company are
present or represented.
Except as otherwise required by the Luxembourg Companies Act of 1915, resolutions shall be approved by partners
representing at least the majority of the shares, provided that the general partner is included in that majority. No reso-
lutions can be taken without the consent of the general partner.
Art. 16. The accounting year shall begin on the 1
st
of January of each year and shall terminate on the 31
st
December
of the same year.
Art. 17. The manager(s) prepare(s) the annual balance sheet, the profit and loss accounts and the report of the ma-
nagement. The annual balance sheet and the profit and loss accounts will be submitted to an independent auditor who
will issue an audit report to the general meeting. The partners shall have the right to make themselves acquainted with
the books and documents of the company without removing them from the premises. They may be assisted by an expert.
E. Dissolution - Liquidation
Art. 18. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators
appointed by the partners. Failing such decision the manager(s) shall be appointed liquidator(s).
F. General provision
Art. 19. For all matters not governed by the present articles of incorporation the partners shall refer to the laws of
Luxembourg.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 December
2009.
112136
<i>Liberation of sharesi>
The subscribers have subscribed the shares as mentioned hereafter:
<i>Limited partners:i>
1. Theo Müller Commanditaire S.à r.l., prenamed, paid EUR 25 in subscription for one B share,
2. Theo Müller, prenamed, paid EUR 999,950 in subscription for thirty-nine thousand nine hundred ninety-eight
(39,998) B shares,
<i>General partner:i>
3. Theo Müller Group S.à r.l., prenamed, paid EUR 25 in subscription for one A share.
Total: EUR 1,000,000 paid for 40,000 shares.
All the shares have been entirely paid-in so that the amount of EUR 1,000,000 (one million euro) is as of now available
to the company, as has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 2.200.-.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. the number of managers is set at 2. The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period of
time:
Dr. Thomas Bachofer, born on 31 January 1956 in Augsburg, whose private address is at Imhofstrasse 12, # 3001,
D-86159 Augsburg, Germany; and
Dr. Edgar Lange, born on 27 March 1964 in Hamburg, whose private address is at Schieggstrasse 7, D-81479 München,
Germany.
2. The partners resolve to set the registered office of the company at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundneun, am dritten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd als Stellvertreter von Notar
Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt.
Sind erschienen:
1) Theo Müller Group S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter luxemburgischem Recht,
mit Sitz in 23, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, noch nicht eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés
von Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500 (Komplementär),
vertreten durch Olivier Too, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in 33, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxemburg, gemäß
privatrechtlicher Vollmacht, ausgestellt am 23. Oktober 2009;
2) Theo Müller Commanditaire S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter luxemburgischem
Recht, mit Sitz in 23, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, noch nicht eingetragen beim Registre de Commerce et des
Sociétés von Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500 (Kommanditist),
vertreten durch Olivier Too, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in 33, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxemburg, gemäß
privatrechtlicher Vollmacht, ausgestellt am 23. Oktober 2009; und
3) Theo Müller, Unternehmer, geboren am 29. Januar 1940 in Aretsried / Fischach, wohnhaft in Holzwiesstrasse 49,
CH 8703 Erlenbach, Schweiz, (Kommanditist),
vertreten durch Olivier Too, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, gemäß
privatrechtlicher Vollmacht, ausgestellt am 23. Oktober 2009.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
112137
Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditgesellschaft, die sie hiermit
gründen, wie folgt zu beurkunden:
A. Form - Zweck - Bezeichnung - Sitz - Dauer
Art. 1. Es besteht hiermit zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten
Anteile eine Kommanditgesellschaft, die die Bezeichnung führt "Theo Müller Group S.e.c.s.".
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an luxemburgischen oder
ausländischen Unternehmen jedweder Rechtsform, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die
Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen, die Erbringung zentraler Dienstleistungen in-
nerhalb des Konzerns sowie die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen und die Errichtung von Niederlassungen.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögenswerten
jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art,
zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweglicher
oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen, um
sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wertpa-
piere und geistiges Eigentum und Immobilien durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben,
durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln. Die Gesell-
schaft kann Lizenzen vergeben und Rechte an geistigem Eigentum übertragen.
Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben.
Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie
jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-
tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von
Wertpapieren bezieht.
Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaf-
ten, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die Verpflichtungen der Gesellschaften, die derselben
Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem sie sie unter
anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios unterstützt und
sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, ab-
treten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.
Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen oder
unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen
oder ihrer Entwicklung förderlich sind.
Art. 4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Innerhalb derselben Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.
Durch Beschluss der Geschäftsführung können auch Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum als auch
im Ausland, gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) eingeteilt in einen (1) A Anteil
mit einem Einheitswert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und neun und dreißig tausend neunhundert neun und neunzig
(39.999) B Anteile mit einem Einheitswert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt eine Stimme hinsichtlich der Generalversammlungen der Gesellschafter.
Art. 6. Das Stammkapital kann jederzeit von der Generalversammlung der Gesellschafter abgeändert werden.
Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Anteil an. Sollte das Eigentum an Anteile aufgeteilt sein,
müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Anteile geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um
die aus den Anteilen resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten.
Art. 8. Anteile sind unter Gesellschafter frei übertragbar. Eine Übertragung an einen Nichtgesellschafter kann nur mit
Einwilligung aller Gesellschafter erfolgen. Die Übertragung der Anteile führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
Art. 9. In Übereinstimmung mit Artikel 1690 des Code Civil, ist eine Abtretung gegenüber der Gesellschaft wirksam,
wenn sie der Gesellschaft mitgeteilt wurde oder von ihr angenommen wurde.
Art. 10. Die Komplementäre haften unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für die Gesellschaftsverpflichtungen.
Die Kommanditisten haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.
Art. 11. Die Gläubiger oder Erben eines Gesellschafters können in keinem Fall die Versiegelung der Vermögensge-
genstände der Gesellschaft erwirken.
112138
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden,
bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung er-
nannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des
Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt
wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten
und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen
Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.
Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich, kann
bzw. können seine/ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte
delegieren. Der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, die jeweiligen Geschäftsführer, der (die)
seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmäch-
tigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel , das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.
Art. 13. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß
im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.
D. Gemeinschaftliche Entscheidungen
Art. 14. Einmal im Jahr, am dritten Mittwoch im Juni um 14.00 Uhr, treffen sich die Gesellschafter am Gesellschaftssitz
oder einem anderen in dem Einberufungsschreiben bekanntgegebenen Ort, oder fassen einen schriftlichen Beschluss,
dessen Tagesordnung die Annahme der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Berichts der Geschäftsführung
112139
und des Wirtschaftsprüfers, die Entscheidung über die Verwendung des Nettogewinns und die Entlastung der Geschäfts-
führung enthält.
Art. 15. Gemeinschaftliche Entscheidungen werden in der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen. Sie kön-
nen auch auf dem Schriftwege erfolgen, wenn alle Gesellschafter dem zustimmen. Jeder Gesellschafter erhält von der
Geschäftsführung wenigstens acht Tage vor der Sitzung ein Einberufungsschreiben mit der Tagesordnung per Einschreib-
sendung.
Sonstige Gesellschafterversammlungen der Gesellschafter müssen ebenfalls einberufen werden, wenn dies durch Ge-
sellschafter beantragt wird, die 20% oder mehr der ausgegebenen Gesellschaftsanteile halten.
Diese einberufenen Gesellschafterversammlungen der Gesellschafter können an den Orten im Großherzogtum Lu-
xemburg und zu den Zeiten abgehalten werden, die in den entsprechenden Einberufungsbekanntmachungen angeführt
sind.
Gesellschafterversammlungen sind beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der Gesellschaftsanteile anwesend oder ver-
treten sind.
Gesellschafterbeschlüsse werden, außer wenn luxemburgische Gesetze etwas anderes besagen, mit einfacher Mehrheit
der vertretenen Gesellschaftsanteile gefasst, vorausgesetzt der Komplementär ist in dieser Mehrheit mit inbegriffen. Keine
Entscheidung kann ohne die Zustimmung des Komplementärs getroffen werden.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Der Geschäftsführer, oder im Fall einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, bereitet die
Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie den Bericht der Geschäftsführung, vor. Die Bilanz und die Gewinn- und
Verlustrechnung werden einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorgelegt und sind Gegenstand eines Prüfungsberichtes
für die Generalversammlung. Die Gesellschafter können am Gesellschaftssitz Einsicht in den Bilanzen und Dokumente
der Gesellschaft nehmen. Sie können sich von einem Experten begleiten lassen.
E. Auflösung und Liquidierung
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren. Fassen
die Gesellschafter keine Entscheidung in dieser Hinsicht, so ist der Geschäftsführer, oder im Fall einer Mehrzahl von
Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat als Liquidator anzusehen.
F. Generalregelung
Art. 19. Für sämtliche in dieser Satzung nicht geregelte Punkte gelten die Luxemburger Gesetze.
<i>Übergangsregelungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am 31. Dezember 2009.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Die Erschienenen haben die Anteile wie folgt gezeichnet:
<i>Kommanditisten:i>
1. Theo Müller Commanditaire S.à r.l., vorgenannt, zahlte EUR 25 für einen B Anteil,
2. Theo Müller, vorgenannt, zahlte EUR 999.950 für 39.998 B Anteile.
<i>Komplementär:i>
3. Theo Müller Group S.à r.l. zahlte EUR 25 für einen A Anteil,
insgesamt: EUR 1.000.000 für 40.000 Anteile.
Alle Anteile wurden voll einbezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag
von EUR 1.000.000 (eine Million Euro), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die aus Anlass der Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf EUR 2.200,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung
der Gesellschafter, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 2 Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für eine
unbestimmte Zeit ernannt:
Dr. Thomas Bachofer, geboren am 31. Januar 1956 in Augsburg, wohnhaft in Imhofstrasse 12, # 3001, D-86159 Augs-
burg, Deutschland; und
Dr. Edgar Lange, geboren am 27. März 1964 in Hamburg, wohnhaft in Schieggstrasse 7, D-81479 München, Deutschland.
112140
2. die Gesellschafter beschließen als Sitz der Gesellschaft 23, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg festzulegen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erscheinenden
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im
Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen hat dieser mit Uns,
Notar, diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: O. TOO und C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46650. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 10. November 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009143440/380.
(090173529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Theo Müller Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 149.100.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the third day of November.
Before, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of
the present deed.
THERE APPEARED:
Theo Müller, Unternehmer, born on 29 January 1940 in Aretsried / Fischach, residing at Holzwiesstrasse 49, CH 8703
Erlenbach, Schweiz,
here represented by Olivier Too, lawyer, professionally residing in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by
virtue of a power of attorney, given in Zurich, Switzerland on 23 October 2009.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Theo
Müller Group S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option,
securities, and any intellectual property rights and real estate, to realise them by way of sale, transfer, exchange or
otherwise and to develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.
The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the
obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.
112141
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
The Company may act as general partner of Theo Müller Group S.e.c.s., a company which is to be incorporated under
the laws of Luxembourg.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (Euro twelve thousand five
hundred) represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (Euro twenty-five) per share each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-
holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
joint signature of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate his or their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.
112142
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established
and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
112143
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
Theo Müller, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 (five hundred) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 (five hundred) shares
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (Euro twelve thousand five
hundred) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2009.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at 2. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of
time:
Dr. Thomas Bachofer, born on 31 January 1956 in Augsburg, whose private address is at Imhofstrasse 12, # 3001, D
86159 Augsburg, Germany; and
Dr. Edgar Lange, born on 27 March 1964 in Hamburg, whose private address is at Schieggstrasse 7, D 81479 München,
Germany.
2. the registered office is established at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed, together with the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundneun, am dritten November.
Vor Maître Carlo Wersandt, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, handelnd als Stell-
vertreter von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welch
Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt.
IST ERSCHIENEN:
Theo Müller, Unternehmer, geboren am 29.Januar 1940 in Aretsried / Fischach, wohnhaft in Holzwiesstrasse 49, CH
8703 Erlenbach, Schweiz,
vertreten durch Olivier Too, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in 33, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, auf-
grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Zürich, Schweiz, am 23. Oktober 2009.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In seiner oben angegebenen Eigenschaft ersucht der Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter
der Bezeichnung "Theo Müller Group S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit
dem Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese
112144
gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Be-
teiligungen.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögenswerten
jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art,
zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweglicher
oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen, um
sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wertpa-
piere und geistiges Eigentum und Immobilien durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben,
durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln. Die Gesell-
schaft kann Lizenzen vergeben und Rechte an geistigem Eigentum übertragen.
Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen , nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben.
Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie
jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-
tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von
Wertpapieren bezieht.
Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaf-
ten, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die Verpflichtungen der Gesellschaften, die derselben
Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem sie sie unter
anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios unterstützt und
sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, ab-
treten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.
Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen oder
unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen
oder ihrer Entwicklung förderlich sind.
Die Gesellschaft kann Komplementär der Theo Müller Group S.e.c.s. sein, einer Gesellschaft, die nach luxemburgi-
schem Recht zu gründen sein wird.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (Euro zwölf tausend fünfhundert), ein-
geteilt in 500 (fünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25 (Euro fünfundzwanzig) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,
soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
112145
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-
stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt
wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten
und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen
Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.
Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich, kann
bzw. können seine/ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte
delegieren. Der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, die jeweiligen Geschäftsführer, der (die)
seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmäch-
tigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel , das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.
112146
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-
lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-
nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1.Januar und endet am 31.Dezember eines jeden
Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31.Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach Artikel 69 (2) des Gesetzes
vom 19. Dezember 2002 über das Handelsregister und die Buchführung von Gesellschaften keine Anwendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
Theo Müller, oben genannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 (fünfhundert) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 (fünfhundert) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500 (Euro zwölftausend fünfhundert)
ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegen-
über erbracht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2009.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr EUR 1.200,-.
112147
<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete
Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 2 Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für eine
unbestimmte Zeit ernannt:
Dr. Thomas Bachofer, geboren am 31. Januar 1956 in Augsburg, wohnhaft in Imhofstrasse 12, # 3001, D 86159 Augs-
burg, Deutschland; und
Dr. Edgar Lange, geboren am 27. März 1964 in Hamburg, wohnhaft in Schieggstrasse 7, D 81479 München, Deutschland.
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 23, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte des Erschienenen mit Uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: O. TOO und C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46648. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 10. November 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009143441/388.
(090173485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
GR Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.948.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 131.299.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales en date du 28 septembre 2009 que M. Henrik Nielsen a transféré:
- deux mille quatre cents (2.400) parts sociales ordinaires de classe A1
- deux mille quatre cents (2.400) parts sociales ordinaires de classe B1
- deux mille quatre cents (2.400) parts sociales ordinaires de classe C1
- deux mille quatre cents (2.400) parts sociales ordinaires de classe D1
- deux mille quatre cents (2.400) parts sociales ordinaires de classe E1
qu'il détenait dans la Société à M. Philipp Manser, ayant son adresse à Gruetrain 1, 8634 Hombrechtikon, Suisse, né le
07.04.1964 à Riehen, Suisse.
Il résulte de ce contrat de transfert de parts sociales que M. Henrik Nielsen ne détient plus de parts sociales ordinaires
de classe A1, de parts sociales ordinaires de classe B1, de parts sociales ordinaires de classe C1, de parts sociales ordinaires
de classe D1 et de parts sociales ordinaires de classe E1.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales en date du 28 septembre 2009 que:
- M. Henrik Nielsen a transféré:
* sept cent quatre-vingt-trois (783) parts sociales ordinaires de classe A1
* sept cent quatre-vingt-trois (783) parts sociales ordinaires de classe B1
* sept cent quatre-vingt-trois (783) parts sociales ordinaires de classe C1
* sept cent quatre-vingt-trois (783) parts sociales ordinaires de classe D1
* sept cent quatre-vingt-trois (783) parts sociales ordinaires de classe E1
* trente-six (36) parts sociales ordinaires de classe A2
* trente-six (36) parts sociales ordinaires de classe B2
* trente-six (36) parts sociales ordinaires de classe C2
* trente-six (36) parts sociales ordinaires de classe D2
* trente-six (36) parts sociales ordinaires de classe E2
qu'il détenait dans la Société à Barclays Private Equity European Fund III 'A';
112148
- M. Henrik Nielsen a transféré:
* huit cent neuf (809) parts sociales ordinaires de classe A1
* huit cent neuf (809) parts sociales ordinaires de classe B1
* huit cent neuf (809) parts sociales ordinaires de classe C1
* huit cent neuf (809) parts sociales ordinaires de classe D1
* huit cent neuf (809) parts sociales ordinaires de classe E1
* trente-sept (37) parts sociales ordinaires de classe A2
* trente-sept (37) parts sociales ordinaires de classe B2
* trente-sept (37) parts sociales ordinaires de classe C2
* trente-sept (37) parts sociales ordinaires de classe D2
* trente-sept (37) parts sociales ordinaires de classe E2
qu'il détenait dans la Société à Barclays Private Equity European Fund III 'B';
- M. Henrik Nielsen a transféré:
* vingt-neuf (29) parts sociales ordinaires de classe A1
* vingt-neuf (29) parts sociales ordinaires de classe B1
* vingt-neuf (29) parts sociales ordinaires de classe C1
* vingt-neuf (29) parts sociales ordinaires de classe D1
* vingt-neuf (29) parts sociales ordinaires de classe E1
* une (1) part sociale ordinaire de classe A2
* deux (2) parts sociales ordinaires de classe B2
* deux (2) parts sociales ordinaires de classe C2
* deux (2) parts sociales ordinaires de classe D2
* deux (2) parts sociales ordinaires de classe E2
qu'il détenait dans la Société à Barclays Private Equity European Fund III 'D';
- M. Henrik Nielsen a transféré:
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe A1
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe B1
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe C1
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe D1
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe E1
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe A2
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe B2
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe C2
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe D2
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe E2
qu'il détenait dans la Société à Barclays Private Equity European Fund III 'E';
- M. Henrik Nielsen a transféré:
* huit cent vingt et une (821) parts sociales ordinaires de classe A1
* huit cent vingt et une (821) parts sociales ordinaires de classe B1
* huit cent vingt et une (821) parts sociales ordinaires de classe C1
* huit cent vingt et une (821) parts sociales ordinaires de classe D1
* huit cent vingt et une (821) parts sociales ordinaires de classe E1
* trente-huit (38) parts sociales ordinaires de classe A2
* trente-huit (38) parts sociales ordinaires de classe B2
* trente-huit (38) parts sociales ordinaires de classe C2
* trente-huit (38) parts sociales ordinaires de classe D2
* trente-huit (38) parts sociales ordinaires de classe E2
qu'il détenait dans la Société à Barclays Private Equity European Fund III 'F';
- M. Henrik Nielsen a transféré:
* soixante-treize (73) parts sociales ordinaires de classe A1
* soixante-treize (73) parts sociales ordinaires de classe B1
* soixante-treize (73) parts sociales ordinaires de classe C1
* soixante-treize (73) parts sociales ordinaires de classe D1
112149
* soixante-treize (73) parts sociales ordinaires de classe E1
* trois (3) parts sociales ordinaires de classe A2
* quatre (4) parts sociales ordinaires de classe B2
* quatre (4) parts sociales ordinaires de classe C2
* quatre (4) parts sociales ordinaires de classe D2
* quatre (4) parts sociales ordinaires de classe E2
qu'il détenait dans la Société à Barclays Private Equity European Fund III 'G' LP;
- M. Henrik Nielsen a transféré:
* treize (13) parts sociales ordinaires de classe A1
* treize (13) parts sociales ordinaires de classe B1
* treize (13) parts sociales ordinaires de classe C1
* treize (13) parts sociales ordinaires de classe D1
* treize (13) parts sociales ordinaires de classe E1
* une (1) part sociale ordinaire de classe A2
* une (1) part sociale de classe B2
* une (1) part sociale ordinaire de classe C2
* une (1) part sociale ordinaire de classe D2
* une (1) part sociale ordinaire de classe E2
qu'il détenait dans la Société à BPE European Partner III LP;
- M. Henrik Nielsen a transféré:
* six (6) parts sociales ordinaires de classe A1
* six (6) parts sociales ordinaires de classe B1
* six (6) parts sociales ordinaires de classe C1
* six (6) parts sociales ordinaires de classe D1
* six (6) parts sociales ordinaires de classe E1
qu'il détenait dans la Société à Eurovent III;
* M. Henrik Nielsen a transféré:
* huit cent trente-huit (838) parts sociales ordinaires de classe A1
* huit cent trente-huit (838) parts sociales ordinaires de classe B1
* huit cent trente-huit (838) parts sociales ordinaires de classe C1
* huit cent trente-huit (838) parts sociales ordinaires de classe D1
* huit cent trente-huit (838) parts sociales ordinaires de classe E1
* trente-neuf (39) parts sociales ordinaires de classe A2
* trente-neuf (39) parts sociales ordinaires de classe B2
* trente-neuf (39) parts sociales ordinaires de classe C2
* trente-neuf (39) parts sociales ordinaires de classe D2
* trente-neuf (39) parts sociales ordinaires de classe E2
qu'il détenait dans la Société à Barclays Industrial Investments Limited;
- M. Henrik Nielsen a transféré:
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe A1
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe B1
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe C1
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe D1
* cent quatorze (114) parts sociales ordinaires de classe E1
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe A2
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe B2
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe C2
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe D2
* cinq (5) parts sociales ordinaires de classe E2
qu'il détenait dans la Société à Clink Street Nominees Limited.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
112150
Luxembourg, le 4 novembre 2009.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143794/140.
(090173882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Areion Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.389.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Annuelle en date du 1
er
octobre 2009 a pris les décisions suivantes:
- Prise d'acte de la démission de Monsieur Carlo CAMPERIO CIANI, Administrateur et Président du Conseil d'Ad-
ministration, avec adresse professionnelle c/o Casa4Funds Luxembourg European Asset Management S.A., 41 Boulevard
Royal L-2449 Luxembourg en date du 25 novembre 2008.
- Démission de Monsieur Roberto BOSSI, Administrateur avec adresse professionnelle c/o 3 Via Nassa CH-6900
Lugano en date du 1
er
octobre 2009.
- Démission de Monsieur Alberto POZZI, Administrateur avec adresse professionnelle c/o 3 Via Nassa CH-6900
Lugano en date du 1
er
octobre 2009.
- Ratification de la cooptation de Monsieur Sylvain FERAUD, Administrateur et Président du Conseil d'Administration,
avec adresse professionnelle c/o Casa4Funds Luxembourg European Asset Management S.A., 41 Boulevard Royal L-2449
Luxembourg en date du 26 novembre 2008.
- Nomination de Monsieur Sylvain FERAUD, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, avec adresse
professionnelle c/o Casa4Funds Luxembourg European Asset Management S.A., 41 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
en date du 1
er
octobre 2009.
- Nomination de Monsieur Giovanni PATRI, Administrateur avec adresse professionnelle c/o Casa4Funds Luxembourg
European Asset Management S.A., 41 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg en date du 1
er
octobre 2009.
- Nomination de Monsieur Michele CANEPA, Administrateur, avec adresse professionnelle, GTA 3, rue Belle-Vue
L-1227 Luxembourg.
- Nomination de Monsieur Carlo SGARBI, Administrateur avec adresse professionnelle, Tissor Capital Management
SA, Via Cantonale-Galleria 2, 6928 Manno - Suisse.
Leurs mandats prendront fin lors de L'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 30 juin 2010.
- Renouvellement du mandat de l'administrateur suivant:
* Madame Miriam SIRONI, Administrateur, avec adresse professionnelle c/o Casa4Funds Luxembourg European Asset
Management S.A., Via San Salvatore 6, CH-6900 Lugano Suisse.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 30 juin 2010.
- Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises:
* DELOITTE S.A., réviseur d'entreprises, 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, RCS Luxembourg B 67.895.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 30 juin 2010.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2009143793/38.
(090173670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
M. Bormann GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 149.113.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend neun, den neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Herr Marc BORMANN, Geschäftsmann, wohnhaft in L-8339 Olm, 10, rue Michel Welter.
112151
2.- Frau Sylvia HANSEN, Angestellte, Ehegattin von Herrn Marc BORMANN, wohnhaft in L-8339 Olm, 10, rue Michel
Welter.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den
sie miteinander abgeschlossen haben:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile
werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zu-
treffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "M. BORMANN GmbH".
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck:
- den An- und Verkauf, die Ein- und Ausfuhr von Gütern, Produkten, Einrichtungen und Materialien,
- die Vermittlung von Handelswaren, Informationen, sowie die Beratung und Dienstleistungen im Bereich des Bäcker-
und Konditoreiwesens,
- den Entwurf und die Herstellung von Dekorationen für die Bäckerei-, Konditorei- und Gastronomie Branche.
Auch kann Sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung
des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,
Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-
werben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-
Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der
Gesellschaft förderlich sind.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ACHTZEHN TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 18.500,-), aufgeteilt in
EIN HUNDERT (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDACHTZIG EURO (€ 185,-),
welche wie folgt übernommen werden:
1.- Herr Marc BORMANN, Geschäftsmann, wohnhaft in L-8339 Olm, 10, rue Michel Welter, einundfünfzig
Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2 - Frau Sylvia HANSEN, Angestellte, Ehegattin von Herrn Marc BORMANN, wohnhaft in L-8339 Olm,
10, rue Michel Welter, neunundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ACHTZEHN TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO
(€ 18.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nach-
gewiesen wurde.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Ge-
sellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
112152
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht
auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-
gen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-
versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Vers-
torbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2009.
<i>Kosteni>
Die Akte Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag
von ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende
Beschlüsse gefasst:
a) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Marc BORMANN, Geschäftsmann, wohnhaft in L-8339 Olm, 10, rue Michel Welter.
Zur administrativen Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Frau Sylvia HANSEN, Angestellte, Ehegattin von Herrn Marc BORMANN, wohnhaft in L-8339 Olm, 10, rue Michel
Welter.
b) Die Gesellschaft wird wie folgt vertreten und verpflichtet:
- durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers,
- durch die alleinige Unterschrift der administrativen Geschäftsführerin bis zu dem Betrag von fünf tausend Euro (€
5.000,-); darüber hinaus bedarf es der zusätzlichen Unterschrift des technischen Geschäftsführers.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.
112153
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. BORMANN, S. HANSEN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 2 novembre 2009. Relation: ECH/2009/1597. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Echternach, den 10. November 2009.
Henri BECK.
Référence de publication: 2009143447/124.
(090173933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Hirslanden Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 89.803.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2009 tenue au 29 avenue de la Porte - Neuve L-2227
Luxembourg, il a été décidé:
- de clôturer la liquidation de la Société;
- de conserver les livres administratifs et comptables de la Société à l'adresse ci-après indiquée: 29 avenue de la Porte
- Neuve L - 2227 Luxembourg, et ce pour une durée de cinq années.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Signatures
<i>Agent Administratifi>
Référence de publication: 2009143771/18.
(090173475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Zeclat Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.630.
Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009143721/10.
(090173471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
School S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.762.394,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.511.
RECTIFICATIF
<i>Acte rectificatif du 30 septembre 2009i>
<i>(concerne dépôt L070164889 du 3 décembre 2007 et dépôt L070168574.04 du 11 décembre 2007)i>
In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of the month of September.
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Me Nora Filali, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 September 2009 granted by the
category B shareholders of School S.àr.l., to be registered with the present deed; and
Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 September 2009
granted by the category A shareholder of School S.àr.l., to be registered with the present deed.
112154
The appearing parties requested the notary to record as follows:
the present deed is passed in order to rectify form errors (erreurs matérielles) which occurred in the deed enacted
by the undersigned notary n° 1077/07 (the "Deed") recording the minutes of the extraordinary general meeting of the
shareholders of 24
th
October 2007 of "School S.à r.l.", a société à responsabilité limitée having its registered office at
41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (the "Company"), incorporated on 15
th
June 2007 by deed of Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1741 of 17
th
August 2007.
The Deed shall be amended as follows:
1. Item II of the first point of the agenda shall be read as follows:
II) by the issue of eleven million eight hundred and twenty-six thousand two hundred and two (11,826,202) category
B shares of a nominal value of one Euro (€ 1) each against the contribution in kind by:
(i) Apax School Sub 1 S.àr.l, a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ("Apax School Sub 1") of all its assets and liabilities
(the "Contribution in Kind 1"); approval of the valuation of the Contribution in Kind 1 at ten million one hundred and
fifty thousand four Euro and ninety-seven cents (€10,150,004.97);
(ii) Apax School Sub 2 S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ("Apax School Sub 2") of all its assets and liabilities
(the "Contribution in Kind 2"); approval of the valuation of the Contribution in Kind 2 at thirty million eight hundred and
two thousand nine hundred and nineteen Euro and nineteen cents (€ 30,802,919.19); and
(iii) Apax School Sub 3 S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ("Apax School Sub 3") of all its assets and liabilities
(the "Contribution in Kind 3"); approval of the valuation of the Contribution in Kind 3 at eighteen million four hundred
and eighty-three thousand one hundred and forty-six Euro and fifty-eight cents (€18,483,146.58);
and subscription for the newly issued category B shares by Apax School Sub 1, Apax School Sub 2 and Apax School
Sub 3; allocation of the balance between the value of each Contribution in Kind and the aggregate nominal value of the
shares to be issued in exchange thereto to the legal reserve account and to the share premium account attached to the
category B shares.
2. in the first resolution, item II shall be read as follows:
II) by the issue of eleven million eight hundred and twenty-six thousand two hundred and two (11,826,202) category
B shares of a nominal value of one Euro (€ 1) each against the contribution in kind to the Company by Apax School Sub
1 of all the assets and liabilities of Apax School Sub 1 (the "Contribution in Kind 1"), the contribution in kind by Apax
School Sub 2 of all the assets and liabilities of Apax School Sub 2 (the "Contribution in Kind 2 ") and the contribution in
kind by Apax School Sub 3 of all the assets and liabilities of Apax School Sub 3 (the "Contribution in Kind 3 "), each time
without exception as described below:
(1) The assets and liabilities of Apax School Sub 1 consist in the following:
ASSETS:
(a) 4,168 category B shares in the Company;
(b) a receivable of €10,139,249.08 against the Company represented by 10,139,249.08 yield-free preferred equity
certificates ("YFPECs 1") having a subscription price of € 1 each issued by the Company in its favour;
(c) 14,487,017 voting preferred shares having a nominal value of CND$ 0.000001 each in Smart Technologies (Holding)
Inc., a company incorporated under the laws of Alberta, with registered office at 300, 1207 - 11
th
Avenue SW, Calgary,
Alberta T3C OM5, and registered under number 2013291691 ("Smart Holdco");
(d) 2 ordinary shares in Apax Smart (Gibraltar) 1 Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, with
registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar and registered in Gibraltar under number 98.881 ("Gibco 1") valua-
tedat € 10,139,249.08 (the "Gibco 1 Shares"),
(e) cash in the amount of € 11,255.89;
LIABILITIES:
(a) a liability in the amount of €10,139,249.08 towards Gibco 1 represented by 10,139,249.08 YFPECs 1 with a sub-
scription price of € 1 each issued in favour of Gibco 1;
(b) a liability towards its shareholder in the amount of € 4,678.09;
(2) The assets and liabilities of Apax School Sub 2 consist in the following:
ASSETS:
(a) 4,166 category B shares in the Company;
(b) a receivable of €30,792,163.47 against the Company represented by 30,792,163.47 yield-free preferred equity
certificates ("YFPECs 2") having a subscription price of € 1 each issued by the Company in its favour;
(c) 43,996,020 voting preferred shares having a nominal value of CND$ 0.000001 each in Smart Holdco;
112155
(d) 2 ordinary shares in Apax Smart (Gibraltar) 2 Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, with
registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar and registered in Gibraltar under number 98.882 ("Gibco 2") valuated
at € 30,792,163.47 (the "Gibco 2 Shares");
(e) cash in the amount of€ 11,255.72;
LIABILITIES:
(a) a liability in the amount of €30,792,163.47 towards Gibco 2 represented by 30,792,163.47 YFPECs 2 having a
subscription price of € 1 each issued in favour of Gibco 2;
(b) a liability towards its shareholder in the amount of € 4,696.66;
(3) The assets and liabilities of Apax School Sub 3 consist in the following:
ASSETS:
(a) 4,166 category B shares in the Company;
(b) a receivable of €18,472,390.86 against the Company represented by 18,472,390.86 yield-free preferred equity
certificates ("YFPECs 3") having a subscription price of € 1 each issued by the Company in its favour;
(c) 26,393,458 voting preferred shares having a nominal value of CND$ 0.000001 each in Smart Holdco;
(d) 2 ordinary shares in Apax Smart (Gibraltar) 3 Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, with
registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar and registered in Gibraltar under number 98.883 ("Gibco 3") valuated
at € 18,472,390.86 (the "Gibco 3 Shares");
(e) cash in the amount of € 11,255.72;
LIABILITIES:
(a) a liability in the amount of €18,472,390,86 towards Gibco 3 represented by 18,472,390.86 YFPECs 3 having a
subscription price of € 1 each issued in favour of Gibco 3;
(b) a liability towards its shareholder in the amount of € 4,684.39.
All the assets and liabilities respectively contributed by Apax School Sub 1, Apax School Sub 2 and Apax School Sub
3 are documented in the form of a balance sheet of Apax School Sub 1, Apax School Sub 2 and Apax School Sub 3 which
will remain attached hereto. They are contributed to the Company with all the rights, commitments and obligations,
known or unknown, which could be attached thereto.
Proof of the transfer of the assets and liabilities constituting the Contribution in Kind 1, the Contribution in Kind 2
and the Contribution in Kind 3 to the Company was shown to the Meeting.
The assets and liabilities of Apax School Sub 1, Apax School Sub 2 and Apax School Sub 3, respectively, have been
further described, and the value thereof assessed by the board of managers of the Company, in a report dated 23 October
2007 as rectified on 25 September 2009.
The conclusion of such report reads as follows:
"The managers, on the basis of the aforementioned, consider that the documentation and assurance received provide
adequate substantiation as to the existence and extent of the assets and liabilities forming the Contributions in Kind.
The managers are of the opinion that the net Contributions in Kind as described above, as offered by:
- Apax School Sub 1 in exchange for new category B shares to be issued by the Company, will be equal at least to ten
million one hundred and fifty thousand four Euro and ninety-seven cents (€ 10,150,004.97) which will correspond at least
to the value of the shares to be issued, and that accordingly the Company may issue two million eighteen thousand five
hundred and thirty-eight (2,018,538) shares with a nominal value of one Euro (€ 1) to Apax School Sub 1;
- Apax School Sub 2 in exchange for new category B shares to be issued by the Company, will be equal at least to
thirty million eight hundred and two thousand nine hundred and nineteen Euro and nineteen cents (€30,802,919.19)
which will correspond at least to the value of the shares to be issued, and that accordingly the Company may issue six
million one hundred and thirty thousand one hundred and fifty-two (6,130,152) shares with a nominal value of one Euro
(€1) to Apax School Sub 2; and
- Apax School Sub 3 in exchange for new category B shares to be issued by the Company, will be equal at least to
eighteen million four hundred and eighty-three thousand one hundred and forty-six Euro and fifty-eight cents
(€18,483,146.58) which will correspond at least to the value of the shares to be issued, and that accordingly the Company
may issue three million six hundred and seventy-seven thousand five hundred and twelve (3,677,512) shares with a nominal
value of one Euro (€ 1) to Apax School Sub 3."
Pursuant to the above, the Meeting resolved to value the Contribution in Kind 1 at ten million one hundred and fifty
thousand four Euro and ninety-seven cents (€ 10,150,004.97) and to issue to Apax School Sub 1 two million eighteen
thousand five hundred and thirty-eight (2,018,538) shares of category B. The Meeting resolved that the balance between
the value of the Contribution in Kind 1 and the aggregate nominal value of the category B shares issued in exchange
thereto, amounting to eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and sixty-six Euro and ninety-
seven cents (€ 8,131,466.97) shall be allocated to the legal reserve account in the amount of two hundred and one
thousand eight hundred and fifty-three Euro and eighty cents (€ 201,853.80) and to the share premium account attached
to the category B shares in the amount of seven million nine hundred and twenty-nine thousand six hundred and thirteen
Euro and seventeen cents (€ 7,929,613.17).
112156
Pursuant to the above, the Meeting resolved to value the Contribution in Kind 2 at thirty million eight hundred and
two thousand nine hundred and nineteen Euro and nineteen cents (€ 30,802,919.19) and to issue to Apax School Sub 2
six million one hundred and thirty thousand one hundred and fifty-two (6,130,152) shares of category B. The Meeting
resolved that the balance between the value of the Contribution in Kind 2 and the aggregate nominal value of the category
B shares issued in exchange thereto, amounting to twenty-four million six hundred and seventy-two thousand seven
hundred and sixty-seven Euro and nineteen cents (€ 24,672,767.19) shall be allocated to the legal reserve account in the
amount of six hundred and thirteen thousand fifteen Euro and twenty cents (€ 613,015.20) and to the share premium
account attached to the category B shares in the amount of twenty-four million fifty-nine thousand seven hundred and
fifty-one Euro and ninety-nine cents (€ 24,059,751.99).
Pursuant to the above, the Meeting resolved to value the Contribution in Kind 3 at eighteen million four hundred and
eighty-three thousand one hundred and forty-six Euro and fifty-eight cents (€ 18,483,146.58) and to issue to Apax School
Sub 3 three million six hundred and seventy-seven thousand five hundred and twelve (3,677,512) shares of category B.
The Meeting resolved that the balance between the value of the Contribution in Kind 3 and the aggregate nominal value
of the category B shares issued in exchange thereto, amounting to fourteen million eight hundred and five thousand six
hundred and thirty-four Euro and fifty-eight cents (€ 14,805,634.58) shall be allocated to the legal reserve account in the
amount of three hundred and sixty-seven thousand seven hundred and fifty-one Euro and twenty cents (€ 367,751.20)
and to the share premium account attached to the category B shares in the amount of fourteen million four hundred and
thirty-seven thousand eight hundred and eighty-three Euro and thirty-eight cents (€ 14,437,883.38).
For avoidance of doubt, the Meeting acknowledged the waiver by the existing shareholders of any preferential sub-
scription right over the newly issued category A shares and the newly issued category B shares.
Intel expressly agrees to the allocation to the legal reserve account out of the share premium account attached to the
category A shares.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at two thousand euro (€ 2,000.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof this present deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, the said appearing persons signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le trente septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Me Nora Filali, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations datées du 25 septembre 2009
donnée par les associés de catégorie B de School S.àr.l., lesquelles seront enregistrées avec le présent acte; et
Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28
septembre 2009, donnée par l'associé de catégorie A de School S.àr.l., laquelle sera enregistrée avec le présent acte.
Les personnes comparantes ont requis le notaire d'acter ce qui suit:
Le présent acte a été fait afin de rectifier des erreurs matérielles s'étant produites dans l'acte n° 1077/07 du notaire
soussigné (l"'Acte") en date du 24 octobre 2007 transcrivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
associés de "School S.à r.l.", une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg (la "Société"), constituée le 15 juin 2007 suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1741 du 17 août 2007.
L'Acte doit être modifié comme suit:
- Le point II du premier point de l'ordre du jour doit se lire comme suit:
II) par l'émission de onze millions huit cent vingt-six mille deux cent deux (11.826.202) parts sociales de catégorie B
ayant une valeur nominale d'un Euro (€1) chacune en contrepartie de l'apport en nature par:
(i) Apax School Sub 1 S.àr.l, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son
siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ("Apax School Sub 1") de tous ses actifs et passifs (l
'"Apport en Nature 1"); approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature 1 à dix millions cent cinquante mille quatre
Euros et quatre-vingt-dix-sept cents (€10.150.004,97);
(ii) Apax School Sub 2 S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son
siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ("Apax School Sub 2") de tous ses actifs et passifs (l
'"Apport en Nature 2"); approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature 2 à trente millions huit cent deux mille neuf
cent dix-neuf Euros et dix-neuf cents (€ 30.802.919,19); et
112157
(iii) Apax School Sub 3 S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son
siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ("Apax School Sub 3") de tous ses actifs et passifs
(l'"Apport en Nature 3"); approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature 3 à dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-
trois mille cent quarante-six Euros et cinquante-huit cents (€18.483.146,58);
et souscription des parts sociales de catégorie B nouvellement émises par Apax School Sub 1, Apax School Sub 2 et
Apax School Sub 3; allocation du solde entre la valeur de chaque Apport en Nature et la valeur nominale totale des parts
sociales devant être émises en échange au compte de la réserve légale et au compte prime d'émission attaché aux parts
sociales de catégorie B.
- dans la première résolution, le point II doit se lire comme suit:
II) par l'émission de onze millions huit cent vingt-six mille deux cent deux (11.826.202) parts sociales de catégorie B
d'une valeur nominale d'un Euro (€1) chacune en contrepartie de l'apport en nature à la Société par Apax School Sub 1
de tous les actifs et passifs d'Apax School Sub 1 (l'"Apport en Nature 1"), l'apport en nature par Apax School Sub 2 de
tous les actifs et passifs d'Apax School Sub 2 (l'"Apport en Nature 2") et l'apport en nature par Apax School Sub 3 de
tous les actifs et passifs d'Apax School Sub 3 (l'"Apport en Nature 3"), chaque fois sans exception tel que décrit ci-dessous:
(1) Les actifs et passifs d'Apax School Sub 1 sont les suivants:
ACTIFS:
(a) 4.168 parts sociales de catégorie B de la Société;
(b) une créance de €10.139.249,08 envers la Société représentée par 10.139.249,08 yield-free preferred equity cer-
tificates ("YFPECs 1") ayant un prix de souscription de € 1 chacun émis par la Société en sa faveur;
(c) 14.487.017 actions préférentielles avec droit de vote d'une valeur nominale de CND$ 0,000001 chacune dans Smart
Technologies (Holdings) Inc., une société constituée sous les lois d'Alberta, ayant son siège social au 300,1207 - 11
th
Avenue SW, Calgary Alberta T3C 0M5, et inscrite sous le numéro 2013291691 ("Smart Holdco");
(d) 2 parts sociales dans Apax School (Gibraltar) 1 Limited, une société constituée sous les lois de Gibraltar, ayant son
siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar et inscrite à Gibraltar sous le numéro 98.881 ("Gibco 1") évaluées à €
10.139.249,08 (les "Parts Sociales de Gibco 1");
(e) espèces pour un montant de € 11.255,89;
PASSIFS:
(a) une dette d'un montant de €10.139.249,08 envers Gibco 1 représentée par 10.139.249,08 YFPECs 1 ayant un prix
de souscription de € 1 chacun émis en faveur de Gibco 1;
(b) une dette envers son associé d'un montant de € 4.678,09;
(2) Les actifs et passifs d'Apax School Sub 2 sont les suivants:
ACTIFS:
(a) 4.166 parts sociales de catégorie B de la Société;
(b) une créance de € 30.792.163,47 envers la Société représentée par 30.792.163,47 yield-free preferred equity cer-
tificates ("YFPECs 2") ayant un prix de souscription de € 1 chacun émis par la Société en sa faveur;
(c) 43.996.020 actions préférentielles avec droit de vote ayant une valeur nominale de CND S 0,000001 chacune dans
Smart Holdco;
(d) 2 parts sociales dans Apax Smart (Gibraltar) 2 Limited, une société constituée sous les lois de Gibraltar, ayant son
siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar et inscrite à Gibraltar sous le numéro 98.882 ("Gibco 2") évaluées à €
30.792.163,47 (les "Parts Sociales de Gibco 2");
(e) espèces pour un montant de € 11.255,72;
PASSIFS:
(a) une dette d'un montant de €30.792.163,47 envers Gibco 2 représentée par €30.792.163,47 YFPECs 2 ayant un
prix de souscription de € 1 chacun émis en faveur de Gibco 2;
(b) une dette envers son associé d'un montant de € 4.696,66;
(3) Les actifs et passifs d'Apax School Sub 3 sont les suivants:
ACTIFS:
(a) 4.166 parts sociales de catégorie B de la Société;
(b) une créance de €18.472.390,86 envers la Société représentée par 18.472.390,86 yield-free preferred equity cer-
tificates ("YFPECs 3") ayant un prix de souscription de € 1 chacun émis par la Société en sa faveur;
(c) 26.393.458 actions préférentielles avec droit de vote ayant une valeur nominale de CND $ 0,000001 chacune dans
Smart Holdco;
(d) 2 parts sociales dans Apax Smart (Gibraltar) 3 Limited, une société constituée sous les lois de Gibraltar, ayant son
siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar et inscrite à Gibraltar sous le numéro 98.883 ("Gibco 3") évaluées à €18.4
72.390,86 (les "Parts Sociales de Gibco 3");
(e) espèces pour un montant de € 11.255,72;
112158
PASSIFS:
(a) une dette d'un montant de €18.472.390,86 envers Gibco 3 représentée par € 18.472.390,86 YFPECs 3 ayant un
prix de souscription de € 1 chacun émis en faveur de Gibco 3;
(b) une dette envers son associé d'un montant de € 4,684.39.
Tous les actifs et passifs respectivement apportés par Apax School Sub 1, Apax School Sub 2 et Apax School Sub 3
sont documentés par un bilan d'Apax School Sub 1, Apax School Sub 2 et Apax School Sub 3 qui resteront annexés au
présent acte. Ils sont apportés à la Société avec tous les droits, engagements et obligations, connus ou non, qui pourraient
y être attachés.
Preuve du transfert des actifs et passifs constituant l'Apport en Nature 1, l'Apport en Nature 2 et l'Apport en Nature
3 à la Société a été donné à l'Assemblée.
Les actifs et passifs d'Apax School Sub 1, Apax School Sub 2 et Apax School Sub 3, respectivement, ont été en outre
décrits et évalués par le conseil de gérance de la Société dans un rapport daté du 23 octobre 2007, tel que rectifié le 25
septembre 2009.
La conclusion dudit rapport est la suivante:
"Les gérants, sur base de ce qui précède, considèrent que la documentation et l'assurance reçues fournissent une
preuve conséquente de l'existence et de l'ampleur des actifs et passifs formant les Apports en Nature.
Les gérants considèrent que les Apports en Nature nets, tels que décrits ci-dessus et tels qu'offerts par:
- Apax School Sub 1 en échange de nouvelles parts sociales de catégorie B devant être émises par la Société, seront
équivalents au moins à dix millions cent cinquante mille quatre Euros et quatre-vingt-dix-sept cents (€ 10.150.004,97),
qui correspondra au moins à la valeur des parts sociales devant être émises, et que la Société peut, en conséquence,
émettre deux millions dix-huit mille cinq cent trente-huit (2.018.538) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (€
1) à Apax School Sub 1;
- Apax School Sub 2 en échange de nouvelles parts sociales de catégorie B devant être émises par la Société, seront
équivalents au moins à trente millions huit cent deux mille neuf cent dix-neuf Euros et dix-neuf cents (€ 30.802.919,19),
qui correspondra au moins à la valeur des parts sociales devant être émises, et que la Société peut, en conséquence,
émettre six millions cent trente mille cent cinquante-deux (6.130.152) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (€
1) à Apax School Sub 2; et
- Apax School Sub 3 en échange de nouvelles parts sociales de catégorie B devant être émises par la Société, seront
équivalents au moins à dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cent quarante-six Euros et cinquante-huit
cents (€ 18.483.146,58), qui correspondra au moins à la valeur des parts sociales devant être émises, et que la Société
peut, en conséquence, émettre trois millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cent douze (3.677.512) parts sociales
d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1) à Apax School Sub 3."
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée a décidé d'évaluer l'Apport en Nature 1 à dix millions cent cinquante
mille quatre Euros et quatre-vingt-dix-sept cents (€ 10.150.004,97) et d'émettre à Apax School Sub 1 deux millions dix-
huit mille cinq cent trente-huit (2.018.538) parts sociales de catégorie B. L'Assemblée a décidé que le solde entre la valeur
de l'Apport en Nature 1 et la valeur nominale totale des parts sociales de classe B émises en échange, d'un montant de
huit millions cent trente et un mille quatre cent soixante-six Euros et quatre-vingt-dix sept cents (€ 8.131.466,97) soit
alloué au compte de réserve légale pour un montant de deux cent un mille huit cent cinquante-trois Euros et quatre-
vingt cents (€ 201.853,80) et au compte prime d'émission attaché aux parts sociales de catégorie B pour un montant de
sept millions neuf cent vingt-neuf mille six cent treize Euros et dix-sept cents (€ 7.929.613,17).
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée a décidé d'évaluer l'Apport en Nature, 2 à trente millions huit cent deux
mille neuf cent dix-neuf Euros et dix-neuf cents (€ 30.802.919,19) et d'émettre à Apax School Sub 2 six millions cent
trente mille cent cinquante-deux (6.130.152) parts sociales de catégorie B. L'Assemblée a décidé que le solde entre la
valeur de l'Apport en Nature 2 et la valeur nominale totale des parts sociales de classe B émises en échange, d'un montant
de vingt-quatre millions six cent soixante-douze mille sept cent soixante-sept Euros et dix-neuf cents (€ 24.672.767,19)
soit alloué au compte réserve légale pour un montant de six cent treize mille quinze Euros et vingt cents (€ 613.015,20)
et au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de catégorie B pour un montant de vingt-quatre millions
cinquante-neuf mille sept cent cinquante et un Euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (€ 24.059.751,99).
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée a décidé d'évaluer l'Apport en Nature 3 à dix-huit millions quatre cent
quatre-vingt-trois mille cent quarante-six Euros et cinquante-huit cents (€ 18.483.146,58) et d'émettre à Apax School
Sub 3 trois millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cent douze (3.677.512) parts sociales de catégorie B. L'Assemblée
a décidé que le solde entre la valeur de l'Apport en Nature 3 et la valeur nominale totale des parts sociales de catégorie
B émises en échange, d'un montant de quatorze millions huit cent cinq mille six cent trente-quatre Euros et cinquante-
huit cents (€ 14.805.634,58) soit alloué au compte réserve légale pour un montant de trois cent soixante-sept mille sept
cent cinquante et un Euros et vingt cents (€ 367.751,20) et au compte de prime d'émission rattaché aux parts sociales
de catégorie B pour un montant de quatorze millions quatre cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-trois Euros et
trente-huit cents (€ 14.437.883,38).
112159
Afin d'éviter tout doute, l'Assemblée a pris note de la renonciation des associés existants à tout droit de souscription
préférentiel aux parts sociales de catégorie A nouvellement émises et aux parts sociales de catégorie B nouvellement
émises.
Intel accepte expressément l'allocation au compte de la réserve légale à partir du compte prime d'émission attaché
aux parts sociales de catégorie A.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes sont évalués à deux mille euros (€ 2.000,-).
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate, à la demande des parties comparantes, que le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, lesdites comparantes ont signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: Filali, Hermelinski-Ayache, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 octobre 2009. Relation: EAC/2009/11947. Reçu douze euros (12,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 23 octobre 2009.
Francis KESSELER.
Référence de publication: 2009143509/322.
(090173844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Fine Tobacco Flavours S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 131.749.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 31 juillet 2009i>
Révocation du commissaire:
- H.R.T. REVISION SA
Nomination du nouveau commissaire:
- Vericom Sa
RCS Luxembourg n° B 51.203
siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
Le mandat de commissaire ainsi nommé prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2009143543/17.
(090173641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Finsweet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 65.643.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Paul BETTINGEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009143679/11.
(090173896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
112160
Socipar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 5.781.
<i>Extraits du procès-verbal de l'assemblée généralei>
<i>ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 2 avril 2009i>
L'assemblée réélit administrateurs pour un an:
M. Gaston SCHWERTZER, docteur en droit, Medingen;
M. Jacquot SCHWERTZER, commerçant, Schrassig;
Mme Nathalie MAIER, employée privée, Schrassig
Réélit commissaire pour un an:
la société DMS & Associés, S.à.r.l. à L-1274 HOWALD, 23, rue des Bruyères.
<i>Extraits du procès-verbal de la réunion du conseili>
<i>d'administration tenue immédiatement après l'assemblée généralei>
1. Est réélu Président pour un an: M. Gaston SCHWERTZER, docteur en droit, Medingen.
2. Conformément à l'art. 7 des statuts et à l'autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, est nommé
administrateur-délégué pour un an:
M. Jacquot SCHWERTZER, commerçant, 51, rue d'Oetrange, Schrassig.
3. Conformément à l'art. 7 des statuts, est nommé fondé de pouvoirs pour un an M. Jean-Yves COLSON, comptable,
1, rue des Cerisiers, Messancy.
.../...
- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs ou par la seule
signature de l'administrateur délégué, sans limitation du montant.
- La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 15.000,00 € (quinze mille euros) par la signature du
fondé de pouvoirs.
- Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par l'administrateur
délégué et/ou le conseil d'administration.
Pour extraits conformes
Jacquot SCHWERTZER
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2009143647/33.
(090173781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
BSkyB Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 127.643.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraits des résolutions de l'Associé unique de la Société au 20 octobre 2009i>
L'Associé unique
- approuve le rapport du liquidateur du 19 octobre 2009,
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister,
- décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du 20 octobre
2009 à l'adresse suivante:
CLERC 1, rue Pletzer L-8080 Bertrange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 20 octobre 2009.
<i>Pour la société
i>CLERC
<i>Liquidateur
i>Christophe Deschamps / Jean-Jacques Soisson
Référence de publication: 2009143776/21.
(090173697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
112161
Presta-Gaz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue des Chemins de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 9.648.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée généralei>
<i>ordinaire des actionnaires de la s.a. Presta-gaz du 22 mai 2009i>
L'Assemblée réélit Administrateurs pour un an
M. Gaston SCHWERTZER, administrateur de société, demeurant à Marxe Knupp, L-5328 MEDINGEN.
M. Jacquot SCHWERTZER, administrateur de société, demeurant à 51, rue d'Oetrange, L-5360 SCHRASSIG.
M. Philippe CARTRY, directeur, demeurant à 154, rue des Espagnols B-6700 ARLON.
Réélit réviseur pour un an:
La société ABACAB S.à.r.l, réviseur d'entreprise, ayant son siège social à 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administrationi>
<i>tenue au siège social le 22 mai 2009, immédiatement après l'assemblée générale ordinaire statuaire annuellei>
Est réélu Président pour un an, M. Gaston SCHWERTZER, administrateur de société, Medingen.
Est reconduit Administrateur-délégué pour un an, M. Jacquot SCHWERTZER, administrateur de société, SCHRASSIG.
Est confirmé Directeur pour un an, M. Philippe CARTRY, demeurant 154, rue des Espagnols à B-6700 ARLON.
Est confirmé fondé de pouvoirs pour un an, M. Stéphane SAUVAGE, responsable opérationnel, demeurant 9, rue de
la Tuilerie à F-57310 BERTANGE.
Est confirmé fondé de pouvoirs pour un an, M. Erwin LAMBERTY, technicien, demeurant 5, rue de la Platinerie à
B-6700 ARLON.
Est confirmé fondé de pouvoirs pour un an, M. Patrick JOSEPH, directeur financier et administratif, demeurant 83,
avenue des Citrinelles à B-1160 BRUXELLES.
.../...
<i>Pouvoirsi>
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois Administrateurs. Pour la gestion
journalière, la société est engagée sans limitation, par la seule signature du Président du Conseil d'Administration ou de
l'Administrateur-délégué. La Direction de la société est confiée au Directeur, M. Philippe CARTRY, qui, par sa seule
signature, engage la société pour la gestion journalière jusqu'à concurrence de 200.000,00 € (deux cent mille euros).
Les Fondés de Pouvoirs, MM. Stéphane SAUVAGE, Erwin LAMBERTY et Patrick JOSEPH, engagent la société, par leur
signature individuelle jusqu'à concurrence de 15.000,00 € (quinze mille euros) pour la gestion journalière.
Pour extraits conformes
Jacquot SCHWERTZER
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2009143646/38.
(090173784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
SL Software_Consult S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 56.789.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. November 2009 abgehalten am Gesellschaftssitzi>
1. Es wird beschlossen, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von bisher 4 Personen auf 3 Personen herabzusetzen.
2. Die Herren Ulrich von der Winkel und Frank Helsper werden von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglieder abbe-
rufen.
3. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wählt die Versammlung einstimmig Herrn Lazar Bojaniċ, wohnhaft in Vojvode
Šupljikca 011, 21000 Novi Sad, Serbien, der das Amt annimmt und bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2013 weiterführt.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
Référence de publication: 2009143372/16.
(090173303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
112162
Citrix Systems Capital and Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 69.543.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>CITRIX SYSTEMS CAPITAL AND FINANCE S.à r.l.
i>Signature / Signature
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2009143719/12.
(090173468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Unirec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 18.960.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>UNIREC S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009143718/12.
(090173467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Immo 70's S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 149.103.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend neun, den neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Herr Dirk TREINEN, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, 15, Duerler.
2.- Herr Jean-Louis BLANKEN, Angestellter, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, 1, Gruefflingen.
Welche Komparenten hier vertreten sind durch Herrn Luc VERELST, Buchhalter, beruflich ansässig in L-9911 Trois-
vierges, 2, rue de Drinklange, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 28. Oktober 2009,
welche Vollmachten, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Komparenten und dem amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschafts-
vertrag zu beurkunden, den sie miteinander abgeschlossen haben:
Titel I. Name, Sitz, Zweck. Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile
werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zu-
treffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "IMMO 70's S.à r.l.".
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Troisvierges.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Vermittlung und die Vermarktung von Grundstücken
und Immobilien.
Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck den Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in-
und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
112163
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,
Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-
werben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-
Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der
Gesellschaft förderlich sind.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500,-), aufgeteilt in EIN
HUNDERT (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125,-), welche
wie folgt übernommen werden:
1.- Herr Dirk TREINEN, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, 15, Duerler, fünfzig Anteile . . . . .
50
2.- Herr Jean-Louis BLANKEN, Angestellter, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, 1, Gruefflingen, fünfzig Anteile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€
12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Ge-
sellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht
auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-
gen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-
versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Vers-
torbenen weitergeführt.
112164
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2009.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, erklärt seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben,
dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Alsdann sind die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesord-
nung nachfolgende Beschlüsse gefasst:
a) Zu Geschäftsführer der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Dirk TREINEN, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, 15, Duerler.
- Herr Jean-Louis BLANKEN, Angestellter, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, 1, Gruefflingen.
b) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten
und verpflichten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Gezeichnet: L. VERELST, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 2 novembre 2009. Relation: ECH/2009/1596. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Echternach, den 10. November 2009.
Henri BECK.
Référence de publication: 2009143589/118.
(090173522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Nidderkuerer Tuterten asbl, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4551 Niederkorn, 26, rue des Ecoles.
R.C.S. Luxembourg F 8.138.
STATUTS
Chapitre I
er
- Dénomination, Objet, Siège et Durée
Art. 1
er
. Il est constitué entre les personnes soussignées une Association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril
1928 et modifiée par celle du 4 mars 1994 sur les associations sans but lucratif. Cette association prend la dénomination
"Nidderkuerer Tuterten asbl".
Art. 2. Le siège de l'association se trouve à Niederkorn.
Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. L'association a pour objet le soutien d'organisation et d'œuvres de bienfaisance par l'intermédiaire d'organisation
de soirées carnavalesques (Kâpesetzungen) et en général toutes organisations quelconques se rattachant à cet objet.
112165
Chapitre II - Les membres
Art. 5. Sont membres de l'association toutes les personnes participant activement à la vie sociale de l'association.
Leur nombre est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.
Les personnes qui désirent devenir membre présentent une demande d'admission au Conseil d'Administration qui
statue sur le bien-fondé de cette demande.
Art. 6. La qualité de membre se perd:
- Par la démission écrite adressée au Conseil d'Administration
- Par le refus de payer la cotisation annuelle au cours de l'exercice
- Par décision d'exclusion prononcée contre celui dont la conduite a jeté le discrédit sur l'association, qui manifeste
un manque d'intérêt, qui refuse de se conformer aux statuts, au règlement interne ainsi qu'aux décisions du Conseil
d'administration et/ou de l'assemblée générale.
La mesure d'exclusion proposée par le Conseil d'administration est de la compétence de l'assemblée générale statuant
à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
Elle ne pourra être appliquée sans que l'intéressé ait été appelé à fournir ses explications.
A cette fin une invitation lui sera adressé au moins 14 jours avant l'assemblée générale, par lettre recommandée.
Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur les fonds sociaux et ne peut réclamer le remboursement des
cotisation ou dons versés par lui.
Art. 7. Le Conseil d'Administration peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des
services ou fait des dons particuliers à l'association. Ce titre ne confère à ces personnes aucun droit au sein de l'A.s.b.l.
Art. 8. La cotisation annuelle ne peut être supérieure à 10 Euros, elle est fixée chaque année par l'assemblée générale
à la majorité absolue. Elle est payable d'avance.
Contre paiement de la cotisation, il sera délivré une carte de membre et un reçu au membre.
Chapitre III - Assemblée générale
Art. 9. Sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale:
1. la modification des stauts
2. la nomination et la révocation des administrateurs
3. la fixation des cotisations annuelles
4. l'approbation annuelle du bilan et du budget
5. la dissolution de l'association
6. l'exclusion d'un membre de l'association
Art. 10. L'assemblée générale se réunit annuellement au mois d'avril-mai.
Art. 11. En cas de besoin le Conseil d'Administration peut convoquer à chaque moment une assemblée générale
extraordinaire.
Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le Conseil d'Administration, et ce endéans les deux
mois lorsque 1/5 des membres en font la demande.
Art. 12. Toute proposition signée par un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle des
membres et déposée par envoi postal au moins huit jours avant l'assemblée générale, doit être portée à l'ordre du jour.
Art. 13. Les associés qui veulent faire convoquer une Assemblée générale extraordinaire ou proposer une question à
l'ordre du jour, doivent soumettre au Président du Conseil d'Administration une note écrite précisant leur intention.
Art. 14. Des résolutions en dehors de l'ordre du jour ne peuvent être prises que si une majorité des deux tiers des
voix émises par les membres présents marque son accord. Aucune résolution en dehors de l'ordre du jour ne peut être
prise sur les points de l'article 9.
Art. 15. Tous les membres associés doivent être convoqués par écrit ou par voie de presse au moins quinze jours
avant l'assemblée. La convocation doit contenir l'ordre du jour.
Art. 16. Il est loisible aux associés de se faire représenter à l'Assemblée générale par un autre associé, muni d'une
procuration écrite. Aucun membre ne peut cependant représenter plus que deux associés.
Art. 17. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des voix émises.
Toutefois concernant les points 1 et 5 de l'article 9 (modifications des statuts / dissolution de l'association) une décision
ne peut être prise qu'à la majorité des 2/3 des membres.
Si les 2/3 des membres ne sont pas représentés à la première assemblée, une deuxième réunion doit être convoquée,
elle pourra délibérer quelque soit le nombre des membres représentés. Dans ce cas la décision sera soumise à l'homo-
logation du Tribunal de Luxembourg conformément à la loi de 1928 sur les A.s.b.l.
112166
Chapitre IV - Administration
Art. 18. L'Administration est exercée par le Conseil d'Administration qui se compose de trois membres au minimum
et de onze au plus.
Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l'Assemblée générale qui peut les révoquer à tout moment.
La durée du mandant des administrateurs est de deux ans.
Les administrateurs sortants seront toujours rééligibles. Leurs fonctions n'expirent qu'après remplacement.
Art. 19. Toutes candidatures pour un mandat d'administrateur doivent être présentées soit par voie de lettre recom-
mandée, soit par une demande orale lors de l'ouverture de l'Assemblée générale, au Président du Conseil d'Administra-
tion.
Les candidats doivent être majeurs, être membres depuis au moins six mois et jouir des droits civils.
Art. 20. Le Conseil d'Administration se compose d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier
ainsi que d'autres membres élus.
Les différents postes sont fixés à la majorité simple par le Conseil d'Administration lors de sa première réunion qui
doit se tenir au plus tard quinze jours après l'Assemblée générale.
Art. 21. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président, chaque fois que le réclame l'intérêt de
l'association, mais au moins une fois par trimestre.
Le Président doit convoquer une réunion à la demande d'un tiers des administrateurs et ceci dans un délai de dix jours
suivant cette demande.
Art. 22. Le Vice-Président et après lui le doyen d'âge du Conseil d'Administration représente le Président dans les
réunions et dans l'Administration en cas d'absence ou d'indisponibilité.
Art. 23. Les décisions du Conseil d'Administration sont valables lorsque la moitié de ses membres est présente. Les
décisions sont prises à la majorité des voix présentes et en cas de partage, la voix du Président ou de celui qui préside la
réunion est prépondérante.
Ces décisions sont constatées par des procès-verbaux, signés par le Président et le Secrétaire.
Art. 24. Le Conseil d'Administration gère les affaires de l'association et dispose dans le cadre de cette gestion des
pouvoirs les plus étendus. Il représente l'association dans tous les actes judiciares et extrajudiciares.
Art. 25. Le Secrétaire effectue et signe au nom de l'association le courrier général, rédige les comptes-rendus et est
le destinataire de tous les documents, propositions à adresser à l'association.
Art. 26. Le trésorier gère le livre de caisse et classe les pièces comptables. Il effectue les transactions financières que
le Conseil d'Administration ou l'Assemblée générale a décidé et présente la situation financière lors de l'Assemblée
générale. Il en est de même du budget relatif au nouvel exercice.
Art. 27. A l'égard de tiers, l'association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs titulaires d'un poste au sein du Conseil d'Administration (ex: président + trésorier, président + secrétaire,
secrétaire + caissier). Pour les quittances la seule signature d'un des administrateurs est suffisante.
Art. 28. L'Exercice sociale commence le 1
er
avril et se termine le 31 mars suivant.
Art. 29. Le Conseil d'Administration soumettra à l'assemblée générale annuelle, pour approbation, les comptes et
rapports sur l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant. Le bilan financier définitif devra comprendre tous les
actifs et passifs financiers de l'association, ainsi que les dettes et prêts.
Art. 30. Chaque année l'Assemblée générale désigne 2 à 3 réviseurs chargés du contrôle de la comptabilité et qui n'ont
pas besoin d'être membres de l'association. Leur mandat est d'une année. Ils sont rééligibles mais ne peuvent pas faire
partie du Conseil d'Administration. Ils soumettent leur rapport à l'approbation de l'Assemblée générale.
Art. 31. En cas de dissolution volontaire de l'association, l'Assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs
et déterminera leurs pouvoirs. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'actif net de l'association sera
affecté à l'Office Social de la Commune de Differdange.
Art. 32. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par les dis-
positions de la loi du 21 avril 1928 resp. celle du 4 mars 1994 sur les associations sans but lucratif.
Signatures.
Référence de publication: 2009143559/115.
(090173918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
112167
Cordell Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.729.
«WORLD BUSINESS» LTD, ayant son siège social actuel à Nassau, Maritime House, Frederick Street, BS (Bahamas)
a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 2 novembre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Signature
<i>un Mandatairei>
Référence de publication: 2009143363/13.
(090173098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Yurger S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 71.818.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2009i>
Il résulte dudit procès-verbal que l'assemblée:
- prend acte de la démission de:
* Monsieur Arne van Roon, né le 6 juin 1944, domicilié à Monaco, 19, boulevard de Suisse de son mandat d'Adminis-
trateur et d'Administrateur-délégué;
* INCOSEC SERVICES LTD avec siège à 83 Bridge Street, GB-Manchester, inscrit au registre de Companies House
(GB) sous le numéro 04247901, de son mandat d'Administrateur;
* COREG SERVICES LTD avec siège à 83 Bridge Street, GB-Manchester inscrit au registre de Companies House(GB)
sous le numéro 04247896, de son mandat d'Administrateur;
* La Fiduciaire Benoy Consulting S.à r.l., 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg inscrit au Registre de commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B39.261, de son mandat de commissaire aux comptes.
- décide de nommer:
* SPRL 1001, avec siège à Albrecht Rodenbachlaan 42, 3600 Genk (B), inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro KBO 0461681495, avec comme représentant permanent Flor Swinnen, banquière, née le 19 juillet 1957
à Waanrode (B), domiciliée 8, Boterbergstraat B-3473 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu
en 2015;
* SPRL Ambras, avec siège à Aarchotsebaan 11, 3370 Boutersem (B), inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro KBO 0471953894, avec comme représentant permanent Peter Muylst, ouvrier, né le 3 février 1967 à
Tirlemont (B), domicilié 4, Everpoelstraat B-3400 Landen comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui aura
lieu en 2015;
* Monsieur Patrick Julien Muylst, comptable, domicilié à Everspoelstraat 4, 3400 Landen (B), né le 31 mars 1965 à
Tienen (B) comme Administrateur et Administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2015.
- décide de nommer commissaire aux comptes pour une durée de six ans, Malpa Magda née le 21 octobre 1946 à
Tirlemont (B), domiciliée à Everspoelstraat 4, 3400 Landen(B) en remplacement de la Fiduciaire Benoy Consulting S.à r.l.,
13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2009143362/34.
(090173022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Vendest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 133.496.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
112168
<i>VENDEST S.A.
i>D. PIERRE / Ch. FRANCOIS
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2009143720/12.
(090173469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Repco 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 110.471.
RECTIFICATIF
Le soussigné Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les
présentes que dans un acte de constatation d'augmentation de capital, reçu par son ministère en date du 24 juillet 2006,
enregistré à Grevenmacher, le 7 août 2006, volume 537, folio 48, case 5, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, le 23 août 2006, référence L060088943.05, pour compte de la société anonyme "REPCO 3 S.A.", ayant
son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.471, publié au Mémorial C numéro 1956 du 18 octobre 2006, il y a lieu
de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:
IL Y A LIEU DE LIRE DANS LA VERSION ANGLAISE:
III. The subscribed capital of the Company is set at EUR 141,370.- (one hundred forty-one thousand three hundred
seventy Euros) represented by 10,654 A Shares and 3,483 B Shares.
AU LIEU DE:
III. The subscribed capital of the Company is set at EUR 141,370.- (one hundred forty-one thousand three hundred
seventy Euros) represented by 10,654 A Shares and 2,661 B Shares.
Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avere necessaire.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 novembre 2009. Relation: GRE/2009/4100. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Junglinster, le 9 novembre 2009.
Jean SECKLER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009143789/27.
(090173799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Repco 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 110.471.
RECTIFICATIF
Le soussigné Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les
présentes que dans un acte de constatation d'augmentation de capital, reçu par son ministère en date du 7 juillet 2006,
enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2006, volume 537, folio 26, case 1, déposé au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, le 23 août 2006, référence L060088942.05, pour compte de la société anonyme "REPCO 3
S.A.", ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.471, publié au Mémorial C numéro 1955 du 18 octobre
2006, il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:
IL Y A LIEU DE LIRE DANS LA VERSION ANGLAISE:
X. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the
article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:
" 5.1. The subscribed capital of the Company is set at Euros 141,370.- (one hundred forty one thousand three hundred
seventy euros), represented by 14,137 (fourteen thousand one hundred thirty seven) shares having a par value of ten
Euros (EUR 10) each divided into 10,654 (ten thousand six hundred and fifty four) class A shares (the "A Shares") and
3,483 (three thousand four hundred eighty three) class B shares (the "A Shares" and together with the B shares, hereinafter
the "Shares")."
" 5.3. The authorized capital and authorized issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of EUR
4,721,785.71 (four million seven hundred twenty one thousand seven hundred eighty five euros and seventy one cents)."
112169
AU LIEU DE:
X. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the
article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:
" 5.1. The subscribed capital of the Company is set at Euros 141,370.- (one hundred forty one thousand three hundred
seventy euros), represented by 14,137 (fourteen thousand one hundred thirty seven) shares having a par value of ten
Euros (EUR 10) each divided into 10,654 (ten thousand six hundred and fifty four) class A shares (the "A Shares") and
2,661 (two thousand six hundred sixty one) class B shares (the "A Shares" and together with the B shares, hereinafter
the "Shares")."
" 5.3. The authorized capital and authorized issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of EUR
4,721,785.71 (four million seven hundred twenty one thousand seven hundred eighty five euros and seventy one cents)."
Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 novembre 2009. Relation: GRE/2009/4099. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Junglinster, le 9 novembre 2009.
Jean SECKLER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009143792/41.
(090173796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Central Shoe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3898 Foetz, Zone Industrielle de Foetz, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 34.837.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009143808/10.
(090173625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
FPM Realty S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 117.790.
Les comptes annuels au 30 juin 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009143809/10.
(090173627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Baikal S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 13.152.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BAIKAL S.A., SPF
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009143705/12.
(090173466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
112170
Netaxel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 133.206.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 31 octobre 2009i>
1. Monsieur Gérald Barbot a démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 31 octobre 2009.
2. Monsieur Pierre-Antoine Barbot, consultant, né le 27 avril 1985 à Chambray-lès-Tours (France), domicilié 62, Ave-
nue Emile Duray, B-1050 Ixelles (Belgique) a été nommé administrateur de la société.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui sera tenue en 2013.
Luxembourg, le 2 novembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143243/16.
(090172867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Knockon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 132.397.
<i>Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2009i>
L'Assemblée a nommé en remplacement de M. Lennart STENKE, administrateur démissionnaire, Me Thomas FELGEN,
né le 14/12/1971 à Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, au poste d'admi-
nistrateur.
Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée qui se tiendra en 2013.
L'Assemblée a nommé en remplacement de M. Lennart STENKE, administrateur délégué démissionnaire, M. Nicolas
KRUCHTEN, né le 28/08/1957 à Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, au
poste d'administrateur délégué. Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée qui se tiendra en 2013.
Luxembourg, le 28 octobre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143250/19.
(090172939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Coaching International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 65.225.
<i>Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2009i>
L'Assemblée a renouvelé le mandat d'administrateur de M. Carl Magnus SCHREITER, né le 27/03/1967 à Skelleftea
(Suède) et résidant au 4, Parke Road Barnes, SW13 9NE Londres.
Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée qui se réunira en 2010.
L'Assemblée a renouvelé le mandat d'administrateur de Me René FALTZ, né le 17/08/1953 à Luxembourg et résidant
professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg. Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée qui se
réunira en 2010.
L'Assemblée n'a pas renouvelé le mandat d'administrateur de M. Lennart STENKE et a nommé en remplacement M.
Nicolas KRUCHTEN, né le 28/08/1957 à Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxem-
bourg.
Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée qui se réunira en 2010.
L'Assemblée n'a pas renouvelé le mandat d'administrateur délégué de M. Lennart STENKE et a nommé en remplace-
ment M. Nicolas KRUCHTEN, né le 28/08/1957 à Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720
Luxembourg.
Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée qui se réunira en 2010.
112171
L'Assemblée a renouvelé le mandat de commissaire aux comptes de la société Server Group Europe S.A. (ancienne-
ment nommé The Server Group Europe S.A.), B 68 574, ayant son siège au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
Le mandat du commissaire arrivera à échéance lors de l'Assemblée qui se réunira en 2010.
Luxembourg, le 28 octobre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143251/29.
(090172964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Marine Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 26.316.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 28 octobre 2009 que:
- ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société pour une durée de deux ans:
* Monsieur Torstein HAGEN, résidant à Leuengasse 2, CH-4057 BASEL
* Maître Charles DURO, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra
en 2011.
- a été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société pour une durée d'un an:
* La société Fiduciaire Grand Ducale SA, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se
tiendra en 2010.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143254/23.
(090173020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
European Resorts S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 48.743.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en
date du 26 octobre 2009 que:
- Le nombre d'administrateurs de la société est augmenté de trois à quatre membres;
- A été nommé aux fonctions d'administrateur de la société Monsieur Jean Pierre VIELLEVOYE, industriel, né le 9 mai
1952 à Liège (B), et demeurant à CH-1204 GENEVE, 2, rue du Puits Saint Pierre.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2012.
Il résulte des résolutions prises lors d'une réunion du Conseil d'administration de la société tenue en date du 26
octobre 2009 que:
- A été nommé aux fonctions de Président du Conseil d'administration de la société jusqu'à la fin de son mandat
d'administrateur, Monsieur Jean Pierre VIELLEVOYE, industriel, né le 9 mai 1952 à Liège (B), et demeurant à CH-1204
GENEVE, 2, rue du Puits Saint Pierre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143253/23.
(090173007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
112172
Harvey Weston International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 78.828.
Nous avons constaté que:
- Monsieur Gabriel JEAN a renoncé à sa fonction d'administrateur de la société,
- la société MARBLEDEAL LTD a renoncé à sa fonction de commissaire aux comptes de la société,
à la date de la dénonciation du siège social, à savoir le 8 juillet 2008.
Bertrange, le 9 novembre 2009.
<i>Pour HARVEY WESTON INTERNATIONAL S.A.
i>Gabriel JEAN
Référence de publication: 2009143259/14.
(090173051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Bemol S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 127.884.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue
en date du 30 octobre 2009 que Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle
a été nommée aux fonctions d'administrateur en remplacement de Maître Lydie LORANG démissionnaire.
Son mandat d'administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui se
tiendra en 2013.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143257/17.
(090173041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Sigma Capital Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.335.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société du 24 septembre 2009i>
L'actionnaire unique de SIGMA CAPITAL INVESTMENTS S.A. ("la société"), a pris en date du 24 septembre 2009 des
résolutions suivantes:
1. D'accepter la démission de Artem Bolotin et de Boris Zimin en tant qu'Administrateurs de la Société, avec effet
immédiat;
2. De nommer comme Administrateur Libena Limited, ayant son siège professionnel au Richmond House, 12 Par la
Ville Road, Hamilton, Bermuda, HM08, registrée au Registre de Commerce sous le numéro 3497 avec M. Boris Zimin,
résidant au 53-3 Festivalnaya Ulitsa, 125502 Moscou, Russie comme représentant permanent, avec effet immédiat pour
une durée déterminée. Le mandat expirera à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2015.
3. De nommer comme Administrateur BMT Management Ltd., ayant son siège professionnel au Richmond House, 12
Par la Ville Road, Hamilton, Bermuda, HM08, registrée au Registre de Commerce sous le numéro 31382 avec M. Artem
Bolotin, résidant au 3 Shestoy Novopodmoskovny Pereulok, Moscou, 125130, Russie comme représentant permanent
avec effet immédiat pour une durée déterminée. Le mandat expirera à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2015.
4. De confirmer que M. Vesselin Danev reste en tant que Administrateur de la Société.
Luxembourg, le 30 octobre 2009.
Luxembourg Corporation Company SA
<i>Mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009143260/25.
(090173052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
112173
Acres 1010, Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 117.497.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2009i>
L'assemblée décide de reconduire la société MAZARS en tant que commissaire aux comptes pour le contrôle des
comptes annuels 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009143282/12.
(090173200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
E.ON Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 114.836.
EXTRAIT
Il résulte que l'associé unique de la Société, E.ON Invest GmbH, a changé de siège social et que celui-ci se trouve
désormais à: 14, Nördliche Münchner Str., D-82031 Grünwald.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2009.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143271/15.
(090172986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Skype Technologies, Société Anonyme.
Capital social: EUR 844.243,75.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 96.677.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion des actionnaires de la Société tenue en date du 6 novembre 2009 que les
actionnaires ont décidé:
de prendre note de la démission de Monsieur Michael van SWAAIJ en tant qu'administrateur de la Société avec effet
immédiat au 6 novembre 2009.
En conséquence, le conseil d'administration de la Société est constitué des personnes suivantes:
M. Joshua Silverman;
M. Norbert Becker;
Mme Laura Shesgreen; et
M. Robert Miller.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143272/22.
(090172992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
112174
Brighton Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 97.323.
En date du 26 juin 2009 l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a décidé de continuer les mandats jusqu'à
l'assemblée qui se tiendra en 2014 de:
- Federico Guillermo Thomas Leonhardt, administrateur, avec adresse au 2631 Diego Palma, RA - 1642 San Isidro,
Buenos Aires
- Rodolfo Dietl, administrateur, avec adresse au 1035 Ladislao Martinez, RA - 1640 Martinez, Buenos Aires
- IB Management Services S.A., Commissaire aux Comptes, avec adresse au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143268/17.
(090172746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Mypa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5691 Ellange, 53-54, Z.A. Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 63.512.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue à Ellange en date dui>
<i>8 septembre 2008i>
1) L'assemblée générale décide d'accepter la démission comme administrateurs de Mme Elke SCHNEIDER et de M.
Werner HUBNER.
2) L'assemblée générale désigne comme nouvel administrateur avec effet à la date de ce jour et dont le mandat court
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2011: M. Marc SCHNEIDER, né le 29 août 1973 à Saarbrücken (Al-
lemagne), demeurant à F-57130 Jussy, 9, rue du Bois de la Dame.
Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 6 novembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143269/19.
(090172945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Millicom International Cellular S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 40.630.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration de la Société tenue à Luxembourg le 1 i>
<i>eri>
<i> septembre 2009i>
Le Conseil d'Administration de Millicom International Cellular S.A. (la "Société"), il a été décidé comme suit:
- de nommer M. Lars Svenningsson, Secrétaire d'Entreprise, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Léon Laval,
L-3372 Luxembourg, en qualité de délégué à la gestion journalière de la société avec effet a partir du 1
er
septembre 2009
et a durée indéterminée;
- de rectifier la fonction de M. Bruno Nieuwland à Directeur de la Fiscalité et des Projets Internationaux.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 23 septembre 2009.
Millicom International Cellular S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143273/18.
(090173000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
112175
Summerwind S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 104.600.
<i>Auszug der von der Generalversammlung der Aktionäre am 29. Oktober 2009 getroffenen Beschlüssei>
1. Erhöhung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von drei (3) auf vier (4)
2. Herr Frank PLETSCH, geboren am 15. Juli 1974 in Trier (Deutschland), beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ist als Verwaltungsratsmitglied bis zum Ende der statutarischen Generalver-
sammlung des Jahres 2010 ernannt worden.
Luxemburg, den 10 November 2009.
Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für SUMMERWIND S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009143275/17.
(090173004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Colonnade Holdco n°11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 142.712.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 27 août 2009i>
Veuillez prendre note que le siège social de l'associé EUROVENT III a été transféré à F-75116 Paris (France), 112,
avenue Kleber.
1. M. Benoît NASR a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Georges SCHEUER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 juin 1967,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
gérant pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 10/11/2009.
Pour avis et extrait sincère et conforme
<i>Pour Colonnade Holdco n°11 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009143276/19.
(090173010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
SafeWorks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 124.427.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 août 2009i>
Il résulte de la décision prise par l'Associé Unique en date du 24 août 2009 que:
- Monsieur Gregory Martin Kennelly, avec adresse professionnelle au 365 Upland Drive, Seattle, WA 98188, USA a
été élu au poste de gérant de catégorie A de la société.
Luxembourg, le 24 août 2009.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009143266/17.
(090173391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
112176
Acres 1010
Amberley S.A.
Areion Fund
Baikal S.A., SPF
Bemol S.A.
Brighton Investments S.A.
BSkyB Finance (Luxembourg) S.à r.l.
Central Shoe S.A.
Citrix Systems Capital and Finance Sàrl
Coaching International S.A.
Colonnade Holdco n°11 S.à r.l.
Compagnie d'Investissement Eaton-Belgravia S.à.r.l.
Cordell Investments S.A.
Economat S.C.I.
E.ON Asset Management S.à r.l.
European Resorts S.A.
Ever Capital S.à r.l.
Fine Tobacco Flavours S.A.
Finsweet S.A.
FPM Realty S.A.
FPM Realty S.A.
Gemalco S.A.H.
GR Luxembourg Holdings S.à r.l.
Harvey Weston International S.A.
Hirslanden Investments S.A.
Immo 70's S.à r.l.
Knockon S.A.
Marine Investments S.A.
M. Bormann GmbH
Millicom International Cellular S.A.
Mypa S.A.
Netaxel S.A.
Nidderkuerer Tuterten asbl
OVC Property Services Limited Société Anonyme
Pimco Luxembourg II
Pimco Luxembourg S.A.
Port Bay SA
Presta-Gaz S.A.
Repco 3 S.A.
Repco 3 S.A.
SafeWorks S.à r.l.
School S. à r.l.
Sigma Capital Investments S.A.
Skype Technologies
SL Software_Consult S.A.
Socipar S.A.
Summerwind S.A.
Theo Müller Group S.à r.l.
Theo Müller Group S.e.c.s.
Unirec S.A.
Vendest S.A.
Yurger S.A.
Zeclat Holding S.A.