This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2313
26 novembre 2009
SOMMAIRE
Akakus Oil Operations SA . . . . . . . . . . . . . .
111004
Alkopharma S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110991
Aluco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111004
Association des Parents d'Elèves du
Sports-Etudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110992
Barony Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110990
BDO Compagnie Fiduciaire . . . . . . . . . . . . .
110988
BNP Paribas Real Estate Advisory & Pro-
perty Management Luxembourg . . . . . . .
111000
Brighton Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
110991
CA CRÉE Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110986
Canton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110987
Cap Santé 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110989
Caryos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111023
C.A.S. Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111000
CMS Management Services S.A. . . . . . . . . .
110999
Delilah Sub Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
110982
EASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110999
Falcon Invest Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110994
Famility S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110994
FDS Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111000
Fenestratus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111024
Food Service Network S.à r.l. . . . . . . . . . . .
111024
Garage Toussaint S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
110990
Global Palaces Management S.à r.l. . . . . . .
110989
Golding Investments IV TF2 S.A. . . . . . . . .
110995
Granit Import Système S.à r.l. . . . . . . . . . .
110990
HR at Work Consultants Luxembourg . . .
110978
HR at Work Consultants Luxembourg . . .
110978
Hucage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110990
Immo Place de Paris S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
110984
Intrasoft International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
110985
La Raphije S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110988
Lauro 28 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110994
Lisbonne Lux S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111024
Lux-Avantage Advisory S.A. Holding . . . . .
110985
Maestro SICAV (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110987
Maidford Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110984
Marc Aalen Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
110988
Marlegreen Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
110983
MC Investment Central Europe S.àr.l. . . .
110990
Multibuilding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111023
Nagoluphy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110983
Palace Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110982
Portunato Marine Services S.A. . . . . . . . . .
110995
Pro-Audio Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
111003
Q & A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110991
Q & A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110991
Ranylux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111023
Renaissance Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
110983
Revesta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111024
Savacom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111002
SIFC Development Holding S.à r.l. . . . . . .
110995
Sunrise S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110986
Swisstar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111023
Swisstar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111004
Swisstar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111002
Teknon Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
110982
TrendConcept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110984
Trisport 69-77 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110985
unitedprint S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111024
Value Opportunities Fund S.A. . . . . . . . . . .
110989
Vescor Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110991
110977
HR at Work Consultants Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8077 Bertrange, 83A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 149.088.
OUVERTURE DE SUCCURSALE
<i>Données relatives à la succursalei>
Date de la création de la succursale: 1
er
novembre 2009
Dénomination de la succursale: HR at Work Consultants Luxembourg
Adresse de la succursale: 83A, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange
Objet: recrutement et sélection de personnel
Représentant permanent de la succursale nommé pour une durée indéterminée: Mustapha ALAOUI, né à Bruxelles
(Belgique), le 16/07/1971 et demeurant avenue de Burlet, 2 à B-1360 Perwez (Belgique)
Pouvoirs de signature: signature individuelle de Mustapha ALAOUI.
<i>Données relatives à la personne morale de droit suissei>
Dénomination: hr-at-work consultants GmbH
Registre de commerce: Handelsregister des Kantons Zug (Suisse) numéro CH-170.4.006.306-1
Siège social: Sumpfstrasse, 24, CH-6300 Zug
Personne habilitée à engager la maison mère: Maite Plimmer Benito, née le 8.9.1965 à Figueras (Espagne) et demeurant
Sonnenrain, 2A, 5647 Oberütti, Suisse
Pouvoir de signature: la société est engagée par la signature individuelle de la gérante (Geschäftsführerin)
Fait à Zug, le 27.10.2009.
<i>Pour Maite Plimmer Benito
Geschäftsführerin
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009143023/28.
(090173250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
HR at Work Consultants Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8077 Bertrange, 83A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 149.088.
ÖFFENTLICHE URKUNDE
NOTARIAL DEED
<i>Gründung der hr-at-work Consultants GmbHi>
<i>Incorporation of hr-at-work Consultants GmbHi>
mit Sitz in Baar
with registered domicile in Baar
27. März 2006
RA
E
Koch & Bättig
lic. iur. Stephan Martin Koch
Rechtsanwalt und Urkundsperson
Obmoos 4 6301 Zug
Vor mir, lic. iur. Stephan Martin Koch, Rechtsanwalt in Zug und Urkundsperson des Kantons Zug, sind heute erschie-
nen:
Before me, lic. iur. Stephan Martin Koch, Attorney-at-law and Notary Public of the canton of Zug, appeared today:
1. W & H Holding GmbH, in Zug
2. Frau Maite PLIMMER BENITO, geb. 8.9.1965, britische Staatsangehörige in 6318 Walchwil, Tonishofstrasse, 5
und haben erklärt:
and stated:
110978
I.
Unter der Firma
hr-at-work consultants GmbH
gründen wir mit Sitz in Baar, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss den Bestimmungen des Schweiz.
Obligationenrechts.
We incorporate a limited liability company under the name
hr-at-work consultants GmbH
with registered domicile in Baar, in accordance with the provisions of the Swiss Code of Obligations (CO).
II.
Wir setzen die Statuten der Gesellschaft in dem uns vorliegenden Wortlaut fest.
We adopt the articles of association as per the wording presented.
III.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 50'000.00 und wird von uns wie folgt übernommen:
The share capital of the company amounts to CHF 50'000.00 and is signed by us as follows:
1. W & H Holding GmbH
eine Stammeinlage zu Fr. 49'000.00
one share of CHF 49'000.00
2. Maite Plimmer Benito
eine Stammeinlage zu Fr. 1'000.00
one share of CHF 1'000.00
IV.
Es sind folgende Einlagen geleistet worden:
The following contributions have been made:
CHF 25'000.00 in Geld, durch Hinterlegung zur ausschliesslichen Verfügung der Gesellschaft bei der unterfertigten
Urkundsperson, gemäss der vorliegenden schriftlichen Bescheinigung.
CHF 25'000.00 in cash, deposited at the exclusive disposal of the company at the undersigned Notary public, as per
the written confirmation presented.
Dadurch ist das Stammkapital zu 50% einbezahlt.
Thereby the share capital is paid in by 50%.
V.
Wir bestätigen hiermit, dass
We herewith confirm, that
1. wir das ganze Stammkapital übernommen haben
1. we have signed the full share capital
2. die beiden Stammeinlagen zu Fr. 49'000.00 und Fr. 1'000.00 zu 50% liberiert worden sind
2. the two shares of CHF 49'000.00 and CHF 1'000.00 have been paid in by 50%
3. der hinterlegte Betrag von Fr. 25'000.00 zur freien Verfügung der Gesellschaft steht
3. the deposited amount of CHF 25'000.00 is at the free disposal of the Company
VI.
Wir wählen als Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift:
We elect as manager with single signature:
Frau Maite PLIMMER BENITO
britische Staatsangehörige, in Walchwil
Die Gewählte erklärt Annahme der Wahl.
The elected declares acceptance of her election.
VII.
Das Domizil der Gesellschaft befindet sich in eigenen Büros an der Adresse:
The registered domicile of the company with own offices is at:
Zugerstrasse 76B
6340 Baar
110979
VIII.
Hiermit erklären wir die hr-at-work consultants GmbH den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegründet und
ermächtigen und beauftragen den Geschäftsführer, die Gesellschaft zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden. Ferner
bevollmächtigen wir die Urkundsperson, allfällige wegen Beanstandung durch die Handelsregisterbehörden erforderliche
Änderungen an den Statuten oder am Errichtungsakt vorzunehmen.
We herewith declare hr-at-work consultants GmbH as being duly incorporated according to the requirements set
forth by law and herewith authorize and mandate the manager, to apply for the registration of the company with the
Register of Commerce. Furthermore we authorize the Notary Public, to deal with possible required changes of the
Articles of Association or to the Notarial Deed.
Zug, 27. März 2006.
W & H Holding GmbH
Frédéric Hubin / Maite Plimmer Benito
<i>Öffentliche Beurkundungi>
Ich, lic. iur. Stephan Martin Koch, Rechtsanwalt in Zug und Urkundsperson des Kantons Zug, beurkunde hiermit
öffentlich:
I, lic. iur. Stephan Martin Koch, Attorney-at-Law and Notary Public of the Canton of Zug, hereby certify:
Diese Urkunde enthält den mir mitgeteilten Willen der Gründer und ist von diesen oder ihrem Vertreter unterzeichnet
worden.
The Notarial Deed reflects the communicated will of the founders and has been signed by the founders resp. their
representative personally.
Die in der Urkunde erwähnten Belege haben mir und den Gründern oder ihrem Vertreter vorgelegen.
All documents mentioned in the Notarial Deed were presented to me and the Founders resp. to their representative.
Zug, 27. März 2006
Stephan Martin Koch
<i>Urkundspersoni>
KOCH & BÄTTIG
lic. iur. Stephan Martin Koch
Rechtsanwalt und Notar
Obmoos 4, Postfach 308
CH-6301 ZUG
Telefon 041 - 720 11 00
Telefax 041 - 720 11 05
PLATINO@SWISSONLINE.CH
lic. iur. Kurt Bättig
Rechtsanwalt und Notar
Zeughausgasse, 9A, Postfach 340
CH-6301 ZUG
Telefon 041 - 710 93 93
Telefax 041 - 710 93 94
KBLAW@SWISSONLINE.CH
Mitglieder des schweizerischen Anwaltsverbandes
- Zug, 27. März 2006 (RA Koch)
- Bescheinigung über die Einzahlung von Stammkapital
Hiermit wird bestätigt, dass bei uns heute der Betrag von
CHF 25'000.00
(fünfundzwanzigtausend Franken)
einbezahlt worden ist.
Dieser Betrag dient zur teilweisen Liberierung des Stammkapitals der zu gründenden
hr-at-work Consultants GmbH
110980
mit Sitz in Baar.
Er wird von uns nach erfolgter Gründung der Gesellschaft den geschäftsführenden Organen ausgehändigt.
Stephan Martin Koch
<i>Urkundspersoni>
STATUTEN DER
ARTICLES OF INCORPORATION OF
HR-AT-WORK CONSULTANTS GMBH
1. Unter der Firma hr-at-work consultants GmbH besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Baar.
Under the firm name hr-at-work consultants GmbH there exists a Limited Liability Company with registered offices
in Baar.
2. Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Ausführung, Wiederverkauf, Verleih, Installation, Einrichtung und Unterhalt
von Netzwerken, Computersystemen und Computer-Software, sowie Beratung auf dem Gebiet der Personalvermittlung
im High-Tech-Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland er-
richten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen,
finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
The purpose of the Corporation is design, implementation, reselling, renting, installation, configuration and mainte-
nance of networks, computer systems and computer software as well as high technology people recruitment advisory
services. The Corporation may open branch offices and subsidiaries in Switzerland and abroad. The Corporation may
acquire, hold, and sell real estate. The Corporation may also engage in any commercial, financial or other activities which
are related to the purpose of the Corporation.
3. Das Stammkapital beträgt Fr. 50'000.00 und besteht aus einer Stammeinlage zu Fr. 49'000.00 und einer Stammeinlage
zu Fr. 1'000.00
The share capital of CHF 50'000.00 is divided into one share of CHF 49'000.00 and one share of CHF 1'000.00
4. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich mindestens 5 Tage vor dem Versammlungsdatum.
Anstelle der Beschlussfassung in der Versammlung können Gesellschaftsbeschlüsse auch auf dem Zirkularweg gefasst
werden.
The general meeting of shareholders is convoked at least five days prior to the date of the meeting. In lieu of a meeting,
resolutions of the shareholders may also be taken by circular.
5. Publikationsorgan ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.
Publications of the corporation are made in the Swiss Official Journal of Commerce.
Beglaubigung
Legalisation
Hiermit wird bestätigt, dass diese Ausfertigung die heute durch die Gründer festgelegten Statuten der hr-at-work
consultants GmbH vollständig und richtig wiedergibt.
This is to certify that this document contains the Articles of Incorporation adopted today by the founders of hr-at-
work consultants GmbH.
Zug, 27. März 2006
Stephan Martin Koch
<i>Urkundspersoni>
BEGLAUBIGUNG / LEGALISATION / NOTARIAL CERTIFICATE
Diese Kopie stimmt mit dem vorgelegten Original überein / Cette copie est conforme à l'original présenté / This is a
true copy of the original as presented.
Zug, 2. JUNI 2009.
Stephan Martin Koch
<i>Die Urkundspersoni> / <i>Le Notairei> / <i>The Notary Publici>
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von
2. has been signed by Stephan Martin Koch
110981
3. in der Eigenschaft als
3. acting in the capacity of Notary public
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der
4. bears the stamp/seal of Notary public of the canton of Zug
5. in / to 6300 Zug
6. am / the 03. Juni 2009 - Bestätigt/Certified
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under No. 5532109
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal
CANTON ZUG
CHANCERY OF STATE
10. Unterschrift / Signature
Herbert Fischer.
Référence de publication: 2009143453/188.
(090173250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Palace Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 320.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 140.274.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009142470/13.
(090172074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Delilah Sub Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 68.597.540,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 147.733.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009142471/13.
(090172098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Teknon Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 101.101.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009142472/12.
(090172106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110982
Marlegreen Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 59.096.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142481/10.
(090172348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Nagoluphy S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 61.986,69.
Siège social: L-8310 Capellen, 1C, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 69.523.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie de manière extraordinaire en date du 6 octobrei>
<i>2008i>
L'an deux mille huit, le six octobre, à dix heures, les actionnaires de la société NAGOLUPHY S.A. se sont réunis en
assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire, au siège social et ont pris, à l'unanimité, les résolutions
suivantes:
Les actionnaires constatent, que suite à la scission de la société Fiduciaire FRH S.à r.l. en date du 24 juin 2008 et à la
constitution de la société Fiducaire Cabexco S.à r.l., issue de la scission, la Fiduciaire Cabexco S.à r.l. a repris le mandat
de commissaire aux comptes en cours.
Les actionnaires ratifient donc la nomination de la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l., ayant son siège social à L-8080
Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent, R.C.S. Luxembourg B 139.890 en tant que nouveau commissaire aux comptes
de la société en remplacement de la société Fiduciaire FRH S.àr.l..
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2010.
Capellen, le 6 octobre 2008.
Pour extrait conforme
Signatures
Référence de publication: 2009141959/24.
(090171893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Renaissance Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 148.870.
EXTRAIT
En date du 27 octobre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Madame Marjoleine van Oort en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- La démission de Monsieur Jorrit Crompvoets en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- La démission de Monsieur Frank Walenta en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Jan Sykora, né le 18 janvier 1972 à Praha 8, République Tchèque, avec adresse professionnelle à Namesti
Republiky 1079/la, 110 00 Prague 1, République Tchèque, est élu comme nouvel administrateur unique de la société avec
effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2015.
Luxembourg, le 2 novembre 2009.
Pour extrait conforme
Vistra (Luxembourg) S. à r.l.
Marjoleine van Oort
Référence de publication: 2009142575/19.
(090172126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110983
Immo Place de Paris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 101.719.
Suite à une cession de parts sociales en date du 15 octobre 2009 qui a été acceptée par la société le même jour, les
parts sociales sont désormais réparties comme suit:
Monsieur Marc TERNES, commerçant
avec adresse professionnelle à L-2314 Luxembourg, 2A, Place de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Monsieur LUIGI MANDERSCHEID, commerçant,
demeurant à L-2761 Luxembourg, 8, rue Yolande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Luxembourg, le 15 octobre 2009.
Signatures
<i>La sociétéi>
Référence de publication: 2009142563/17.
(090172571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
TrendConcept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 71.497.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung die am 29. Dezember 2004 in Luxemburg stattfand:i>
Die Ausserordentliche Generalversammlung beschließt, nachdem Herr Horst Baumann sein Amt als Verwaltungs-
ratsmitglied zum 31. Dezember 2004 niederlegt, Herrn Rudolf Kessel, geboren am 03. Dezember 1958 in Neumagen-
Dhron, Deutschland, mit Berufsanschrift in 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, als zusätzliches
Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 1. Januar 2005 bis zum Zeitpunkt der Ordentlichen Generalversammlung, die
über den Jahresabschluss der TrendConcept S.A. für das am 31. Dezember 2004 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu
ernennen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 03. November 2009.
Die TrendConcept S.A.
Lothar Rafalski / Jean-Marie Schomer
Référence de publication: 2009142571/18.
(090172188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Maidford Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 148.074.
EXTRAIT
En date du 27 octobre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Madame Johanna van Oort en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- La démission de Monsieur Jorrit Crompvoets en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- La démission de Monsieur Frank Walenta en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Vladimir Jaros, né le 23 février 1969 à Kladno, République Tchèque, avec adresse professionnelle à Namesti
Republiky 1079/1a, 110 00 Prague 1, République Tchèque, est élu comme nouvel administrateur unique de la société avec
effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2015.
Luxembourg, le 28 Octobre 2009.
Pour extrait conforme
Vistral (Luxembourg) S. à r.l.
Marjoleine van Oort
Référence de publication: 2009142574/19.
(090172147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110984
Trisport 69-77 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6941 Niederanven, 15, rue de Münsbach.
R.C.S. Luxembourg B 104.846.
<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2009i>
Les actionnaires de la société TRISPORT 69-77 S.A. réunis en Assemblée Générale ordinaire du 10 juin 2009, ont
décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs de:
- Monsieur Larry Conklin, indépendant, demeurant à L-6212 Consdorf, 63, rue Hicht.
- Monsieur Charles Wirtz, employé privé, demeurant à L-6769 Grevenmacher, 13, am Weiher.
- Monsieur Dan Epps, conseil fiscal, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de cinq années,
soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
D'autre part, l'assemblée générale constatant que le mandat de l'administrateur délégué de:
- Monsieur Larry Conklin, indépendant, demeurant à L-6212 Consdorf, 63, rue Hicht
est arrivé à échéance décide de le renouveler dans sa fonction pour une nouvelle période de cinq années, soit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
De plus, la mandat du commissaire aux comptes de:
- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie,
étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de cinq années, soit
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
Niederanven, le 10 juin 2009.
Pour extrait conforme
Signatures
Référence de publication: 2009142081/27.
(090172380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Lux-Avantage Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 46.042.
Cooptation d'un administrateur
Le Conseil d'Administration du 23 octobre 2009 a décidé de coopter Monsieur Charles WAGENER (adresse profes-
sionnelle: 130, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg) en tant que nouvel administrateur jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2009, en raison de la démission de Monsieur Nicolas ROL-
LINGER survenue le 4 août 2009.
Luxembourg, le 4 novembre 2009.
Certifié conforme et sincère
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2009142512/16.
(090172322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Intrasoft International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 56.565.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142483/10.
(090172345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110985
CA CRÉE Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 80.061.
L'an deux mille neuf. Le quatorze octobre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A comparu:
Madame Véronique SACREZ, décoratrice, demeurant à L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
Laquelle comparante déclare être la seule associée de la société à responsabilité limitée CA CRÉE S. à r.l., avec siège
social à L-4335 Esch/Alzette, 14a, rue Henri Tudor,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 80.061,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 janvier 2001, publié au Mémorial C
numéro 652 du 20 août 2001,
dont le capital social est de CINQ CENT MILLE FRANCS LUXEMBOURGEOIS (LUF 500.000.-) divisé en CINQ
CENTS (500) parts sociales de MILLE FRANCS LUXEMBOURGEOIS (LUF 1.000.-) chacune.
Laquelle comparante prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1. Le siège social est transféré de son adresse actuelle L-4335 Esch/Alzette, 14a, rue Henri Tudor à L-8077 Bertrange,
238C, rue de Luxembourg, de sorte que le premier alinéa de l'article quatre (4) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 4. 1
er
alinéa. "Le siège de la société est établi à Bertrange."
2. Le capital social est converti en euros de sorte que le capital représente maintenant DOUZE MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS SOIXANTE-HUIT CENTS (€ 12.394,68). Pour arrondir ce capital et pour dis-
poser de parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-), la comparante déclare qu'elle a versé
à la caisse de la société le montant de CENT CINQ EUROS ET TRENTE-DEUX CENTS (€ 105,32) pour pouvoir disposer
d'un capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-).
Suite à cette décision, l'article six (6) des statuts est modifié comme suit:
" Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par CINQ CENTS
(500) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune."
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Véronique Sacrez, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12433. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. Boiça.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 2 novembre 2009.
Francis KESSELER.
Référence de publication: 2009142383/39.
(090172508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Sunrise S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 71.264.
Les administrateurs de la société Sunrise S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71 264, jusqu'alors établi au 8-10, rue Jean Monnet à
L-2180 Luxembourg, ont démissionné de leur poste de Président et d'administrateur de la société avec effet au 28 octobre
2009.
Luxembourg, le 28 octobre 2009.
Sonia StiII / Mariateresa Battaglia / Sandrine Pellizzari
<i>Président et Administrateur démissionnaire / Administrateur démissionnaire / Administrateur démissionnairei>
Référence de publication: 2009142520/14.
(090172447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110986
Maestro SICAV (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 127.905.
L'assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2009 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Raymond Mel-
chers, Luca Diener, Germain Trichies et Guy Reiter en tant que membres du conseil d'administration de Maestro SICAV
(Lux) et de nommer Monsieur Mark Wallace comme un nouveau membre du Conseil d'Administration de la Société.
Par conséquent, le Conseil d'Administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2010:
- Raymond Melchers, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Luca Diener, Membre du Conseil d'Administration
4, Kalandergasse, CH-8070 Zurich
- Germain Trichies, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Mark Wallace, Membre du Conseil d'Administration
4, Kalandergasse, CH-8070 Zurich
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été réélu comme réviseur d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Sebastian Best / Fernand Schaus
Référence de publication: 2009142516/27.
(090172417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Canton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 130.344.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 octobre 2009i>
- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Katiuscia Carraesi, employée privée, avec
adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg.
- L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Sonia Still, employée privée, avec
adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.
- L'Assemblée renouvelle le mandat de Président et d'administrateur de Maître Aloyse May, avocat à la Cour avec
adresse professionnelle 2-4 avenue Marie-Thérèse à L -2132 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
- L'Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de la société AACO (Accounting, Auditing,
Consulting & Outsourcing Sàrl ayant son siège social au 23 Val Fleuri à L - 1526 Luxembourg. L'Assemblée nomme en
remplacement du commissaire aux comptes la société H.R.T. Révision S.A. ayant son siège social au 23 Val Fleuri à L -
1526 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2013.
Luxembourg, le 20 octobre 2009.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009142523/26.
(090172489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110987
Marc Aalen Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, Place Clairfontaine.
R.C.S. Luxembourg B 44.178.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 28 octobre 2009 que:
1. L'Assemblée accepte la démission, en tant qu'Administrateurs, de:
- Luxembourg Management Corp. - LMC Corp.
- Conseils & Management Corp. - CMC Corp.
- Luxembourg Consult Services - LCS Corp.
2. L'Assemblée accepte la démission, en tant que Commissaire, de:
- Conseils & Management Services S.àr.l.
3. Sont élus Administrateurs jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31
décembre 2010:
- Madame Effimia Kalokouvarou, née le 29 septembre 1948 à Athènes, Grèce, avec adresse professionnelle au 4,
Koumbari Street, Athènes, Grèce, 10674;
- Monsieur Stamatios Vassiliou, né le 7 juin 1959 à Athènes, Grèce, avec adresse professionnelle au 54, Menandrou
Street, Athènes, Grèce, 10431;
- Monsieur Alexander Kalokouvaros né le 11 août 1938 à Athènes, Grèce, avec adresse professionnelle au 30, Rimini
Street, Filothei, Grèce, 15237.
4. Est élue Commissaire jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31
décembre 2009:
- PKF Abax Audit, RC B 142867, avec adresse au 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
5. Le siège social de la société est transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 9, Place Clairefontaire,
L-1341 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 30 octobre 2009.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2009142117/32.
(090172370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
BDO Compagnie Fiduciaire, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 147.571.
Madame Vania BARAVINI a démissionné de son mandat d'administrateur en date du 3 novembre 2009.
Luxembourg, le 3 novembre 2009.
Signature
<i>Le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2009142500/11.
(090172009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
La Raphije S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4832 Rodange, 468, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 111.722.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142577/10.
(090171971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110988
Cap Santé 3000, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8050 Bertrange, Shopping Center «La Belle Etoile», route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 71.510.
<i>Assemblée générale extraordinaire de la sociétéi>
L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures.
<i>Ordre du jouri>
- Cession de parts sociales.
L'associé unique est présent de façon que l'intégralité du capital social est représentée par:
Monsieur Michel SCHWEITZER, domicilié
60, avenue de Guise à F-57100 THIONVILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Monsieur Michel SCHWEITZER, prédit, cède 38 parts sociales à Mademoiselle Lara SCHWEITZER, demeurant 60,
avenue de Guise à F-57100 THIONVILLE, pour le prix convenu entre parties.
Monsieur Michel SCHWEITZER, prédit, cède 38 parts sociales à Mademoiselle Capucine SCHWEITZER, demeurant
60, avenue de Guise à F-57100 THIONVILLE, pour le prix convenu entre parties.
Suite à ces cessions, la répartition des parts sociales est la suivante:
M. Michel SCHWEITZER, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 parts sociales
Mlle Lara SCHWEITZER, mentionnée ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 parts sociales
Mlle Capucine SCHWEITZER, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 12.00 heures.
Fait à Bertrange, le 16 septembre 2009.
M. Michel SCHWEITZER / Mlle Lara SCHWEITZER /
Mlle Capucine SCHWEITZER.
Référence de publication: 2009142495/27.
(090171930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Value Opportunities Fund S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.448.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009142463/13.
(090171990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Global Palaces Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.500,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 140.703.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009142468/13.
(090172056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110989
Garage Toussaint S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6840 Machtum, 3, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 21.444.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142578/10.
(090171973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Hucage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 130.597.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142579/10.
(090171974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
MC Investment Central Europe S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 107.135.
RECTIFICATIF
Suite a une erreur matérielle lors du dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2008 de la Société en date du 17
septembre 2009 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la référence L090144817.04,
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142580/13.
(090171937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Granit Import Système S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 59.846.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009142581/10.
(090171917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Barony Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 37.623.
J'ai le regret de vous remettre, par la présente, ma démission en tant que Commissaire de votre société, avec effet
rétroactif au 28 octobre 2009.
Luxembourg, le 3 novembre 2009.
Olivier LIEGEOIS.
Référence de publication: 2009142573/10.
(090172360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110990
Vescor Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 110.743.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142576/10.
(090171969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Alkopharma S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 103.500.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2009142582/13.
(090171923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Q & A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2559 Luxembourg, 14, rue Valentin Simon.
R.C.S. Luxembourg B 122.088.
Les comptes annuels au 31.03.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2009142586/10.
(090171932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Q & A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2559 Luxembourg, 14, rue Valentin Simon.
R.C.S. Luxembourg B 122.088.
Les comptes annuels au 31.03.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2009142587/10.
(090171933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Brighton Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 97.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142438/10.
(090172301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110991
A.P.E.S.E., Association des Parents d'Elèves du Sports-Etudes, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2630 Senningerberg, 66, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg F 8.123.
STATUTS
Les présents statuts ont été rédigés selon les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par les
lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.
Chapitre I
er
. Dénomination - Siège - Objet
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination "Association des Parents d'Élèves du Sports-Etudes" (A.P.E.S.E.), asso-
ciation sans but lucratif. Elle a son siège à 66, route de Trêves L-2630 Luxembourg.
Art. 2. L'association a pour objet:
2.1. de contribuer à la prospérité et au bien-être du lycée, dans le respect des lois et des règlements régissant l'en-
seignement public luxembourgeois
2.2. de favoriser le dialogue et les contacts constructifs entre les parents d'une part, le personnel enseignant et les
autorités scolaires d'autre part
2.3. de transmettre aux autorités scolaires les suggestions des parents d'élèves en matière d'administration et d'or-
ganisation
2.4. d'aider les parents dans leur rôle éducatif surtout là où il se recoupe avec celui de l'établissement scolaire
2.5. d'offrir à tous les parents d'élèves accueil et soutien ainsi que l'expérience nécessaire à l'exercice des diverses
tâches qu'ils remplissent dans des organismes ou comités analogues.
Art. 3. L'association.
3.1. poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
3.2. peut s'associer à tout groupement analogue national ou international susceptibles de lui prêter un concours utile
pour atteindre les buts qu'elle poursuit.
Chapitre II. Membres - Admission - Exclusion - Cotisation
Art. 4. Les membres sont admis à la suite d'une demande écrite ou d'une demande verbale.
4.1. l'association se compose de membres actifs et de membres d'honneur
4.2. peuvent être membre d'honneur de plein droit, sur leur demande, les membres du personnel enseignant du
"Sports-Etudes".
4.3. peuvent être nommés membres d'honneur par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration,
des personnes physiques ou morales ayant rendu des services ou fait des dons à l'association
4.4. les membres d'honneur jouissent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits que les membres actifs
4.5. peuvent être membres actifs de l'association les parents d'élèves et les personnes justifiant qu'ils ont la charge
d'un enfant élève du "Sports-Etudes".
Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite
au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 12 mois à compter du jour de l'échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.
Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte
aux intérêts de l'association. A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la
décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est
envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun
droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 25€(EUR).
Chapitre III. Administration
Art. 9. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration
régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d'administration.
Art. 10. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant simple lettre
missive devant mentionner l'ordre du jour proposé.
110992
Art. 11. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle
doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.
Art. 12. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
12.1. modification des statuts et règlement interne
12.2. nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse
12.3. approbation des budgets et comptes
12.4. dissolution de l'association
Art. 13. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre
des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, ces règles sont
modifiées comme suit:
13.1. la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié ou moins de ses membres sont présents,
13.2. la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts
des voix des membres présents,
13.3. si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée
par le tribunal civil.
Art. 14. Les délibérations de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers par affichage
au siège.
Art. 15. L'association est gérée par un conseil d'administration élu pour une durée de deux (2) années par l'assemblée
générale. Le conseil d'administration se compose d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier; ainsi que 18 autres
membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale. Les pouvoirs des administra-
teurs sont les suivants: le président représente officiellement l'association et assure l'observation des statuts. Il assume
la présidence du conseil d'administration. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé présent.
Le secrétaire assure la rédaction des comptes rendus de réunions. Le trésorier gère les comptes.
Art. 16. Le conseil d'administration qui se réunit au moins une fois par trimestre scolaire sur convocation de son
président ne peut valablement délibérer que si 2/3 des membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise
à la majorité simple des membres si expressément demandé par un / plusieurs membre(s) du conseil d'administration
présent.
Art. 17. Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives à lui dévolues
par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'association.
Art. 18. Il représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à
l'égard de ceux-ci, une (1) signature de membres en fonction est nécessaire. Toutefois, dans toutes les relations avec les
tiers, la signature sera seulement valable si une décision du conseil d'administration y relative existe, et a été notifiée par
rapport du secrétaire.
Chapitre IV. Exercice social - Dissolution - Ressources
Art. 19. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités,
les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L'exercice budgétaire couvre l'année scolaire. Les
comptes sont arrêtés en fin d'année scolaire et soumis à l'assemblée générale avec le rapport du réviseur de caisse. A fin
d'examen, l'assemblée désigne un réviseur de caisse. Le mandat de celui-ci est incompatible avec celui d'administrateur
en exercice.
Art. 20. En cas de liquidation de l'association, les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.
Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites.
Art. 22. Les ressources de l'association comprennent notamment:
22.1. les cotisations des membres
22.2. les subsides et subventions
22.3. les dons ou legs en sa faveur
Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toute rémunération.
110993
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, ainsi qu'au règlement
interne en vigueur approuvé par l'assemblée générale.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.
Entre les soussignés
Romain Baum / Lucien Bechthold / Viviane Biel / Pierre Kieffer / Karin Kips / François Klopp / Mariella Losito /
Monique Pütz / Serge Rabiller / Claude Weibel / Akro WELTER
Paul ZENS
5, rue JP Sauvage L-2514 Luxembourg
et tous ceux qui adhéreront par la suite est constitué une association sans but lucratif dont les statuts sont arrêtés
comme suit:
"Association des Parents d'Elèves du Sports-Etudes"
(A.P.E.S.E.)
Association sans but lucratif
Siège social: 66, route de Trêves L- 2630 LUXEMBOURG
<i>Le Receveuri>
(signé): Guy REULAND.
Référence de publication: 2009137436/9498/122.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07874. - Reçu 324,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090166767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2009.
Lauro 28 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 137.434.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009142465/12.
(090172015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Famility S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 125.902.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009142479/10.
(090172349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Falcon Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 66.913.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009142473/12.
(090172119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110994
SIFC Development Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: KRW 51.000.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 110.942.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009142474/13.
(090172112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Portunato Marine Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 139.286.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2009.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009142461/12.
(090171925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
Golding Investments IV TF2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 149.046.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundneun, am achtundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg (Luxemburg)
ist erschienen:
Die Gesellschaft Golding Mezzanine SICAV IV, mit Sitz in 1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher
Vollmacht, ausgestellt am 8. September 2009.
Die Vollmacht nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar bleibt
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründet, wie
folgt zu beurkunden.
I. Name, Sitz, Zweck und Dauer
Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen "Golding In-
vestments IV TF2 S.A.".
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss
des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland gegründet werden.
Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-
tigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert
wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden.
Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form in anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften sowie jede andere Art von Investierung, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder jede andere
110995
Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder jede andere Weise von Wertpapieren jeder Art, sowie die Verwal-
tung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und der Entwicklung von in- und ausländischen Handels-, Industrie- oder
Finanzgesellschaften beteiligen und sie kann diesen Gesellschaften jede Art von Beistand leisten, sei es in der Form von
Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise.
Die Gesellschaft kann Anleihen in jedwelcher Form aufnehmen, Schuldverschreibungen ausgeben und Sicherheiten
bestellen.
Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Industrie- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten
ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet.
II. Aktienkapital
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000.-). Es ist in dreihundertzehn
(310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100.-) eingeteilt und in voller Höhe einbezahlt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-
ralversammlung, welcher in derselben Form wie für Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesell-
schaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ("Gesetz von 1915") und zu den darin festgelegten
Bedingungen eigene Aktien erwerben.
Art. 6. Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.
Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Das Eigentum an
Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.
Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein,
müssen diejenigen die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie
bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen
solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.
III. Verwaltungsrat
Art. 7. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesell-
schaft sein müssen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen,
welche nicht durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten
sind.
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung
je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.
Art. 9. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können
an die in Artikel 60 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Personen übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung,
Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.
Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsrats-
mitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und deren Zeichnungsberechtigung regeln. Er setzt
die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.
Art. 10. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauereines oder
mehrerer Jahre bestellt.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Ver-
waltungsräte bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei
gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl
von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und
ohne Angabe von Gründen abberufen.
Art. 11. Der Verwaltungsrat wird aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere
stellvertretende Vorsitzende bestellen.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden Vor-
sitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zumin-
dest 14 Tage vor der Sitzung zu erfolgen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung
110996
vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche
Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und
an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.
Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu bestim-
menden Ort statt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein anderes
Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich durch
Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungs-
ratsmitglieder gleichzeitig vertreten.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenz-
schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden
oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.
Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig durch
Brief, Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnete Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem
Verwaltungsratsmitglied schriftlich, durch Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel gebilligt werden. Eine sol-
che Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und die Bestätigung wird dem Beschlussprotokoll beizufügen sein.
IV. Überwachung
Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre
der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung fest.
Art. 13. Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesell-
schaft. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die sonstigen
Geschäftsunterlagen der Gesellschaft.
Sie berichten der Generalversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht geeignete
Vorschläge.
Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung bestellt die Rechnungsprüfer für die Dauer eines oder mehrerer Jahre.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, die sie bestellt
und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.
Die Wiederwahl der Rechnungsprüfer, ist zulässig. Sie können jederzeit durch die Generalversammlung ohne Angabe
von Gründen abberufen werden.
V. Generalversammlung der Aktionäre
Art. 15. Die ordnungsmäßig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft.
Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche
wenigstens 1/10 des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.
Art. 16. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung
bestimmten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils um 13.30 Uhr am zweiten Mittwoch des Monats April
eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Tag fällt, der in Luxemburg nicht Bankarbeitstag ist, am nächsten
darauffolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.
Art. 17. Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder außerhalb
des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.
Art. 18. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer einberufen. Sie muss
binnen einer Frist von 15 Tagen einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten,
den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer hierzu schriftlich unter Angabe der Tagesordnung auffordern.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer General-
versammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten.
Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein
stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung
bestimmte Person.
110997
Art. 19. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschrif-
tiicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen ge-
fasst, sofern die Vorschriften des Gesetzes von 1915 keine anderweitigen Bestimmungen treffen. Über die Verhandlungen
und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die vom jeweiligen Vorsitzenden unterzeichnet
werden.
VI. Rechnungslegung
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung
auf. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds so lange zuge-
führt bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.
Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Ge-
winn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Rechnungsprüfern vor,
die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.
Die Generalversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und bestimmt über
die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 aus den verteilungs-
fähigen Gewinnen und Reserven die Ausschüttung einer Dividende beschließen.
Gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes von 1915 ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden als Abschlag auf die
zu erwartende Dividendenberechtigung am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.
VII. Auflösung der Gesellschaft
Art. 22. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.
VIII. Schlussbestimmungen
Art. 23. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere das Gesetz von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2010 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklärt die Erschienene, die dreihundertzehn (310) Aktien wie folgt zu zeichnen:
Golding Mezzanine SICAV IV, vorgenannt; dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Gesamtes Aktienkapital: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Sämtliche Aktien wurden voll und bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000.-) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes von 1915
erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründerin schätzt die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-
dung erwachsen, auf ungefähr EUR 1.200,-.
<i>Generalversammlungi>
Die vorbezeichnete Partei, welche die Gesamtheit des übernommenen Grundkapitals vertritt und sich als ordnungs-
gemäß einberufen betrachtet, hat unmittelbar folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer auf einen.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Jan-Hendrik Bornemann, Produkt Management, HSH Asset Management S.A., beruflich ansässig in Kuterstrasse 8-12,
D-24103 Kiel
- Markus Gierke, Managing Director der LRI Invest S.A., Luxembourg, geboren am 13. Juli 1968 in Saarburg, beruflich
ansässig in 1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
110998
- Harald Strelen, HSH Nordbank Securities S.A., geboren am 1. Februar 1974 in Oldenburg, beruflich ansässig in 2, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
- Silvan Trachsler, Managing Director, Golding Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l., geboren am 23. März 1954 in
Basel, Schweiz, beruflich ansässig in 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
Harald Strelen wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
3.- Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg.
4.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
5.- Die Aufträge der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 20143
befindet. Der Auftrag des Rechnungsprüfers endet mit der Generalversammlung des Geschäftsjahres 2010.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: N. SCHMIDT-TROJE - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 octobre 2009. Relation: LAC/2009/40988. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Franck SCHNEIDER.
FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations erteilt.
Luxemburg, den neunundzwanzigsten Oktober zweitausendneun.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009142448/212.
(090172182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
CMS Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 81.525.
Une liste des fondés de pouvoirs de la Société CMS Management Services S.A. en fonction au 2 novembre 2009 a été
déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CMS Management Services S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009142491/12.
(090172624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
EASA, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 24.158.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 6 mai 2009i>
(...)
"... Par ailleurs, le mandat d'administrateur de Monsieur José Manuel Martinez Serrano vient à échéance à l'issue de la
présente assemblée. L'assemblée décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2012, statuant sur les comptes de l'exercice 2011. Cette résolution est adoptée à
l'unanimité des voix."
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Karin DUBOIS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009142498/16.
(090171991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
110999
C.A.S. Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 68.168.
Une liste des fondés de pouvoirs de la Société CAS Services S.A. en fonction au 2 novembre 2009 a été déposée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CAS Services S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009142492/12.
(090172626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
BNP Paribas Real Estate Advisory & Property Management Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 38.058.
Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142595/10.
(090171986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2009.
FDS Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 72.425.
L'an deux mille neuf, le treize octobre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée FDS GROUP
S.A., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 72.425,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 13 du 5 janvier 2000, et dont les statuts ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 15 décembre 2006, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2420 du 28 décembre 2006.
L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant profes-
sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'assemblée appelle à la fonction de scrutatrice Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant profession-
nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l'enregistrement.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion de la totalité des 680.986 actions privilégiées sans droit de vote portant les n° 454.012 à 794.504 et les
n° 907.993 à 1.248.485 en actions ordinaires, chaque actionnaire recevant 1 action ordinaire pour 1 action privilégiée
convertie.
2. Modification des 1
e
r
et 4
ème
alinéas de l'article 5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa. "Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 13.619.730 (treize millions six cent dix-neuf mille
sept cent trente euros) représenté par 1.361.973 (un million trois cent soixante et une mille neuf cent soixante-treize)
actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune."
111000
Art. 5. 4
ème
alinéa. "Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 137.000.000 (cent
trente-sept millions d'euros) qui sera représenté par 13.700.000 (treize millions sept cent mille) actions d'une valeur
nominale de EUR 10 (dix euros) chacune."
3. Modification de la première phrase de l'article 17 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"Chaque action donne droit à une voix."
4. Modification de l'article 19 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélè-
vement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit."
5. Suppression du 3
ème
alinéa de l'article 20 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les
modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération."
II.- Que le capital social de la société s'élève à EUR 13.619.730 (treize millions six cent dix-neuf mille sept cent trente
euros) représenté par 680.987 (six cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-sept) actions ordinaires et 680.986 (six
cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-six) actions privilégiées sans droit de vote.
III.- Que dans le cadre de la présente assemblée générale extraordinaire les 680.986 actions privilégiées sans droit de
vote disposent d'un droit de vote conformément à l'article 46 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée.
IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
V.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 680.987 actions ordinaires et les 680.986 actions privilégiées
sans droit de vote représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,
les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité des voix dans chaque catégorie
d'actions les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de convertir la totalité des 680.986 actions privilégiées sans droit de vote portant les n°
454.012 à 794.504 et les n° 907.993 à 1.248.485 en actions ordinaires, chaque actionnaire reçevant 1 action ordinaire
pour 1 action privilégiée convertie.
L'assemblée décide que les détenteurs d'actions privilégiés bénéficieront des droits acquis jusqu'à la date de signature
du présent acte en leur qualité de porteurs d'actions privilégiées.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale, suite à la résolution qui précède, decide de modifier le 1
er
et le 4
ème
alinéa de l'article 5 des
statuts, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa. "Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 13.619.730 (treize millions six cent dix-neuf mille
sept cent trente euros) représenté par 1.361.973 (un million trois cent soixante et une mille neuf cent soixante-treize)
actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune."
Art. 5. 4
ème
alinéa. "Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 137.000.000 (cent
trente-sept millions d'euros) qui sera représenté par 13.700.000 (treize millions sept cent mille) actions d'une valeur
nominale de EUR 10 (dix euros) chacune."
111001
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la 1
ère
phrase de l'article 17 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle
suivante:
"Chaque action donne droit à une voix."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
"Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélè-
vement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit."
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer le 3
ème
alinéa de l'article 20 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur
suivante:
"La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les
modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à approximativement EUR 1.300,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. M. TONELLI, E. DUBLET, V. BARAVINI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 22 octobre 2009, LAC/2009/44315: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2009.
Jacques DELVAUX.
Référence de publication: 2009142948/119.
(090172771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Swisstar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 55.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142882/10.
(090173141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Savacom, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 59.267.
DISSOLUTION
L'an deux mille neuf, le cinq novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
111002
A comparu:
La société SIMAC TRADING, établie et ayant son siège social à Butterfield House, P.O. Box 219, George Town, Grand
Cayman, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Pascale TROQUET, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxem-
bourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Berne le 6 juillet 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- qu'elle est le seul et unique actionnaire de la société anonyme dénommée "SAVACOM", établie et ayant son siège
social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sous le numéro B 59.267, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 25 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 452 du 20 août 1997;
- Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE US DOLLARS ($ 2.500.000,-), représenté par DEUX
MILLE CINQ CENTS (2.500) actions d'une valeur nominale de MILLE US DOLLARS ($ 1.000,-) chacune;
- Le mandant a acquis toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société;
- Le mandant détenant toutes les actions de la société a déclaré au notaire instrumentant qu'il a décidé irrévocablement:
- de dissoudre et de mettre la société en liquidation avec effet immédiat;
- de désigner le mandant comme liquidateur;
- Le mandant, en sa capacité de liquidateur de la société, déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les
passifs de la société en liquidation ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, qu'en conséquence l'activité de
liquidation a été terminée, et que tous les actifs restant sont devenus la propriété de l'actionnaire unique, lequel est investi
ainsi de tout l'actif.
- Le mandant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement
inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement l'obligation de
payer tous ces passifs éventuels actuellement inconnus.
- En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la société a pris fin, est déclarée clôturée, la société ayant disparu
et cessé d'exister.
- Comme conséquence de ce qui précède, les titres au porteur représentant le capital social de la société ont été
annulés en présence du notaire instrumentant.
- Les livres et documents de la société seront conservés au L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt pendant
cinq ans. Pour les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: P. Troquet, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 6 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13401. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie BOIÇA.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2009.
Blanche MOUTRIER.
Référence de publication: 2009143455/51.
(090173504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2009.
Pro-Audio Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 136.817.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142883/10.
(090173138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
111003
Swisstar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 55.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142880/10.
(090173143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Aluco S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg.
R.C.S. Luxembourg B 10.459.
Le bilan arrêté au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 5 novembre 2009.
<i>Pour ALUCO S.A.
i>Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman
Référence de publication: 2009142775/13.
(090172813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Akakus Oil Operations SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 147.563.
COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER
of the management boards of
AKAKUS OIL OPERATIONS B.V.
and
AKAKUS OIL OPERATIONS S.A.
<i>Draft terms of Cross-Border Mergeri>
The management boards of:
1. Akakus Oil Operations B.V., a private company with limited liability under Dutch law (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid), having its official seat in 's-Gravenhage, the Netherlands and its office address at Koningskade
30, 2596 AA 's-Gravenhage, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under
number 27355032 (the "Acquiring Company"); and
2. Akakus Oil Operations S.A., a public limited liability company (société anonyme) under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at Avenue de la Liberté, 13-15, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Register of Commerce of Luxembourg under number B 147.563 (the "Company Ceasing to Exist"
and together with the Acquiring Company, the "Merging Companies").
Whereas:
(i) the Acquiring Company is the holder of the entire issued (and paid up) share capital of the Company Ceasing to
Exist;
(ii) the Company Ceasing to Exist has a branch duly registered in Libya (the "Libyan Branch");
(iii) none of the Merging Companies have a supervisory board;
(iv) the Merging Companies have not been dissolved or declared bankrupt, nor has a suspension of payment been
declared with respect to the Merging Companies;
(v) none of the Merging Companies have a works council or a trade union that has amongst its members employees
of one of the Merging Companies or any of their subsidiaries.
propose a cross-border merger within the meaning of the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of
the Council of the European Union of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies and the
relevant local laws applicable to the Merging Companies as a result of which merger:
- the Company Ceasing to Exist will cease to exist; and
111004
- the Acquiring Company will acquire all the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist by way of universal
transfer with the Acquiring Company.
The data to be mentioned pursuant to Sections 2:312 paragraph 2 and 2:333d of the Dutch Civil Code and article 261
of the law of August 10, 1915 as amended (the "Luxembourg Law") are as follows:
a. Type of legal entity, name and official seat/registered office of the Merging Companies.
(i) The private company with limited liability Akakus Oil Operations B.V., under the laws of the Netherlands, having
its official seat in 's-Gravenhage, the Netherlands.
(ii) The public limited liability company (société anonyme) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg Akakus
Oil Operations S.A., with its registered office at Avenue de la Liberté, 13-15, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
b. Articles of association of the Acquiring Company.
The articles of association of the Acquiring Company shall not be amended in connection with the merger.
The articles of association of the Acquiring Company were drawn up by deed of incorporation executed on the thirtieth
day of September two thousand nine before G.C. van Eck, civil law notary in Rotterdam, the Netherlands. The consecutive
wording of the current articles of association of the Acquiring Company is attached to these draft terms of cross-border
merger as Annex A.
c. Rights and compensations at the expense of the Acquiring Company granted pursuant to article 261 (2) f) of the
Luxembourg Law.
As there are no persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights against the Company
Ceasing to Exist, no special rights and no compensations will be granted at the expense of the Acquiring Company to
anyone.
d. Benefits to be granted to a member of the management board of the Merging Companies or to another party
involved with the merger, in connection with the merger pursuant to article 261 (2) g) of the Luxembourg Law.
None.
e. Intentions with regard to the composition of the management board of the Acquiring Company after the cross-
border merger.
There is no intention to change the composition of the management board after the cross-border merger.
The present composition is as follows:
Management board:
- Mr Álvaro Racero Baena;
- Mr Abulkasim M. Zwary; and
- Mr Naim K. Gheriani
f. Date per which the financial data of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of
the Acquiring Company pursuant to article 261 (2) e) of the Luxembourg Law.
The financial data of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of the Acquiring
Company as per 30 September 2009. The last financial year of the Company Ceasing to Exist will therefore end on 29
September 2009.
g. Proposed measures in connection with the allotment of shares.
In this cross-border merger of a parent company with its 100% subsidiary, there is no allotment of shares in the
Acquiring Company.
h. Contemplated continuation or termination of activities.
The activities of the Company Ceasing to Exist will be continued by the Acquiring Company, including the activity of
the Libyan Branch. For the avoidance of doubt, this cross border merger will not imply or provoke any termination of
activity of the Merging Companies and the Libyan Branch.
i. Corporate approvals to effect the cross-border merger in conformity with the draft terms of cross-border merger.
The resolution to effect the cross-border merger in conformity with the common draft terms of cross-border merger
is neither subject to the approval of a company body of the Merging Companies nor of any third party.
j. Effects of the merger on the goodwill and the distributable reserves of the Acquiring Company.
The effects of the cross-border merger on the goodwill will be as follows: None.
The effects of the cross-border merger on the distributable reserves:
The distributable reserves reflected in the interim accounts of the Company Ceasing to Exist will be added to the
distributable reserves of the Acquiring Company.
k. Likely effects on employment.
The cross-border merger is not expected to have any material effect on employment because the activities of the
Company Ceasing to Exist will be continued by the Acquiring Company.
l. Procedures for employee participation.
111005
As:
(i) none of the Merging Companies has, in the six months before the filling of the subject terms of merger, an average
number of more than five hundred (500) employees on which regulations dealing with employee participation are appli-
cable according to the laws of a member state of the European Union; and
(ii) none of the Merging Companies is subject to regulations dealing with employee participation;
no employee participation arrangements as referred to in Section 2:333k of the Dutch Civil Code in conjunction with
Section 16, paragraph 2 through 4 of the directive have to be made by the Acquiring Company.
m. Information on the valuation of assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring
Company pursuant to article 261 (4) d)
The valuation of the relevant assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring
Company was lastly done on 30 September 2009 on the basis of "net asset value"
n. Date of the most recently adopted annual accounts or interim financial statements.
The date of the most recently adopted annual accounts of the Merging Companies' accounts used to establish the
conditions of the cross-border merger is:
Acquiring Company:
Since the Acquiring Company has been incorporated on 30 September 2009 and the first financial year of the Acquiring
Company will end on 31 December 2009 this item is not applicable.
Company Ceasing to Exist:
30 September 2009
o. Proposal for the level of compensation of shareholders.
No cash compensation for shareholders that vote against the proposal to effectuate the cross-border merger is pro-
posed, as the sole shareholder of the Company Ceasing to Exist is the Acquiring Company which will not vote against
the cross-border merger and which, furthermore, waived the offer of a cash compensation.
p. Annexes.
Annexes to these draft terms form an integrated part of this proposal.
<i>Projet de Fusion Transfrontalièrei>
Les conseils d'administration de:
1. Akakus Oil Operations B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid) de droit néerlandais, ayant son siège officiel à 's-Gravenhage, les Pays-Bas et son adresse à Koningskade 30, 2596
AA 's- Gravenhage, les Pays-Bas, immatriculée au Registre de Commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro
27355032 (la "Société Absorbante") ; et
2. Akakus Oil Operations S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13 - 15, Avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 147.563 (la "Société qui Cesse d'Exister" et ensemble avec la Société Absorbante, les
"Sociétés qui Fusionnent") ;
Considérant que:
(i) La Société Absorbante est le détenteur de l'intégralité du capital social émis (et libéré) de la Société qui Cesse
d'Exister;
(ii) La Société qui Cesse d'Exister a une succursale dûment enregistrée en Libye (la "Succursale Libyenne") ;
(iii) Aucune des Sociétés qui Fusionnent n'a de conseil de surveillance ;
(iv) Les Sociétés qui Fusionnent n'ont pas été dissoutes ou déclarées en faillite, aucun sursis de paiement n'a été déclaré
non plus concernant les Sociétés qui Fusionnent;
(v) Aucune des Sociétés qui Fusionnent n'a de comité d'entreprise ou d'organisation syndicale qui a parmi ses membres
des employés de l'une des Sociétés qui Fusionnent ou de l'une de leurs filiales.
proposent une fusion transfrontalière au sens de la Directive 2005/56/EC du Parlement Européen et du Conseil de
l'Union Européenne du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés à responsabilité limitée et les lois
locales pertinentes applicables aux Sociétés qui Fusionnent, fusion à la suite de laquelle :
- la Société qui Cesse d'Exister n'existera plus ; et
- la Société Absorbante acquerra tous les actifs et passifs de la Société qui Cesse d'Exister par un transfert universel
avec la Société Absorbante.
Les renseignements qui doivent être mentionnés en vertu des Sections 2:312 paragraphe 2 et 2:333d du Code Civil
Néerlandais et de l'article 261 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi Luxembourgeoise") sont les suivants :
a. Type de personne morale, dénomination et siège officiel/social des Sociétés qui Fusionnent.
(i) La société à responsabilité limitée Akakus Oil Operations B.V., de droit néerlandais, ayant son siège officiel à 's-
Gravenhage, les Pays-Bas.
111006
(ii) La société anonyme de droit luxembourgeois Akakus Oil Operations S.A., ayant son siège social au 13 - 15, Avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
b. Statuts de la Société Absorbante.
Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés par l'effet de la fusion. Les statuts de la Société Absorbante
ont été établis par un acte de constitution signé le trente septembre deux mille neuf par-devant G.C. van Eck, notaire de
droit civil à Rotterdam, les Pays-Bas. Le libellé des statuts actuels de la Société Absorbante est annexé en tant qu'Annexe
A au présent projet de fusion transfrontalière.
c. Droits et compensations aux frais de la Société Absorbante accordés en vertu de l'article 261 (2) f) de la Loi
Luxembourgeoise.
Etant donné que personne ne dispose, en tout autre capacité qu'actionnaire, de droits spéciaux contre la Société qui
Cesse d'Exister, aucun droit spécial et aucune compensation ne seront accordés à quiconque aux frais de la Société
Absorbante.
d. Avantages à accorder à un membre du conseil d'administration des Sociétés qui Fusionnent ou à toute autre partie
impliquée dans la fusion, en relation avec la fusion en vertu de l'article 261 (2) g) de la Loi Luxembourgeoise.
Aucun.
e. Intentions concernant la composition du conseil d'administration de la Société Absorbante après la fusion trans-
frontalière.
Il n'y a aucune intention de changer la composition du conseil d'administration après la fusion transfrontalière.
La composition actuelle est la suivante :
Conseil d'Administration :
- M. Álvaro Racero Baena;
- M. Abulkasim M. Zwary; et
- M. Naim K. Gheriani
f. Date à partir de laquelle les données financières de la Société qui Cesse d'Exister seront comptabilisées dans les
comptes annuels de la Société Absorbante en vertu de l'article 261 (2) e) de la Loi Luxembourgeoise.
Les données financières de la Société qui Cesse d'Exister seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société
Absorbante à compter du 30 septembre 2009. Le dernier exercice social de la Société qui Cesse d'Exister prendra donc
fin le 29 septembre 2009.
g. Mesures proposées concernant l'affectation des actions.
Dans le cas d'une fusion transfrontalière d'une société mère avec sa filiale détenue à 100%, il n'y a pas d'affectation des
actions dans la Société Absorbante.
h. Continuation ou cessation envisagée des activités.
Les activités de la Société qui Cesse d'Exister seront poursuivies par la Société Absorbante, y compris l'activité de la
Succursale Libyenne. Pour éviter tout doute, cette fusion transfrontalière n'impliquera ni ne provoquera la fin de l'activité
des Sociétés qui Fusionnent et de la Succursale Libyenne.
i. Approbations d'appliquer la fusion transfrontalière conformément au projet de fusion transfrontalière.
La décision d'appliquer la fusion transfrontalière conformément au projet commun de fusion transfrontalière n'est
soumise ni à l'approbation d'un organe social des Sociétés qui Fusionnent ni de n'importe quel tiers.
j. Effets de la fusion sur le fonds de commerce et les réserves distribuables de la Société Absorbante.
Les effets de la fusion transfrontalière sur le fonds de commerce sont les suivants : Aucun.
Les effets de la fusion transfrontalière sur les réserves distribuables :
Les réserves distribuables reflétées dans les comptes intérimaires de la Société Qui Cesse d'Exister seront ajoutées
aux réserves distribuables de la Société Absorbante.
k. Effets probables sur l'emploi.
La fusion transfrontalière est censée n'exercer aucun effet matériel sur l'emploi dans la mesure où les activités de la
Société qui Cesse d'Exister seront poursuivies par la Société Absorbante.
l. Procédures pour la participation des travailleurs.
Etant donné :
(i) qu'aucune des Sociétés qui Fusionnent a, dans les six mois précédant le dépôt du projet de fusion, un nombre moyen
de plus de cinq cents (500) employés auxquels les règles relatives à la participation des travailleurs s'appliquent selon les
lois d'un Etat membre de l'Union Européenne; et
(ii) qu'aucune des Sociétés qui fusionnent n'est soumise à des règles relatives à la participation des travailleurs;
aucun arrangement de participation des travailleurs comme mentionné à la Section 2:333k du Code Civil Néerlandais
en relation avec la Section 16, paragraphe 2 à 4 de la directive ne doit être pris par la Société Absorbante.
m. Renseignements sur l'évaluation du patrimoine actif et passif de la Société qui Cesse d'Exister à acquérir par la
Société Absorbante en vertu de l'article 261 (4) d)
111007
L'évaluation de l'actif et du passif en question de la Société qui Cesse d'Exister à acquérir par la Société Absorbante a
été effectuée dernièrement le 30 septembre 2009 sur la base de "valeur de l'actif net"
n. Date des comptes annuels récemment adoptés ou des états financiers intérimaires.
La date des comptes annuels les plus récemment adoptés des Sociétés qui Fusionnent utilisés afin d'établir les conditions
de la fusion transfrontalière est :
Société Absorbante :
Etant donné que la Société Absorbante a été constituée le 30 septembre 2009 et que le premier exercice social de la
Société Absorbante prendra fin le 31 décembre 2009, ce point n'est pas applicable.
Société qui Cesse d'Exister :
30 septembre 2009
o. Proposition pour le niveau de compensation des actionnaires.
Aucune soulte en espèces pour les actionnaires qui votent contre la proposition d'appliquer la fusion transfrontalière
n'est proposée, dans la mesure où l'actionnaire unique de la Société qui Cesse d'Exister est la Société Absorbante qui ne
votera pas contre la fusion transfrontalière et qui plus est, a renoncé à la proposition d'une soulte en espèces.
p. Annexes.
Les annexes de ce projet constituent une partie intégrée à cette proposition.
Amsterdam le 20/11/2009.
Akakus Oil Operations B.V.
Management Board, Conseil d'Administration
Álvaro Recero Baena / Mr Naim K. Gheriani / Mr Abulkasim M. Zwary
<i>Director / Director / Director
i>Akakus Oil Operations S.A.
<i>Management Board, Conseil d'Administration
i>Alvaro Recero Baena / Mr Naim K. Gheriani / Mr Abulkasim M. Zwary
<i>Director, Administrateur / Director, Administrateur / Director, Administrateuri>
Annex A: current articles of association Acquiring Company
<i>Oprichting BVi>
<i>('Akakus Oil Operations B.V')i>
Op dertig September tweeduizend negen is voor mij, mr. Gerard Cornelis van Eck, notaris met plaats van vestiging
Rotterdam, verschenen:
mr. Bastiaan Cornelis Cornelisse, geboren te Reimerswaal op veertien oktober negentienhonderd vierenzeventig, met
kantooradres Weena 690, 3012 CN Rotterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
Repsol Exploración Murzuq S.A., een vennootschap naar Spaans recht, statutair gevestigd te Paseo de la Castellana,
280, 28046 Madrid, Spanje en geregistreerd bij het Registro Mercantil de Madrid, Spanje, onder nummer Hoja M-11068,
Tomo 764, Folio 200 (de "oprlchter").
De comparant heeft het volgende verklaard:
de oprichter richt hierbij op een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de "vennootschap"), met de
volgende Statuten:
STATUTEN:
Art. 1. Begripsbepallngen.
1.1 In deze Statuten wordt verstaan onder:
a. een "aandeel":
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen elk aandeel
A als elk aandeel B;
b. een "aandeelhouder":
een houder van één of meer aandelen; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen iedere houder van
aandelen A als iedere houder van aandelen B;
c. de "algemene vergadering":
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders;
d. een "algemene vergadering van aandeelhouders":
een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
e. de "directie":
het bestuur van de vennootschap;
111008
f. een "dochtermaatschappij":
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
g. "schriftelijk":
bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar
bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
h. het "uitkeerbare eigen vermogen":
het deel van hat eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die
krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
i. een "vennootschapsorgaan":
de directie, de algemene vergadering, de Vergadering A of de Vergadering B;
j. de "Vergadering A":
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde houders van aandelen A; en
k. de "Vergadering B":
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde houders van aandelen B.
1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze Statuten, tenzij het tegendeel blijkt.
Art. 2. Naam en zetel.
2.1 De naam van de vennootschap is: Akakus Oil Operations B.V.
2.2 De vennootschap is gevestigd te 's-Gravenhage.
Art. 3. Doel. De vennootschap heeft ten doel:
a. het verlenen van diensten van welke aard dan ook op het gebied van onderzoek, exploitatie, vervoer, opslag, be-
handeling en verkoop van ruw materiaal, meer in het bijzonder van ruwe olie en aanverwante producten, op een
internationale basis;
b. het voeren van een onderneming en het aangaan van overeenkomsten welke nodig zijn om de ontwikkeling van de
vennootschap te stimuleren;
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Art. 4. Maatschappelijk kapitaal.
4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend euro (EUR 18.000,-)
4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in een miljoen acht honderd duizend (1.800.000) aandelen met een no-
minaal bedrag van een eurocent (EUR 0,01) elk, en wel acht honderd twee en tachtig duizend (882.000) aandelen A en
negen honderd achttien duizend (918.000) aandelen B.
4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
Art. 5. Register van aandeelhouders.
5.1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden
opgenomen.
5.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 6. Ultglfte van aandelen.
6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemen vergadering. De algemene vergadering kan
haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.
6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
6.3 ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke
nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de artikelen 6.2,6.3 en 6.4 en met dien verstande dat
houders van aandelen van de uit te geven soort voorrang hebben boven de houders van aandelen van de andere soort.
Eenzelfde voorkeursrecht geldt bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot
uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.
6.5 Het bepaalde in de artikelen 6.1,6.2,6.3 en 6.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot
het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
6.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van
vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
6.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
Art. 7. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.
7.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen,
met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.
111009
7.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten daarvan mag de vennootschap slechts
verstrekken tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.
7.3 De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in artikel 7.2 genoemde
leningen.
7.4 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
7.5 Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap kan geschieden:
a. door intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
b. door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
7.6 Intrekking van alle geplaatste aandelen A is mogelijk, maar alleen met goedkeuring van de Vergadering A en in-
trekking van alle geplaatste aandelen B is mogelijk maar alleen met goedkeuring van de Vergadering B. In geval van
intrekking van alle geplaatste aandelen van een soort wordt op elk aandeel van die soort als terugbetaling een bedrag
gelijk aan het nominale bedrag van een aandeel van die soort uitgekeerd.
7.7 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen, al dan niet met terugbetaling, moet naar evenredigheid op
alle aandelen van dezelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming
van alle betrokken aandeelhouders.
7.8 De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt
gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Hetgeen in deze Statuten is bepaald
terzake van een voorstel tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing.
7.9 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van
de artikelen 2:208 en 2:209 van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 8. Levering van aandelen.
8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van
vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel ver-
bonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar
is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.
Art. 9. Blokkeringsregeling (goedkeuring algemene vergadering).
9.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit
artikel 9 is bepaald, tenzij (i) alle medeaandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht hebben
verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
9.2 Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen (de "verzoeker") behoeft daarvoor de goed-
keuring van de algemene vergadering. Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan door middel van een kennisgeving
gericht aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat de verzoeker wenst over te dragen en de persoon of
personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. De directie is verplicht om ter behandeling van het verzoek tot
goedkeuring een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na
ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld.
9.3 Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, mag de verzoeker tot drie maanden nadien
de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe
in het verzoek om goedkeuring waren genoemd.
9.4 Indien:
a. door de algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen binnen zes weken
nadat het verzoek door de directie is ontvangen; of
b. de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering gelijktijdig met de weigering aan de
verzoeker opgave doet van één of meer personen die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring
betrekking heeft tegen contante betaling te kopen ("gegadlgden"),
wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder a bedoelde geval, op de laatste dag van
de daarin genoemde termijn van zes weken. De vennootschap kan alleen met instemming van de verzoeker als gegadigde
optreden.
9.5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen door de gegadigden worden gekocht
tegen een prijs, die wordt vastgesteld door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg of door één of meer door
hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de
prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te
benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel waarbij de vennootschap is ingeschreven in het Handels-
register. Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de
vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.
111010
9.6 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de
aandelen waarop het verzoek betrekking heeft zij wensen te kopen; een gegadigde van wie deze opgave niet binnen
genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin
kan een gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden.
9.7 De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke
gegadigde of gegadigden hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen
welke prijs.
9.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 9 dienen te worden gedaan bij aangetekende brief of tegen
ontvangstbewijs. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt overeenkomstig hetgeen ter-
zake in deze Statuten is bepaald.
9.9 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun prijsvaststelling komen ten laste van:
a. de verzoeker, indien deze zich terugtrekt;
b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door gegadigden zijn gekocht,
met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.
9.10 De voorgaande leden van dit artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechten tot het nemen
van aandelen en voorkeursrechten.
Art. 10. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.
10.1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en
op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
10.2 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een
aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend.
Art. 11. Certificaten van aandelen. De vennootschap verieent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van
aandelen.
Art. 12. Directeuren.
12.1 De directie bestaat uit een of meer directeuren A en/of een of meer directeuren B. Het aantal directeuren wordt
vastgesteld door de algemene vergadering. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
12.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van ten minste twee personen
voor iedere vacature, op te maken:
a. indien het een directeur A betreft: door de vergadering A; en
b. indien het een directeur B betreft: door de Vergadering B.
12.3 De algemene vergadering is vrij in de benoeming van een directeur indien het vennootschapsorgaan dat ingevolge
artikel 12.2 een voordracht dient op te maken, niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht
heeft opgemaakt.
12.4 Een tijdig door het vennootschapsorgaan dat ingevolge artikel 12.2 een voordracht dient op te maken, opgemaakte
voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen
bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan
de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
16.5 ledere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
12.6 Tot een schorsing of ontslag van een directeur anders dan op voorstel van het vennootschapsorgaan dat ingevolge
artikel 12.2 voor de benoeming van een directeur van die betreffende soort een voordracht dient op te maken, kan de
algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer
dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
12.7 Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden.
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opherfing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de
schorsing.
12.8 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe
aan de algemene vergadering.
Art. 13. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.
13.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
13.2 In de directie heett iedere directeur één stem.
13.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Iedere
directeur A heeft recht op het uitbrengen van evenveel stemmen als er directeuren B aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en omgekeerd. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
13.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits
het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van
111011
besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie
zijnde directeuren.
13.5 Besluiten van de directie worden genoteerd in een notulenboek dat door de directie wordt gehouden.
13.6 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader
kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene
vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taak-
verdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
Art. 14. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.
14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt
mede aan een directeur A en een directeur B, gezamenlijk handelend.
14.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van
hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur
van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het
Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbe-
voegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een
tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren.
14.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het
bepaalde in artikel 14.1 onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aange-
wezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van
de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé
betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
Art. 15. Goedkeuring van directlebesluiten.
15.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze bes-
luiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
15.2 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 15 tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
Art. 16. Ontstentenis of belet.
16.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren tijdelijk met het besturen
van de vennootschap belast mits nog ten aanzien van ten minste één directeur A en één directeur B geen sprake is van
ontstentenis of belet.
16.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren van een bepaalde soort of van de enige directeur van een
bepaalde soort, is de persoon die daartoe door de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort
wordt aangewezen, tezamen met de directeur of directeuren van de andere soort, of tezamen met de persoon die als
tijdelijk bestuurder door de vergadering van houders van aandelen van de andere soort is aangewezen, tijdelijk met het
bestuur van de vennootschap belast.
Art. 17. Boekjaar en jaarrekening.
17.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
17.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste
zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening
op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
17.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396
lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
17.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
17.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen,
dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
17.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot on-
derzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
17.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
17.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde
bestuur.
Art. 18. Winst en uitkeringen.
18.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de algemene
vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt
tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
18.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
111012
18.3 De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen en/of tot het doen
van uitkeringen op aandelen ten laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie kan besluiten tot het doen
van tussentijdse uitkeringen op aandelen.
18.4 Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering, tenzij in het besluit een ander
tijdstip is vastgesteld.
18.5 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen
vermogen.
18.6 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, teilen de aandelen in haar kapitaal die de
vennootschap houdt, niet mee.
Art. 19. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
19.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar.
19.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht.
19.3 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van
de vennootschap hebben het recht aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te
roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot
oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden ge-
houden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
Art. 20. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.
20.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene
vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen worden door aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende ten
minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 19.3.
20.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
20.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn
vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 20.2 bedoelde termijn.
20.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is
verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het ge-
plaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de
overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
20.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals
deze zijn vermeld in net register van aandeelhouders. De aandeelhouder die daarmee instemt, kan in plaats van door een
oproepingsbrief, worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
20.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens
deze Statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan
kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van
de vennootschap vertegenwoordigd is.
Art. 21. Toegang en vergaderrechten.
21.1 ledere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord
te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door
een schriftelijk gevolmachtigde.
21.2 ledere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de
vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering
aanwezig zijn.
21.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.
21.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.
Art. 22. Voorzitter en notulist van de vergadering.
22.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen door de ter vergadering
aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd,
treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste
ter vergadering aanwezige persoon.
22.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
Art. 23. Notulen, aantekening van aandeelhoudersbesluiten.
23.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist
van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke
daarvan door hen ondertekend.
111013
23.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet
ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschritt van de ge-
nomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore
van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel
uit de aantekeningen verstrekt.
Art. 24. Besluitvorming in vergadering.
24.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
24.2 Voor zover de wet of deze Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
24.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
24.4 Indien de door de wet of deze Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene
vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de
algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd
en met algemene stemmen.
24.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de
vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden
uitgebracht.
Art. 25. Besluitvorming buiten vergadering.
25.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering van aandeelhouders ook
schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in
artikel 21.3 is van overeenkomstige toepassing.
25.2 ledere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk
schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt
deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 23.2.
Art. 26. Besluitvorming door de Vergadering A en de Vergadering B.
26.1 Besluiten van de Vergadering A kunnen worden genomen in een vergadering van houders van aandelen A en
besluiten van de Vergadering B kunnen worden genomen in een vergadering van houders van aandelen B.
26.2 Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls de directie dat
nodig acht. Houders van aandelen van de betreffende soort, hebben het recht aan de directie te verzoeken een vergadering
van houders van aandelen van die soort bijeen te roepen. Het recht komt niet toe aan andere aandeelhouders.
26.3 Hetgeen in deze Statuten is bepaald omtrent algemene vergaderingen van aandeelhouders is van overeenkomstige
toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort, voor zover in artikel 26.2 geen afwijkende
regeling is getroffen en met dien verstande dat de betreffende vergadering steeds zelf een voorzitter aanwijst. Het bepaalde
in artikel 25 is eveneens van overeenkomstige toepassing.
26.4 Indien en voor zolang geen aandelen A dan wel aandelen B geplaatst zijn, of alle geplaatste aandelen A dan wel
alle geplaatste aandelen B worden gehouden door de vennootschap, komen alle bevoegdheden die deze Statuten toe-
kennen aan de Vergadering A, dan wel de Vergadering B, toe aan de algemene vergadering.
Art. 27. Statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd deze Statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene
vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot
de vergadering worden vermeld.
Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten
kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
Art. 28. Ontbinding en vereffening.
28.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt
gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
28.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren
vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen
tot vereffenaars te benoemen.
28.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zo veel mogelijk van kracht.
28.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen
aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
28.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk
Wetboek.
Art. 29. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig december tweeduizend negen. Dit artikel
vervalt na afloop van het eerste boekjaar.
111014
Slotbepalingen.
Op rechtshandelingen van de vennootschap
a. strekkende tot het verkrijgen van goederen die een jaar voor oprichting van de vennootschap of nadien toebe-
hoorden aan de oprichter of een aandeelhouder van de vennootschap; en
b. die worden verricht voordat twee jaren zijn verstreken na de inschrijving van de vennootschap in het Handelsregister,
is van toepassing het bepaalde in artikel 2:204c van het Burgerlijk Wetboek.
Ten slotte heeft de comparant verklaard:
a. het bij oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend euro (EUR 18.000,--) en is
verdeeld in een miljoen acht honderd duizend (1.800.000) aandelen met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR
0,01) elk (de "geplaatste aandelen") en wel acht honderd twee en tachtig duizend (882.000) aandelen A en negen honderd
achttien duizend (918.000) aandelen B, genummerd A1 tot en met A882.000 en B1 tot en met B918.000.
Alle geplaatste aandelen worden hierbij genomen door de oprichter.
De geplaatste aandelen worden a pari geplaatst.
De geplaatste aandelen zijn in geld volgestort. Storting in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de
stukken waarvan artikel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft (Bijlage). De vennootschap aanvaardt
hierbij de Stortingen op de geplaatste aandelen.
b. voor de eerste maal wordt tot directeur A van de vennootschap benoemd:
de beer José Mariá Perez Garrldo, wonende te Frederikstraat 673, 2514 LT 's-Gravenhage, geboren te Madrid, Spanje,
op vijf en twintig juli negentienhonderd zeven en vijftig.
Verklaring van geen bezwaar.
Terzake van deze oprichting is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op vier en twintig september
tweeduizend negen, onder nummer B.V. 1567665, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van
Justitie die aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage).
Volmacht.
Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht, welke in kopie aan deze akte zal
worden gehecht (Bijlage).
Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de
inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daana door mij, notaris, ondertekend.
(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
mr. G.C. van ECK
<i>Notaris te Rotterdami>
NOTE ABOUT TRANSLATION:
This document is an English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has
been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. Inevitably, however,
differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law.
In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The
concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood
under the laws of other jurisdictions.
<i>Incorporationi>
<i>('Akakus Oil Operations B.V.')i>
This thirtieth day of September two thousand nine, there appeared before me, Gerard Cornelis van Eck, civil law
notary in Rotterdam, the Netherlands:
Bastiaan Cornelis Cornelisse, born in Reimerswaal, the Netherlands, on the fourteenth day of October nineteen
hundred and seventy-four, employed at Weena 690, 3012 CN Rotterdam, the Netherlands, for the purposes hereof
acting as attorney - duly authorized in writing - of:
Repsol Exploración Murzuq S.A., a limited liability company under the laws of Spain, with its official seat at Paseo de
la Castellana, 280, 28046 Madrid, Spain, registered with the Registro Mercantil de Madrid under number Hoja M-11068,
Tomo 764, Folio 200 (the "Incorporator").
111015
The person appearing declared the following:
the Incorporator hereby incorporates a private limited liability company under Dutch law ('besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid') (the "Company"), with the following Articles of Association:
ARTICLES OF ASSOCIATION:
Art. 1. Definitions.
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
a. a "Share":
a share in the capital of the Company, unless the contrary is apparent, this shall include each Share A and each Share
B;
b. a "Shareholder":
a holder of one or more Shares, unless the contrary is apparent, this shall include each holder of Shares A and each
holder of Shares B;
c. the "Shareholders' Body":
the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote;
d a "General Meeting of Shareholders":
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;
e. the "Management Board":
the management board of the Company;
f. a "Subsidiary":
a subsidiary of the Company as referred to in Section 2:24a of the Dutch Civil Code;
g. "in writing":
by letter, by telecopier, by e-mail, or by a legible and reproducible message otherwise electronically sent, provided
that the identity of the sender can be sufficiently established;
h. the "Distributable Equity":
the part of the Company's equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must be
maintained pursuant to the law;
i. a "Company Body":
the Management Board, the Shareholders' Body, the Class A Meeting or the Class B Meeting;
j. the "Class A Meeting":
the Company Body consisting of holders of Shares A entitled to vote; and
k. the "Class B Meeting":
the Company Body consisting of holders of Shares B entitled to vote.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is
apparent.
Art. 2. Name and Official Seat.
2.1 The Company's name is: Akakus Oil Operations B.V.
2.2 The official seat of the Company is in 's-Gravenhage, the Netherlands.
Art. 3. Objects. The objects of the Company are:
a. to render services of any kind in the area of exploration, exploitation, transportation, storage, treatment and sale
of raw materials, in particular of crude oil and related products, on an international basis;
b. to perform such business and enter into such agreements as may be suitable to promote the development of the
company,
and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.
Art. 4. Authorized Capital.
4.1 The authorized capital of the Company equals eighteen thousand euro (EUR 18,000.)
4.2 The authorized capital of the Company is divided into one million eight hundred thousand (1,800,000) Shares with
a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, of which eight hundred eighty-two thousand (882,000) are Shares A
and nine hundred eighteen thousand (918,000) are Shares B.
4.3 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.
Art. 5. Register of Shareholders.
5.1 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders
are recorded.
5.2 Section 2:194 of the Dutch Civil Code applies to the register of Shareholders.
111016
Art. 6. Issuance of Shares.
6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the Shareholders' Body. The Shareholders' Body may transfer
this authority to another Company Body and may also revoke such transfer.
6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
6.3 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal
value of his Shares, subject to the provisions of Articles 6.4 and provided that holders of Shares of the class that is to be
issued shall have preference over holders of Shares of the other class. Shareholders shall have a similar right of pre-
emption if rights are granted to subscribe for shares.
6.4 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the Company Body
competent to issue such Shares.
6.5 The provisions of Articles 6.1, 6.2, 6.3 and 6.4 shall apply by analogy to the granting of rights to subscribe for Shares,
but do not apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.
6.6 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law
notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.
6.7 The full nominal value of each Share must be paid upon issuance.
Art. 7. Own shares, Reduction of the Issued Capital.
7.1 The Company and its subsidiaries may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due obser-
vance of the limitations prescribed by law.
7.2 The Company may grant loans with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or depositary receipts
thereof, but not in excess of the amount of the Distributable Equity.
7.3 The Company shall maintain a non-distributable reserve up to the outstanding amount of the loans referred to in
Article 7.2.
7.4 The Shareholders' Body may resolve to reduce the Company's issued capital.
7.5 A reduction of the Company's issued capital may be effected:
a. by cancellation of Shares held by the Company or for which the Company holds the depositary receipts; or
b. by reducing the nominal value of Shares, to be effected by an amendment of these Articles of Association.
7.6 Cancellation of all issued Shares A shall be possible, but with the approval of the Class A Meeting only and can-
cellation of all issued Shares B shall be possible, but with the approval of the Class B Meeting only.
If all issued Shares of a class are cancelled, an amount equal to the nominal value of such Share will be paid on each
Share of such class as repayment.
7.7 A reduction of the nominal value of Shares, with or without repayment, must be effected in proportion to all Shares
of the same class. This principle may be deviated from with the consent of all Shareholders involved.
7.8 The notice of a General Meeting of Shareholders at which a resolution to reduce the Company's issued capital
shall be proposed, shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved. The
provisions in these Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by
analogy.
7.9 A reduction of the Company's issued capital shall furthermore be subject to the provisions of Sections 2:208 and
2:209 of the Dutch Civil Code.
Art. 8. Transfer of Shares.
8.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary
registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.
8.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after
the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant
provisions of the law.
Art. 9. Blocking Clause (approval Shareholders' Body).
9.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article
9, unless (i) all co-Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a
period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by law to transfer his Shares to a former Shareholder.
9.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (hereinafter the "Applicant") shall require the approval
of the Shareholders' Body for such transfer. The request for approval shall be made by the Applicant by means of a written
notification to the Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer and the person or persons to
whom the Applicant wishes to transfer such Shares. The Management Board shall be obliged to convene and to hold a
General Meeting of Shareholders to discuss the request for approval within six weeks from the date of receipt of the
request. The contents of such request shall be stated in the convocation.
111017
9.3 Within a period of three months of the Shareholders' Body granting the approval requested, the Applicant may
transfer the total number of the Shares to which the request relates, and not part thereof, to the person or persons
named in the request.
9.4 If:
a. the Shareholders' Body does not adopt a resolution regarding the request for approval within six weeks after the
request has been received by the Management Board; or
b. the approval has been refused without the Shareholders' Body having informed the Applicant, at the same time as
the refusal, of one or more interested parties who are prepared to purchase all the Shares to which the request for
approval relates for payment in cash (hereinafter: "Interested Parties"),
the approval requested shall be considered to have been granted, in the event mentioned under a on the final day of
the six week period mentioned under a.
The Company shall only be entitled to act as an Interested Party with the consent of the Applicant.
9.5 The Shares to which the request for approval relates can be purchased by the Interested Parties at a price to be
mutually agreed between the Applicant and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they
do not reach agreement on the price or the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more
independent experts to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the
Chamber of Commerce at which the Company is registered in the Commercial Register. If an expert is appointed, he
shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to obtain all such information as will be useful
to him in setting the price.
9.6 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of the
number of the Shares to which the request for approval relates they wish to purchase. An Interested Party who fails to
submit notice within said term shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the
preceding sentence has been given, an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.
9.7 The Applicant may withdraw up to one month after the day on which he is informed to which Interested Party or
Parties he can sell all the Shares to which the request for approval relates and at what price.
9.8 All notifications and notices referred to in this Article 9 shall be made by certified mail or against acknowledgement
of receipt. The convocation of the General Meeting of Shareholders shall be made in accordance with the relevant
provisions of these Articles of Association.
9.9 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price,
shall be borne by:
a. the Applicant if he withdraws;
b. the Applicant and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties,
provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased;
c. the Company, in cases not provided for under a or b.
9.10 The preceding provisions of this Article 9 shall apply by analogy to rights to subscribe for Shares and rights of
pre-emption.
Art. 10. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.
10.1 The provisions of Article 8 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a
usufruct in Shares.
10.2 On the creation of a right of pledge in a Share and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting
rights attributable to such Share may not be assigned to the pledgee or the usufructuary.
Art. 11. Depositary Receipts for Shares. The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for
Shares.
Art. 12. Management Board Members.
12.1 The Management Board shall consist of one or more members A and/or one or more members B. The number
of Management Board members shall be determined by the Shareholders' Body.
Both individuals and legal entities can be Management Board members.
12.2 Management Board members are appointed by the Shareholders' Body from a list of nominees, containing the
names of at least two persons for each vacancy, to be drawn up by:
a. if a Management Board member A is concerned: the Class A Meeting; and
b. if a Management Board member B is concerned: the Class B Meeting.
12.3 If the Company Body that is to draw up a nomination pursuant to Article 12.2, should fail to draw up a list of
nominees within three months after the vacancy has occurred, the Shareholders' Body may appoint a member of the
Management Board at its own discretion.
12.4 A list of nominees drawn up in time by the Company Body that is to draw up a nomination for the appointment
of a Management Board member pursuant to Article 12.2. shall be binding. However, the Shareholders' Body may at all
111018
times deprive the list of nominees of its binding character by a resolution adopted with a majority of not less than two
thirds of the votes cast, representing more than half of the issued capital.
12.5 A Management Board member may be suspended or dismissed by the Shareholders' Body at any time.
12.6 A resolution of the Shareholders' Body to suspend or dismiss a Management Board member other than on the
proposal of the Company Body that pursuant to Article 16.2 is to draw up a nomination for the appointment of a
Management Board member of the applicable class, may only be adopted with a majority of two thirds of the votes cast,
representing more than half of the issued capital.
12.7 Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in the aggregate.
If, at the end of that period, no decision has been taken on termination of the suspension or on dismissal, the suspension
shall end.
12.8 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members
is vested in the Shareholders' Body.
Art. 13. Duties, Decision-making process and Allocation of Duties.
13.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
13.2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.
13.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by more than half of the votes cast. Each Management
Board member A is entitled to cast a number of votes that equals as many votes as the number of Management Board
members B present or represented at the meeting and vice versa. If there is a tie in voting, the decision shall be referred
to the Shareholders' Body.
13.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided
the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this
manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Ma-
nagement Board members then in office.
13.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management
Board.
13.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.
In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The Shareholders' Body may decide that such rules and allocation of duties must be put
in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.
Art. 14. Representation, Conflicts of Interest.
14.1 The Company shall be represented by the Management Board. A Management Board member A and a Management
Board member B, acting jointly, shall also be authorized to represent the Company.
14.2 The Management Board may appoint officers with general or limited power to represent the Company. Each
officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board
shall determine each officer's title. Such officers may be registered at the Commercial Register, indicating the scope of
their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not extend to any transaction
where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more Management Board
members.
14.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the
provisions of Article 14.1 shall continue to apply unimpaired unless the Shareholders' Body has appointed one or more
other persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict. A resolution
of the Management Board with respect to a matter involving a conflict of interest with one or more Management Board
members in a private capacity shall be subject to the approval of the Shareholders' Body, but the absence of such approval
shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.
Art. 15. Approval of Management Board Resolutions.
15.1 The Shareholders' Body may require Management Board resolutions to be subject to its approval. The Manage-
ment Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.
15.2 The absence of approval by the Shareholders' Body of a resolution as referred to in this Article 15 shall not affect
the authority of the Management Board or its members to represent the Company.
Art. 16. Vacancy or Inability to Act.
16.1 If a seat is vacant on the Management Board ('ontstentenis') or a Management Board member is unable to perform
his duties ('belet'), the remaining Management Board members shall be temporarily entrusted with the management of
the Company, provided that at least one member A and one member B are not absent or prevented from performing
their duties.
16.2 If all Management Board members or the sole Management Board member of a certain class are absent or
prevented from performing their duties, the person appointed for that purpose by the meeting of holders of Shares of
the applicable class, shall be temporarily entrusted with the management of the Company together with the Management
111019
Board member or Management Board members of the other class, or together with the person appointed by the meeting
of holders of Shares of the other class for the purpose of being temporarily entrusted with the management of the
Company.
Art. 17. Financial Year and Annual accounts.
17.1 The Company's financial year shall be the calendar year.
17.2 Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances
this period is extended by the Shareholders' Body by not more than six months, the Management Board shall prepare
annual accounts and deposit the same for inspection by the Shareholders at the Company's office.
17.3 Within the same period, the Management Board shall also deposit the annual report for inspection by the Sha-
reholders, unless Section 2:396, subsection 6 or Section 2:403 of the Dutch Civil Code applies to the Company.
17.4 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
17.5 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them
is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.
17.6 The Company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such
appointment shall be made by the Shareholders' Body.
17.7 The Shareholders' Body shall adopt the annual accounts.
17.8 The Shareholders' Body may grant full or limited discharge to the Management Board members for the manage-
ment pursued.
Art. 18. Profits and Distributions.
18.1 The allocation of profits accrued in a financial year shall be determined by the Shareholders' Body. If the Share-
holders' Body does not adopt a resolution regarding the allocation of the profits prior to or at latest immediately after
the adoption of the annual accounts, the profits will be reserved.
18.2 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the law given the
contents of the annual accounts.
18.3 The Shareholders' Body may resolve to make interim distributions on Shares and/or to make distributions on
Shares at the expense of any reserve of the Company. In addition, the Management Board may decide to make interim
distributions on Shares.
18.4 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless
another date of payment has been determined in the resolution.
18.5 Distributions on Shares may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distributable
Equity.
18.6 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.
Art. 19. General Meetings of Shareholders.
19.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held within six months after the end of the financial year.
19.2 Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
19.3 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company's issued capital may request the
Management Board to convene a General Meeting of Shareholders, stating specifically the subjects to be discussed. If the
Management Board has not given proper notice of a General Meeting of Shareholders within four weeks following receipt
of such request such that the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be
authorized to convene a meeting themselves.
Art. 20. Notice, Agenda and Venue of Meetings.
20.1 Notice of General Meetings of Shareholders shall be given by the Management Board. Furthermore, notice of
General Meetings of Shareholders may be given by Shareholders representing in the aggregate at least half of the Com-
pany's issued capital, without prejudice to the provisions of Article 19.3.
20.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
20.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such
notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 20.2.
20.4 A subject for discussion of which discussion has been requested in writing not later than thirty days before the
day of the meeting by one or more Shareholders who individually or jointly represent at least one percent of the Com-
pany's issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects for discussion,
provided that no important interest (zwaarwichtig belang) of the Company dictates otherwise.
20.5 The notice of the meeting shall be sent by letters to the addresses of the Shareholders shown in the register of
Shareholders. Instead of through notice letters, any Shareholder that gives his consent, may be sent notice of the meeting
by means of a legible and reproducible message electronically sent to the address stated by him for this purpose to the
company.
111020
20.6 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Association,
the Company has its official seat. General Meetings of Shareholders may also be held elsewhere, but in that case valid
resolutions of the Shareholders' Body may only be adopted if all of the Company's issued capital is represented.
Art. 21. Admittance and Rights at Meetings.
21.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and
to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing.
21.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meeting
may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.
21.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings of Share-
holders.
21.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.
Art. 22. Chairperson and Secretary of the Meeting.
22.1 The chairperson of a General Meeting of Shareholders shall be appointed by more than half of the votes cast by
the persons with voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member
shall act as chairperson, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the
meeting shall act as chairperson.
22.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.
Art. 23. Minutes, Recording of Shareholders' Resolutions.
23.1 The secretary of a General Meeting of Shareholders shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The
minutes shall be adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by
them.
23.2 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the Shareholders' Body. If the Management
Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Management Board is provided
with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall be deposited at the
Company's office for inspection by the Shareholders. On application, each of them shall be provided with a copy of or
an extract from the records.
Art. 24. Adoption of Resolutions in a Meeting.
24.1 Each Share confers the right to cast one vote.
24.2 To the extent that the law or these Articles of Association do not require a qualified majority, all resolutions of
the Shareholders' Body shall be adopted by more than half of the votes cast.
24.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
24.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by law or these
Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the Shareholders' Body may only be adopted
in a meeting, if in such meeting ail of the Company's issued capital is represented and such resolution is carried by
unanimous vote.
24.5 In the Shareholders' Body, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company or a subsidiary,
nor for any Share for which the Company or a subsidiary holds the depositary receipts.
Art. 25. Adoption of Resolutions without holding Meetings.
25.1 Resolutions of the Shareholders' Body may also be adopted in writing without holding a General Meeting of
Shareholders, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provision of
Article 21.3 shall apply by analogy.
25.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon
as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 23.2.
Art. 26. Adoption of Resolutions in Class A Meeting and Class B Meeting.
26.1 Resolutions of the Class A Meeting may be adopted in a meeting of holders of Shares A and resolutions of the
Class B Meeting may be adopted in a meeting of holders of Shares B.
26.2 Meetings of holders of Shares of a certain class are held as often as the Management Board deems such necessary.
Holders of Shares of a specific class may request the Management Board to convene a meeting of holders of Shares of
such class. This right does not accrue to other Shareholders.
26.3 The provisions in these Articles of Association with respect to General Meetings of Shareholders shall apply by
analogy to meetings of holders of Shares of a certain class, to the extent that Article 26.2 does not provide otherwise
and provided that the applicable meeting shall appoint its own chairman.
Also, the provisions of Article 25 shall apply by analogy..
111021
26.4 If and as long as no Shares A or Shares B have been issued or all issued Shares A or all issued Shares B are held
by the Company, all powers vested in the Class A Meeting or the Class B meeting, as the case may be, under these Articles
of Association shall be vested in the Shareholders' Body.
Art. 27. Amendment of the Articles of Association. The Shareholders' Body may resolve to amend these Articles of
Association. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General Meeting of Shareholders,
the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited
and kept available at the Company's office for inspection by the Shareholders, until the conclusion of the meeting.
Art. 28. Dissolution and Liquidation.
28.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the Shareholders' Body. When a proposal
to dissolve the Company is to be made at a General Meeting of Shareholders, this must be stated in the notice of such
meeting.
28.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the Shareholders' Body, the Management Board members
shall become liquidators of the dissolved Company's property. The Shareholders' Body may decide to appoint other
persons as liquidators.
28.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
28.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-
holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.
28.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of Book 2, Title 1, of the Dutch Civil Code.
Art. 29. The first financial year of the Company shall end on the thirty-first day of December two thousand nine. This
article shall cease to exist after the end of the first financial year.
<i>Final provisions.i>
Legal acts of the Company
a. pertaining to the acquisition of assets which were owned by the Incorporator or shareholder of the Company, in
either case within one year prior to incorporation of the Company or thereafter, and
b. which occur within the two-years period following registration of the Company with the Trade Register,
shall be subject to the provisions of Section 2:204c of the Dutch Civil Code.
Finally, the person appearing has declared:
a. At incorporation, the issued capital of the Company equals eighteen thousand euro (EUR 18,000.) and is divided
into one million eight hundred thousand (1,800,000) shares with a nominal value of one eurocent (EUR 0,01) each (the
"Issued Shares") of which eight hundred eighty-two thousand (882,000) are Shares A and nine hundred eighteen thousand
(918,000) are Shares B, numbered A1 through A882,000 and numbered B1 through B918,000. All of the Issued Shares
are hereby subscribed for by the Incorporator.
The Issued Shares are issued at par.
The Issued Shares have been paid for in cash. Payment in foreign currency is permitted. The documents which must
be attached by virtue of Section 2:203a of the Dutch Civil Code have been attached to this deed (Annex). The Company
hereby accepts the payments made for the Issued Shares.
b. The first Management Board member A of the Company is:
Mr. José Mariá Perez Garrido, residing at Frederikstraat 673, 2514 LT 's-Gravenhage, the Netherlands, born in Madrid,
Spain on the twenty-fifth day of July nineteen hundred fifty-seven.
Statement of No Objections.
With respect to the foregoing incorporation, a ministerial Statement of No Objections of the Dutch Ministry of Justice
was granted on the twenty-fourth day of September two thousand nine, under number B.V. 1567665, which is evidenced
by a written statement from the Dutch Ministry of Justice attached to this deed (Annex).
Power of Attorney.
The authorisation granted to the person appearing is evidenced by one (1) private power of attorney which immediately
after the execution will be attached in copy to this deed (Annex).
End.
The person appearing is known to me, civil law notary.
This deed was executed in Rotterdam, the Netherlands, on the date stated in the first paragraph of this deed.
The contents of the deed have been stated and clarified to the person appearing.
The person appearing has declared not to wish the deed to be fully read out, to have noted the contents of the deed
timely before its execution and to agree with the contents.
After limited reading, this deed was signed first by the person appearing and thereafter by me, civil law notary.
111022
<i>Indications complémentaires au projet commun de fusion transfrontalière entre Akakus Oil Operations B.V. et Akakus Oil Operationsi>
<i>S.A. conformément à l'article 262 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commercialesi>
(i) Le projet commun de fusion transfrontalière est déposé par la société absorbante Akakus Oil Operations B.V.
auprès du registre de la chambre de commerce de la Haye aux Pays-Bas {Het handelsregister van de Kamers van Koo-
phandel te Den Haag) et publié dans le bulletin national néerlandais (Staatscourant).
(ii) Les modalités d'exercice des droits des créanciers sont prévus dans les droits nationaux respectifs des sociétés qui
fusionnent comme suit:
a. Akakus Oil Operations B.V.: Section 2:333h à 2:316 du Code Civil Néerlandais; et
b. Akakus Oil Operations S.A.: article 268 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Les créanciers des sociétés qui fusionnent pourront obtenir, sans frais, une information exhaustive sur les modalités
d'exercice de leurs droits à l'adresse suivante: Koningskade 30, 2596 AA 's- Gravenhage, les Pays-Bas.
Référence de publication: 2009146052/1036.
(090180011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2009.
Swisstar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 55.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142881/10.
(090173142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Multibuilding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 71.473.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MULTIBUILDING S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009142899/12.
(090172666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Ranylux, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 27.606.
Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009142908/10.
(090172900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Caryos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.
R.C.S. Luxembourg B 110.154.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
111023
Fiduciaire GSL
37, rue Romain Fandel
L-4149 Esch-sur-Alzette
Signature
Référence de publication: 2009142940/13.
(090173189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Food Service Network S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 107.308.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142906/10.
(090172908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Lisbonne Lux S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.907.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009142907/10.
(090172907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Revesta S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 29.807.
Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009142909/10.
(090172898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
unitedprint S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 131.115.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009142923/10.
(090173349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Fenestratus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 131.100.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009142886/10.
(090173135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
111024
Akakus Oil Operations SA
Alkopharma S.àr.l.
Aluco S.A.
Association des Parents d'Elèves du Sports-Etudes
Barony Holding S.A.
BDO Compagnie Fiduciaire
BNP Paribas Real Estate Advisory & Property Management Luxembourg
Brighton Investments S.A.
CA CRÉE Sàrl
Canton S.A.
Cap Santé 3000
Caryos S.A.
C.A.S. Services S.A.
CMS Management Services S.A.
Delilah Sub Holdings S.à r.l.
EASA
Falcon Invest Sicav
Famility S.A.
FDS Group S.A.
Fenestratus S.A.
Food Service Network S.à r.l.
Garage Toussaint S.à r.l.
Global Palaces Management S.à r.l.
Golding Investments IV TF2 S.A.
Granit Import Système S.à r.l.
HR at Work Consultants Luxembourg
HR at Work Consultants Luxembourg
Hucage S.à r.l.
Immo Place de Paris S.à r.l.
Intrasoft International S.A.
La Raphije S.A.
Lauro 28 S.A.
Lisbonne Lux S. à r. l.
Lux-Avantage Advisory S.A. Holding
Maestro SICAV (Lux)
Maidford Finance S.A.
Marc Aalen Luxembourg S.A.
Marlegreen Holding S.A.
MC Investment Central Europe S.àr.l.
Multibuilding S.A.
Nagoluphy S.A.
Palace Invest S.à r.l.
Portunato Marine Services S.A.
Pro-Audio Concept S.A.
Q & A S.à r.l.
Q & A S.à r.l.
Ranylux
Renaissance Finance S.A.
Revesta S.A.
Savacom
SIFC Development Holding S.à r.l.
Sunrise S.A.
Swisstar S.A.
Swisstar S.A.
Swisstar S.A.
Teknon Investments S.A.
TrendConcept S.A.
Trisport 69-77 S.A.
unitedprint S.à r.l.
Value Opportunities Fund S.A.
Vescor Services S.A.