This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2080
22 octobre 2009
SOMMAIRE
ACF I Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
99826
Air Ghelamco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99811
Anticalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99796
Bigonlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99795
Caobang RC 4 Glory S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
99811
Caobang RC 4 Glory S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
99810
Caobang RC 4 Glory S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
99840
Caobang RC 4 Glory S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
99810
Chemical Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . .
99794
Circle International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
99813
Dexton Development Corporation S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99812
Eole Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99796
EPF St Georges Retail Park S.à r.l. . . . . . . .
99811
Euric S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99796
Financière Stoppato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99796
Global Energy - Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
99799
Guadelete Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
99798
ILP III S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99828
Indigo Capital V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99795
International Investment Services . . . . . . .
99810
Juky S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99797
Katana Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
99811
Katana Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
99810
Katana Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
99809
Keywest International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
99798
Kuwaiti Algerian Investment Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99840
Limra International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
99810
LNR Arman S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99795
Lucien Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99798
Majentel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99809
Matex Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99798
MCT Berlin Drei S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99822
MCT Berlin Zwei S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99818
MDS International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99797
Metalift S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99813
MEZZANINE 2000 (Prezioso) S.à r.l. . . . .
99795
MF 2 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99811
MR CIE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99794
Navcon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99817
PBL Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99797
Pierica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99794
Siegwerk Holding Luxembourg S.A. . . . . .
99797
Smiths Detection International Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99795
Sohoma S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99831
Solficorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99839
Sol Melia Vacation Network S.à r.l. . . . . . .
99797
Strategic Management Consulting S.A. . .
99798
Strategic Management Consulting S.A. . .
99794
Tishman Speyer French Core Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99815
Valora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99818
Venthône S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99796
Versailles III Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99831
Züblin Immobilière Luxembourg S.A. . . . .
99794
99793
Pierica, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 127.225.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2009129359/13.
(090155673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Chemical Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 109.021.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2009129356/12.
(090155675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Züblin Immobilière Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 92.642.
Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129351/10.
(090155611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Strategic Management Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 79.252.
Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009129404/9.
(090155714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
MR CIE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 129.319.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129400/10.
(090155490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
99794
MEZZANINE 2000 (Prezioso) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 109.147.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129401/10.
(090155865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Indigo Capital V S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 130.207.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129399/10.
(090155863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Smiths Detection International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 106.277.
Les comptes annuels au 31 juillet 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129397/10.
(090155892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Bigonlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9521 Wiltz, 24, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 126.493.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Sonia Livoir.
Référence de publication: 2009129370/10.
(090155642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
LNR Arman S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 86.291.
<i>Mention rectificative des comptes annuels révisés au 30 novembre 2007i>
<i>et déposés au registre de commerce et des sociétés le 4 août 2009 sous la référence L090120859.04i>
Les comptes annuels révisés au 30 novembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jan Willem OVERHEUL
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009129371/14.
(090155754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
99795
Anticalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9521 Wiltz, 24, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 125.926.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2009.
Sonia Livoir.
Référence de publication: 2009129369/10.
(090155645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Venthône S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 12, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 87.453.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2009.
Sonia Livoir.
Référence de publication: 2009129368/10.
(090155646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Eole Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 86.612.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2009.
Sonia Livoir.
Référence de publication: 2009129367/10.
(090155654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Euric S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 41.643.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2009.
Sonia Livoir.
Référence de publication: 2009129366/10.
(090155657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Financière Stoppato, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 133.411.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 octobre 2009.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Jean SECKLER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009129216/14.
(090155997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
99796
Siegwerk Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 66.882.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2006 de la société Siegwerk GmbH & Co.KG ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2009.
Référence de publication: 2009129355/11.
(090155652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
MDS International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 92.148.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2009129364/11.
(090155664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
PBL Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.616.
Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2009129373/11.
(090155766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Sol Melia Vacation Network S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 102.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2009129376/11.
(090155761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Juky S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 94.261.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129362/10.
(090155668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
99797
Keywest International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 97, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 82.693.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2009129363/11.
(090155667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Guadelete Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 123.610.
Les comptes annuels au 30 novembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GUADELETE INVESTMENTS S.à r.l.
i>Eric MAGRINI / Philippe TOUSSAINT
Référence de publication: 2009129396/11.
(090155933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Matex Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 138.691.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129387/10.
(090155967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Strategic Management Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 79.252.
Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009129405/9.
(090155716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Lucien Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 815.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 du Lucien Holdings S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Lucien Holdings S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2009129402/13.
(090155868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
99798
Global Energy - Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 148.479.
STATUTES
In the year two thousand nine, on the twenty-second of September,
before Maître Joëlle Baden, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared
1) Mr Dennis Michael Franjoine, construction management officer, born on 21 July 1959 in Niagara Falls, NY, United
States of America, with professional address at 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, United States
of America;
2) Mr David Paul Franjoine, construction management officer, born on 30 August 1960 in Niagara Falls, NY, United
States of America, with professional address at 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, United States
of America;
3) Mr Robert William Zuchlewski, construction management officer, born on 9 January 1969 in Buffalo, NY, United
States of America, with professional address at 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, United States
of America;
all three here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with, with professional address in Luxembourg,
by virtue of three proxies under private seal with power of substitution given on 15 and 16 September 2009.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
"Global Energy - Lux S.à r.l." (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the
case may be, the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
2.3. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the manager(s) and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. To the extent permitted under Luxem-
bourg law, the Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of
99799
debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons and the Company
may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of
its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company,
and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those
activities are not considered as regulated activities of the financial sector.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate
to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company's corporate capital is set at twenty-five thousand United States dollars (USD 25,000) represented
by one thousand (1,000) shares in registered form without designation of a nominal value, all subscribed and fully paid-
up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
The transfer of shares (inter vivos) to non- shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders who set the term of their
office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The managers need not to be
shareholders.
7.2. The members of the board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers»
and «Category B Managers».
7.3. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the compe-
tence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which
shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or in accordance
with article 10.1. of the Articles.
99800
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his
proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager
and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by
a majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers
such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
Art. 10. Representation
10.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single manager, or, in
case the Company is managed by a board of managers, by the joint signatures of any two managers of the Company.
10.2. If the general meeting of shareholders decided to create two categories of managers (Category A Managers and
Category B Managers), the Company will only be bound by the joint signature of any Category A Manager together with
any Category B Manager.
10.3. The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles and within the
limits of such power.
Art. 11. Liability of the managers
11.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.
11.2. To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as
those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles,
shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred
or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by
reason of being or having been managers, officers or delegatees of the Company, by reason of any transaction carried
out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with
the execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each
case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.
11.3. To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the
Law, a manager shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other managers, or for any loss or damage
caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which
shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful
default.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. Without prejudice to articles 12.2. and 12.4. of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted
at general meetings.
99801
12.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2. of these Articles and shall cast
their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his share holding. Each share is entitled to one vote.
12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
Art. 13. Notices, quorum, majority and voting proceedings
13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager of the Company. The single manager, or as the
case may be, the board of managers must convene or consult the shareholders following the request of shareholders
representing more than one-half of the share capital of the Company.
13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail.
13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in
advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting.
13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
13.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.
13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-
half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However,
in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.
13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year and annual general meeting
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December of such year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders of the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
14.4. If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice, on the third Monday of June of each year at 10.00 a.m. and if such day is not a business day for
banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
14.5. If there are not more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held
at such place and time as may be specified in the convening notice of the meeting which shall take place within the time
limit set forth by the Law.
Art. 15. Statutory/External auditor
15.1. If there are more than twenty-five shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or
several statutory auditor(s) (commissaire(s)).
15.2. To the extent required by Law, the operations of the Company shall be supervised by one or several external
auditors (réviseurs d'entreprises).
15.3. The statutory/external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.4. The statutory/external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which
will determine their number, their remuneration and the term of their office.
99802
Art. 16. Allocation of Profits
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.
16.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
16.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount
distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
17.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the share-
holders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2009.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
- Mr Dennis Michael Franjoine, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for 290 (two hundred
and ninety) shares in registered form, without designation of a nominal value, and to fully pay them up by way of a
contribution in cash amounting to seven thousand two hundred and fifty United States dollars (USD 7,250.00).
- Mr David Paul Franjoine, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for 640 (six hundred and
forty) shares in registered form, without designation of a nominal value, and to fully pay them up by way of a contribution
in cash amounting to sixteen thousand United States dollars (USD 16,000.00).
- Mr Robert William Zuchlewski, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for 70 (seventy)
shares in registered form, without designation of a nominal value, and to fully pay them up by way of a contribution in
cash amounting to one thousand seven hundred and fifty United States dollars (USD 1,750.00).
The amount of twenty-five thousand United States dollars (USD 25,000) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entirety of
the subscribed share capital have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Dennis Michael Franjoine, Construction Management Officer, born on 21 July 1959 in Niagara Falls, NY, United
States of America, with professional address at 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, United States
of America;
99803
- Mr David Paul Franjoine, Construction Management Officer, born on 30 August 1960 in Niagara Falls, NY, United
States of America, with professional address at 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, United States
of America;
- Mr Robert William Zuchlewski, Construction Management Officer, born on 9 January 1969 in Buffalo, NY, United
States of America, with professional address at 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, United States
of America.
2. The registered office of the Company is set at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences
between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt- deux septembre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu
1) Mr Dennis Michael Franjoine, Construction Management Officer, né le 21 juillet 1959 à Niagara Fals, NY, Etats-Unis
d'Amérique, avec adresse professionnelle à 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, Etats-Unis
d'Amérique;
2) Mr David Paul Franjoine, Construction Management Officer, né le 30 août 1960 à Niagara Falls, NY Etats-Unis
d'Amérique, avec adresse professionnelle à 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, Etats-Unis
d'Amérique;
3) Mr Robert William Zuchlewski, Construction Management Officer, né le 9 janvier 1969 à Buffalo, NY, Etats-Unis
d'Amérique, avec adresse professionnelle à 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, Etats-Unis
d'Amérique;
tous les trois ici représentés par Mr Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu de trois procurations sous seing privé avec pouvoir de substition données à Luxembourg, les 15 et 16 sep-
tembre 2009,
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon
suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Global Energy - Lux
S.à r.l.» (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2. Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil
de gérance. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une
résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.3. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents
déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces évènements seraient de nature à compromettre l'activité normale
de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera
une société luxembourgeoise.
99804
Art. 3. Objet social
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous
titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments
de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra
participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre
effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un porte-
feuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres
titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, la Société
pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut
également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant
sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements
de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés
ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur
financier.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou
indirectement ou se rapportent à son objet.
Art. 4 Durée
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
4.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital social - Parts sociales
Art. 5 Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) représenté par mille (1.000)
parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des
associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être consulté par chaque associé qui le désire.
6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Si
plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas nécessairement
associé(s).
99805
7.2 Les membres du conseil de gérance peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement
«Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
7.3 Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des
associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la com-
pétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à
l'article 10.1. des Statuts.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour
de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de
gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations
écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier
préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.
9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par
téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également
nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par
écrit.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, au moins un Gérant de
catégorie A et un Gérant de catégorie B est présent ou représenté. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises
valablement qu'à la majorité des voix exprimées et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été
nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les
résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à la réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valable et engageront la Société comme si elles
avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par
télégramme, telex, facsimile ou courrier électronique.
Art. 10. Représentation
10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la
Société est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société.
10.2. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),
la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.
10.3. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui
ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2 des Statuts et dans les limites de ce
pouvoir.
Art. 11 Responsabilité des gérants
11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi
que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des
99806
présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dom-
mages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures
auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la
Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou
dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses
dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces
personnes peuvent jouir.
11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la
Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte
ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage
ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par,
une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
IV. Assemblées générales des asociés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. Sans préjudice des articles 12.2. et 12.4. des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en
assemblées générales.
12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2. des présents Statuts et ex-
primeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.
12.3. Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part
sociale donne droit à un vote.
12.4. L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions
de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.
Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
13.1. Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas
échéant, le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de
la moitié du capital social de la Société.
13.2. Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.3. Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours
avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la
convocation de ladite assemblée.
13.4. Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations res-
pectives des assemblées.
13.5. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associée et se considèrent eux-
mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
13.6. Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre
personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.7. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation
écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront
adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
13.8. Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être
adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.
13.9. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
14.1. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre de la même année.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance
dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs
de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y
en a) et des associés de la Société.
99807
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaire et bilan au siège social de la Société.
14.4. Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège
social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le
troisième lundi du mois de juin à 10h00 du matin et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée
générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.
14.5. Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq associés, l'assemblée générale des associés se tiendra au lieu
et heure indiqués dans la convocation respective de l'assemblée.
Art. 15. Commissaire / Réviseur d'entreprise
15.1. Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou
plusieurs commissaires.
15.2. Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs
d'entreprises.
15.3. Le(s) commissaire(s) /réviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6 ans et sera
(seront) rééligibles.
15.4. Le(s) commissaire(s) / réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des associés de
la Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.
Art. 16. Affectation des bénéfices
16.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société
tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.
16.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets an-
nuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
(v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué
en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés,
les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la
Société.
17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.
VII. Dispositions générales
Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre
(le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2009.
<i>Souscription et Libérationi>
Sur ces faits,
- Mr Dennis Michael Franjoine, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 290 (deux cent
quatre-vingt-dix) parts sociales sous forme nominative, sans désignation de valeur nominale, et de les libérer intégralement
par un apport en numéraire d'un montant de sept mille deux cent cinquante dollars américains (USD 7.250,00).
- Mr David Paul Franjoine, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 640 (six cent qua-
rante) actions ordinaires sous forme nominative, sans désignation de valeur nominale, et de les libérer intégralement par
un apport en numéraire d'un montant de seize mille dollars américains (USD 16.000,00).
99808
- Mr Robert William Zuchlewski, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 70 (soixante-
dix) parts sociales sous forme nominative, sans désignation de valeur nominale, et de les libérer intégralement par un
apport en numéraire d'un montant de mille sept cent cinquante dollars américains (USD 875,00)
Le montant de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé
au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Dennis Michael Franjoine, Construction Management Officer, né le 21 juillet 1959 à Niagara Falls, NY,
Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle à 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, Etats-
Unis d'Amérique;
- Monsieur David Paul Franjoine, Construction Management Officer, né le 30 août 1960 à Niagara Falls, NY Etats-Unis
d'Amérique, avec adresse professionnelle à 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, Etats-Unis
d'Amérique;
- Monsieur Robert William Zuchlewski, Construction Management Officer, né le 9 janvier 1969 à Buffalo, NY, Etats-
Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle à 1330 Niagara Falls Blvd. - Suite 207, Tonawanda, NY 14150, Etats-Unis
d'Amérique.
2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et
français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2009, LAC / 2009 / 39131. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): SCHNEIDER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2009129497/585.
(090156591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Majentel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 77.599.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009129667/9.
(090156117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Katana Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 87.677.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
99809
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/10/09.
Signature.
Référence de publication: 2009129646/10.
(090156155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Katana Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 87.677.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/10/09.
Signature.
Référence de publication: 2009129647/10.
(090156154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Caobang RC 4 Glory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 97.277.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/10/09.
Signature.
Référence de publication: 2009129648/10.
(090156149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Caobang RC 4 Glory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 97.277.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/10/09.
Signature.
Référence de publication: 2009129649/10.
(090156148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Limra International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 101.300.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009129626/14.
(090156088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
International Investment Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 38.203.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
99810
<i>INTERNATIONAL INVESTMENT SERVICES
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009129629/12.
(090156085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
EPF St Georges Retail Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 134.040.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 8 octobre 2009.
TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009129642/12.
(090156169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Caobang RC 4 Glory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 97.277.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/10/09.
Signature.
Référence de publication: 2009129643/10.
(090156162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
MF 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 108.985.
Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129616/10.
(090156098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Katana Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 87.677.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/10/09.
Signature.
Référence de publication: 2009129645/10.
(090156157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Air Ghelamco, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 122.850.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
99811
Patrick ROCHAS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009129608/11.
(090156073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Dexton Development Corporation S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4974 Dippach, 20, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 146.951.
In the year two thousand and nine on the ninth day of September.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Halkinvest België BVBA, with registered office at Sint Jobsteenweg 32, 's Gravenwezel Belgium, Company number
0811.171.408,
here represented by Mr Guy HORNICK, "maître en sciences économiques", with professional address at 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on August 17, 2009.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The Sole member, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to document that it is the
sole member of Dexton Development Corporation S.àr.l., a limited liability company having its registered office at 2,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, incorporated on June 2, 2009 by a deed received by Me Carlo WER-
SANDT, civil law notary residing in Luxembourg, published in the "Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations"
number 1443 of July 27, 2009,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B, under number 146951.
The Sole Member requests the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Member decides to transfer of the registered office of the company from 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg to 20, rue Belle-Vue, L-4974 Dippach.
<i>Second resolutioni>
The Sole Member decides to amend the 1
st
sentence of article 2 of the bylaws, which henceforth will read as follows:
"The registered office is established in Dippach."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at one thousand euros.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, he signed together with the notary the present original deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendneun, am neunten September.
Vor Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz zu Luxembourg.
Ist erschienen:
Halkinvest België BVBA, mit Sitz in Sint Jobsteenweg 32, 's Gravenwezel, Belgium, Gesellschaftsnummer 0811.171.408,
hier vertreten durch Herrn Guy HORNICK, „maître en sciences économiques", berufsansässig in L-1653 Luxemburg,
2, avenue Charles de Gaulle,
aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 17. August 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger
Urkunde beigebogen bleibt.
99812
Die alleinige Gesellschafterin, vertreten vier hiervor erwähnt, hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie
die Alleingesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Dexton Development Corporation S.àr.l., mit Sitz in
L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle ist, welche durch notarielle Urkunde vom 2. Juni 2009 des Notars Carlo
WERSANDT, mit Sitz in Luxemburg, gegründet wurde, und im „Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations" Num-
mer 1443 vom 27. Juli 2009 veröffentlicht wurde,
eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 146951.
Die alleinige Gesellschafterin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von L-1653 Luxembourg, 2, avenue
Charles de Gaulle nach L-4974 Dippach, 20, rue Belle-Vue, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst Artikel 2, erster Absatz, der Satzungen wie folgt anzupassen:
„Der Sitz der Gesellschaft ist Dippach."
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf eintausend euro geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben er-
schienenen Person die vorliegende Urkunde in English, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag
derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist
die englische Fassung rechtsgültig.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten
Komparent hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: Guy Hornick, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 septembre 2009. LAC/2009/36664. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Für gleichlautende Kopie.
Carlo WERSANDT.
Référence de publication: 2009129512/79.
(090156473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Metalift S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Circle International S.A.).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 145.317.
L'an deux mille neuf, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CIRCLE INTERNATIO-
NAL S.A.", établie et ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg N° B 145.317, constituée suivant acte reçu
du notaire Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 mars 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 756 du 7 avril 2009.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au
18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabel Dias, employée privée, domiciliée professionnellement
au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée professionnellement au
74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)
actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
99813
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en "METALIFT S.A." et modification subséquente de l'article
1
er
alinéa 1
er
des statuts;
2. Création de deux catégories d'administrateurs A et B;
3. Modifications des pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société;
4. Démission de deux administrateurs;
5. Nomination de deux nouveaux administrateurs;
6. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective;
7. Refonte des articles 5 et 6 des statuts;
8. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La dénomination sociale de la société est changée en "METALIFT S.A.".
En conséquence, l'article 1
er
alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de METALIFT S.A.".
<i>Deuxième résolutioni>
Il est créé deux catégories d'administrateurs A et B, administrateurs auxquels l'assemblée donnera pouvoir de signature
"A" ou pouvoir de signature "B" lors de leur nomination.
<i>Troisième résolutioni>
La société se trouve valablement engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un
administrateur de la catégorie B.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs en la personne de Monsieur Michaël ZIANVENI et
de Monsieur Sébastien GRAVIERE.
Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs sortants pour leurs mandats jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée nomme deux nouveaux administrateurs:
- Madame Mariele BERTE, entrepreneur, née le 1
er
avril 1971 à Milan - Italie - et domiciliée au 76, Corso Sempione,
Milan, Italie;
- Monsieur Giancarlo BESANA, ingénieur, né le 9 juin 1941 à Côme - Italie - et domicilié au 5, via Montecristo, Varese,
Italie.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblé générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social 2014.
<i>Sixième résolutioni>
Les administrateurs de la société sont affectés aux catégories A et B de la manière suivante:
1. Sont appelés aux fonctions d'administrateur de la catégorie A:
- Madame Mariele BERTE, préqualifiée;
- Monsieur Giancarlo BESANA, préqualifié.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs de la catégorie B:
- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé à une refonte des articles 5 et 6 des statuts, qui auront désormais
la teneur suivante:
99814
" Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d'un administrateur, l'assemblée
générale lui donnera pouvoir de signature "A" ou pouvoir de signature "B".
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive."
" Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par télécon-
férence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les
administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les
mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut
également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante
en cas de partage des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur
de la catégorie B."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Sabella, I. Dias, C. Peyron et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 septembre 2009. LAC/2009/39349. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck Schneider.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009129505/110.
(090156449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.950.
In the year two thousand and nine, on the eighteenth day of September.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.
There appears:
Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorpo-
rated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 130.391,
here represented by Ms Suzana Fuia, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by
virtue of a proxy established under private seal on September 15, 2009 in Luxembourg.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
99815
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established in Luxembourg under the name of "Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l.", having its registered office
at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
section B, under number 134.950 (the "Company"), incorporated by a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, of December 18, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 250 dated
January 30, 2008 and which bylaws have been lastly amended by a deed of the undersigned notary of February 8, 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1374, dated June 4, 2008.
II. The Company's share capital is fixed at nine hundred and sixty thousand five hundred and twenty-five Euro (€
960,525.-) represented by thirty-eight thousand four hundred and twenty-one (38,421) shares of twenty-five Euro (€
25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of thirty-nine thousand
four hundred seventy-five Euro (€ 39,475.-) to raise it from its present amount of nine hundred sixty thousand five hundred
and twenty-five Euro (€ 960,525.-) to one million Euro (€ 1,000,000.-) by creation and issue of one thousand five hundred
and seventy-nine (1,579) new shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each (the "New Shares"), vested with the same rights
and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l., prenamed, resolves to subscribe for the one thousand five hundred and
seventy-nine (1,579) New Shares, with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and to fully pay them up in the
amount of thirty-nine thousand four hundred and seventy-five Euro (€ 39,475.-) by contribution in cash in the same
amount.
The total amount of thirty-nine thousand four hundred and seventy-five Euro (€ 39,475.-) has been fully paid up in
cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.
IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
" Art. 6. The share capital is fixed at one million Euro (€ 1,000,000.-) represented by forty thousand (40,000) shares,
with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each ".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholder's meeting are estimated at approximately two thousand Euro (€ 2,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, The present notarised deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille neuf, le dix-huitième jour de septembre.
Par-devant Nous, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 130.391,
ici représentée par Mademoiselle Suzana Fuia, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 septembre 2009 à Luxembourg.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
"Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l.", ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.950 (la
"Société"), constituée par un acte de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 18 décembre
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 250 du 30 janvier 2008, dont les statuts ont
99816
été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 8 février 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1374 du 4 juin 2008.
II. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent soixante mille cinq cent vingt-cinq Euro (€ 960.525,-) représenté
par trente-huit mille quatre cent vingt et une (38.421) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-)
chacune.
III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-neuf mille quatre cent
soixante-quinze Euro (€ 39.475,-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent soixante mille cinq cent vingt-cinq
Euro (€ 960.525,-) à un million d'Euro (€ 1.000.000,-), par la création et l'émission de mille cinq cent soixante-dix-neuf
(1.579) nouvelles parts sociales (les "Nouvelles Parts") d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune, investies
des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux mille cinq cent soixante-dix-neuf (1.579)
Nouvelles Parts, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune et les libérer intégralement pour un montant
de trente-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euro (€ 39.475,-) par apport en numéraire d'un même montant.
Un montant de trente-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euro (€ 39.475,-) a été intégralement libéré en numéraire
et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.
IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à un million d'Euro (€ 1.000.000,-) représenté par quarante mille (40.000) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€25,-) chacune."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille Euro (€ 2.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Suzana Fuia, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 24 septembre 2009. LAC/2009/38975. Reçu 75,-.
<i>Pour le Receveuri> (signé): Franck Schneider.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 30 septembre 2009.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2009129506/110.
(090156432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Navcon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 135.811.
Constituée par-devant Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 janvier 2008, acte
publié au Mémorial C no 500 du 27 février 2008.
Le bilan au 30 novembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NAVCON S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009129706/14.
(090156376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
99817
Valora S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 73.804.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009129669/9.
(090156112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
MCT Berlin Zwei S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 114.385.
In the year two thousand and nine,
on the twenty-fifth day of the month of September.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") of "MCT BERLIN ZWEI S.A." (the
"Company") a "société anonyme", established and having its registered office at 5 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 03 February 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 951 of 16 May 2006 and entered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, Section B, under the number 114 385.
The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since.
The Meeting is declared opened in the chair by Mr Jean-Paul SCHAUL, managing director, with professional address
in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mr Marcel MARBACH, accountant, with professional address in
Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr Kai SCHOLER, residing in D-66701 Beckingen.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of article 6 of the Company's articles of association. Decision to amend the first paragraph of article
6 of the Company's articles of association by insertion after the first sentence of the following new sentence:
„At least one of those members shall be designed as category „B" director, the others being designed as category „A"
directors."
2. Amendment of article 9 of the Company's articles of association. Decision to amend article 9 of the Company's
articles of association and to replace the present text by the following:
"For any amount inferior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound in any circumstances by
the joint signature of any two directors whatever the category to which they belong, unless special decisions have been
reached concerning the authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors
pursuant to article 10 of the present articles of association.
For amounts equal or superior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound by the joint signature
of one category "A" director and one category "B" director, unless special decisions have been reached concerning the
authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors pursuant to article
10 of the present articles of association."
3. Appointment of directors. Appointment (after the resignation of Mr Fons Mangen as a Company's director) of the
following persons as directors:
<i>Category "A" directorsi>
a) Volker Hemprich, residing at 2-4, Place du Molard, 3458 Geneva, Switzerland;
b) Frederic Königsegg, residing at 2-4, Place du Molard, 3458 Geneva, Switzerland;
<i>Category "B" directorsi>
c) Marcel Marbach, residing at 5, avenue Monterey, 2163 Luxembourg;
d) Jean-Paul Schaul, residing at 5, avenue Monterey, 2163 Luxembourg.
The directors' terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of 2014, unless they previously
resign or are revoked.
99818
4. Decision to put into force the foregoing decisions on October 1
st
, 2009.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVES to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association by insertion
after the first sentence of the following new sentence:
„At least one of those members shall be designed as category „B" director, the others being designed as category „A"
directors."
It was resolved that the complete text of the first paragraph of such Article 6 will then read as follows:
"The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether shareholders or
not. At least one of those members shall be designed as category „B" director, the others being designed as category „A"
directors. Members are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which
may at any time remove them."
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVES to amend article 9 of the Company's articles of association and to replace the present text
by the following:
"For any amount inferior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound in any circumstances by
the joint signature of any two directors whatever the category to which they belong, unless special decisions have been
reached concerning the authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors
pursuant to article 10 of the present articles of association.
For amounts equal or superior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound by the joint signature
of one category "A" director and one category "B" director, unless special decisions have been reached concerning the
authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors pursuant to article
10 of the present articles of association."
<i>Third resolutioni>
The Meeting RESOLVES to accept, with effect on September 30, 2009, the resignation of Mr Fons MANGEN, with
professional address in Luxembourg, as current director of the Company and to grant him full discharge for the accom-
plishment of his duties as director up to September 30, 2009.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting RESOLVES to appoint as:
<i>Category "A" directors of the Company:i>
a) Mr Volker Hemprich, residing at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Geneva, Switzerland;
b) Mr Frederic Königsegg, residing at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Geneva, Switzerland;
<i>Category "B" directors of the Company:i>
c) Mr Marcel Marbach, residing at 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
d) Mr Jean-Paul Schaul, residing at 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
The directors' term of office, whether Category "A" or Category "B", will expire after the annual meeting of share-
holders of 2014, unless they previously resign or are revoked.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting RESOLVES to put into force the foregoing resolutions on October 1
st
, 2009.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that upon request of
the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the
same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.
99819
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendneun,
am fünfundzwanzigsten September.
Vor Uns dem unterzeichneten Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Lu-
xemburg),
fand eine außerordentliche Hauptversammlung (die „Versammlung") der Aktionäre der „MCT BERLIN ZWEI S.A."
statt, eine société anonyme -Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 5 avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg (die „Gesellschaft"), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen am 03. Februar 2006,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 951 vom 16. Mai 2006, und eingetragen ins
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, Sektion B, unter der Nummer 114 385.
Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht abgeändert.
Die Versammlung wurde eröffnet durch den Vorsitzenden Herrn Jean-Paul SCHAUL, managing director, berufsansässig
in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herr Marcel MARBACH, Buchhalter, berufsansässig in Luxemburg
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Kai SCHOLER, wohnhaft in D-66701 Beckingen.
Nach Bildung des Versammlungsbüros gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
(i) Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1.- Abänderung von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung. Beschluss den ersten Absatz des Artikels 6 der Gesellschafts-
satzung abzuändern, durch Einfügung nach dem ersten Satz eines folgenden neuen Satzes:
"Wenigstens einer dieser Mitglieder wird Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „B" bezeichnet, die anderen sind
Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A".
2.- Abänderung von Artikel 9 der Gesellschaftsordnung. Beschluss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung abzuändern und
den bestehenden Text durch folgenden neuen Text zu ergänzen:
„Für Beträge unter zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft in jeder Hinsicht durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, ungeachtet ihrer Kategorie rechtlich gebunden, es sei denn, dass eine
gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel dieser
Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde.
Für Beträge von und über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „A" und eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „B rechtlich ge-
bunden, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertre-
tungsbefugnis nach Artikel dieser Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde."
3.- Ernennung von Verwaltungsratmitgliedern. Ernennung (nach Rücktritt von Herrn Fons Mangen als Verwaltungs-
ratsmitglied) der nachstehenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder:
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A"i>
a) Volker Hemprich, wohnhaft in at 2-4, Place du Molard, 3458 Genf, Schweiz;
b) Frederic Königsegg, wohnhaft in 2-4, Place du Molard, 3458 Genf, Schweiz;
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „B"i>
c) Marcel Marbach, wohnhaft in 5, avenue Monterey, 2163 Luxemburg;
d) Jean-Paul Schaul, wohnhaft in 5, avenue Monterey, 2163 Luxemburg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder wird nach der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre welche im
Jahre 2014 stattfinden wird, enden, sofern sie nicht früher ausscheiden oder abberufen werden.
4.- Beschluss die vorstehenden Entschlüsse am 1. Oktober 2009 in Kraft zu setzen.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand
einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.
(iii) Die durch die erscheinenden Parteien und den unterzeichneten Notar ne varietur abgezeichneten Vollmachten
der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungs-
behörde hinterlegt zu werden.
99820
(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten, und da die anwe-
senden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden
zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.
(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetre-
ten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.
Daraufhin hat die Hauptversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse ge-
fasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt den ersten Absatz des Artikels 6 der Gesellschaftssatzung abzuändern, durch Einfügung
nach dem ersten Satz eines neuen Satzes wie folgt:
"Wenigstens einer dieser Mitglieder wird Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „B" bezeichnet, die anderen sind
Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A"."
Es wurde noch beschlossen, dass der vollständige Wortlaut des ersten Absatzes dieses Artikels 6 nun wie folgt lautet:
„Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, geleitet. Wenigstens
einer dieser Mitglieder wird Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „B" bezeichnet, die anderen sind Verwaltungsrats-
mitglieder der Kategorie „A". Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs Jahren
gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen kann."
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Versammlung beschließt Artikel 9 der Gesellschaftsordnung abzuändern und den bestehenden Text durch fol-
genden neuen Text zu ergänzen:
„Für Beträge unter zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft in jeder Hinsicht durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, ungeachtet ihrer Kategorie rechtlich gebunden, es sei denn, dass eine
gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel dieser
Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde."
„Für Beträge von und über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „A" und eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „B rechtlich ge-
bunden, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertre-
tungsbefugnis nach Artikel dieser Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, mit Wirkung zum 30. September 2009, den Rücktritt von Herrn Fons MANGEN, be-
rufstätig in Luxemburg als derzeitiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen und ihm volle und gänzliche
Entlastung für die Ausübung seines Mandates als Verwaltungsratsmitglied, bis zum 30. September 2009 zu erteilen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die Ernennung als:
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A" der Gesellschaft:i>
a) Herr Volker Hemprich, wohnhaft in at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Genf, Schweiz;
b) Herr Frederic Königsegg, wohnhaft in 2-4, Place du Molard, CH-3458 Genf, Schweiz;
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „B" der Gesellschaft:i>
c) Herr Marcel Marbach, wohnhaft in 5, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg;
d) Herr Jean-Paul Schaul, wohnhaft in 5, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder, sei es der Kategorie „A" oder der Kategorie „B", wird nach der jährlichen
Generalversammlung der Aktionäre welche im Jahre 2014 stattfinden wird, enden, sofern sie nicht früher ausscheiden
oder abberufen werden.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, dass die vorstehenden Beschlüsse am 1. Oktober 2009 in Kraft treten werden.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch
verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage der Komparenten. Im Falle einer
Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten
Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J.P. SCHAUL, M. MARBACH, K. SCHOLER, J.J. WAGNER.
99821
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. September 2009. Relation: EAC/2009/11562. Erhalten fünfundsiebzig Euro
(75.- EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Sondersammlung für Ge-
sellschaften und Vereinigungen.
Beles, den. 07 OCT. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009129520/214.
(090156217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
MCT Berlin Drei S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 118.011.
In the year two thousand and nine,
on the twenty-fifth day of the month of September.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") of "MCT BERLIN DREI S.A." (the
"Company") a "société anonyme", established and having its registered office at 5 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 10 July 2006, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1710 of 13 September 2006 and entered in the Luxembourg Register of
Commerce and Companies, Section B, under the number 118 011.
The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since.
The Meeting is declared opened in the chair by Mr Jean-Paul SCHAUL, managing director, with professional address
in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mr Marcel MARBACH, accountant, with professional address in
Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr Kai SCHOLER, residing in D-66701 Beckingen.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of article 6 of the Company's articles of association. Decision to amend the first paragraph of article
6 of the Company's articles of association by insertion after the first sentence of the following new sentence:
„At least one of those members shall be designed as category „B" director, the others being designed as category „A"
directors."
2. Amendment of article 9 of the Company's articles of association. Decision to amend article 9 of the Company's
articles of association and to replace the present text by the following:
"For any amount inferior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound in any circumstances by
the joint signature of any two directors whatever the category to which they belong, unless special decisions have been
reached concerning the authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors
pursuant to article 10 of the present articles of association.
For amounts equal or superior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound by the joint signature
of one category "A" director and one category "B" director, unless special decisions have been reached concerning the
authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors pursuant to article
10 of the present articles of association."
3. Appointment of directors. Appointment (after the resignation of Mr Fons Mangen as a Company's director) of the
following persons as directors:
<i>Category "A" directorsi>
a) Volker Hemprich, residing at 2-4, Place du Molard, 3458 Geneva, Switzerland;
b) Frederic Königsegg, residing at 2-4, Place du Molard, 3458 Geneva, Switzerland;
<i>Category "B" directorsi>
c) Marcel Marbach, residing at 5, avenue Monterey, 2163 Luxembourg;
d) Jean-Paul Schaul, residing at 5, avenue Monterey, 2163 Luxembourg.
The directors' terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of 2014, unless they previously
resign or are revoked.
99822
4. Decision to put into force the foregoing decisions on October 1
st
. 2009.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVES to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association by insertion
after the first sentence of the following new sentence:
„At least one of those members shall be designed as category „B" director, the others being designed as category „A"
directors."
It was resolved that the complete text of the first paragraph of such Article 6 will then read as follows:
"The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether shareholders or
not. At least one of those members shall be designed as category „B" director, the others being designed as category „A"
directors. Members are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which
may at any time remove them."
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVES to amend article 9 of the Company's articles of association and to replace the present text
by the following:
"For any amount inferior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound in any circumstances by
the joint signature of any two directors whatever the category to which they belong, unless special decisions have been
reached concerning the authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors
pursuant to article 10 of the present articles of association.
For amounts equal or superior to ten thousand Euro (EUR 10.000,00), the Company will be bound by the joint signature
of one category "A" director and one category "B" director, unless special decisions have been reached concerning the
authorized signature in the case of delegation of powers of proxies given by the board of directors pursuant to article
10 of the present articles of association."
<i>Third resolutioni>
The Meeting RESOLVES to accept, with effect on September 30,2009, the resignation of Mr Fons MANGEN, with
professional address in Luxembourg, as current director of the Company and to grant him full discharge for the accom-
plishment of his duties as director up to September 30, 2009.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting RESOLVES to appoint as:
<i>Category "A" directors of the Company:i>
a) Mr Volker Hemprich, residing at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Geneva, Switzerland;
b) Mr Frederic Königsegg, residing at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Geneva, Switzerland;
<i>Category "B" directors of the Company:i>
c) Mr Marcel Marbach, residing at 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
d) Mr Jean-Paul Schaul, residing at 5, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
The directors' term of office, whether Category "A" or Category "B", will expire after the annual meeting of share-
holders of 2014, unless they previously resign or are revoked.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting RESOLVES to put into force the foregoing resolutions on October 1
st
, 2009.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that upon request of
the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the
same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.
99823
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendneun,
am fünfundzwanzigsten September.
Vor Uns dem unterzeichneten Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Lu-
xemburg),
fand eine außerordentliche Hauptversammlung (die „Versammlung") der Aktionäre der „MCT BERLIN DREI S.A." statt,
eine société anonyme -Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 5 avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg (die „Gesellschaft"), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen am 10. Juli 2006, veröffentlicht im
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1710 vom 13. September 2006, und eingetragen ins Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister, Sektion B, unter der Nummer 118 011.
Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht abgeändert.
Die Versammlung wurde eröffnet durch den Vorsitzenden Herrn Jean-Paul SCHAUL, managing director, berufsansässig
in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herr Marcel MARBACH, Buchhalter, berufsansässig in Luxemburg
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Kai SCHOLER, wohnhaft in D-66701 Beckingen.
Nach Bildung des Versammlungsbüros gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
(i) Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1.- Abänderung von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung. Beschluss den ersten Absatz des Artikels 6 der Gesellschafts-
satzung abzuändern, durch Einfügung nach dem ersten Satz eines folgenden neuen Satzes:
"Wenigstens einer dieser Mitglieder wird Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „B" bezeichnet, die anderen sind
Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A".
2.- Abänderung von Artikel 9 der Gesellschaftsordnung. Beschluss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung abzuändern und
den bestehenden Text durch folgenden neuen Text zu ergänzen:
„Für Beträge unter zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft in jeder Hinsicht durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, ungeachtet ihrer Kategorie rechtlich gebunden, es sei denn, dass eine
gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel dieser
Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde.
Für Beträge von und über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „A" und eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „B rechtlich ge-
bunden, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertre-
tungsbefugnis nach Artikel dieser Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde."
3.- Ernennung von Verwaltungsratmitgliedern. Ernennung (nach Rücktritt von Herrn Fons Mangen als Verwaltungs-
ratsmitglied) der nachstehenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder:
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A"i>
a) Volker Hemprich, wohnhaft in at 2-4, Place du Molard, 3458 Genf, Schweiz;
b) Frédéric Königsegg, wohnhaft in 2-4, Place du Molard, 3458 Genf, Schweiz;
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „B"i>
c) Marcel Marbach, wohnhaft in 5, avenue Monterey, 2163 Luxemburg;
d) Jean-Paul Schaul, wohnhaft in 5, avenue Monterey, 2163 Luxemburg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder wird nach der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre welche im
Jahre 2014 stattfinden wird, enden, sofern sie nicht früher ausscheiden oder abberufen werden.
4.- Beschluss die vorstehenden Entschlüsse am 1. Oktober 2009 in Kraft zu setzen.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand
einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.
(iii) Die durch die erscheinenden Parteien und den unterzeichneten Notar ne varietur abgezeichneten Vollmachten
der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungs-
behörde hinterlegt zu werden.
99824
(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten, und da die anwe-
senden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden
zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.
(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetre-
ten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.
Daraufhin hat die Hauptversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse ge-
fasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt den ersten Absatz des Artikels 6 der Gesellschaftssatzung abzuändern, durch Einfügung
nach dem ersten Satz eines neuen Satzes wie folgt:
"Wenigstens einer dieser Mitglieder wird Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „B" bezeichnet, die anderen sind
Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A"."
Es wurde noch beschlossen, dass der vollständige Wortlaut des ersten Absatzes dieses Artikels 6 nun wie folgt lautet:
„Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, geleitet. Wenigstens
einer dieser Mitglieder wird Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „B" bezeichnet, die anderen sind Verwaltungsrats-
mitglieder der Kategorie „A". Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs Jahren
gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen kann."
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Versammlung beschließt Artikel 9 der Gesellschaftsordnung abzuändern und den bestehenden Text durch fol-
genden neuen Text zu ergänzen:
„Für Beträge unter zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft in jeder Hinsicht durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, ungeachtet ihrer Kategorie rechtlich gebunden, es sei denn, dass eine
gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel dieser
Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde."
„Für Beträge von und über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „A" und eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie „B rechtlich ge-
bunden, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertre-
tungsbefugnis nach Artikel dieser Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen delegiert wurde."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, mit Wirkung zum 30. September 2009, den Rücktritt von Herrn Fons MANGEN, be-
rufstätig in Luxemburg als derzeitiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen und ihm volle und gänzliche
Entlastung für die Ausübung seines Mandates als Verwaltungsratsmitglied, bis zum 30. September 2009 zu erteilen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die Ernennung als:
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „A" der Gesellschaft:i>
a) Herr Volker Hemprich, wohnhaft in at 2-4, Place du Molard, CH-3458 Genf, Schweiz;
b) Herr Frederic Königsegg, wohnhaft in 2-4, Place du Molard, CH-3458 Genf, Schweiz;
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie „B" der Gesellschaft.i>
c) Herr Marcel Marbach, wohnhaft in 5, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg;
d) Herr Jean-Paul Schaul, wohnhaft in 5, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder, sei es der Kategorie „A" oder der Kategorie „B", wird nach der jährlichen
Generalversammlung der Aktionäre welche im Jahre 2014 stattfinden wird, enden, sofern sie nicht früher ausscheiden
oder abberufen werden.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, dass die vorstehenden Beschlüsse am 1. Oktober 2009 in Kraft treten werden.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch
verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage der Komparenten. Im Falle einer
Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten
Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J.P. SCHAUL, M. MARBACH, K. SCHOLER, J.J. WAGNER.
99825
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. September 2009. Relation: EAC/2009/11563. Erhalten fünfundsiebzig Euro
(75.- EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Sondersammlung für Ge-
sellschaften und Vereinigungen.
Beles, den 07 OCT. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009129519/214.
(090156227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
ACF I Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 139.901.
In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth day of September,
before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
"AXA Capital Fund L.P.", a limited partnership governed by the laws of Scotland, whose registered office is at 50,
Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, EH3 9WJ, Scotland, registered with the Scottish Registrar under number 6596,
whose general partner is "AXA Private Equity Capital Limited", whose registered office is at Jersey, 22, Grenville Street,
St. Helier, Jersey, Channel Islands (the "Shareholder"),
here represented by Me Jennifer FERRAND, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 24 Sep-
tember 2009,
Said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of "ACF
I Investment S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one
hundred thousand euro (EUR 100,000.-), with registered office at 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 25 June 2008, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations dated 25 July 2008 number 1836 and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 139901 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company
have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of 8 July 2008, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations dated 26 August 2008 number 2059.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To amend the Company's corporate object by amending article 3 of the Company's articles of incorporation which
shall read as follows:
"The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of securities in Luxembourg and/or in foreign
companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights with a view to carrying out such purpose.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes."
2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the Company's corporate object by amending article 3 of the Company's articles
of incorporation which shall read as follows:
"The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of securities in Luxembourg and/or in foreign
companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights with a view to carrying out such purpose.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes."
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
99826
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt-cinq septembre,
par-devant nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
"AXA Capital Fund L.P.", une limited partnership régie par le droit écossais, ayant son siège social au 50, Lothian Road,
Festival Square, Edinburgh, EH3 9WJ, Ecosse, immatriculée au Scottish Registrar sous le numéro 6596, son general partner
étant "AXA Private Equity Capital Limited", ayant son siège social à Jersey, 22, Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel
Islands (l'"Associé"),
représentée aux fins des présentes par Me Jennifer FERRAND, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration donnée le 24 septembre 2009.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de "ACF I Investment S.à r.l.",
une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de cent mille euro (EUR
100.000,-), dont le siège social est au 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée
suivant acte du notaire soussigné en date du 25 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
25 juillet 2008 numéro 1836 et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 139901 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire
soussigné en date du 8 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 26 août 2008 numéro
2059.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Modification de l'objet social de la Société par modification de l'article 3 des statuts de la Société qui aura la teneur
suivante:
"La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de valeurs mobilières dans toute société et entreprise
luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à
ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions
en vue de réaliser cet objet.
D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime
utile à l'accomplissement et au développement de son objet."
2 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé a décidé de modifier l'objet social de la Société par modification de l'article 3 des statuts de la Société qui
aura la teneur suivante:
"La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de valeurs mobilières dans toute société et entreprise
luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à
ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions
en vue de réaliser cet objet.
D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime
utile à l'accomplissement et au développement de son objet."
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par son nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: J. FERRAND, J.J. WAGNER.
99827
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11627. Reçu soixante-quinze Euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 08 OCT. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009129515/110.
(090156282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
ILP III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 127.503.
In the year two thousand nine, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Adrien COULOMBEL, employee, having professional residence in Luxembourg,
acting in his capacity as attorney of the Manager of the "société en commandite par actions", "ILP III S.C.A., SICAR",
which was incorporated by a deed of the undersigned notary of 13 April 2007, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1269 of June 26, 2007, and whose articles of incorporation have been modified for the
last time pursuant to a deed of the undersigned notary on May 8, 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1176 of June 16, 2009, registered in the Luxembourg Company Register under section B number
127503 and having its registered office at 30, rue Marie Adelaide, L-2128 Luxembourg, (the "Company"),
by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the Company's Manager on 23 September 2009, a certified
copy of these resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the notary, shall remain annexed to the present
deed which they shall be formalised.
The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I.- The subscribed share capital of the Company is presently set at thirty-nine million three hundred eighteen thousand
seven hundred forty-seven euro twenty cents (EUR 39,318,747.20) divided into:
- one (1) Management Share,
- three million six hundred eighty-one thousand four hundred seven point four two three nine (3,681,407.4239) Class
A Shares
- two hundred forty-seven thousand three hundred sixty-seven point two nine five nine (247,367.2959) Class B Shares
and
- three thousand ninety nine (3,099) Class C Shares.
II.- Pursuant to Article 8 of the Company's Articles of Incorporation, the Company's authorised capital is set at one
hundred fifty million euro (EUR 150,000,000.-).
III.- Pursuant to the Company's Articles of Incorporation, the Company's Manager has been authorised to increase
the Company's subscribed share capital within the limits of the authorised capital and to amend Article 8 of the Articles
of Incorporation so as to reflect the increase of capital.
IV.- The Company's Manager, in its resolutions adopted on 23 September 2009, and in accordance with the authorities
conferred on it pursuant to the Articles of Incorporation, resolved to increase the subscribed corporate capital by the
amount of one million five hundred twenty-five thousand euro (EUR 1,525,000.-) in order to raise it from its present
amount of thirty-nine million three hundred eighteen thousand seven hundred forty-seven euro twenty cents (EUR
39,318,747.20) to an amount of forty million eight hundred forty-three thousand seven hundred forty-seven euro twenty
cents (EUR 40,843,747.20) by the creation and the issue of one hundred forty-two thousand eight hundred ninety-eight
point one four eight zero (142,898.1480) new Class A Shares and nine thousand six hundred and one point eight five two
zero (9,601.8520) new class B Shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) per share, having the same rights
attached as the existing Shares.
V.- The Company's Manager further resolved to waive to the extent necessary the preferential subscriptions rights
reserved to the existing Shareholders and to accept the subscriptions on 23 September 2009 of one hundred forty-two
thousand eight hundred ninety-eight point one four eight zero (142,898.1480) new Class A Shares and nine thousand six
hundred and one point eight five two zero (9,601.8520) new class B Shares.
VI.- All these new Shares have been entirely subscribed and entirely paid in cash for a total amount of one million five
hundred twenty-five thousand euro (EUR 1,525,000.-) as follows:
99828
Number
of shares
subscribed
Share Capital
Contribution
(EUR)
A Shares
Efibanca S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,888.8889
338,888.89
Società Cattolica di Assicuarazione Coop.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,296.2963
112,962.96
Orlyan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,416.6667
254,166.67
Finogest Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,555.5556
135,555.55
Halfmoon Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,083.3333
50,833.33
Pamphili Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,694.4444
16,944.45
Banca Popolare di Vicenza ScpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,120.3704
141,203.70
Compagnie Monegasque de Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,388.8889
33,888.89
FIN PO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,694.4444
16,944.45
Union Bancaire Privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,694.4444
16,944.45
Futura Invest S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,648.1481
56,481.48
Yleen Investments Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,824.0741
28,240.74
Private Equity International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,648.1481
56,481.48
Gema 96 SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,648.1481
56,481.48
Gain Capital Participations SA, SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,824.0741
28,240.74
Kzewl Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,648.1481
56,481.48
Gravilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,824.0741
28,240.74
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,898.1480
1,428,981.48
B Shares
Danio Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,601.8520
96,018.52
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,500.0000
1,525,000.00
The total cash sum of one million five hundred twenty-five thousand euro (EUR 1,525,000.-) is at the disposal of the
Company as has been proved to the undersigned notary.
VII.- As a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital. Article 8 b of the Articles of
Incorporation is therefore amended and shall forthwith read as follows:
Art. 8. (b). "The issued share capital of the Company is set at forty million eight hundred forty-three thousand seven
hundred forty-seven euro twenty cents (EUR 40,843,747.20) divided into:
- one (1) Management Share,
- three million eight hundred twenty-four thousand three hundred and five point five seven one nine (3,824,305.5719)
Class A Shares
- two hundred fifty-six thousand nine hundred sixty-nine point one four seven nine (256,969.1479) Class B Shares and
- three thousand ninety nine (3,099) Class C Shares."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document, are estimated at approximately three thousand five hundred euro.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the day named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person, said appearing person signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Adrien Coulombel, employé, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité mandataire de l'Associé Gérant Commandité de la société en commandite par actions "ILP III
S.C.A., SICAR", constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 avril 2007, publié au Mémorial. Recueil
99829
des Sociétés et Associations, numéro 1269 du 26 juin 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 mai 2009, publié au Mémorial. Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1176 du 16 juin 2009, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 127503 et ayant
son siège social au 30 rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg (la "Société"),
en vertu des pouvoirs lui conférés par les résolutions de l'Associé Gérant Commandité, prises en date du 23 septembre
2009 dont la copie certifiée de ces résolutions, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle personne comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les décla-
rations et constatations suivantes:
I.- Le capital souscrit de la Société s'élève actuellement à trente-neuf millions trois cent dix-huit mille sept cent qua-
rante-sept euros vingt cents (EUR 39.318.747,20) représenté par:
- une (1) Action de Commandité,
- trois millions six cent quatre-vingt-et-un mille quatre cent sept virgule quatre deux trois neuf (3.681.407,4239) actions
de Classe A,
- deux cent quarante-sept mille trois cent soixante-sept virgule deux neuf cinq neuf (247.367,2959) actions de Classe
B et
- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) Actions de Classe C.
II.- En vertu de l'Article 8 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société, est fixé à cent cinquante millions
d'euros (EUR 150.000.000.-).
III.- En vertu des statuts de la Société, l'Associé Gérant Commandité de la Société a été autorisé à augmenter le capital
souscrit dans les limites du capital autorisé et à modifier l'Article 8 des Statuts de manière à refléter l'augmentation de
capital.
IV.- L'Associé Gérant Commandité de la Société, dans ses résolutions du 23 septembre 2009, et en conformité des
pouvoirs lui conférés en vertu des Statuts, a décidé une augmentation du capital souscrit à concurrence d'un million cinq
cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.525.000.-) afin de le porter de son montant actuel de trente-neuf millions trois cent
dix-huit mille sept cent quarante-sept euros vingt cents (EUR 39.318.747,20) à quarante millions huit cent quarante-trois
mille sept cent quarante-sept euros vingt cents (EUR 40.843.747,20) par la création et l'émission de cent quarante-deux
mille huit cent quatre-vingt-dix-huit virgule un quatre huit zéro (142.898,1480) nouvelles actions de Classe A et neuf mille
six cent un virgule huit cinq deux zéro (9.601,8520) nouvelles actions de Classe B, ayant une valeur de dix euros (EUR
10.-) par action et ayant les mêmes droits que les Actions existantes.
V.- L'Associé Gérant Commandité de la Société a également décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel
des Actionnaires existants dans la mesure du nécessaire et a admis les souscriptions le 23 septembre 2009 de cent
quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-dix-huit virgule un quatre huit zéro (142.898,1480) nouvelles actions de Classe
A et neuf mille six cent un virgule huit cinq deux zéro (9.601,8520) nouvelles actions de Classe B.
VI.- Toutes ces nouvelles Actions Ordinaires ont été entièrement souscrites et entièrement libérées en numéraire
pour un montant d'un million cinq cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.525.000.-) comme suit:
Nombre
d'actions
souscrites
Libération
du capital
(EUR)
Classe A
Efibanca S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.888,8889
338.888,89
Società Cattolica di Assicuarazione Coop.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.296,2963
112.962,96
Orlyan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.416,6667
254.166,67
Finogest Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.555,5556
135.555,55
Halfmoon Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.083,3333
50.833,33
Pamphili Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.694,4444
16.944,45
Banca Popolare di Vicenza ScpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.120,3704
141.203,70
Compagnie Monegasque de Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.388,8889
33.888,89
FIN PO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.694,4444
16.944,45
Union Bancaire Privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.694,4444
16.944,45
Futura Invest S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.648,1481
56.481,48
Yleen Investments Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.824,0741
28.240,74
Private Equity International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.648,1481
56.481,48
Gema 96 SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.648,1481
56.481,48
Gain Capital Participations SA, SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.824,0741
28.240,74
Kzewl Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.648,1481
56.481,48
Gravilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.824,0741
28.240,74
99830
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.898,1480 1.428.981,48
Classe B
Danio Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.601,8520
96.018,52
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.500,0000 1.525.000,00
Le montant en numéraire d'un million cinq cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.525.000.-) se trouve à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.
VII,- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital souscrit, l'Article 8 (b) des Statuts de la Société est
modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
Art. 8. (b). "Le capital social souscrit de la Société est fixé à quarante millions huit cent quarante-trois mille sept cent
quarante-sept euros vingt cents (EUR 40.843.747,20) représenté par:
- une (1) Action de Commandité,
- trois millions huit cent vingt-quatre mille trois cent cinq virgule cinq sept un neuf (3.824.305,5719) actions de Classe
A,
- deux cent cinquante-six mille neuf cent soixante-neuf virgule un quatre sept neuf (256.969,1479) actions de Classe
B et
- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) Actions de Classe C."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à environ trois mille cinq cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire
instrumentant le présent acte.
Signé: A. COULOMBEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11571. Reçu soixante-quinze Euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 08 OCT. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009129514/193.
(090156298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Sohoma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 81.656.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129670/10.
(090156111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Versailles III Partners, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 148.474.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth day of the month of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
99831
1. Mr. Patrick Le Juste, born in Ukkel, Belgium, on April 9, 1965, professionally residing at Boulevard Helvétique 17,
1207 Geneva (Switzerland); hereby represented by Ms. Marjorie Binet, Maître en droit, residing professionally in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy, given in Brussels, on September, 24, 2009.
2. Mr. Stefaan Beullens, born in Mechelen, Belgium, on May 05, 1960, professionally residing at Avenue Louise 283, bte
20, 1050 Bruxelles (Belgium); hereby represented by Ms. Marjorie Binet, prenamed, by virtue of a proxy, given in Brussels,
on September 24, 2009.
3. Mr. Marc Vael, born in Sint-Gillis-Waas, Belgium, on July 9, 1970, professionally residing at Avenue Louise 283, bte
20, 1050 Bruxelles (Belgium); hereby represented by Ms. Marjorie Binet, prenamed, by virtue of a proxy, given in Brussels,
on September 24, 2009.
4. Mr. Philippe Pirson, born in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on March 18, 1958, professionally residing
at Route des Trois Cantons 9, L-8399 Windhof (Grand Duchy of Luxembourg); hereby represented by Ms. Marjorie
Binet, prenamed, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on September 24, 2009.
5. Mr. Bob Van Aken, born in Wilrijk, Belgium, on August 14, 1972, professionally residing at Route des Trois Cantons
9, L-8399 Windhof (Grand Duchy of Luxembourg); hereby represented by Ms. Marjorie Binet, prenamed, by virtue of a
proxy, given in Brussels, on September 24, 2009.
The said proxies, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as aforementioned, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they organize between them and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may
become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which shall be governed by
the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorpo-
ration under the name of "Versailles III Partners" (hereinafter the "Company").
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interest, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, and in particular in Versailles III, a société d'investissement à capital variable organized as a société en com-
mandite par actions, to be incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "SICAV"), and qualified
as a specialised investment fund ("SIF") in accordance with the law of February 13, 2007 on SIFs - and to act as its general
partner and shareholder with unlimited liability. The Company may further hold any other form of investment, acquire
by purchase, subscription or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise securities of any kind
and administrate, control and develop its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the
manager or, in the case of several managers, the board of managers. Within the same municipality, the registered office
may be transferred through simple resolution of the manager or, in the case of several managers, the board of managers.
In the event that the manager or, in the case of several managers, the board of managers determine(s) that extraor-
dinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
99832
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
(3/4) of the share capital at least. The shares to be subscribed shall be offered preferably to the existing partner(s), in
proportion to the share in the capital represented by his/their shares.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to new
partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three
quarters (3/4) of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters (3/4) of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-
lution of the Company.
Art. 10. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners. In dealings with
third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the general
meeting of partners which sets the term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole
partner, or as the case may be, the partners. The Company shall be bound in all circumstances by the signature of its
manager or, in case of several managers, by the joint signatures of any two managers or by the signature or any person
to whom such signatory power has been delegated by the sole manager, or as the case may be, the board of managers.
Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by its board of managers which shall choose among its
members a chairman, and may choose among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram or facsimile,
e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than
one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution is equal,
the chairman of the meeting shall have a casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two (2) managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two (2) managers or by any person duly appointed to that
effect by the board of managers.
99833
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) does/do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. He is/they are authorised agent(s) only and are therefore
merely responsible for the execution of his/their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 16. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Except if a higher majority is provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The amendment of these articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 18. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of
section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company's financial year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of
the same year.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager or, in the case of several
managers the board of managers, prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The balance is available
for distribution by the general meeting of partners. The manager or, in the case of several managers, the board of managers
may distribute interim dividends to the extent sufficient funds are available therefore.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
1. Mr. Patrick Le Juste, prenamed, subscribes for four thousand one hundred and twenty-five (4,125) shares and pays
them fully in cash for an amount of four thousand one hundred and twenty-five Euros (EUR 4,125.-);
2. Mr. Stefaan Beullens, prenamed, subscribes for two thousand three hundred and seventy-five (2,375) shares and
pays them fully in cash for an amount of two thousand three hundred and seventy-five Euros (EUR 2,375.-);
3. Mr. Marc Vael, prenamed, subscribes for for two thousand two hundred and fifty (2,250) shares and pays them fully
in cash for an amount of two thousand two hundred and fifty Euros (EUR 2,250.-);
4. Mr. Philippe Pirson, prenamed, subscribes for one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) shares and pays
them fully in cash for an amount of one thousand eight hundred and seventy-five Euros (EUR 1,875.-).
5. Mr. Bob Van Aken, prenamed, subscribes for one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) shares and pays
them fully in cash for an amount of one thousand eight hundred and seventy-five Euros (EUR 1,875.-).
Proof of such payments, for a total amount of twelve thousand Euros (EUR 12, 500.-) fully subscribed and paid-in, has
been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2009.
99834
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,000.-
<i>Resolutions of sole partneri>
The appearing parties, representing the entire subscribed share capital, have immediately proceeded to pass the fol-
lowing resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at Route des Trois Cantons 9, L-8999 Windhof, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the board of managers of the Company for an unlimited period:
- Mr. Patrick Le Juste, born in Ukkel, Belgium, on April 9, 1965, professionally residing at Boulevard Helvétique 17,
1207 Geneva (Switzerland);
- Mr. Stefaan Beullens, born in Mechelen, Belgium, on May 05, 1960, professionally residing at Avenue Louise 283, bte
20, 1050 Bruxelles (Belgium);
- Mr. Philippe Pirson, born in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on March 18, 1958, professionally residing
at Route des Trois Cantons 9, L-8399 Windhof (Grand Duchy of Luxembourg);
- Mr. Bob Van Aken, born in Wilrijk, Belgium, on August 14, 1972, professionally residing at Route des Trois Cantons
9, L-8399 Windhof (Grand Duchy of Luxembourg).
The managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to
bind the Company by the joint signatures of any two of them.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above appearing
party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in
case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le vingt-cinq septembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Patrick Le Juste, né à Ukkel, Belgique, le 9 avril 1965, ayant son adresse professionnelle à Boulevard
Helvétique 17, 1207 Genève (Suisse); ici représenté par Mademoiselle Marjorie Binet, Maître en droit, ayant son adresse
professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Bruxelles, le 24 septembre 2009.
2. Monsieur Stefaan Beullens, né à Mechelen, Belgique, le 5 mai 1960, ayant son adresse professionnelle à Avenue
Louise 283, bte 20, 1050 Bruxelles (Belgique); ici représenté par Mademoiselle Marjorie Binet, prénommée, en vertu
d'une procuration donnée à Bruxelles, le 24 septembre 2009.
3. Monsieur Marc Vael, né à Sint-Gillis-Waas, Belgique, le 9 juillet 1970, ayant son adresse professionnelle à Avenue
Louise 283, bte 20, 1050 Bruxelles (Belgique); ici représenté par Mademoiselle Marjorie Binet, prénommée, en vertu
d'une procuration donnée à Bruxelles, le 24 septembre 2009.
4. Monsieur Philippe Pirson, né à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, le 18 mars 1958, ayant son adresse
professionnelle à Route des Trois Cantons 9, L-8399 Windhof (Grand Duché de Luxembourg); ici représenté par Ma-
demoiselle Marjorie Binet, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 24 septembre 2009.
5. Monsieur Bob Van Aken, né à Wilrijk, Belgique, le 14 août 1972, ayant son adresse professionnelle à Route des
Trois Cantons 9, L-8399 Windhof (Grand Duché de Luxembourg); ici représenté par Mademoiselle Marjorie Binet,
prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Bruxelles, le 24 septembre 2009.
Les procurations signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et par le notaire, resteront annexées
au présent acte et seront soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
Lesdites parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'établir l'acte
de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent organiser entre elles et d'arrêter les statuts tels
que stipulés ci-après:
A. Objet - Durée - Nom - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui deviendront associés, une société à responsabilité
limitée, qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les
présents statuts sous la dénomination de "Versailles III Partners" (ci-après la "Société").
99835
Art. 2. L'objet de la Société est de détenir une participation de quelque forme qu'elle soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, et en particulier dans Versailles III, une société d'investissement à capital variable sous la forme
d'une société en commandite par actions devant être constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et or-
ganisée comme un fonds d'investissement spécialisé conformément à la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investisse-
ment spécialisés, et d'agir comme son associé gérant commandité et associé avec une responsabilité illimitée. La Société
peut entreprendre toute forme d'investissement, acquérir par achat, souscription ou par toute autre manière ainsi que
l'aliénation par la vente, échange ou autre valeurs mobilières de toute nature et administrer, contrôler et développer son
portefeuille.
La Société peut également garantir, accorder des prêts, accorder des sûretés à ou autrement assister les sociétés dans
lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de société que la Société.
La Société peut également agir en tant que associé avec ou sans responsabilité limitée pour toutes les dettes et obli-
gations de sociétés en commandite ou entités similaires.
La Société peut également pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, exécuter toutes les opérations
utiles ou nécessaires pour l'accomplissement de son objet ou qui sont liées directement ou indirectement à son objet.
La Société peut procéder à des emprunts, de quelque nature ou forme, ainsi qu'émettre des obligations.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, sur
décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou autres bureaux
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Le siège social pourra être transféré dans la même commune sur
simple décision du gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Si le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance estime que des événements politiques ou militaires
extraordinaires, ayant des conséquences sur les activités normales de la Société à son siège social ou sur la facilité de
communication entre ce siège social et des personnes à l'étranger, ont lieu ou sont imminents, le siège social peut,
temporairement, être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; de telles me-
sures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré ce transfert provisoire, restera une
société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500.-), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune].
Chaque part donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence à l'associé
ou aux associés existant(s), en proportion à la part du capital social que représentent ses/leurs parts sociales.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis devront désigner
un mandataire unique qui les représentera à l'égard de la Société.
Art. 8. Les parts de la Société sont librement cessibles entre les associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des
nouveaux associés qu'avec l'approbation des autres associés donnée en assemblée générale, à la majorité des trois-quarts
(3/4) du capital social.
En cas de décès, les parts sociales du défunt ne peuvent être transférées à de nouveaux associés qu'avec l'approbation
des autres associés donnée en assemblée générale, à la majorité des trois-quarts (3/4) du capital social. Une telle appro-
bation n'est cependant pas requise au cas où les parts sont transférées aux ascendants, descendants ou au conjoint
survivant.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 10. Ni les créanciers, ni les ayants-droit, ni les héritiers ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, faire apposer
des scellés sur les avoirs ou les documents de la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), qui n'a (ont) pas besoin d'être associé(s). Dans les relations
avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circons-
tances et autoriser toutes les transactions en rapport avec l'objet de la Société. Le(s) gérant(s) est (sont) désigné(s) par
l'assemblée générale des associés qui détermine la durée de son (leur) mandat. Le(s) gérants sont librement et à tout
moment révocable(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.
La Société sera engagée, dans tous les cas, par la signature de son gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par les
signatures conjointes de deux gérants, ou par la signature de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le gérant ou par le conseil de gérance le cas échéant.
99836
Art. 12. En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par son conseil de gérance qui devra désigner un président
en son sein, et pourra désigner un vice-président parmi ses membres. Il peut également choisir un secrétaire, qui n'a pas
besoin d'être gérant et qui aura pour mission de conserver les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur décision du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la société à moins qu'il n'en soit autrement indiqué
dans l'avis de convocation. Le président préside toutes les réunions du conseil de gérance, mais, en son absence, le conseil
de gérance peut désigner un autre gérant comme président pro tempore par un vote à la majorité des membres présents
à une telle réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt quatre (24) heures avant
la date prévue pour cette réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de l'urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à l'avis de convocation par consentement écrit, câble, télégramme, fac-
simile, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale n'est pas requise pour une
réunion se tenant à un moment et un lieu déterminé dans une résolution précédente adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une
réunion du conseil de gérance ou en cas de résolutions écrites, approuvées et signées par l'ensemble des membres du
conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter à une réunion du conseil de gérance en désignant, par écrit ou par câble,
télégramme, facsimile, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son mandataire.
Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues.
Chaque gérant peut participer à chaque réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes présentes à l'assemblée de
s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne
à une telle réunion.
Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si une majorité au moins de ses membres est
présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à une telle réunion. Si, au cours d'une réunion, le nombre de voix pour ou contre une résolution
sont à égalité, le président de l'assemblée aura une voix prépondérante.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par circulaire lorsqu'il exprime son approbation par
écrit, par câble, télégramme, facsimile, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble formera le
procès-verbal prouvant la résolution.
Art. 13. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil de gérance sont signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux qui peuvent être produits dans
le cadre de procédures judiciaires ou autre, sont signés par le président ou par deux (2) gérants ou par toute personne
dûment désignée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 15. Le(s) gérant(s) n'assume(nt), en raison de sa (leur) position, aucune responsabilité personnelle en relation avec
les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simple(s) mandataire(s), il(s) n'est/ne sont responsable
(s) que pour l'exécution de leur mandat.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient ou représente.
Art. 17. A l'exception d'une majorité plus importante décidée par les présents statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
La modification de ces statuts ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par la majorité
des associés représentant au moins trois-quarts du capital social.
Art. 18. L'associé unique exerce les pouvoirs accordés à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la
section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Exercice social - Comptes annuels - Distribution de bénéfices
Art. 19. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le
conseil de gérance, dresse un inventaire indiquant les valeurs de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé a accès
à cet inventaire et au bilan au siège social de la Société.
99837
Art. 21. Cinq pourcent (5%) du bénéfice net sont réservés pour l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que la
réserve atteigne dix pourcent (10%) du capital social de la Société. Le solde peut être librement utilisé par les associés.
Le solde peut être distribué sur décision de l'assemblée générale des associés. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants,
le conseil de gérance, peut distribuer des dividendes intérimaires lorsque des fond suffisants sont disponibles pour dis-
tribution.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin
d'être associés, et qui sont désignés par l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rému-
nération. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation
de l'actif et le paiement du passif de la Société.
Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes, sera partagé entre les associés en proportion
de leurs parts sociales détenues dans la Société.
Art. 23. Pour toute question qui n'est pas réglée par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
1. Monsieur Patrick Le Juste, prénommé, souscrit quatre mille cent vingt-cinq (4.125) parts sociales et les libère inté-
gralement contre un paiement en numéraire d'un montant de quatre mille cent vingt-cinq euros (EUR 4.125.-);
2. Monsieur Stefaan Beudens, prénommé, souscrit for deux mille trois-cent soixante-quinze (2.375) parts sociales et
les libère intégralement contre un paiement en numéraire d'un montant de deux mille trois-cent soixante-quinze euros
(EUR 2.375.-);
3. Monsieur Marc Vael, prénommé, souscrit deux mille deux-cent cinquante (2.250) parts sociales et les libère inté-
gralement contre un paiement en numéraire d'un montant de deux mille deux-cent cinquante euros (EUR 2.250.-);
4. Monsieur Philippe Pirson, prénommé, souscrit mille huit-cent soixante-quinze (1.875) parts sociales et les libère
intégralement contre un paiement en numéraire d'un montant de mille huit-cent soixante-quinze euros (EUR 1.875,);
5. Monsieur Bob Van Aken, prénommé, souscrit mille huit-cent soixante-quinze (1.875) parts sociales et les libère
intégralement contre un paiement en numéraire d'un montant de mille huit-cent soixante-quinze euros (EUR 1.875,).
La preuve de tels paiements, pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) entièrement
souscrit et entièrement libéré, a été donnée au notaire soussigné qui déclare que les conditions prévues à l'article 183
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2009.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison de sa constitution, sont estimés approximativement à EUR 1.000,-
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Les parties comparantes, représentant la totalité du capital souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au Route des Trois Cantons 9, L-8999 Windhof, Grand Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du conseil de gérance de la Société, pour une durée illimitée:
- Monsieur Patrick Le Juste, né à Ukkel, Belgique, le 9 avril 1965, ayant son adresse professionnelle à Boulevard
Helvétique 17, 1207 Genève (Suisse);
- Monsieur Stefaan Beullens, né à Mechelen, Belgique, le 5 mai 1960, ayant son adresse professionnelle à Avenue Louise
283, bte 20, 1050 Bruxelles (Belgique);
- Monsieur Philippe Pirson, né à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, le 18 mars 1958, ayant son adresse
professionnelle à Route des Trois Cantons 9, L-8399 Windhof (Grand Duché de Luxembourg);
- Monsieur Bob Van Aken, born in Wilrijk, Belgium, on August 14, 1972, professionally residing at Route des Trois
Cantons 9, L-8399 Windhof (Grand Duchy of Luxembourg).
Les gérants sont investis des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et
d'engager la Société par la signature conjointe de deux d'entre eux.
Dont acte, passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes que, à la demande de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi de sa traduction française; en cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise prévaudra.
99838
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état civil et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. BINET - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 octobre 2009. Relation: LAC/2009/40738. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le huit octobre de l'an deux mille neuf.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009129513/393.
(090156476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Solficorp, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 98.905.
DISSOLUTION
L'an deux mil neuf, le dix-sept septembre
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOLFICORP, avec siège social
à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine DECKER, alors
de résidence à Wiltz, en date du 15 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro
481 du 24 juin 1999,
Dont les statuts on été modifiés aux termes d'un acte sous seing privé dressé le 29 juin 2001, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 365 du 06 mars 2002.
inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 98.905
L'assemblée est ouverte à 11.30 heures et désigne comme président/ scrutateur Madame Geneviève Bertrand, em-
ployée, demeurant la Roche, Belgique, Mousny 45, lequel désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadja Schickes,
employée, demeurant à Lullange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jouri>
1. Mise en liquidation de la société
2. Nomination d'un liquidateur
3. Approbation des comptes de liquidation
4. Décharge donnée aux administrateurs
5. Clôture de la liquidation de la société
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement
délibérer telle qu'elle est constituée.
Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions
suivantes:
L'assemblée prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolution.i>
L'assemblée décide de mettre en liquidation la société et nomme Monsieur Benoît DE BIEN, consultant, demeurant à
L-9515 Wiltz, 59, rue Grande Duchesse Charlotte en tant que liquidateur.
99839
<i>Deuxième résolution.i>
L'assemblée approuve les comptes de liquidation basés sur la situation comptable au 17 septembre 2009, date à laquelle
la société n'a plus d'activité.
<i>Troisième résolution.i>
L'assemblée constate que le liquidateur a préalablement réalisé les actifs avant la liquidation et qu'il n'existe plus aucun
actif ne nécessitant d'acte de liquidation particulier. Le liquidateur a pris les dispositions nécessaires de manière à ce que
les provisions et les charges liées à la liquidation soient apurées.
<i>Quatrième résolution.i>
L'assemblée donne décharge conseil d'administration pour son mandat et les tâches liées à la liquidation jusqu'à la date
de ce jour.
<i>Cinquième résolution.i>
L'assemblée décide que les documents sociaux resteront déposés pendant cinq ans au domicile du liquidateur.
<i>Sixième résolution.i>
L'assemblée prononce la clôture finale de la liquidation de la société SOLFICORP qui cessera d'exister avec effet au
17 septembre 2009.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.45 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant au comparant en raison des présentes est estimé à 900.-EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état
et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. de Bien, G. Bertrand, N. Schickes, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 21 septembre 2009 - WIL/2009/763 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-
<i>Le Receveuri> (signé): J. Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial.
Wiltz, le 9 octobre 2009.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2009129524/71.
(090156610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Caobang RC 4 Glory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 97.277.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/10/09.
Signature.
Référence de publication: 2009129650/10.
(090156147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Kuwaiti Algerian Investment Company S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 21.292.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009129651/11.
(090156144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
99840
ACF I Investment S.à r.l.
Air Ghelamco
Anticalux S.A.
Bigonlux S.A.
Caobang RC 4 Glory S.A.
Caobang RC 4 Glory S.A.
Caobang RC 4 Glory S.A.
Caobang RC 4 Glory S.A.
Chemical Engineering S.A.
Circle International S.A.
Dexton Development Corporation S.àr.l.
Eole Properties S.A.
EPF St Georges Retail Park S.à r.l.
Euric S.A.
Financière Stoppato
Global Energy - Lux S.à r.l.
Guadelete Investments S.à r.l.
ILP III S.C.A., SICAR
Indigo Capital V S.à r.l.
International Investment Services
Juky S.A.
Katana Investments S.A.
Katana Investments S.A.
Katana Investments S.A.
Keywest International S.A.
Kuwaiti Algerian Investment Company S.A.
Limra International S.à r.l.
LNR Arman S.à r.l.
Lucien Holdings S.àr.l.
Majentel S.A.
Matex Services S.A.
MCT Berlin Drei S.A.
MCT Berlin Zwei S.A.
MDS International
Metalift S.A.
MEZZANINE 2000 (Prezioso) S.à r.l.
MF 2 S. à r.l.
MR CIE S.à r.l.
Navcon S.A.
PBL Luxembourg S.A.
Pierica
Siegwerk Holding Luxembourg S.A.
Smiths Detection International Luxembourg S.à r.l.
Sohoma S.à r.l.
Solficorp
Sol Melia Vacation Network S.à r.l.
Strategic Management Consulting S.A.
Strategic Management Consulting S.A.
Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l.
Valora S.A.
Venthône S.A.
Versailles III Partners
Züblin Immobilière Luxembourg S.A.