logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2035

16 octobre 2009

SOMMAIRE

Apax Boston A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97678

Argance S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97658

ARMAND RACCOGLI et SERVAIS STEM-

PER & Cie (Bureau d'Assurances)  . . . . . .

97648

Arnarbaeli & Reilley & Cie SNC  . . . . . . . . .

97640

Banque LBLux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97658

Bonafide Invest G.m.b.h.  . . . . . . . . . . . . . . . .

97640

Boston A1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97678

Carson Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97651

Carts & Kiosks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97652

Casual International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

97670

Corton Meyney S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97651

Crediinvest Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97676

Donatello Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97677

Doosan Heavy Industries European Hol-

dings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97656

Dory 1 (NFR) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97656

ECPROD S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97679

ERE III - No 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97637

ETF - EUROVIA TRAVAUX FERROVIAI-

RES Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

97639

Expanding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97680

FACTS Services S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97673

Fondation FNEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97648

Grosvenor First European Property Invest-

ments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97651

Guyana Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

97657

International Wires For Companies S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97658

K.B. Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97657

LIPP 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97637

L.T.T. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97650

LuxReal - Real Estate Association of Lu-

xembourg a.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97642

Lux T.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97659

Maine Coon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97650

Metalmachine Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . .

97669

Mira Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97652

Müller Trade AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97677

MZ Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97658

Noble Holding International SCA  . . . . . . .

97670

Noble Holding International SCA  . . . . . . .

97673

Pan-Eco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97676

Paris Coiffure S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97662

Partners Group Global Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97634

Partners Group Global Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97653

Partners Group Global Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97662

Partners Group Global Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97666

Pearson Luxembourg N°. 1.  . . . . . . . . . . . . .

97657

Recherches Scientifiques Luxembourg  . . .

97659

R.H. Conseil Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97659

Rover International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

97647

Salamina Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97680

S.G.A. Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97662

Sigma Tau Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

97666

Société Générale Immobilière Luxem-

bourgeoise S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97650

SOCIETE INTERNATIONALE D'ARCHI-

TECTURE, société d'architectes inter-
professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97653

The Swatch Group Financial Services (Lu-

xembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97666

TSA Mexican Funds S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

97660

Wouterbos N.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97652

97633

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 108.922.

In the year two thousand and nine.
On the eleventh day of September at 09.00 a.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on June 12, 2007 relatively to an increase of the corporate capital of PART-
NERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I.- The company PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having

its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B108922, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 30 

th

 of June 2005,

published in the Memorial C number 688 of the 13 

th

 of July 2005, and whose articles of incorporation have been amended

by deed of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of nine million two hundred and twenty-two thousand seven hundred and thirty-

six Euro and nineteen cents (9,222,736.19.- EUR) represented by thirty thousand five hundred and ninety point twenty-
four (30,590.24) Manager Shares and one hundred and fifty-three thousand eight hundred and sixty-four point fifty-one
(153,864.51) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of fifty million Euro (50,000,000.- EUR) divided into:
- nine hundred thousand (900,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- one hundred thousand (100,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on June 12, 2007 the General Manager has decided to increase, within the limits of

the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of one hundred and eighty-three thousand
eight hundred and thirty-four Euro and seventy-two cents (183,834.72.- EUR), in order to raise it from its present amount
of  nine  million  two  hundred  and  twenty-two  thousand  seven  hundred  and  thirty-six  Euro  and  nineteen  cents
(9.222,736.19.- EUR) to the amount of nine million four hundred and six thousand five hundred and seventy Euro and
ninety-one cents (9,406,570.91.- EUR) by issuing:

- three thousand and seventy-seven point twenty-five (3,077.25) new Ordinary Shares having a par value of fifty Euro

(50.- EUR) each, issued with a total share premium of two million nine hundred and twenty-three thousand three hundred
and eighty-seven Euro and fifty cents (2,923,387.50.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;

97634

- five hundred and ninety-nine point forty-four (599.44) Manager Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR)

each, issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of one hundred and
eighty-three thousand eight hundred and thirty-four Euro and seventy-two cents (183,834.72.- EUR) as well as the amount
of  two  million  nine  hundred  and  twenty-three  thousand  three  hundred  and  eighty-seven  Euro  and  fifty  cents
(2,923,387.50.- EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital. (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of nine million four hundred and six thousand five hundred and seventy Euro

and ninety-one cents (9,406,570.91.- EUR) represented by thirty-one thousand one hundred and eighty-nine point sixty-
eight (31,189.68) Manager Shares and one hundred and fifty-six thousand nine hundred and forty-one point seventy-six
(156,941.76) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two thousand seven hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den elften September um 09.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 12. Juni 2007 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP GLOBAL
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B108922, wurde gegründet gemäss
Urkunde  aufgenommen  durch  Notar  Henri  HELLINCKX,  mit  dem  damaligen  Amtssitz  in  Mersch,  am  30.  Juni  2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 688 vom 13. Juli 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

97635

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von neun Millionen zwei hundert zwei und zwanzig tausend sieben hundert

sechs und dreissig Euro neunzehn Cents (9.222.736,19.- EUR), eingeteilt in dreissig tausend fünf hundert neunzig Komma
vier und zwanzig (30.590,24) Manager-Aktien und ein hundert drei und fünfzig tausend acht hundert vier und sechzig
Komma ein und fünfzig (153.864,51) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfzig Millionen Euro (50.000.000.- EUR) und ist aufgeteilt

in:

- neun hundert tausend (900.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie; und
- ein hundert tausend (100.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000.- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950.- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50.- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 12. Juni 2007 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten

Kapitals, das Gesellschaftskapital um ein hundert drei und achtzig tausend acht hundert vier und dreissig Euro zwei und
siebzig Cents (183.834,72.- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von neun Millionen zwei hundert zwei
und zwanzig tausend sieben hundert sechs und dreissig Euro neunzehn Cents (9.222.736,19.- EUR) auf neun Millionen
vier hundert sechs tausend fünfhundert siebzig Euro ein und neunzig Cents (9.406.570,91.- EUR) zu bringen durch die
Ausgabe von:

- drei tausend sieben und siebzig Komma fünf und zwanzig (3.077,25) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert

von je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von zwei Millionen neun hundert drei und
zwanzig tausend drei hundert sieben und achtzig Euro fünfzig Cents (2.923.387,50.- EUR) welcher gänzlich der Spezial
Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- fünf hundert neun und neunzig Komma vier und vierzig (599,44) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je

fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von ein hundert drei und
achtzig tausend acht hundert vier und dreissig Euro zwei und siebzig Cents (183.834,72.- EUR) erhalten hat, so wie den
Betrag von zwei Millionen neun hundert drei und zwanzig tausend drei hundert sieben und achtzig Euro fünfzig Cents
(2.923.387,50.- EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von neun Millionen vier hundert sechs tausend fünf hundert siebzig Euro ein

und neunzig Cents (9.406.570,91.- EUR), eingeteilt in ein und dreissig tausend ein hundert neun und achtzig Komma acht
und sechzig (31.189,68) Manager-Aktien und ein hundert sechs und fünfzig tausend neun hundert ein und vierzig Komma
sechs und siebzig (156.941,76) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zwei

tausend sieben hundert Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

97636

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: RÖSSLER; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2009. Relation GRE/2009/3324. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Junglinster, den 29. September 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009125635/177.
(090151668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2009.

LIPP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ERE III - No 7 S.à r.l.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 139.279.

In the year two thousand and nine, on the tenth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"ERE III - N°6 S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", existing under Luxembourg law, established and having its

registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
Such appearing party is the sole partner of "ERE III - N°7 S.à r.l." (hereinafter the "Company") a société à responsabilité

limitée having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 139.279, incorporated pursuant to
a deed of the undersigned notary on 12 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1619 of 2 July 2008.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to amend the company's name into "LIPP 1 S.à r.l.".
As a consequence, article 4 of Articles of Incorporation is modified and now reads as follows:

Art. 4. The Company will have the name "LIPP 1 S.à r.l.".

<i>Second resolution

The sole partner decides resolves to amend the nominal value of the existing shares in order to reduce said nominal

value from twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) per share to one Pound Sterling (GBP 1.-) per share, resulting in the
conversion of the existing six hundred and thirty (630) shares representing the entire Company's share capital into twelve
thousand six hundred (12,600) shares having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

The sole partner decides resolves to confer all necessary powers to the managers of the Company in order to proceed

to the conversion of the shares.

<i>Third resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Company's Articles is amended and now reads

as follows:

Art. 6. The subscribed capital is fixed at twelve thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 12,600.-) divided into

twelve thousand six hundred (12,600) shares, having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each."

<i>Fourth resolution

The sole partner decides to accept the resignation of Mr Peter CLUFF as Manager of the Company and to give it full

and complete discharge for the accomplishment of its duties as Manager up the date of this general meeting.

<i>Fifth resolution

The sole partner decides to appoint as manager for an unlimited period Mrs Zivana KRUSIC, employee, with profes-

sional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

97637

<i>Sixth resolution

The sole partner decides to appoint as independent auditor for an unlimited period "Deloitte S.A.", having its registered

office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

"ERE III - N°6 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son

siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

représentée par Monsieur Eric BIREN, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "ERE III - N°7 S.à r.l." (ci-après la "Société"), une société à respon-

sabilité  limitée  ayant  son  siège  social  au  68-70,  boulevard  de  la  Pétrusse,  L-2320  Luxembourg,  Grand-Duché  de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.279,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1619 du 2 juillet 2008.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en "LIPP 1 S.à r.l.".
En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 4. La Société aura la dénomination "LIPP 1 S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier la valeur nominale des parts sociales existantes afin de réduire ladite valeur no-

minale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) par part sociale à une Livre Sterling (GBP 1,-) par part sociale, ce dont il résulte
la conversion des six cent trente (630) parts sociales existantes représentant la totalité du capital social de la Société en
douze mille six cents (12.600) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés aux gérants de la Société pour procéder à ladite conversion des parts sociales.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'article 6 des Statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à douze mille six cents Livres Sterling (GBP 12.600,-), divisé en douze mille

six cents (12.600) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune."

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Peter CLUFF en tant que gérant de la Société et lui donne

décharge pleine et entière pour l'accomplissement de son mandat jusqu'au jour de la présente assemblée générale.

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide de nommer comme gérant pour une durée illimitée Madame Zivana KRUSIC, employée privée,

demeurant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide de nommer comme réviseur d'entreprise pour une durée illimitée la société "Deloitte S.A.",

ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

97638

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 septembre 2009. Relation: EAC/2009/10807. Reçu soixante-quinze Euros

(75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 21 septembre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009125596/105.

(090151082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2009.

ETF - EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4714 Pétange, 2, rue Eucosider.

R.C.S. Luxembourg B 51.824.

<i>Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration extraordinaire du 31.08.2009

Le conseil d'administration enregistre la démission au mandat d'Administrateur de:
- Monsieur DEHE Henri - 7, Rue Emile Augier - F-78110 LE VESINET (France)
Le conseil d'Administration nomme comme administrateur:
- Monsieur Jean-Pierre PASERI - 22, rue de Civry - F-75016 PARIS (France)
pour la durée du mandat de Monsieur Henri DEHE restant à courir, soit à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera

sur les comptes de l'exercice 2012.

<i>Actualisation des délégations de pouvoirs

Pouvoirs d'engager la société vis-à-vis des tiers
Vis-à-vis des tiers, la société sera valablement engagée selon les dispositions ci-après:
1. Tous actes dépassant la gestion journalière et plus particulièrement les actes d'aliénation ou d'échange de biens

immobiliers,  la  constitution  d'hypothèques  et  de  toutes  autres  garanties  réelles,  les  désistements  d'hypothèques,  les
renonciations à tous droits réels et à toutes actions résolutoires, les mainlevées avant comme après paiement de toutes
inscriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que les actes d'emprunt à long terme, devront porter la signature de deux
Administrateurs spécialement désignés à cet effet par le Conseil d'Administration.

Ont pouvoir de signer ces documents:
- Monsieur Jean-Pierre PASERI, Président, demeurant 22 rue de Civry, 75016 PARIS -FRANCE, Né le 29 avril 1963 à

PARIS (75018) - FRANCE

- Monsieur Jean-Marc REIBELL, Administrateur Délégué, demeurant 5 rue de Civry, 75016 PARIS - FRANCE, Né le

13 septembre 1966 à PARIS (75014) - FRANCE

- Monsieur Luc BODSON, Administrateur, demeurant 63 rue Saint Didier, 75116 PARIS, Né le 8 juillet 1961 à BOU-

LOGNE BILLANCOURT (92100) - FRANCE

2. Pour les actes relevant de la gestion journalière, dont les cautions bancaires et garanties d'un montant inférieur à

300.000 € (trois cent mille euros) par marché, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux des
trois porteurs de procuration générale désignés ci-dessous:

- Monsieur Guillaume LEBOUCHER, demeurant 39 rue de l'Amiral, 95000 CERGY - FRANCE, Né le 30 janvier 1971

à PARIS (75016) - FRANCE

- Monsieur Murry ROELAND, demeurant 42 Hoevestraat, B- 3040 OTTENBURG - BELGIQUE, Né le 19 février 1955

à AALST - BELGIQUE

- Madame Fabienne TINELLI, demeurant 16 rue de la terre noire, L-4842 RODANGE -LUXEMBOURG, Née le 5

janvier 1971 à PETANGE - LUXEMBOURG.

97639

Pétange, le 07 octobre 2009.

Pour extrait conforme
Murry ROELAND / Fabienne TINELLI
<i>Directeur d'Exploitation / Responsable Administratif et Finance

Référence de publication: 2009128023/42.
(090154336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Arnarbaeli &amp; Reilley &amp; Cie SNC, Société en nom collectif.

Capital social: EUR 1.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 139.390.

<i>Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 31 décembre 2008 que Arnarbaeli ehf. a transféré la

totalité de ses 435.750 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à:

- Amaravati Limited, une limited company, constituée et régie selon les lois de Chypre, enregistrée au Registrar of

Companies and Officiai Receiver, sous le numéro HE 243238, ayant son siège social au 284 Makarios Avenue, 3601
Limassol, Chypre.

Depuis cette date, les parts de la Société sont réparties comme suit:

Evalesco SGPS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000 parts sociales

Brinco Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000 parts sociales

Fonro Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500 parts sociales

Amaravati Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

435.750 parts sociales

Monsieur Thomas REILLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

435.750 parts sociales

Monsieur Luca LEONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2009.

Arnarbaeli &amp; Reilley &amp; Cie SNC
Signature

Référence de publication: 2009127160/25.
(090152922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Bonafide Invest G.m.b.h., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 148.324.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und neun, den zweiundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse BIEL, mit dem Amtsitz in Esch-sur-Alzette.

IST ERSCHIENEN:

Herr Thomas BACKS, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-80538 München, 6 St. Anna-Platz.
Welcher Komparent erklärte eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen und bat den unterfertigten

Notar folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.

Art. 1. Zweck - Benennung - Sitz - Dauer. Es wird hiermit eine Einpersonengesellschaft mit beschränkter Haftung

errichtet die geregelt wird durch die bestehenden Gesetze und namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie ihre
Abänderungsgesetze und durch vorliegende Statuten. Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.

Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Gegenstandzweck als Initiator von Investmentfonds und deren Advisor Anlageaus-

schusstätigkeiten bei Investmentfonds zu handeln und die Vermittlung von Versicherungsprodukten.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit einem ähnlichen oder komplementären Gesellschaftszweck

beteiligen und Filialen, Büros oder Zweigstellen in jedem europäischen Land aufrichten.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art ausüben,

soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft nimmt den Namen BONAFIDE INVEST G.m.b.h. an.

97640

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EUROS (12.500,- EUROS)

aufgeteilt in HUNDERT (100) Anteile zu je HUNDERT FÜNF UND ZWANZIG EUROS (125,- EUROS), vollständig und
in bar eingezahlt, was der Notar ausdrücklich bestätigt.

Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Sie sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft,

welche nur einen einzigen Besitzer für jede einzelne anerkennt. An Nichtgesellschafter ist die Übertragung von Anteilen
unter Lebenden lediglich mit dem Einverständnis aller Gesellschafter gestattet. Sollten eines Tages mehr Gesellschafter
vorhanden sein, so ist die Übertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter dem Einverständnis der Mitgesellschafter
unterworfen.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, welche die

ausgedehntesten Vollmachten haben um die Geschäfte der Gesellschaft zu führen und um die Disponierungs- und Ver-
waltungsakte auszuführen, welche den Gesellschaftszweck betreffen.

Art. 8. Geschäftsjahr - Inventar - Gewinnverteilung. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am ei-

nunddreissigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endigt am 31.
Dezember 2009.

Art. 9. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden

Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz welche den Inventar
zusammenfasst, ausgestellt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Verfügung des Nettogewinns, nach Überweisung von fünf Prozent des Gewinns

auf die gesetzliche Reserve.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit oder den Bankrott eines Gesellschafters

aufgelöst.

Art. 11. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden so wird die eventuelle Liquidation vom Geschäftsführer im Amt oder

von eimem Liquidator, der von der Generalversammlung der Gesellschaft bezeichnet wird, ausgeführt, unter Zugrund-
legung der Mehrheit welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder Abänderungsgesetzen festgelegt ist.
Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der
Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden nach Abzug der Passiva unter die Gesellschaftler im Verhältnis ihrer zukünftigen

Anteile aufgeteilt.

Art. 12. Für alle in den gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte verweisen die Parteien auf

die gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Kosten

Der alleinige Gesellschafter erkläre , dass die ungefähren Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art,

die der Gesellschaft bei ihrer Errichtung erwachsen oder die sie zu tragen hat, sich auf neunhundert euros (900,- euros)
belaufen.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleiniger Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zum technischen Geschäftsführer wird für eine unbegrenzte Dauer: Herr Thomas BACKS, vorbenannt, ernannt.
2.- Zum administrativen Geschäftsführer wird für eine unbegrenzte Dauer Herr Lothar ANTZ, Kaufmännischer An-

gestellter, wohnhaft in D-54293 Trier, 7 Mittelweg, ernannt.

3.- Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von den beiden vorbenannten Geschäftsführer vertreten.
4.- Der Gesellschaftssitz ist in L-6633 Wasserbillig, 74 route de Luxembourg.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat die Parteien darauf aufmerksam gemacht, dass der obengennante Gesellschaftszweck

einer ministeriellen Handelsermächtingung bedarf.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtig Urkunde

unterschrieben.

Signé: Backs; Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2009. Relation: EAC/ 2009/11460. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.-

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

97641

Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009126164/79.
(090152078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.

LuxReal - Real Estate Association of Luxembourg a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg F 8.097.

STATUTEN

<i>Gründung einer

<i>ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

<i>(A.S.B.L.)

Datum: 23. September 2009
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Ort: 2-4 Place de Paris,
L-1011 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
Zwischen den folgenden Personen und allen Personen, welche zu einem späteren Zeitpunkt laut den Bestimmungen

dieser Satzung als Mitglieder aufgenommen werden, wird eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet, welche durch
das abgeänderte Gesetz vom 21. April 1928 betreffend Vereinigungen und Stiftungen ohne Gewinnzweck bzw. dessen
Nachfolge-gesetzgebung (das "Gesetz") sowie durch folgende Satzung geregelt wird:

Anwesende Gründungsmitglieder:
a) Alexandra Brehm, 100, cité Grand Duc Jean, L-7233 Bereldange, Großherzogtum Luxemburg;
b) Daniel Engel, 126, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Großherzogtum Luxemburg;
c) Rene Ensch, 17, rue de l'Alzette, L-7210 Helmsange, Großherzogtum Luxemburg;
d) Xavier Hauboldt, 69, rue Alfred Pichon, F-57160 Scy-Chazelles, Frankreich;
e) Sandra Müller, 15, rue Notre Dame, L-2240 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
f) Sven Rein, 7, rue de Luxembourg, L-5364 Schrassig, Großherzogtum Luxemburg;
g) Thorsten Steffen, Am Rosenberg 11, D- 54331 Oberbillig, Bundesrepublik Deutschland;
h) Jürgen Wiegand, Kirschenstraße 27, D-66706 Perl, Bundesrepublik Deutschland.
Vertretene Gründungsmitglieder:
a) Catherine Rückel, 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vertreten durch Herrn Gün-

ter Simon per Vollmacht vom 23. September 2009.

(anwesende und vertretene Gründungsmitglieder bilden gemeinsam die "Gründungsmitglieder");

SATZUNG

VOM 23. SEPTEMBER 2009

§ 1. Name, Sitz und Geschäftsjahr.
(1) Der Name des Vereins lautet: „LuxReal - Real Estate Association of Luxembourg a.s.b.l." (der "Verein").
(2) Er hat seinen Sitz und seine Verwaltung in Luxemburg - Stadt. Der Vorstand kann die Adresse des Sitzes in den

Grenzen der Gemeinde Luxemburg-Stadt festlegen bzw. verlegen. Abweichend hiervon wird die erste Adresse des Sitzes
des Vereins von der Mitgliederversammlung festgelegt.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung des Vereins und endet

am 31. Dezember 2010.

§ 2. Vereinszweck.
(1) Zweck des Vereins ist:
(a) die Unterstützung der Mitglieder bei der Berufsausübung mit der Vertretung der gemeinsamen Interessen der

Mitglieder auf gesellschaftlicher und politischer Ebene,

(b) die Förderung der beruflichen Fort- und Weiterbildung, die Integration von Theorie und Praxis sowie der Profes-

sionalität,

(c) die Weiterentwicklung des Branchenstandards in der Immobilienwirtschaft in Übereinstimmung mit § 4 Abs. 3

dieser Satzung und

(d) die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Institutionen und Verbänden im Bereich der Immobilien-

wirtschaft.

97642

(2) Der Vereinszweck und die Förderung der in dem § 2 (1) dieser Satzung genannten Punkte wird insbesondere

verwirklicht durch:

(a) die Durchführung von Diskussionsforen zu aktuellen Themen,
(b) die Förderung des Ausbildungsniveaus der Mitglieder,
(c) die Förderung der Vernetzung durch Aufbau und Pflege von nationalen und internationalen Kontakten zum Erfah-

rungsaustausch.

§ 3. Gemeinnützigkeit.
(1) Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit gemäß § 2 dieser Satzung ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne des Gesetzes. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel des Vereins sind ausschließlich zu satzungsmäßigen Zwecken zu verwenden. Eine Gewinnausschüttung

an Mitglieder oder Dritte erfolgt nicht.

(3) Niemand darf durch Vereinsausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch unverhältismäßig hohe Ver-

gütungen  begünstigt  werden.  Für  den  Ersatz  von  Aufwendungen  ist,  soweit  nicht  andere  gesetzliche  Bestimmungen
anzuwenden sind, eine angemessene Entschädigung zu leisten. Im Einzelfall ist die Prüfung der Angemessenheit Sache des
Vorstandes.

(4) Bei Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung erfolgt keine Rückerstattung einge-

brachter Vermögenswerte.

(5) Eine Änderung des Vereinszwecks darf nur unter den im Rahmen der vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen

erfolgen.

§ 4. Mitglieder.
(1) Der Verein besteht aus:
a) Gründungsmitgliedern (Abs. 2),
b) ordentlichen Mitgliedern (Abs. 3),
c) fördernden Mitgliedern (Abs. 4) und
d) Ehrenmitgliedern (Abs. 5)
Die Mindestzahl der ordentlichen Mitglieder beträgt drei.
(2) Die Gründungsmitglieder sind im Anhang dieser Satzung aufgeführt. Die Gründungsmitglieder sind zugleich or-

dentliche oder fördernde Mitglieder.

(3) Für eine ordentliche Mitgliedschaft des Vereins kann sich jede natürliche Person bewerben, die einen beruflichen

Bezug zur Immobilienwirtschaft hat, so dass ein positiver Beitrag zur Erreichung der Vereinszwecke zu erwarten ist.

(4) Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person, juristische Person oder sonstige Einrichtung werden, die ein

Interesse an der Arbeit des Vereins bekundet.

(5) Mit Zustimmung der Mitgliederversammlung kann der Vorstand Kooperationspartner des Vereins oder herausra-

gende Persönlichkeiten für besondere Verdienste um den Verein oder die Verwirklichung der Vereinsziele zu Ehrenmit-
gliedern ernennen. Ehrenmitgliedern wird Befreiung von der Beitragspflicht gewährt.

§ 5. Aufnahmeverfahren.
(1) Aufnahmeanträge für eine Mitgliedschaft werden vom Antragsteller/der Antragstellerin an den Vorstand gerichtet.
(2) Aus dem Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft hat eine berufliche Tätigkeit des Antragstellers/der Antragstellerin

mit Bezug zur Immobilienwirtschaft hervorzugehen.

(3) Bei fördernden Mitgliedern sind im Aufnahmeantrag die Person zu benennen, die den Antragsteller/die Antrags-

tellerin vertreten soll.

(4) Über die Annahme des Aufnahmeantrags entscheidet der Vorstand im Rahmen der regelmäßigen Vorstandsitzun-

gen. Die Entscheidung über eine Aufnahme muss einstimmig getroffen werden.

§ 6. Rechte und Pflichten der Mitglieder.
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie haben in der Mitgliederver-

sammlung gleiches Stimmrecht.

(2) Falls ein Mitglied in Arbeitskreisen oder sonstigen Gremien des Vereins mitwirkt, in dem urheberrechtlich schutz-

fähige Werke er- oder bearbeitet werden, überlässt das Mitglied bereits jetzt sämtliche urheberrechtlichen Nutzungs-
und  Verwertungsrechte  dem  Verein  zur  ausschließlichen  Wahrnehmung.  Personen-vereinigungen  oder  juristische
Personen, die Mitglieder in Arbeitskreise oder sonstige Gremien im Sinne von vorstehend Satz 1 entsenden, verschaffen
dem Verein die aus dem in der Person des Mitarbeiters entstehenden Urheberrechte resultierenden Nutzungs- und
Verwertungsrechte zur ausschließlichen Wahrnehmung. Ein Anspruch des Mitgliedes oder des Mitarbeiters auf Beteiligung
an den vom Verein aus seiner Wahrnehmung dieser Rechte entstehenden Einnahmen entsteht nicht.

(3) In Ausübung der dem Verein gemäß § 6 Abs. 3 dieser Satzung zustehenden ausschließlichen Nutzungs- und Ver-

wertungsrechte an den in den Arbeitskreisen und sonstigen Gremien des Vereins erarbeiteten Arbeitsergebnissen räumt
der  Verein  allen  seinen  jeweiligen  Mitgliedern  das  nicht-ausschließliche  Recht  ein,  diese  Ergebnisse  im  Rahmen  ihrer

97643

eigenen gewerblichen oder sonstigen Erwerbstätigkeit für eigene Zwecke zu nutzen sowie in diesem Rahmen zu verviel-
fältigen und den eigenen Beschäftigten, jedoch keinen Dritten zugänglich zu machen. Eine Entgeltpflicht hierfür besteht
nicht.

§ 7. Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich im Voraus zu entrichten. Der maximale Betrag des Mitgliedsbei-

trags beträgt für ordentliche Mitglieder 300 Euro und für fördernde Mitglieder 3.000 Euro. Die Höhe des Mitgliedsbei-
trages setzt die Mitgliederversammlung fest.

§ 8. Erlöschen der Mitgliedschaft.
(1) Die Mitgliedschaft geht verloren durch
a) Tod,
b) freiwilligen Austritt,
c) Streichung aus der Mitgliederliste und
d) Ausschluss.
(2) Der freiwillige Austritt muss dem Vorstand schriftlich gemeldet werden.
(3) Mitglieder, die ihren Beitrag über das Ende des Vereinsjahres hinaus nicht entrichtet haben, können nach zweima-

liger erfolgloser Mahnung auf Beschluss des Vorstandes aus der Mitgliederliste gestrichen werden.

(4) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein

wichtiger Grund vorliegt. Ausschließungsgründe sind insbesondere grobe Verstöße gegen diese Satzung und Interessen
des Vereins.

§ 9. Organe des Vereins.
(1) Die Organe des Vereins sind:
i. die Mitgliederversammlung,
ii. der Vorstand und
iii. der Beirat.
(2) Auf Beschluss des Vorstands können weitere organisatorische Einrichtungen und Gliederungen, vor allem Aus-

schüsse mit besonderen Aufgaben geschaffen werden.

§ 10. Mitgliederversammlung.
(1) Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder an.
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Jedes Mitglied kann an einer Mitgliederversammlung teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied als Bevollmächtigten ernennt. Die Bevollmächtigung hat schriftlich zu erfolgen und ist für jede Mitglie-
derversammlung gesondert zu erteilen. Mehrfachvertretungen sind zulässig.

(3) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Die Einberufung muss mindestens vier Wochen

vor dem Termin der Versammlung erfolgen. Die Einberufung hat schriftlich in Form eines Briefes oder eines elektronischen
Mediums (E-mail) unter Beifügung einer Tagesordnung zu erfolgen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des
Einladungsschreibens folgenden Tag, es gilt das Datum des Poststempels oder das Absendedatum der E-mail. Das Einla-
dungsschreiben  gilt  dem  Mitglied  als  zugegangen,  wenn  es  an  die letzte  vom  Mitglied dem Verein  schriftlich bekannt
gegebene Post- oder Emailadresse gerichtet ist.

§ 12. Anträge.
Anträge an die Mitgliederversammlung aus der Reihe der Mitglieder sind mindestens fünf Tage vor Zusammentritt der

ordentlichen Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich mit kurzer Begründung einzureichen.

§ 13. Ordentliche Mitgliederversammlung, Außerordentliche Mitgliederversammlung.
(l)Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.
(2) Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Auf schriftliches Verlangen von min-

destens  einem  Zehntel  aller  Mitglieder  muss  der  Vorstand  unter  Angabe  der  vorgeschlagenen  Tagesordnung  eine
Mitgliederversammlung einberufen. Außerdem muss der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung einbe-
rufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert.

§ 14. Aufgaben und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung.
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ des Vereins.
(2) Soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung spezifische Erfordernisse das Anwesenheitsquorum betreffend vorse-

hen,  ist  bei  ordnungsgemäßer  Einladung  die  Mitgliederversammlung  ohne  Rücksicht  auf  die  Anzahl  der  erschienenen
Mitglieder beschlussfähig. Soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung spezifische Mehrheitserfordernisse vorsehen, wer-
den Beschlüsse grundsätzlich durch Handzeichen mit einfacher Stimmenmehrheit in Einklang mit Abs. (9) getroffen.

(3) Die Mitgliederversammlung ist für alle Aufgaben zuständig, sofern diese nicht gemäß der Satzung einem anderen

Vereinsorgan übertragen wurden und beschließt über:

a) Zweck des Vereins,

97644

b) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich,
c) die Genehmigung des Jahresabschlusses,
d) die Entlastung des Vorstandes,
e) die Neuwahl des Vorstandes,
f) Satzungsänderungen,
g) die Festsetzung der Beiträge der persönlichen Mitglieder,
h) die Festsetzung der Beiträge der fördernden Mitglieder,
i) Gebührenbefreiungen,
j) Anträge an die Mitgliederversammlung durch den Vorstand und von persönlichen sowie fördernden Mitgliedern,
k) den Ausschluss von Mitgliedern und
1) die Auflösung des Vereins.
(4) Die Mitgliederversammlung wählt aus der Reihe der Mitglieder den Vorstand. Gewählt sind die Personen, die die

meisten der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. Die Wahl findet geheim auf Stimmzetteln statt.

(5) Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des Vorstands abwählen. Zur Abwahl von Mitgliedern des Vorstands

sind 3/4 der in der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen, mindestens die Mehrheit aller Mitglieder erforderlich.

(6) Die Mitgliederversammlung nimmt den jährlich vorzulegenden Geschäftsbericht des Vorstands und den Prüfungs-

bericht  des  Rechnungsprüfers  entgegen  und  erteilt  dem  Vorstand  Entlastung.  Ihr  sind  die  Jahresrechnung  und  der
Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstands schriftlich vorzulegen. Sie
bestellt einen Rechnungsprüfer, der weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehört und
auch nicht Angestellter des Vereins sein darf. Der Rechnungsprüfer hat die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu
prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. Der Rechnungsprüfer hat Zugang zu allen
Buchungs- und Rechnungsunterlagen des Vereins.

(7) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Änderung der Satzung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen

Stimmen. Anträge auf Satzungsänderung müssen den Text der vorgeschlagenen Satzungsänderungen enthalten und mit
der Einladung zur Mitgliederversammlung rechtzeitig (4 Wochen vor der Mitgliederversammlung) den Mitgliedern zuge-
sandt  werden.  Wenn  2/3  der  Mitglieder  in  der  Versammlung  nicht  anwesend  sind,  muss  eine  erneute  Versammlung
einberufen werden. Hierin können über Satzungsänderungen mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen, ohne
Anwesenheitsquorum, abgestimmt werden. Soweit gesetzlich erforderlich, ist diese Entscheidung durch das Tribunal Civil
zu genehmigen. Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen können Änderungen des Vereinszwecks nur unter
den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen beschlossen werden.

(8) Bei einer Mitgliederversammlung, die über die Auflösung des Vereins entscheiden soll, ist dies als separater Punkt

in der Tagesordnung aufzuführen. Die Mitgliederversammlung wird über die Auflösung unter den für Statutenänderungen
vorgesehenen Bedingungen entscheiden.

(9) Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet im Falle einer

Wahl das Los, in anderen Fällen die Stimme des Vorsitzenden bzw. des die Versammlung leitenden Vorstandsmitgliedes.

(10) Über den Ablauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von dem die

Versammlung leitenden geschäftsführenden Vorstand, dem Protokollführer und dem Sekretär zu unterzeichnen ist.

§ 15. Vorstand.
(1) Der Vorstand besteht aus bis zu zehn Mitgliedern (§15 (1) a-e)) und sollte, die aus den unterschiedlichen Bran-

chenbereichen kommenden, im Verein vertretenen Gruppen repräsentieren:

a) dem Vorsitzenden,
b) dem Stellvertreter,
c) dem Schriftführer,
d) dem Schatzmeister und
e) bis zu sechs weiteren Vorstandsmitgliedern.
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung in der Weise gewählt, dass in getrennten Wahlgängen zunächst

der Vorsitzende, sodann der Stellvertreter und dann die übrigen Vorstandsmitglieder gewählt werden. Mit Ausnahme des
Vorsitzenden und des Stellvertreters verteilt der Vorstand die Funktionen unter sich. Die Mitgliederversammlung kann
durch Beschluss getrennte Wahlgänge beschließen.

(3) Die Vorstandsarbeit ist ehrenamtlich. Auf Antrag wird lediglich eine Aufwandsentschädigung von externen Kosten

gegen Beleg gewährt.

(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.
(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so übernimmt ein anderes Vorstandsmitglied

dessen Aufgaben oder die Position kann vorübergehend von den restlichen Vorstandsmitgliedern durch Ernennung eines
Beiratsmitglieds zum vorübergehenden Vorstandsmitglied gefüllt werden, sofern das Beiratsmitglied auch Mitglied des
Vereins  ist.  Die  Wahl  eines  neuen  Vorstandsmitglieds  erfolgt  sodann  bei  der  nächsten  Mitglieder-Versammlung.  Die
jeweils gewählten Vorstandsmitglieder bleiben im Amt, bis Nachfolger gewählt sind.

97645

(6) Eine Ämterhäufung auf eine Person des Vorstands wird zugelassen. Der Vorsitzende darf kein weiteres Amt im

Vorstand innehaben.

(7) Der Vorstand kann einen Beirat mit bis zu fünf Mitgliedern bestellen, die nicht notwendigerweise Mitglieder des

Vereins sein müssen. Der Vorstand kann beschließen, dass in der jeweils nächsten Mitgliederversammlung Beiratsmit-
glieder in den Vorstand gewählt werden sollten, sofern diese Beiratsmitglieder auch Mitglieder des Vereins sind. Der
Beirat erfüllt gegenüber dem Vorstand eine beratende Funktion, ohne dass der Vorstand in seinen Entscheidungen an
Empfehlungen des Beirats gebunden ist. Beiratsmitglieder sind zur Teilnahme an Vorstandssitzungen berechtigt. Beirats-
mitglieder haben kein Stimmrecht in Vorstandssitzungen.

§ 16. Geschäftsbereich des Vorstandes.
(1) Der Vorstand des Vereins hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Vereinszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten des Vereins, soweit
sie nicht vom Gesetz oder nach dieser Satzung der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

(2) Der Vorsitzende und der Stellvertreter sind geschäftsführende Vorstände. Der Verein wird grundsätzlich durch

die gemeinsame Unterschrift von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter zusammen mit einem weiteren Vors-
tandsmitglied  rechtsverbindlich  verpflichtet,  diese  sind  gemeinschaftlich  zur  Vertretung  des  Vereins  berechtigt  und
vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten, soweit erforderlich nach Maßgabe
der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

(3) Ferner kann der Vorstand Spezialvollmachten an Personen, die nicht notwendigerweise Mitglieder des Vorstands

sein müssen, ausstellen.

(4) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus.
(5) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 17. Beschlussfassung des Vorstandes.
(1) Der Vorstand trifft sich zu regelmäßigen Vorstandssitzungen, die jedoch mindestens einmal pro Quartal stattfinden

sollten. Die Sitzung des Vorstands wird geleitet vom Vorsitzenden, sowie in Abwesenheit des Vorsitzenden von dem
stellvertretenden Vorsitzenden.

(2) Die Einberufung der Vorstandssitzung erfolgt mit einer Frist von mindestens einer Woche vor Beginn der anbe-

raumten  Sitzung  durch  schriftliche  Benachrichtigung  aller  Vorstandsmitglieder.  In  dringlichen  Fällen  kann  von  der
Einhaltung dieser Frist abgesehen werden, sofern die Hintergründe solcher Umstände in der schriftlichen Benachrichtigung
über die Einberufung der Sitzung mitgeteilt wurden.

Auf eine schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Vorstandsmitglieder dem schriftlich oder telegra-

phisch, durch Telegramm, Telex oder Telefax zustimmen. Hat der Vorstand durch Beschlussfassung im voraus einen Plan
über die künftig abzuhaltenden Vorstandssitzungen mit Orts- und Zeitangabe aufgestellt, ist eine gesonderte Einladung zu
den einzelnen Sitzungen nicht erforderlich.

(3) Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, darunter

mindestens einer der geschäftsführenden Vorstände. Ein Vorstandsmitglied kann sich durch ein anderes Vorstandsmitglied
vertreten lassen, das dazu durch Brief, Telegramm oder Telefax bevollmächtigt wurde. Ein Vorstandsmitglied kann meh-
rere Vorstandsmitglieder vertreten.

(4) Schriftliche und von allen Vorstandsmitgliedern genehmigte und unterzeichnete Beschlüsse stehen in Vorstandssi-

tzungen gefassten Beschlüssen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Vorstandsmitglied schriftlich, durch Brief,
Telegramm, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel durch Unterzeichnung genehmigt werden. Die schriftlichen
Genehmigungen sind dem Beschlussprotokoll beizufügen und dienen als Nachweis der Zustimmung zu dem Beschluss.

(5) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet

die Stimme des Vorsitzenden des Vorstands bzw. in seiner Abwesenheit die des Stellvertreters.

§ 18. Dauer, Auflösung des Vereins.
(1) Der Verein wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
(2) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer satzungsmäßig berufenen Mitgliederversammlung unter Einhaltung

der Regeln des § 14 dieser Satzung beschlossen werden.

(3) Für den Fall der Auflösung des Vereins werden die Mitglieder des Vorstandes zu Liquidatoren ernannt. Zur Bes-

chlussfassung der Liquidatoren ist Einstimmigkeit erforderlich. Rechte und Pflichten der Liquidatoren bestimmen sich im
übrigen nach den Vorschriften des Gesetzes.

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins ist das Vermögen einem anderen luxemburgischen Verein ohne Ge-

winnzweck, welcher ein dem Verein ähnlichen oder einen sonstigen philanthropischen Zweck hat, zu übertragen.

§ 19. Protokolle.
(1) Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederversammlung sind schriftlich zu protokollieren und den Mitgliedern

auf Verlangen zur Einsicht zur Verfügung zu stellen.

97646

(2) Dritte, welche ein berechtigtes Interesse an Beschlüssen der Mitgliederversammlung beweisen können, können

Auszüge aus den Protokollen der Mitgliederversammlung anfragen. Beschlüsse, welche laut gesetzlichen Bestimmungen
veröffentlicht werden, werden in den durch das Gesetz vorgesehenen Formen veröffentlicht.

(3) Die Sitzungsprotokolle des Vorstands sind vom Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung und

einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. Vollmachten sind dem Protokoll anzuheften. Der Vorsitzende des
Vorstands oder zwei Vorstandsmitglieder sind ermächtigt, Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle zu unter-
zeichnen.

§ 20. Allgemeines. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden im Einklang mit dem Gesetz und

sonstigen anwendbaren Gesetzen entschieden.

§ 21. Inkrafttreten der Satzung. Vorstehende Satzung wurde von der Gründungsversammlung in Luxemburg, am 23.

September 2009 beschlossen.

<i>Anhang

<i>Gründungsmitglieder

Die Gründungsmitglieder des Vereins sind:
- Alexandra Brehm, 100, cité Grand Duc Jean, L-7233 Bereldange, deutsch;
- Daniel Engel, 126, rue du Kiem, L-8030 Strassen, luxemburgisch;
- Rene Ensch, 17, rue de l'Alzette, L-7210 Helmsange, luxemburgisch;
- Xavier Hauboldt, 69, rue Alfred Pichon, F-57160 Scy-Chazelles, französisch;
- Sandra Müller, 15, rue Notre Dame, L-2240 Luxemburg, deutsch;
- Sven Rein, 7, rue de Luxembourg, L-5364 Schrassig, deutsch;
- Catherine Rückel, 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg, deutsch;
- Thorsten Steffen, Am Rosenberg 11, D- 54331 Oberbillig, deutsch;
- Jürgen Wiegand, Kirschenstraße 27, D-66706 Perl, deutsch.
Référence de publication: 2009126634/297.
(090152788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Rover International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 45.731.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 1 

<i>er

<i> octobre 2009.

<i>Résolutions:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2009 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

Mmes Silvia Ferrero, administrateur de sociétés, demeurant Via G. Galilei 26, I-10036 Settimo Torinese (Italie), pré-

sident;

Irène Acciani, employée privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, administrateur;

MM. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, administrateur;

Francesco Molaro, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-

xembourg, administrateur;

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009127049/27.
(090152986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

97647

ARMAND RACCOGLI et SERVAIS STEMPER &amp; Cie (Bureau d'Assurances), Société Civile Particulière.

Siège social: L-7374 Bofferdange, 201, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg E 2.096.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf. Le dix-sept septembre.
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Armand RACCOGLI, assureur, né à Luxembourg, le 3 juillet 1957, demeurant à L-7374 Bofferdange, 201,

route de Luxembourg..

2.- Monsieur Servais STEMPER, assureur, né à Dudelange, le 22 mai 1953, demeurant à L-3514 Dudelange, 250A, route

de Kayl.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
a) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société civile particulière "ARMAND RACCOGLI ET SERVAIS STEM-

PER &amp; Cie (BUREAU D'ASSURANCES)" (No. Matricule 19977000583), avec siège social à L-7374 Bofferdange, 201, route
de Luxembourg;

inscrite au Registre de Commerce sous le numéro E 2.096;
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit alors de résidence à Hespérange en date du 14 avril 1997,

publié au Mémorial C de 1997, page 19.355;

b) Que d'un commun accord les prédits associés de la société civile particulière "ARMAND RACCOGLI ET SERVAIS

STEMPER &amp; Cie (BUREAU D'ASSURANCES)" ont décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés
étant investis proparte des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de CINQ (5) années à L-3514 Dudelange,

250A, route de Kayl. Les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu'il
n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Raccogli, Stemper, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 18 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11004. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce

et des Sociétés.

Bettembourg, le 22 septembre 2009.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2009128315/38.
(090154364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Fondation FNEL, Fondation.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 43, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg G 77.

Etablissement d'utilité publique

<i>Comptes annuels au 31 juillet 2007 et Rapport du réviseur d'entreprises

<i>Bilan au 31 juillet 2007 (en euros)

ACTIF

Note(s)

2007

2006

EUR

EUR

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Concessions, brevets, licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 280,41

713,11

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 359 824,60 1 401 477,51

Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 194,76

10 477,45

97648

Immobilisations corporelles en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

15 233,99

1 368 019,36 1 427 188,95
1 369 299,77 1 427 902,06

Actif circulant
Créances
Autres créances
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 865,78

3 956,11

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques
et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174 004,61

188 948,43

189 870,39

192 904,54

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 333,54

---

1 560 503,70 1 620 806,60

PASSIF
Capitaux propres
Fond social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

14 873,61

14 873,61

Réserves
Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

122 648,37

122 648,37

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 781,17

(11 947,61)

Déficit/ excédent de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 544,53)

23 728,78

Subventions et dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1 383 881,67 1 471 180,82
1 531 640,29 1 620 483,97

Dettes
Dettes sur achats et prestations de services
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 863,41

322,63

Autres dettes
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 000,00

---

1 560 503,70 1 620 806,60

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

<i>Compte de profits et Pertes pour l'exercice se clôturant au 31 juillet 2007 (en euros)

CHARGES

Note(s)

2007

2006

EUR

EUR

Consommation de marchandises, de matières premières et consommables . . .

34 720,69

41 087,48

Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 863,66

32 498,41

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188 820,62

181 900,84

Charges sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 198,62

22 399,89

Autres charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,00

---

212 419,24

204 300,73

Corrections de valeur sur immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,4

corporelles et incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 633,40

72 370,99

Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 994,53

13 382,99

Excédent de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

23 728,78

394 631,52

387 369,38

PRODUITS
Montant net du chiffre d'affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 604,39

35 260,37

Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

338 615,48

347 624,54

Autres intérêts et produits assimilés
autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 662,93

3 457,05

Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

4 204,19

1 027,42

Déficit de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 544,53

---

394 631,52

387 369,38

97649

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.
Référence de publication: 2009126683/70.
(090152818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

S.O.G.I.L., Société Générale Immobilière Luxembourgeoise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3442 Dudelange, 13, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 73.870.

Le bilan arrêté au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 2 octobre 2009.

<i>Pour Société Générale Immobilière Luxembourgeoise SARL
Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman

Référence de publication: 2009126999/13.
(090152647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

L.T.T. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 67.920.

EXTRAIT

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de LTT HOLDING S.A. tenue le 3 août 2009 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:
- Le Conseil d'Administration approuve la démission de Madame Natacha Steuermann en sa qualité d'administrateur

de la Société et décide de coopter en remplacement Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant pro-
fessionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

- Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010.
- Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Madame Véronique Wauthier, Madame Delphine Goergen, Madame Cristina Floroiu et Monsieur Didier Schönberger

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009127003/19.
(090152884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Maine Coon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 77.750.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale

<i>extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 28 septembre 2009

La démission de Monsieur Lorenzo GIANELLO de son poste d'administrateur de la société est acceptée.
Monsieur Daniele MARIANI, employé privé, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur

de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme
MAINE COON S.A.
Régis DONATI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2009127004/16.
(090152838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

97650

Corton Meyney S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 67.894.

EXTRAIT

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société CORTON MEYNEY S.A. qui s'est tenue en date du

<i>3 août 2009.

Il a été décidé ce qui suit:
- Le Conseil d'Administration approuve la démission de Madame Natacha Steuermann en sa qualité d'administrateur

de la Société et décide de coopter en remplacement Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant pro-
fessionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

- Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010.
- Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Madame Véronique Wauthier, Madame Delphine Goergen et Monsieur Didier Schönberger

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009127005/20.
(090152885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Grosvenor First European Property Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 60.935.

EXTRAIT

- Il est à prendre en compte que le mandat de la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. en tant que commissaire aux

comptes a expiré le 14 octobre 2008 et n'a pas été renouvelé.

- Il résulte du procès-verbal d'une réunion des actionnaires de la Société tenue en date du 31 juillet 2009 les décisions

suivantes:

*  Reconnaître et  accepter la  démission  de M. Stephen Cowen en  tant qu'administrateur de  la Société,  avec  effet

immédiat; et

* Nommer M. Mark Robin Preston, né le 20 janvier 1968 à Weston, Grande-Bretagne, et ayant son adresse profes-

sionnelle au 70 Grosvenor Street, WK1 3JP London, Grande-Bretagne, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet
immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009127006/21.
(090152896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Carson Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 147.048.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 25 septembre 2009

Monsieur PIZZOLA Fabrizio, profession libérale, 1, Via N. Gialdi, I - 43036 Fidenza (Italie), est nommé administrateur

de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme
CARSON HOLDING S.A.
Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009127008/14.
(090152707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

97651

Mira Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 95.966.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue en date du 03 mars 2008

<i>Commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale décide, avec effet immédiat, de révoquer la société International Allied Services ayant son siège

social à L-9544 Wiltz, 2 Rue Hannelaast de ses fonctions de commissaire aux comptes.

L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, la société MGI FISOGEST Sàrl, ayant son siège social

à L-2311 Luxembourg, 55-57, Avenue Pasteur, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B20114, aux fonctions de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Luxembourg, le 03 mars 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2009127012/16.
(090152506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Wouterbos N.V., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 57.842.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 septembre 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Peter Gerard SIJBEN, directeur, demeurant au 15, Wouterbos, B-3680 Opoeteren, Belgique, Président;
- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, Luxembourg;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- EWA Révision S.A., société anonyme, 45, avenue J-F Kennedy, L-9053 Ettelbruck.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009127014/20.
(090152520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Carts &amp; Kiosks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 147.062.

<i>Extrait des résolutions des associées prises en date du 10 septembre 2009

1. Le nombre de gérants a été augmenté de deux (2) à quatre (4).
2.  M.  Marc  BAUWENS,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Sint  Gillis-Waas  (Belgique),  le  21  avril  1947,  demeurant

professionnellement à B-2630 Aartselaar (Belgique), 61, Gustaaf De Smetlaan, a été nommé comme gérant pour une
durée indéterminée.

3. M. Gary BOND, administrateur de sociétés, né à Windlesham (Royaume-Uni), le 21 septembre 1960, demeurant

professionnellement à GB-W1H 6AG Londres (Royaume-Uni), 43/4, Portman Square, Hesketh House, a été nommé
comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 30 SEP. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Carts &amp; Kiosks S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009127031/20.
(090152801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

97652

S.I.A., SOCIETE INTERNATIONALE D'ARCHITECTURE, société d'architectes interprofessionnelle,

Société Anonyme.

Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.

R.C.S. Luxembourg B 52.229.

L'assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2009 a accepté la démission de la société BTG CONCEPT S.A. de la

fonction d'administrateur de la société.

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

<i>Pour la société
Jean-Michel Dangis
<i>Comptable

Référence de publication: 2009127017/14.
(090152914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 108.922.

In the year two thousand and nine.
On the eleventh day of September at 08.55 a.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on February 26, 2007 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I.- The company PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having

its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B108922, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 30 

th

 of June 2005,

published in the Memorial C number 688 of the 13 

th

 of July 2005, and whose articles of incorporation have been amended

by deed of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of eight million three hundred and twenty thousand two hundred and seventy-

four Euro and eighty-three cents (8,320,274.83.- EUR) represented by twenty-seven thousand six hundred and forty-
seven point fifty-one (27,647.51) Manager Shares and one hundred and thirty-eight thousand seven hundred and fifty-
eight point zero one (138,758.01) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of fifty million Euro (50,000,000.- EUR) divided into:
- nine hundred thousand (900,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- one hundred thousand (100,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

97653

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on February 26, 2007 the General Manager has decided to increase, within the limits

of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of nine hundred and two thousand four
hundred and thirty-six Euro and sixty-three cents (902,461.36.- EUR), in order to raise it from its present amount of eight
million three hundred and twenty thousand two hundred and seventy-four Euro and eighty-three cents (8,320,274.83.-
EUR) to the amount of nine million two hundred and twenty-two thousand seven hundred and thirty-six Euro and nineteen
cents (9,222,736.19.- EUR) by issuing:

- fifteen thousand one hundred and six point fifty (15,106.50) new Ordinary Shares having a par value of fifty Euro (50.-

EUR) each, issued with a total share premium of fourteen million three hundred and fifty-one thousand one hundred and
seventy-five Euro (14,351,175.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;

- two thousand nine hundred and forty-two point seventy-three (2,942.73) Manager Shares having a par value of fifty

Euro (50.- EUR) each, issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of nine hundred and two
thousand four hundred and sixty-one Euro and thirty-six cents (902,461.36.- EUR) as well as the amount of fourteen
million three hundred and fifty-one thousand one hundred and seventy-five Euro (14,351,175.- EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital. (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of nine million two hundred and twenty-two thousand seven hundred and

thirty-six Euro and nineteen cents (9,222,736.19.- EUR) represented by thirty thousand five hundred and ninety point
twenty-four (30,590.24) Manager Shares and one hundred and fifty-three thousand eight hundred and sixty-four point
fifty-one (153,864.51) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand two hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den elften September um 08.55 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.

97654

Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 26. Februar 2007 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP GLOBAL
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B108922, wurde gegründet gemäss
Urkunde  aufgenommen  durch  Notar  Henri  HELLINCKX,  mit  dem  damaligen  Amtssitz  in  Mersch,  am  30.  Juni  2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 688 vom 13. Juli 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von acht Millionen drei hundert zwanzig tausend zwei hundert vier und siebzig

Euro drei und achtzig Cents (8.320.274,83.- EUR), eingeteilt in sieben und zwanzig tausend sechs hundert sieben und
vierzig Komma ein und fünfzig (27.647,51) Manager-Aktien und ein hundert acht und dreissig tausend sieben hundert acht
und fünfzig Komma null eins (138.758,01) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfzig Millionen Euro (50.000.000.- EUR) und ist aufgeteilt

in:

- neun hundert tausend (900.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie; und
- ein hundert tausend (100.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000.- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950.- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50.- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 26. Februar 2007 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des ge-

nehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um neun hundert zwei tausend vier hundert ein sechzig Euro sechs und
dreissig Cents (902.461,36.- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von acht Millionen drei hundert zwanzig
tausend zwei hundert vier und siebzig Euro drei und achtzig Cents (8.320.274,83.- EUR) auf neun Millionen zwei hundert
zwei und zwanzig tausend sieben hundert sechs und dreissig Euro neunzehn Cents (9.222.736,19.- EUR) zu bringen durch
die Ausgabe von:

- fünfzehn tausend ein hundert sechs Komma fünfzig (15.106,50) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je

fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von vierzehn Millionen drei hundert ein und fünfzig
tausend ein hundert fünf und siebzig Euro (14.351.175.- EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft
zugeteilt wird;

- zwei tausend neun hundert zwei und vierzig Komma drei und siebzig (2.942,73) Manager-Aktien mit einem Nomi-

nalwert von je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von neun hundert zwei
tausend vier hundert ein sechzig Euro sechs und dreissig Cents (902.461,36.- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von
vierzehn Millionen drei hundert ein und fünfzig tausend ein hundert fünf und siebzig Euro (14.351.175.- EUR) als Emissi-
onsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

97655

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von neun Millionen zwei hundert zwei und zwanzig tausend sieben hundert

sechs und dreissig Euro neunzehn Cents (9.222.736,19.- EUR), eingeteilt in dreissig tausend fünf hundert neunzig Komma
vier und zwanzig (30.590,24) Manager-Aktien und ein hundert drei und fünfzig tausend acht hundert vier und sechzig
Komma ein und fünfzig (153.864,51) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

fünftausend zwei hundert Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: RÖSSLER; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2009. Relation GRE/2009/3323. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Junglinster, den 29. September 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009125636/176.

(090151668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2009.

Doosan Heavy Industries European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.754.

Veuillez prendre note que le siège social du commissaire aux comptes, la société anonyme KPMG AUDIT, a été

transféré au L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer.

Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Doosan Heavy Industries European Holdings S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) SA.
Signatures

Référence de publication: 2009127025/14.
(090152854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Dory 1 (NFR) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 116.773.

EXTRAIT

Il est à noter que le siège social de l'associé CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P. est désormais au 399 Park Avenue,

th

 floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique.

Luxembourg, le 20 août 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.
<i>Gérant

Référence de publication: 2009127032/13.
(090153188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

97656

K.B. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4756 Pétange, 8, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 147.707.

<i>Extrait de la démission du gérant technique de la société.

Par courrier à la société et aux associés du 02 octobre 2009, M. Rahmi BOLER, demeurant à F-57270 Uckange (France),

1B, Lotissement de la Voie Romaine gérant technique de la société, a décidé de démissionner de son poste avec effet au
02 octobre 2009.

- Depuis cette date Monsieur Izzet KARABULUT est gérant unique de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 octobre 2009.

K.B. S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009127033/18.

(090152758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Guyana Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 114.457.

EXTRAIT

Il est à noter que les associés suivants ont changé d'adresse comme suit:

Singh Sudeep Kumar, son adresse étant désormais 8, Devonshire Place, W8 5UD London, Royaume-Uni;

Mehta Kumar Chimanlal, son adresse étant désormais Villa 63, Street 17C, al Barsha 2, Dubai, Emirats Arabes Unis

Luxembourg, 24 septembre 2009.

Vincent Bouffioux
<i>Gérant

Référence de publication: 2009127034/14.

(090153193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Pearson Luxembourg N°. 1., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.137.

A la suite de la cession en date du 18 septembre 2009 des 10.000 parts sociales détenues par Pearson Overseas

Holdings Ltd, celles-ci sont dorénavant toutes détenues par:

- Pearson plc, avec siège social à 80, Strand, GB-WC2R 0RL (Royaume-Uni), Londres, inscrite auprès du "Companies

House" sous le numéro 00053723.

Luxembourg, le 01/10/2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Pearson Luxembourg N°1.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009127035/16.

(090152670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

97657

Banque LBLux, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 11.035.

<i>Auszug aus dem Beschlussprotokoll Nr. 514 vom 11. Mai 2009 des Verwaltungsrates der Banque LBLux S.A.

Vorbehaltlich  der  Zustimmung  durch  die  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier  (CSSF)  beschließt  der

Verwaltungsrat, mit Wirkung zum 15. Mai 2009, den Vorsitz des Verwaltungsrates Herrn Stefan Ermisch zu übertragen.

Für die Richtigkeit des Auszuges
Norbert Palsa / Bernd-Dieter Bützow
<i>Directeur / Conseiller Juridique

Référence de publication: 2009127037/13.
(090152602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Argance S.àr.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 130.053.

Le 11 juin 2009, la société anonyme BGL, associée unique de la Société, ayant son siège social au 50, avenue J.F. Kennedy,

L-2951 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.481, a modifié
sa dénomination sociale en BGL BNP Paribas avec effet au 21 septembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2009.

<i>Pour la Société
Pascal HOBLER

Référence de publication: 2009127133/15.
(090152588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

MZ Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 102.499.

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 29 septembre 2009

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société MAZARS, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg

aux fonctions de réviseur externe en application de l'article 22 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle
qu'elle a été modifiée.

Le mandat ainsi conféré viendra à terme lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'année 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009127149/14.
(090153210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

IWFC S.A., International Wires For Companies S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 63.636.

- Monterey Audit Sàrl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société:
IWFC S.A., International Wires For Companies S.A., R.C.S. Luxembourg B 63.636, domiciliée 29, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2009.

Philippe GAIN
<i>Gérant

Référence de publication: 2009127068/12.
(090153117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

97658

R.H. Conseil Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.

R.C.S. Luxembourg B 81.887.

<i>Extraits des principales résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire

<i>le 22 septembre 2009

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse de Monsieur Patrick Sganzerla, gérant administratif, a été modifiée.
Monsieur Sganzerla a désormais pour adresse professionnelle le 17, rue des Jardiniers à L-1835 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.
17, rue de Jardiniers
B.P.2650 L-1026 Luxembourg
Patrick Sganzerla
<i>Gérant

Référence de publication: 2009127142/18.
(090152483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Lux T.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 11.570.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 4 mars 2009

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de coopter Monsieur Didier HANS, né le 10 juillet 1954 à Verviers

(Belgique) et demeurant professionnellement 151, route de Falize B-4960 Malmedy (Belgique), comme administrateur de
LUX T.P. S.A. pour reprendre le mandat de Monsieur Gaëtan PEETERS, né le 9 août 1958 à Anvers (Belgique), démis-
sionnaire.

Le mandat de Monsieur Didier HANS viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2009127148/17.
(090153207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

RSL, Recherches Scientifiques Luxembourg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg F 225.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2009

(1) Acceptation de modifier à partir du 1 

er

 janvier 2010 l'article 17 des statuts de l'association de la manière suivante:

« Art. 17. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre. Les comptes de l'association sont arrêtés

au 31 décembre de l'année en cours».

(2) Partie de l'article 9 des statuts est modifié comme suit (modification de la première phrase):
«L'assemblée générale se réunit en session ordinaire au mois de mars et en session extraordinaire chaque fois que le

conseil d'administration l'estime nécessaire ou que la demande écrite au président en est faite par un cinquième des
membres associés».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Fibetrust
Jean Beissel

Référence de publication: 2009127127/18.
(090153000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

97659

TSA Mexican Funds S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 116.101.

In the year two thousand and nine, on the ninth day of September,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Ms. Catherine Cadet, private employee, residing professionally in Luxembourg, acting as special mandatory of the

managers of TSA Mexican Funds S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, by deed of Maître Paul Bettingen, notary, deed dated
10 April 2006, published in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Mémorial C") number 1308, of
6 July 2006 and registered with the Luxembourg Register of trade and companies under the number B 116.101 (the
"Company"), by virtue of a resolution of the board of managers dated 8 September, 2009, which shall remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities.

The Company's articles of incorporation have been lastly amended by deed of the undersigned notary on 10 July 2009,

published in the Mémorial C number 1641 of 26 

th

 August 2009.

The special mandatory of the Company has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The Company's subscribed capital is set at one million three hundred seventy eight thousand nine hundred thirty

one Euros (EUR 1,378,931.-) represented by one million three hundred seventy eight thousand nine hundred thirty one
(1,378,931 ) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

II. Pursuant to Article 5 of the articles of association of the Company (the "Articles"), the company's board of managers

is authorised to increase in one or more steps, and within the limits of the authorised share capital, the share capital by
an additional amount of fourteen million three hundred eighty nine thousand eight hundred eighty eight Euros (EUR
14,389,888.-). This increase of the share capital decided by the board of managers within the limitations of the authorised
share capital may be subscribed for, and shares may be issued with, or without issue premium and paid up by contribution
in kind or in cash or in any other way determined by the board of managers.

On the basis of the powers granted to the company's board of managers as set out here above, the board of managers

has resolved by resolutions taken on 8 September 2009, that the Company's share capital shall be increased by an amount
of three hundred fifty six thousand one hundred five Euros (EUR 356,105.-), being the equivalent of five hundred ten
thousand United States Dollars (USD 510,000.-), up to an amount of one million seven hundred thirty five thousand and
thirty six Euros (EUR 1,735,036.-) by way of issuance of three hundred fifty six thousand one hundred five (356,105) new
shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares (the
"New Shares").

All new shares have been subscribed by the Company's sole shareholder Tamweelview S.A., a public company limited

by shares (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 13, rue Edward Steichen, 1 

st

 Floor, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered

with the Luxembourg register of trade and companies under number B 66.944, and fully paid up in cash so that the amount
of three hundred fifty six thousand one hundred five Euros (EUR 356,105.-) is now at a free disposal of the company as
certified to the undersigned notary by the blocking certificate.

III. After such increase of capital, paragraphs 1 and 2 of Article 5 of the Company's Articles are amended and now read

as follows:

Art. 5. Capital. (Paragraphs 1 and 2). "The capital of the Company is set at one million seven hundred thirty five thousand

and thirty six Euros (EUR 1,735,036.-) represented by one million seven hundred thirty five thousand and thirty six
(1,735,036) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Within the limits of the authorised share capital, the share capital may be increased by an additional amount of fourteen

million  thirty  three  thousand  seven  hundred  eighty  three  Euros  (EUR  14,033,783.-)  at  the  initiative  of  the  board  of
managers, with or without an issue premium, in accordance with the terms and conditions set out below by creating and
issuing new shares, it being understood as follows:"

The rest of Article 5 of the Articles remains unchanged.
There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately EUR 1,900.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

97660

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, the person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le neuf septembre.
Par devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Catherine Cadet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de

mandatrice spéciale du Conseil de Gérance de TSA Mexican Funds S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois constituée suivant un acte reçu par Maître Paul Bettingen en date du 10 avril 2006, publié dans la gazette
officielle du Grand-Duché de Luxembourg ("Mémorial C") numéro 1308 du 6 juillet 2006 et inscrite auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous numéro B116.101 (la "Société") en vertu d'une résolution du conseil
de  gérance  en  date  du  8  septembre  2009,  laquelle  restera  annexée  au  présent  acte  pour  être  soumise  avec  lui  aux
formalités de l'enregistrement.

Les statuts de la société ont été dernièrement modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du

10 juillet 2009, publié au Mémorial C numéro 1641 du 26 août 2009..

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:
I. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million trois cent soixante dix-huit mille neuf cent trente et un

Euros (EUR 1.378.931,-) divisé en un million trois cent soixante dix-huit mille neuf cent trente et un (1.378.931) parts
sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

II. Le conseil de gérance a été autorisé, suivant l'article 5 des statuts de la Société (les "Statuts") à augmenter le capital

souscrit en une ou plusieurs tranches jusqu'au montant supplémentaire de quatorze million trois cent quatre-vingt neuf
mille huit cent quatre-vingt huit Euros (EUR 14.389.888,-). Cette augmentation de capital décidée par le conseil de gérance
dans les limites du capital social autorisé peut être souscrite, et les actions peuvent être émises, avec ou sans prime
d'émission et payées par apport en nature, en numéraire ou toute autre manière décidée par le conseil de gérance.

Sur base des pouvoirs conférés par le conseil de gérance, le conseil de gérance a décidé par résolutions datées du 8

septembre 2009, que le capital social de la Société devait être augmenté par un montant de trois cent cinquante six mille
cent cinq Euros (EUR 356.105,-) ceci étant l'équivalent à cinq cent dix mille dollars américains (USD 510.000,-) pour le
porter à un montant total d'un million sept cent trente cinq mille trente six Euros (EUR 1.735.036,-) par l'émission de
trois cent cinquante six mille cent cinq (356.105) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes (les "Nouvelles Actions").

Toutes les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique de la société, Tamweelview

S.A., une société anonyme du droit luxembourgeois, ayant son siège sociale au 13, rue Edward Steichen, 1 

ère

 étage,

L-2540 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous
numéro B 66.944, et entièrement payées en numéraire à ce que la somme de trois cent cinquante six mille cent cinq
Euros (EUR 356.105,-) est dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné
par un certificat de blocage.

III. Suite à cette augmentation de capital, les paragraphes 1 et 2 de l'Article 5 des Statuts auront la teneur suivante:

Art. 5. Capital. (Paragraphes 1 et 2). "Le capital social souscrit est fixé à un million sept cent trente cinq mille et trente

six Euros (EUR 1.735.036,-) divisé en un million sept cent trente cinq mille et trente six (1.735.036) parts sociales d'une
valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

Dans les limites du capital social autorisé, le capital social peut être augmenté d'un montant additionnel de quatorze

millions trente trois mille sept cent quatre-vingt trois Euros (EUR 14.033.783,-) à l'initiative du conseil de gérance, avec
ou sans prime d'émission, dans le respect des termes et conditions définis ci-dessous par la création et l'émission de
nouvelles actions, étant entendu que:"

Le reste de l'Article 5 reste inchangé.
L'ordre du jour ayant ainsi été épuise, l'assemblée est achevé.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de

cette augmentation de capital s'élève à environ EUR 1.900,-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, es qualités qu'elle agit, connue du notaire

par nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

97661

signé: C. Cadet et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 septembre 2009. Relation: LAC/2009/37762. Reçu soixante-quinze euros

(75€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009126697/121.
(090153149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Paris Coiffure S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 52.705.

<i>Décisions de l'Associée unique du 1 

<i>er

<i> octobre 2009

L'associée  unique  de  la  société  PARIS  COIFFURE  S.à.r.l.  a  décidé,  en  date  du  1 

er

  octobre  2009,  de  prendre  les

résolutions suivantes:

- La révocation de Monsieur Didier AVICE, coiffeur, né le 1 

er

 mars 1961 à Paris (France) et demeurant à F-93420

Villepinte, 3ter, rue de l'Eglise de son mandat de gérant technique de la société est acceptée.

- Est nommé gérant technique en remplacement du gérant technique révoqué, pour une durée indéterminée, Monsieur

Bernard DICHAMP, coiffeur, né le 26 janvier 1960 à Paris (France) et demeurant à F-91800 Brunoy, 14, avenue du
Président Kennedy.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de la gérante administrative et du gérant

technique.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009127055/19.
(090153237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

S.G.A. Ventures S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 87.967.

Nous vous informons que le siège social de la société S.G.A. VENTURES S.A., au 15, boulevard Roosevelt, L-2450

Luxembourg a été dénoncé avec effet immédiat au 22 septembre 2009.

Luxembourg, le 22 septembre 2009.

<i>Pour la société S.G.A. VENTURES S.A.
FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A.
15, Bld. Roosevelt - B.P. 814, L-2018 Luxembourg
R.C.S. B 42.411
Signature

Référence de publication: 2009127056/14.
(090152892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 108.922.

In the year two thousand and nine.
On the eleventh day of September at 08.50 a.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

97662

here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on November 3, 2006 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I. - The company PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having

its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B108922, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 30 

th

 of June 2005,

published in the Memorial C number 688 of the 13 

th

 of July 2005, and whose articles of incorporation have been amended

by deed of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of seven million one hundred and fifty thousand four hundred and seventeen Euro

and fifty-one cents (7,150,417.51.- EUR) represented by twenty-three thousand eight hundred and thirty-two point eighty-
six (23,832.86) Manager Shares and one hundred and nineteen thousand one hundred and seventy-five point fifty-one
(119,175.51) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of fifty million Euro (50,000,000.- EUR) divided into:
- nine hundred thousand (900,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- one hundred thousand (100,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on November 3, 2006 the General Manager has decided to increase, within the

limits of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of one million one hundred and sixty-
nine thousand eight hundred and fifty-seven Euro and thirty-two cents (1,169,857.32.- EUR), in order to raise it from its
present amount of seven million one hundred and fifty thousand four hundred and seventeen Euro and fifty-one cents
(7,150,417.51.- EUR) to the amount of eight million three hundred and twenty thousand two hundred and seventy-four
Euro and eighty-three cents (8,320,274.83.- EUR) by issuing:

- nineteen thousand five hundred and eighty-two point fifty (19,582.50) new Ordinary Shares having a par value of fifty

Euro (50.- EUR) each, issued with a total share premium of eighteen million six hundred and three thousand three hundred
and seventy-five Euro (18,603,375.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;

- three thousand eight hundred and fourteen point sixty-five (3,814.65) Manager Shares having a par value of fifty Euro

(50.- EUR) each, issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of one million one
hundred and sixty-nine thousand eight hundred and fifty-seven Euro and thirty-two cents (1,169,857.32.- EUR) as well as
the amount of eighteen million six hundred and three thousand three hundred and seventy-five Euro (18,603,375.- EUR)
as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

97663

Art. 5. Share capital. (paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of eight million three hundred and twenty thousand two hundred and seventy-

four Euro and eighty-three cents (8,320,274.83.- EUR) represented by twenty-seven thousand six hundred and forty-
seven point fifty-one (27,647.51) Manager Shares and one hundred and thirty-eight thousand seven hundred and fifty-
eight point zero one (138,758.01) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand seven hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den elften September um 08.50 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 3. November 2006 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP GLOBAL
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B108922, wurde gegründet gemäss
Urkunde  aufgenommen  durch  Notar  Henri  HELLINCKX,  mit  dem  damaligen  Amtssitz  in  Mersch,  am  30.  Juni  2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 688 vom 13. Juli 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von sieben Millionen ein hundert fünfzig tausend vier hundert siebzehn Euro

ein und fünfzig Cents (7.150.417,51.- EUR), eingeteilt in drei und zwanzig tausend acht hundert zwei und dreissig Komma
sechs und achtzig (23.832,86) Manager-Aktien und ein hundert neunzehn tausend ein hundert fünf und siebzig Komma
ein und fünfzig (119.175,51) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfzig Millionen Euro (50.000.000.- EUR) und ist aufgeteilt

in:

- neun hundert tausend (900.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie; und
- ein hundert tausend (100.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

97664

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000.- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950.- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50.- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 3. November 2006 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des

genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um eine Million ein hundert neun und sechzig tausend acht hundert sieben
und fünfzig Euro zwei und dreissig Cents (1.169.857,32.- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von sieben
Millionen ein hundert fünfzig tausend vier hundert siebzehn Euro ein und fünfzig Cents (7.150.417,51.- EUR) auf acht
Millionen drei hundert zwanzig tausend zwei hundert vier und siebzig Euro drei und achtzig Cents (8.320.274,83.- EUR)
zu bringen durch die Ausgabe von:

- neunzehn tausend fünf hundert zwei und achtzig Komma fünfzig (19.582,50) neuen Vorzugsaktien mit einem Nomi-

nalwert von je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von achtzehn Millionen sechs
hundert drei tausend drei hundert fünf und siebzig Euro (18.603.375.- EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der
Gesellschaft zugeteilt wird;

- drei tausend acht hundert vierzehn Komma fünf und sechzig (3.814,65) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von

je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von einer Million ein hundert
neun und sechzig tausend acht hundert sieben und fünfzig Euro zwei und dreissig Cents (1.169.857,32.- EUR) erhalten
hat, so wie den Betrag von achtzehn Millionen sechs hundert drei tausend drei hundert fünf und siebzig Euro (18.603.375.-
EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von acht Millionen drei hundert zwanzig tausend zwei hundert vier und siebzig

Euro drei und achtzig Cents (8.320.274,83.- EUR), eingeteilt in sieben und zwanzig tausend sechs hundert sieben und
vierzig Komma ein und fünfzig (27.647,51) Manager-Aktien und ein hundert acht und dreissig tausend sieben hundert acht
und fünfzig Komma null eins (138.758,01) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf

tausend sieben hundert Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: RÖSSLER; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2009. Relation GRE/2009/3322. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial;

Junglinster, den 29. September 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009125637/177.
(090151668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2009.

97665

Sigma Tau Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 52.948.

RECTIFICATIF

Au terme du Conseil d'administration du 19 juin 2009, il a été décidé de transférer le siège social de la société du

19-21, boulevard du Prince Henri - L-1724 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, avec effet au 01.09.08.

Sigma Tau Europe S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009127062/12.
(090152926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

The Swatch Group Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5835 Alzingen, 10, rue Hondsbreck.

R.C.S. Luxembourg B 116.665.

AUSZUG

Für die am 11. Mai 2009 abgehaltene Hauptversammlung stand Herrn Edgar Geiser einer Wiederwahl als Verwal-

tungsmitglied nicht mehr zur Verfügung und ist somit seit dem 11. Mai 2009 nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrates
der Gesellschaft.

Es wird weiterhin festgehalten, dass Herr Wälti eine neue Anschrift hat.
Seine Anschrift lautet nun wie folgt: 4, rue Jean Pierre Lanter, L-5943 Itzig.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im September 2009.

The Swatch Group Financial Services (Luxembourg) S.A.
Patrick Reuter

Référence de publication: 2009127061/17.
(090153051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 108.922.

In the year two thousand and nine.
On the eleventh day of September at 08.45 a.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number Bl07523,

here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on October 2, 2006 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I.- The company PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having

its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B108922, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 30 

th

 of June 2005,

97666

published in the Memorial C number 688 of the 13 

th

 of July 2005, and whose articles of incorporation have been amended

by deed of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of six million two hundred and forty-seven thousand nine hundred and fifty-six

Euro and fifteen cents (6,247,956.15.- EUR) represented by twenty thousand eight hundred and ninety point thirteen
(20,890.13) Manager Shares and one hundred and four thousand and sixty-nine point zero one (104,069.01) Ordinary
Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of fifty million Euro (50,000,000.- EUR) divided into:
- nine hundred thousand (900,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- one hundred thousand (100,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on October 2, 2006 the General Manager has decided to increase, within the limits

of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of nine hundred and two thousand four
hundred and sixty-one Euro and thirty-six cents (902,461.36.-EUR), in order to raise it from its present amount of six
million two hundred and forty-seven thousand nine hundred and fifty-six Euro and fifteen cents (6,247,956.15.- EUR) to
the  amount  of  seven  million  one  hundred  and  fifty  thousand  four  hundred  and  seventeen  Euro  and  fifty-one  cents
(7,150,417.51.- EUR) by issuing:

- fifteen thousand one hundred and six point fifty (15,106.50) new Ordinary Shares having a par value of fifty Euro (50.-

EUR) each, issued with a total share premium of fourteen million three hundred and fifty-one thousand one hundred and
seventy-five Euro (14,351,175.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;

- two thousand nine hundred and forty-two point seventy-three (2,942.73) Manager Shares having a par value of fifty

Euro (50.- EUR) each, issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of nine hundred and two
thousand four hundred and sixty-one Euro and thirty-six cents (902,461.36.- EUR) as well as the amount of fourteen
million three hundred and fifty-one thousand one hundred and seventy-five Euro (14,351,175.- EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital. (paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of seven million one hundred and fifty thousand four hundred and seventeen

Euro and fifty-one cents (7,150,417.51.- EUR) represented by twenty-three thousand eight hundred and thirty-two point
eighty-six (23,832.86) Manager Shares and one hundred and nineteen thousand one hundred and seventy-five point fifty-
one (119,175.51) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand one hundred and fifty Euro.

97667

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den elften September um 08.45 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 2. Oktober 2006 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP GLOBAL
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B108922, wurde gegründet gemäss
Urkunde  aufgenommen  durch  Notar  Henri  HELLINCKX,  mit  dem  damaligen  Amtssitz  in  Mersch,  am  30.  Juni  2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 688 vom 13. Juli 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von sechs Millionen zwei hundert sieben und vierzig tausend neun hundert

sechs und fünfzig Euro fünfzehn Cents (6.247.956,15.- EUR), eingeteilt in zwanzig tausend acht hundert neunzig Komma
dreizehn (20.890,13) Manager-Aktien und ein hundert vier tausend neun und sechzig Komma null eins (104.069,01) Vor-
zugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfzig Millionen Euro (50.000.000.- EUR) und ist aufgeteilt

in:

- neun hundert tausend (900.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie; und
- ein hundert tausend (100.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000.- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950.- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50.- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 2. Oktober 2006 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des ge-

nehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um neun hundert zwei tausend vier hundert ein und sechzig Euro sechs und
dreissig Cents (902.461,36.- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von sechs Millionen zwei hundert sieben

97668

und vierzig tausend neun hundert sechs und fünfzig Euro fünfzehn Cents (6.247.956,15.- EUR) auf sieben Millionen ein
hundert fünfzig tausend vier hundert siebzehn Euro ein und fünfzig Cents (7.150.417,51.- EUR) zu bringen durch die
Ausgabe von:

- fünfzehn tausend ein hundert sechs Komma fünfzig (15.106,50) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je

fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von vierzehn Millionen drei hundert ein und fünfzig
tausend ein hundert fünf und siebzig Euro (14.351.175.- EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft
zugeteilt wird;

- zwei tausend neun hundert zwei und vierzig Komma drei und siebzig (2.942,73) Manager-Aktien mit einem Nomi-

nalwert von je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von neun hundert zwei
tausend vier hundert ein und sechzig Euro sechs und dreissig Cents (902.461,36.- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag
von vierzehn Millionen drei hundert ein und fünfzig tausend ein hundert fünf und siebzig Euro (14.351.175.- EUR) als
Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).

(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von sieben Millionen ein hundert fünfzig tausend vier hundert siebzehn Euro

ein und fünfzig Cents (7.150.417,51.- EUR), eingeteilt in drei und zwanzig tausend acht hundert zwei und dreissig Komma
sechs und achtzig (23.832,86) Manager-Aktien und ein hundert neunzehn tausend ein hundert fünf und siebzig Komma
ein und fünfzig (119.175,51) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf

tausend ein hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebxend.

WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: RÖSSLER; J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2009. Relation GRE/2009/3321. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial;

Junglinster, den 29. September 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009125638/176.

(090151668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2009.

Metalmachine Trading S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 88.826.

Nous vous informons que le siège social de la société METALMACHINE TRADING S.A., au 15, boulevard Roosevelt,

L-2450 Luxembourg a été dénoncé avec effet immédiat au 22 septembre 2009.

97669

Luxembourg, le 22 septembre 2009.

<i>Pour la société METALMACHINE TRADING S.A.
FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A.
15, Bld. Roosevelt - B.P. 814, L-2018 Luxembourg
R.C.S. B 42.411
Signature

Référence de publication: 2009127057/14.
(090152891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Casual International S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R.C.S. Luxembourg B 67.264.

FIDEX AUDIT S.à r.l., Luxembourg, démissionne de son poste de liquidateur avec effet immédiat.
Le siège de la société situé jusqu'alors au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg est dénoncé avec effet

immédiat.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2009.

SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2009127064/12.
(090153023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Noble Holding International SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.368.

In the year two thousand and nine, on the twenty-third of September.
Before us Maitre Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) NOBLE DRILLING CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware,

United States of America, having its registered address at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
DE 19801, United States of America; and

2) NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l., a limited liability company (Gesellschaft mit bes-

chränkter  Haftung  -société  à  responsabilité  limitée)  continued  and  existing  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of
Luxembourg, having its registered office and central administration at 25C Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (toge-
ther the "Partners").

The appearing parties are here both represented by Robert W. Adriaansen, attorney-at-law, professionally residing in

the City of Luxembourg, by virtue of two separate proxies given on 23 September, 2009.

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, requested the undersigned notary to record the following:
- The Partners are the 2 (two) shareholders of Noble Holding International SCA, a partnership limited by shares

(Kommanditgesellschaft auf Aktien - Société en commandité par actions) organized and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office and central administration at 25C Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg (the "Company"). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Camilles Mines, notary
residing in Capellen, on July 17 

th

 , 2009 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number

1618 of August 21 

st

 , 2009.

- NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l. is also the general partner (Komplementär - associé

commandité) of the Company (the "General Partner").

The agenda of the meeting is the following:
1. Acknowledge the transfer, with full corporate and legal continuance and without dissolution, of the registered office

and central administration of the General Partner from P.O. Box 309GT, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
KY1-1104 Cayman Islands to 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, resolved in a
general meeting held before the undersigned notary today September 23 

rd

 , 2009 (the "Migration Meeting");

97670

2. Acknowledge the re-registration of the General Partner as a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter

Haftung - société à responsabilité limitée) with the name NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à
r.l. and its acquisition of the Luxemburgian nationality, both resolved at the Migration Meeting;

3. Amend Article 10 of the articles of association of the Company accordingly;
4. Replace 1 (one) of the current Members of the Supervisory Board of the Company; and
5. Miscellaneous.
Thereupon, the appearing parties, represented as stated here-above, requested the notary to record the following:

<i>First resolution

The Partners resolve to acknowledge that the General Partner transferred, as at the date of the Migration Meeting,

with full corporate and legal continuance and without dissolution, its registered office and central administration from
P.O. Box 309GT, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands to 25C, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second resolution

The Partners resolve to acknowledge that the General Partner has re-registered as a limited liability company (Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung - société à responsabilité limitée) with the name NOBLE HOLDING INTERNATIO-
NAL (LUXEMBOURG) S.à r.l., acquired the Luxembourgian nationality and as from the date of the Migration Meeting, is
subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Partners resolve to amend the first sentence of Article 10 of the articles

of association of the Company so as to reflect the migration of the General Partner described here-above. The first
sentence of Article 10 of the articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

Art. 10. First sentence. The Company shall be managed by NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG)

S.à r.l. in its capacity of general partner (Komplementär) and manager of the Company".

<i>Fourth resolution

The Partners resolve to remove Michael Gamo from the Supervisory Board and to replace him with Christopher

Maan, born on February 10 

th

 , 1984 in Schiedam, The Netherlands, professionally residing at 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

The term of office of this new Supervisory Board member shall end at the general meeting called to approve the

accounts of the accounting year 2010 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.

There being no further business, the meeting was adjourned.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 1,200 (one thousand two hundred euro).

<i>Statement

The undersigned notary, who reads and understands English, states herewith that upon request of the aforementioned

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German version, and in case of any conflict in
between the English and the German versions, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document
The document having been read to the appearing parties, said appearing parties signed together with the notary the

present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, den dreiundzwanzigsten September.
Vor dem Notar Maitre Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) NOBLE DRILLING CORPORATION, eine Aktiengesellschaft (corporation) gegründet und bestehend nach dem

Recht vom Staat Delaware, Vereinigten Staaten von Amerika, mit Firmensitz Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, DE 19801, Vereinigten Staaten von Amerika; und

2) NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (so-

ciété à responsabilité limitée) (weiter)bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Firmensitz und
Hauptverwaltung 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,

97671

(zusammen die "Gesellschafterinen").
Beide Parteien sind hier vertreten durch Robert W. Adriaansen, Meister der Rechte, berufsmäßig wohnhaft in Lu-

xemburg, gemäß privatschriftlichen individuellen Vollmachten, ausgestellt am 23. September 2009.

Die Vollmachten wurden nach Unterzeichnung „ne varietur" durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar

der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie oben angegeben, ersuchten den unterzeichneten Notar folgendes zu beurkunden:
- Die Gesellschafterinnen sind die 2 (zwei) Aktionäre von Noble Holding International SCA, eine Kommanditgesell-

schaft auf Aktien (Société en commandité par actions) gegründet und bestehend nach dem Recht vom Großherzogtum
Luxemburg, mit Firmensitz und Hauptverwaltung In 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (die "Gesellschaft"). Die
Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgezeichnet durch Maître Camilles Mines, Notar mit Amtssitz in Ca-
pellen, am 17. Juli 2009 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1618 vom 21.
August 2009.

- NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l., ist auch der Komplementär (associé commandité)

der Gesellschaft (der "Komplementär").

Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Die Verlegung, mit ganzer Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit und ohne vorherige Auflösung, des Sitzes und der

Hauptverwaltung vom Komplementär von P.O. Box 309GT, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104
Caymaninseln nach 25C Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, beschlossen bei einer heute dem dreiundzwanzigsten Sep-
tember 2009 bei dem unterzeichneten Notar abgehaltenen Hauptversammlung (die "Verlegungsversammlung"), aner-
kennen;

2. Anerkennung der Umwandlung vom Komplementär in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-

ponsabilité limitée) mit dem Namen NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l. und ihren Erwerb
der Luxemburgischen Staatsangehörigkeit, beides bei der Verlegungsversammlung beschlossen;

3. Entsprechend Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft abändern;
4. 1 (ein) Mitglied des Aufsichtsrat der Gesellschaft zu ersetzen; und
5. Sonstiges.
Anschließend ersuchten die Erschienenen, vertreten wie oben angegeben, den unterzeichneten Notar folgendes zu

beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterinnen erkennen an, dass der Komplementär am Datum der Verlegungsversammlung, mit ganzer

Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit und ohne vorherige Auflösung, seinen Sitz und seine Hauptverwaltung von P.O.
Box 309GT, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104 Caymaninseln nach 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxemburg, verlegt hat.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterinnen erkennen an, dass der Komplementär in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société

à responsabilité limitée) mit den Name NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l. umgewandelt
wurde, die Luxemburgische Staatsangehörigkeit erworben hat, und ab dem Datum der Velegungsversammlung dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg unterliegt.

<i>Dritter Beschluss

Als Folge der vorgehenden Beschlüsse beschließen die Gesellschafterinnen, Artikel 10, Satz 1 der Satzung der Gesell-

schaft abzuändern, um die oben beschriebene Verlegung wiederzugeben.

Der erste Satz von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft wird folgenden Wortlaut haben:

Art. 10. Satz 1. Die Gesellschaft wird durch NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.ä r.l. in ihrer

Eigenschaft als Komplementär und Geschäftsführer der Gesellschaft verwaltet".

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterinnen beschließen, Michael Gamo als Mitglied des Aufsichtsrats abzuberufen, und ihn mit Christopher

Maan, geboren am 10. Februar 1984 in Schiedam (Niederlande), beruflich wohnhaft in 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxemburg, zu ersetzen.

Das Mandat dieses neuen Aufsichtsratsmitglieds endet mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten zum

31. Dezember 2010 entscheidet oder vorzeitig zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die Versammlung geschlossen.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, welcher Art auch immer, welche von der Gesellschaft zu tragen

sind oder auf Grund dieser Urkunde belastet werden, sind auf etwa EUR 1.200 (eintausendzweihundert Euro) geschätzt.

97672

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im
Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Verlesung und Erklärung

alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. W. Adriaansen et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 septembre 2009. Relation: LAC/2009/39368. Reçu soixante-quinze euros

Eur75.-

<i>Le Receveur (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009126291/155.
(090151892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.

FACTS Services S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.790.

Il résulte du contrat de cession que:
Qadamala S.A. cède 20 actions détenues dans FAcTS Services S.à.r.l. à Stronghold S.A., société anonyme de droit

luxembourgeois dont le siège est établi au 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en date du 17 septembre
2009;

Qadamala S.A. cède 20 actions détenues dans FAcTS Services S.à.r.l. à Les Hellébores S.A., société anonyme de droit

luxembourgeois dont le siège est établi au 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en date du 17 septembre
2009;

Qadamala S.A. cède 40 actions détenues dans FAcTS Services S.à.r.l. à FAcTS Services Sàrl, société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois dont le siège est établi au 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en date du
17 septembre 2009;

Qadamala S.A. cède 20 actions détenues dans FAcTS Services S.à.r.l. à ASTC Participations S.A., société anonyme de

droit luxembourgeois dont le siège est établi au 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en date du 17 septembre
2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2009

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009127298/25.
(090153891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

Noble Holding International SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.368.

In the year two thousand and nine, on the twenty-third of September.
Before Us Maitre Marline SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) NOBLE HOLDING INTERNATIONAL L.L.C., a limited liability company organized and existing under the laws of

the State of Delaware, United States of America, having its registered address at Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, DE 19801, United States of America; and

2) NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l., a limited liability company (Gesellschaft mit bes-

chränkter  Haftung  -  société  à  responsabilité  limitée)  continued  and  existing  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of
Luxembourg, having its registered office and central administration at 25C Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

(together the "Partners").

97673

Both parties are represented here by Robert W. Adriaansen, attorney-at-law, professionally residing in the City of

Luxembourg, by virtue of two separate proxies given on 23 September, 2009.

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

The Partners are the 2 (two) shareholders of Noble Holding International SCA, a partnership limited by shares (Kom-

manditgesellschaft auf Aktien - Société en commandité par actions) organized and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office and central administration at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
(the "Company"). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Camilles Mines, notary residing in Ca-
pellen, on July 17 

th

 , 2009 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1618 of August

21 

st

 , 2009.

The agenda of the meeting is the following:
1. Approve the transfer of all the 8,550 shares held by NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à

r.l. in the Company, to Noble Holding S.C.S., a limited partnership (Kommanditgesellschaft - Société en commandite
simple) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office and central
administration at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

2. Acknowledge that as a result of the above NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l. is no

longer General Partner (Komplementär - associé commandité) or Manager (Geschäftsführer - gérant) of the Company;

3. Appoint Noble Holding SCS as General Partner and Manager of the Company;
4. Amend Article 10 of the articles of association of the Company accordingly; and
5. Miscellaneous.
Thereupon, the appearing parties, represented as stated here-above, requested the notary to record the following:

<i>First resolution

The Partners resolve to approve the transfer of all the 8,550 (eight thousand five hundred fifty) registered shares with

a par value of USD 5 (five United States Dollars) each currently held by NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LU-
XEMBOURG) S.à r.l., to Noble Holding S.C.S.

<i>Second resolution

As a result of the first resolution, the Partners resolve to acknowledge that NOBLE HOLDING INTERNATIONAL

(LUXEMBOURG) S.à r.l. is no longer General Partner (Komplementär -associé commandité) or Manager (Geschäftsführer
- gérant).

<i>Third resolution

The Partner resolve to appoint Noble Holding S.C.S. as General Partner and Manager.

<i>Fourth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Partners resolve to amend the first sentence of Article 10 of the articles

of association of the Company so as to reflect the changes described here-above. The first sentence of Article 10 of the
articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

Art. 10. First sentence. The Company shall be managed by Noble Holding S.C.S. in its capacity of general partner

(Komplementär) and manager of the Company".

There being no further business, the meeting was adjourned.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 1,200 (one thousand two hundred euro).

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the aforementioned

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German version, and in case of any conflict in
between the English and the German versions, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document
The document having been read to the appearing parties, said appearing parties signed together with the notary the

present deed.

97674

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, den dreiundzwanzigsten September.
Vor dem Notar Maitre Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) NOBLE HOLDING INTERNATIONAL L.L.C., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Com-

pany) gegründet und bestehend nach dem Recht vom Staat Delaware, Vereinigten Staaten von Amerika, mit Firmensitz
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Vereinigten Staaten von Amerika; und

2) NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (so-

ciété à responsabilité limitée) (weiter)bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Firmensitz und
Hauptverwaltung 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,

(zusammen die "Gesellschafterinnen").
Beiden Parteien sind hier vertreten durch Robert W. Adriaansen, Meister der Rechte, berufsmäßig wohnhaft in Lu-

xemburg, gemäß privatschriftlichen individuellen Vollmachten, ausgestellt am 23. September 2009.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung „ne varietur" durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar

der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie oben angegeben, ersuchen den unterzeichneten Notar folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschafterinnen sind die 2 (zwei) Aktionäre von Noble Holding International SCA, eine Kommanditgesellschaft

auf Aktien (Société en commandite par actions) gegründet und bestehend nach dem Recht vom Grossherzogtum Lu-
xemburg,  mit  Firmensitz  und  Hauptverwaltung  25C  boulevard  Royal,  L-2449  Luxembourg  (die  "Gesellschaft").  Die
Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgezeichnet durch Maître Camilles Mines, Notar mit Amtssitz in Ca-
pellen, am 17. Juli 2009 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1618 vom 21.
August 2009.

Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Zustimmung der Übertragung von den gegenwärtig durch NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG)

S.à r.l. gehaltenen 8,550 (achttausendfünfhundertfünfzig) Anteilen in der Gesellschaft auf Noble Holding S.C.S. eine Kom-
manditgesellschaft  (Société  en  commandite  simple)  gegründet  und  bestehend  nach  dem  Recht  des  Großherzogtum
Luxemburg, mit Firmensitz in 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg;

2. Anerkennung, dass NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l. als Folge des oben genannten

nicht mehr Komplementär und Geschäftsführer der Gesellschaft ist;

3. Ernennung von Noble Holding S.C.S. zum Komplementär und Geschäftsführer der Gesellschaft;
4. Entsprechend Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft abändern; und
5. Sonstiges.
Anschließend ersuchten die Erschienenen, vertreten wie oben angegeben, den unterzeichneten Notar folgendes zu

beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterinnen beschließen der Übertragung von den gegenwärtig durch NOBLE HOLDING INTERNATI-

ONAL (LUXEMBOURG) Sà r.l. gehaltenen 8,550 (achttausendfünfhundertfünfzig) Anteilen in der Gesellschaft mit einem
Nennwert von je fünf United States Dollars (USD 5), auf Noble Holding S.C.S., zuzustimmen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterinnen beschließen anzuerkennen, dass NOBLE HOLDING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG)

S.à r.l., als Folge des vorhergehenden Beschlusses nicht mehr Komplementär und Geschäftsführer der Gesellschaft ist.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterinnen beschließen, Noble Holding S.C.S. zum Komplementär und Geschäftsführer der Gesellschaft

zu ernennen.

<i>Vierter Beschluss

Als Folge der vorgehenden Beschlüsse beschließen die Gesellschafterinnen, Artikel 10, Satz 1 der Satzung der Gesell-

schaft abzuändern, um die oben beschriebenen Änderungen wiederzugeben.

Der erste Satz von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft wird folgenden Wortlaut haben:

Art. 10. Satz 1. Die Gesellschaft wird durch Noble Holding S.C.S. in ihrer Eigenschaft als Komplementär und Ge-

schäftsführer der Gesellschaft verwaltet".

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die Versammlung geschlossen.

97675

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, welcher Art auch immer, welche von der Gesellschaft zu tragen

sind oder auf Grund dieser Urkunde belastet werden, sind auf etwa EUR 1.200 (eintausendzweihundert Euro) geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichneten Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar die ge-

genwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. W. Adriaansen et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 septembre 2009. Relation: LAC/2009/39369. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur

 (signé):Franck SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009126297/137.
(090151905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.

Crediinvest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 98.745.

<i>Extraits des Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 07 septembre 2009

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 07 septembre 2009, que Mes-

sieurs Xavier Cornella Castel, Agusti Garcia Puig, Iain Macleod et Sergi Martin Amoros ont été réélus en leur qualité
d'administrateur de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2010 et
que KPMG Luxembourg a été réélu en sa qualité de réviseur d'entreprise de la Société pour une période d'un an se
terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2010.

Monsieur José Luis Dorado (résidant au 8 Tramontana, 28223 Madrid, Espagne) a été élu administrateur de la société

pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour CREDIINVEST SICAV
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Peter BUN / Luc Biever

Référence de publication: 2009127045/20.
(090153128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Pan-Eco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 106.738.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 16 septembre 2009

Monsieur GIANELLO Lorenzo, 68, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, est renommé administrateur et adminis-

trateur-délégué. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Pour extrait sincère et conforme
PAN-ECO S.A.
Georges DIEDERICH / Mohammed KARA
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009126985/15.
(090152825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

97676

Donatello Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 106.552.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 1 

er

 août 2008, il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1 

er

 août 2008, le siège social de la société de son adresse actuelle du 9-11, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg vers le 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d'Administration
Edoardo Tubia / Onelio Piccinelli

Référence de publication: 2009127067/13.
(090152524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Müller Trade AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 96.180.

Im Jahre zweitausendneun, am achtzehnten September.
Vor dem unterzeichnen Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.
Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "MÜLLER TRADE

AG" mit Sitz in L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Sektion B unter der Nummer 96.180,
gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Urbain Tholl mit dem Amtswohnsitz in Mersch, am 5.

August 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1467 vom 10. Oktober 2002

Die Versammlung wurde eröffnet um 15 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Frau Bianca MÜLLER, Kauffrau,

wohnhaft in L-9147 Erpeldange, Parc Welwert 3A. Die Gesellschafterversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung
eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen

Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 100 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital

darstellen, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung
somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9911 Troisvierges, rue de Drinklange 9, nach L-9227 Diekirch, Esplanade

50 und in diesem Sinne wird Artikel 1, § 2 der Satzungen abgeändert, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ Art. 1. §2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Diekirch".
2. Änderung des Gesellschaftsgegenstandes Artikel 2. §1 der Gesellschaftssatzungen erhält nunmehr folgenden Wort-

laut:

Art. 2. §1. "Zweck der Gesellschaft ist der Holzhandel, der Holzeinschlag, das Holzrücken sowie der Transport von

Holz für eigene Rechnung."

3. Verschiedenes.
Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig

gefasst:

<i>Erster Beschluss.

Die Versammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft nach L-9227 Diekirch, Esplanade 50 zu verlegen und in diesem

Sinne wird Artikel 1 §2 der Satzungen abgeändert, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. §2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Diekirch ".

<i>Zweiter Beschluss.

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftsgegenstand zu ändern, Artikel 2 §1 erhält folgenden Wortlaut:.

„ Art. 2. §1. Zweck der Gesellschaft ist der Holzhandel, der Holzeinschlag, das Holzrücken sowie der Transport von

Holz für eigene Rechnung."

97677

<i>Kosten.

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, wer-

den geschätzt auf € 750,-.

Worüber Urkunde, Aufgenommen Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesende, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand

und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: B. MÜLLER, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2009. DIE/2009/9201. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME AUX FINS DE PUBLICATION AU MEMORIAL.

Ettelbruck, le 30 septembre 2009.

Pierre PROBST
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009126671/56.
(090152851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Boston A1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Apax Boston A S.à r.l.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.361.

L'an deux mille neuf, le huit septembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

APAX WW NOMINEES LTD, une société constituée sous les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège

social au 33, Jermyn Street, Londres SW1Y 6DN, inscrite au Companies House à Londres sous le numéro 4693597,

ici représentée par Madame Cindy TEIXEIRA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 7 septembre 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société Apax Boston A S.à r.l., société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, constituée suivant acte notarié du 3 juillet 2008, publié au Mémorial Recueil C numéro 1994 du 16 août 2008,
et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié du 25 août 2008, publié au Mémorial Recueil C numéro 2420 du 3
octobre 2008.

- Qu'elle a pris la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société en "Boston A1 S.à r.l." et de modifier en conséquence

l'article 1 

er

 des statuts comme suit:

Version anglaise:

Art. 1. Denomination.
The name of the limited liability company ("société à responsabilité limitée") is Boston A1 S.à r.l. (the "Company").

The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation."

Version française:

 Art. 1 

er

 . Dénomination.

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Boston A1 S.à r.l. (la "Société"). La Société sera

régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes."

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. TEIXEIRA, G. LECUIT.

97678

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36542. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009128606/43.
(090155291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

ECPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8225 Mamer, 18, route de Dippach.

R.C.S. Luxembourg B 93.762.

L'an deux mille neuf, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Ecprod S.A.", avec siège social à L-8225

Mamer, 18, route de Dippach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
B 93.762,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20

mai 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 668 du 25 juin 2003.

L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Paul WEILER, employé, demeurant profes-

sionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter.

Qui désigne comme secrétaire Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-2740 Luxem-

bourg, 3, rue Nicolas Welter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc BERTRAND, administrateur de sociétés, demeurant profession-

nellement à L-8225 Mamer, 18, route de Dippach.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I./ Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
A. Elargissement de l'objet social
B. Adaptation subséquente de l'article 2, des statuts.
II./ Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire.

III./ Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

IV./ Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur l'objet porté à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L'assemblée décide d'élargir l'objet social de la Société et en conséquence l'article 2 des statuts est modifié de la façon

suivante:

Art. 2. La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
- l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de plaisance et des bateaux de plaisance ainsi que

les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

- d'enseigner l'art (du point de vue pratique) de conduire/commander de façon responsable des navires de plaisance.

La formation comprend aussi la réception du bateau loué, la mise en bain de l'équipage, la navigation terrestre, la navigation
avec GPS, des manoeuvres au moteur, la sécurité à bord

- la réalisation d'études d'implantations, de faisabilité ou autres, l'établissement de cahiers de charges, la conception et

le suivi de projets se rapportant à l'informatique au sens le plus large du terme, à sa mise en service, son exploitation ou
son développement, ou se rapportant aux méthodes techniques et accessoires de gestion, d'organisation, contrôle et
applications informatiques, la réalisation de tous travaux sur ordinateurs quels que soient, d'analyse de programmation,
de perforation, d'encodage à façon, d'assistance pour l'installation de système d'exploitation et de banques de données
ou autres, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement."

97679

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 11.30 heures.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge s'élève approximativement à 900,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. DECKER, M. MAYER, P. WEILER, L. BERTRAND.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2009. Relation: LAC/2009/38026. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre pour des besoins administratifs.

Luxembourg, le 24 septembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009126689/63.
(090152566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Expanding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 113.081.

- Monterey Audit Sàrl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société:
Expanding S.A., Société Anonyme, R.C.S. Luxembourg B 113.081, domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2009.

Philippe GAIN
<i>Gérant

Référence de publication: 2009127069/12.
(090153097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Salamina Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 47.905.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 1 

<i>er

<i> octobre 2009

1. Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de M. Eric MAGRINI, venus à échéance, n'ont pas été

renouvelés.

2. Le mandat d'administrateur de M. Pietro LONGO, venu à échéance, n'a pas été renouvelé.
3. M. Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

4. M. David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

5. Me Pietro MOGGI a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

6. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 1 

er

 OCT 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SALAMINA HOLDING S.A
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009127137/26.
(090152649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

97680


Document Outline

Apax Boston A S.à r.l.

Argance S.àr.l.

ARMAND RACCOGLI et SERVAIS STEMPER &amp; Cie (Bureau d'Assurances)

Arnarbaeli &amp; Reilley &amp; Cie SNC

Banque LBLux

Bonafide Invest G.m.b.h.

Boston A1 S.à r.l.

Carson Holding S.A.

Carts &amp; Kiosks S.à r.l.

Casual International S.A.

Corton Meyney S.A.

Crediinvest Sicav

Donatello Sicav

Doosan Heavy Industries European Holdings S.à r.l.

Dory 1 (NFR) S.à r.l.

ECPROD S.A.

ERE III - No 7 S.à r.l.

ETF - EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES Luxembourg S.A.

Expanding S.A.

FACTS Services S.àr.l.

Fondation FNEL

Grosvenor First European Property Investments S.A.

Guyana Holding S.à r.l.

International Wires For Companies S.A.

K.B. Sàrl

LIPP 1 S.à r.l.

L.T.T. Holding S.A.

LuxReal - Real Estate Association of Luxembourg a.s.b.l.

Lux T.P. S.A.

Maine Coon S.A.

Metalmachine Trading S.A.

Mira Group S.A.

Müller Trade AG

MZ Finance S.A.

Noble Holding International SCA

Noble Holding International SCA

Pan-Eco S.A.

Paris Coiffure S.à.r.l.

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Pearson Luxembourg N°. 1.

Recherches Scientifiques Luxembourg

R.H. Conseil Sàrl

Rover International S.A.

Salamina Holding S.A.

S.G.A. Ventures S.A.

Sigma Tau Europe S.A.

Société Générale Immobilière Luxembourgeoise S.à r.l.

SOCIETE INTERNATIONALE D'ARCHITECTURE, société d'architectes interprofessionnelle

The Swatch Group Financial Services (Luxembourg) S.A.

TSA Mexican Funds S.à r.l.

Wouterbos N.V.