This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2031
16 octobre 2009
SOMMAIRE
Aeris Technology Investment Company
S.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97446
AIM Group International S.A. . . . . . . . . . . .
97461
ASK Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97463
Atto Holding S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97462
Beim Kabouter Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97462
BELUXOIL Handel und Transport S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97456
B-Lux G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97462
BREDA et Fils s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97484
CELSIUS EUROPEAN Lux 2 S.à r.l. . . . . .
97482
Craft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97461
EPP Suresnes Curie (Lux) S.à r.l. . . . . . . . .
97457
Grand Banquet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97451
GuardOne International S.A. . . . . . . . . . . . .
97455
GuardOne International S.A. . . . . . . . . . . . .
97451
GuardOne International S.A. . . . . . . . . . . . .
97450
ICO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97446
International Power Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97473
INVESCO European Hotel Real Estate II
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97484
Investrand Investments I S.à r.l. . . . . . . . . .
97471
Jemco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97472
Klenke Schifffahrt S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . .
97456
Lambert Sport S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97464
LMT LUX SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97463
Luxembourg Corporation Company S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97455
Mahe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97481
Messagerie Maritime Luxembourgeoise
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97452
Office Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
97463
Participation Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
97451
Partners Group Global Mezzanine 2005
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97452
Partners Group Global Mezzanine 2005
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97458
Partners Group Global Mezzanine 2005
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97464
Partners Group Global Mezzanine 2005
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97468
Partners Group Global Mezzanine 2005
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97442
Patron Eurosail Holdings Sàrl . . . . . . . . . . .
97467
Pesa Transports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
97487
Polyval Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97462
Punta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97451
Raffaella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97445
Rainbow Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
97457
Reybier Développement S.A. . . . . . . . . . . . .
97486
Right Choice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97456
RWZ Lux GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97472
Salros S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97445
Santarem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97463
Schomburg-Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
97456
Sidint S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97445
Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97482
Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97481
Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97473
Soparef S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97458
Systems Advisers Group S.A. . . . . . . . . . . .
97446
T2 Capital Finance Company S.A. . . . . . . .
97467
Tersicore Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97457
Tinerama Investment A.G. . . . . . . . . . . . . . .
97488
United First Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97473
Volja Lux, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97472
YNVENYTYS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97468
97441
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 108.922.
In the year two thousand and nine.
On the eleventh day of September at 09.20 a.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED:
The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. having its registered office in L-1611 Luxembourg,
55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,
here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,
avenue de la Gare,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed
to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS
GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on February 28, 2008 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I.- The company PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having
its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B108922, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 30
th
of June 2005,
published in the Memorial C number 688 of the 13
th
of July 2005, and whose articles of incorporation have been amended
by deed of the undersigned notary on this day, not yet formalized.
II.- The Company has a share capital of twelve million four hundred and thirty-one thousand four hundred and eighty-
seven Euro and seventy cents (12,431,487.70.- EUR) represented by forty-one thousand and fifty-three point twenty-
seven (41,053.27) Manager Shares and two hundred and seven thousand five hundred and seventy-six point fifty-one
(207,576.51) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.
III.- The Company has an authorized capital of fifty million Euro (50,000,000.- EUR) divided into:
- nine hundred thousand (900,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- one hundred thousand (100,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as
follows:
Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising
the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and
- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100,- EUR) as determined
by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).
The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are
referred to as "Contributions".
The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of
the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.
The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,
drawdowns and payments upon drawdown.
V.- Pursuant to a resolution taken on February 28, 2008 the General Manager has decided to increase, within the limits
of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of two hundred and ninety-five thousand
eight hundred and eighteen Euro and forty-two cents (295,818.42.- EUR), in order to raise it from its present amount of
twelve million four hundred and thirty-one thousand four hundred and eighty-seven Euro and seventy cents
(12,431,487,70.- EUR) to the amount of twelve million seven hundred and twenty-seven thousand three hundred and six
Euro and twelve cents (12,727,306.12.- EUR) by issuing:
- four thousand nine hundred and fifty-one point seventy-seven (4,951.77) new Ordinary Shares having a par value of
fifty Euro (50.- EUR) each, issued with a total share premium of four million seven hundred and four thousand one hundred
97442
and eighty-one Euro and fifty-eight cents (4,704,181.58.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the
Company;
- nine hundred and sixty-four point sixty (964.60) Manager Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR) each,
issued without share premium.
VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment
delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of two hundred and
ninety-five thousand eight hundred and eighteen Euro and forty-two cents (295,818.42.- EUR) as well as the amount of
four million seven hundred and four thousand one hundred and eighty-one Euro and fifty-eight cents (4,704,181.58.- EUR)
as share premium.
The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.
VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)
of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital. (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of twelve million seven hundred and twenty-seven thousand three hundred
and six Euro and twelve cents (12,727,306.12.- EUR) represented by forty-two thousand and seventeen point eighty-
seven (42,017.87) Manager Shares and two hundred and twelve thousand five hundred and twenty-eight point twenty-
eight (212,528.28) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."
<i>Declarationi>
The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,
1915 on commercial companies.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately three thousand one hundred and fifty Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil
status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zwei tausend und neun.
Den elften September um 09.20 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,
avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,
hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,
55, avenue de la Gare,
auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-
kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP
GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 28. Februar 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP GLOBAL
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-
kunden:
I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit
Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B108922, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 30. Juni 2005,
97443
veröffentlicht im Memorial C Nummer 688 vom 13. Juli 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.
II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zwölf Millionen vier hundert ein und dreissig tausend vier hundert sieben
und achtzig Euro und siebzig Cents (12.431.487,70.- EUR), eingeteilt in ein und vierzig tausend drei und fünfzig Komma
sieben und zwanzig (41.053,27) Manager-Aktien und zwei hundert sieben tausend fünf hundert sechs und siebzig Komma
ein und fünfzig (207.576,51) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfzig Millionen Euro (50.000.000.- EUR) und ist aufgeteilt
in:
- neun hundert tausend (900.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie; und
- ein hundert tausend (100.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-
dienliche Angaben:
Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt
auszugeben:
- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000.- EUR) ausgegeben (d.h.
Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950.- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager
festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50.- EUR).
Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-
onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.
Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen
Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.
Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme
von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.
V.- Gemäss eines am 28. Februar 2008 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des ge-
nehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um zwei hundert fünf und neunzig tausend acht hundert achtzehn Euro zwei
und vierzig Cents (295.818,42.- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölf Millionen vier hundert ein
und dreissig tausend vier hundert sieben und achtzig Euro und siebzig Cents (12.431.487,70.- EUR) auf zwölf Millionen
sieben hundert sieben und zwanzig tausend drei hundert sechs Euro und zwölf Cents (12.727.306,12.- EUR) zu bringen
durch die Ausgabe von:
- vier tausend neun hundert ein und fünfzig Komma sieben und siebzig (4.951,77) neuen Vorzugsaktien mit einem
Nominalwert von je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von vier Millionen sieben
hundert vier tausend ein hundert ein und achtzig Euro und acht und fünfzig Cents (4.704.181.58.- EUR) welcher gänzlich
der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;
- neun hundert vier und sechzig Komma sechzig (964,60) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro
(50.- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.
VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen
übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von zwei hundert fünf und
neunzig tausend acht hundert achtzehn Euro zwei und vierzig Cents (295.818,42.- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag
von vier Millionen sieben hundert vier tausend ein hundert ein und achtzig Euro und acht und fünfzig Cents (4.704.181,58.-
EUR) als Emissionsagio.
Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-
drücklich von ihm festgestellt wird.
VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von
Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zwölf Millionen sieben hundert sieben und zwanzig tausend drei hundert
sechs Euro und zwölf Cents (12.727.306,12.- EUR), eingeteilt in zwei und vierzig tausend siebzehn Komma sieben und
achtzig (42.017,87) Manager-Aktien und zwei hundert zwölf tausend fünf hundert acht und zwanzig Komma acht und
zwanzig (212.528,28) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.-EUR) pro Aktie."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten,
Honorare und Auslagen werden auf ungefähr drei tausend ein hundert fünfzig Euro abgeschätzt.
97444
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige
Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: RÖSSLER; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2009. Relation GRE/2009/3328. Reçu soixante quinze euros 75 €
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial;
Junglinster, den 29. September 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009125631/178.
(090151668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Sidint S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 104.154.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2009.
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2009126878/12.
(090152592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Salros S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 78.197.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2009.
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2009126879/12.
(090152590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Raffaella, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 97.361.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RAFFAELLA S.À.R.L.
Angelo TERRUZZI
Référence de publication: 2009126785/12.
(090152478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97445
ICO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1541 Luxembourg, 42, boulevard de la Fraternité.
R.C.S. Luxembourg B 99.530.
Le bilan arrêté au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 2 octobre 2009.
<i>Pour I.C.O. SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2009126866/13.
(090152613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'In-
vestissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 108.375.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgelaufene
Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 30. September 2009.
<i>Für die Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR
i>Die Zentralverwaltungsstelle
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Manfred Dietrich / Diane Wolf
Référence de publication: 2009126872/16.
(090153067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Systems Advisers Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 68.587.
In the year two thousand and nine, on the twenty-third of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Systems Advisers Group S.A., a Luxem-
bourg public limited company (société anonyme) established under laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies register under number B 68.587, having its registered office at L-8069 Bertrange, 15, Rue de l'In-
dustrie, incorporated under the name of APACHE HOLDING S.à r.l. pursuant to a notarial deed of Maître Jean SECKLER,
notary residing in Junglinster on January 25
th
, 1999, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché
de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), number 344 of May 14
th
, 1999, amended for the
last time pursuant to a notarial deed of Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg on April 4
th
, 2006,
published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations), number 1333 of July 11
th
, 2006 (the Company).
The Meeting is opened with Mr Colm SMITH, Certified Public Accountant, residing professionally in Luxembourg, as
chairman.
The chairman appoints Mrs Corinne PETIT, private employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary of
the Meeting.
The Meeting elects Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the
Meeting.
The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of the Bureau
or the Bureau.
The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. the shareholder of the Company (the Shareholder) present or represented at the Meeting and the number of shares
which it holds are recorded in an attendance list, which will be signed by the Shareholder present and/or the holders of
powers of attorney who represent the Shareholder who are not present and the Members of the Bureau. The said list
97446
as well as the powers of attorney, after having been signed "ne varietur" by the persons who represent the Shareholders
who are not present and the undersigned notary, will remain attached to these minutes;
II. it appears from the attendance list that all one thousand two hundred and forty (1,240) shares with a nominal par
value of twenty-five euro (EUR 25), representing the entire subscribed share capital of the Company of thirty-one thou-
sand euro (EUR 31,000), are present or duly represented at the Meeting. The Shareholder present or represented declares
that it has had due notice of, and has been duly informed of the agenda prior to, the Meeting. The Meeting decides to
waive the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the
agenda, set out below;
III. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 374,000 (three hundred seventy-four
thousand euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) represented by
1,240 (one thousand two hundred and forty) shares (the Shares) and, all having a nominal value of EUR 25 (twenty-five
euro) per share each to an amount of EUR 405,000 (four hundred and five thousand euro) represented by 16,200 (sixteen
thousand two hundred) Shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) per share each;
3. Subscription and payment by a contribution in cash;
4. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 840,000 (eight hundred forty thousand
euro) in order to raise it from its previous amount of EUR 405,000 (four hundred and five thousand euro) represented
by 16,200 (sixteen thousand two hundred) shares and, all having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) per share
each to an amount of EUR 1,245,000 (one million two hundred and forty-five thousand euro) represented by 49,800
(forty-nine thousand eight hundred) Shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) per share each;
5. Subscription and payment by a contribution in kind;
6. Decision to amend article 3, first paragraph of the articles of association.
IV. the Meeting, after deliberation, passed the following resolutions by an unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at this Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 31,000 (thirty-
one thousand euro) by an amount of EUR 374,000 (three hundred seventy-four thousand euro) to an amount of EUR
405,000 (four hundred and five thousand euro) by the issuance of 14,960 (fourteen thousand nine hundred and sixty)
new Shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each.
Consequently, all the 14,960 (fourteen thousand nine hundred and sixty) new Shares to be issued have been fully
subscribed and paid up in cash by Mr Stephen JAMES so that the amount of EUR 374,000 (three hundred seventy-four
thousand euro) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 14,960 (fourteen thousand nine hundred and sixty) new Shares to be issued have been fully subscribed and paid
up in cash by Mr Stephen JAMES
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 405,000 (four
hundred and five thousand euro) by an amount of EUR 840,000 (eight hundred forty thousand euro) to an amount of
EUR 1,245,000 (one million two hundred and forty-five thousand euro) by the issuance of 33,600 (thirty-three thousand
six hundred) new Shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each.
Consequently, all the 33,600 (thirty-three thousand six hundred) new Shares to be issued have been fully subscribed
and paid up by a contribution in kind of an unquestionable shareholder's claim towards the company by Mr Stephen JAMES
so that the amount of EUR 840,000 (eight hundred forty thousand euro) is at the free disposal of the Company as has
been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 33,600 (thirty-three thousand six hundred) new Shares to be issued have been fully subscribed and paid up by
a contribution in kind by Mr Stephen JAMES.
97447
<i>Expertisei>
Pursuant to Articles 26-1 and 32-1 (5) of the modified law of 10
th
August 1915 on commercial companies, the
contribution in kind has been confirmed to the undersigned notary by a report dated September 11
th
, 2009, established
by the réviseur d'entreprises Grant Thornton Lux Audit S.A., with registered office at 83, Pafebruch, L-8308 Capellen,
R.C.S. Luxembourg number B 43.298.
The precited report which has the following conclusions shall remain attached to the present deed to be filed at the
same time:
<i>"Conclusion:i>
Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de
l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
Ce rapport est uniquement émis conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales et destiné au Conseil d'Administration, aux Actionnaires et au Notaires actant l'opération. Ce rapport ne
peut être utilisé à d'autres fins, ne peut être transmis à des tiers et ne peut être inclut ou référencé dans d'autres document
que ceux de l'Assemblée des Actionnaires décidant l'augmentation de capital de la Société, sans notre autorisation pré-
alable."
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the second and the third resolution, the Shareholder of the Company decides to amend article
3, first paragraph of the articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as
follows:
" Art. 3. First paragraph. The corporate capital is fixed at one million two hundred and forty-five thousand euro (EUR
1,245,000.-), divided into forty-nine thousand eight hundred (49,800) shares with a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each, entirely paid up."
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 2,900 (two thousand nine hundred euro).
There being no further business on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of the
present deed.
The document having been read to the appearing persons, acting in the here above stated capacities, known to the
notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present
original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mil neuf, le vingt-trois septembre.
Par devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de Systems Advisers Group S.A.,
une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 15, Rue de l'Industrie, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 68.587, constituée sous la
dénomination de APACHE HOLDING S.à r.l. suivant acte notarié reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence
à Junglinster du 25 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 344 du 14 mai 1999,
modifié pour la dernière fois suivant acte notarié reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 4 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1333 du 11 juillet 2006 (la
Société).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Colm SMITH, expert comptable, demeurant professionnellement
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président, le secrétaire et le scrutateur forment les Membres du Bureau ou le Bureau.
Le Bureau étant ainsi constitué, le président prie le notaire d'acter que:
97448
I. l'actionnaire de la Société (l'Actionnaire) présent ou représenté et le nombre d'actions détenue par lui ressortent
d'une liste de présence, signée par l'Actionnaire et/ou les mandataires de l'Actionnaire représenté en vertu de procura-
tions émises par ces derniers et les membres du Bureau. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après avoir
été signées "ne varietur" par les mandataires de l'Actionnaire représenté et par le notaire soussigné, resteront annexées
aux présentes minutes;
II. il résulte de cette liste de présence que les mille deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25) représentant l'intégralité du capital social souscrit d'un montant de trente et un mille euros (EUR
31.000) de la Société sont présentes ou représentées à la présente Assemblée. L'Actionnaire présent ou représenté
déclare avoir été dûment convoqué et informé de l'ordre du jour antérieurement à l'Assemblée. L'Assemblée décide de
renoncer aux formalités de convocation. L'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur tous
les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après;
III. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 374.000 (trois cent soixante-quatorze
mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 1.240 (mille
deux cent quarante) actions (les Actions), d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) par action, à un montant
de EUR 405.000 (quatre cent cinq mille euros) représenté par 16.200 (seize mille deux cents) Actions, d'une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) par action;
3. Souscription et libération par un apport en espèces;
4. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 840.000 (huit cent quarante mille euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 405.000 (quatre cent cinq mille euros) représenté par 16.200 (seize mille
deux cents) actions, d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) par action, à un montant de EUR 1.245.000 (un
million deux cent quarante-cinq mille euros) représenté par 49.800 (quarante-neuf mille huit cents) Actions, d'une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) par action;
5. Souscription et libération par un apport en nature;
6. Modification de l'article 3, alinéa 1
er
des statuts de la Société.
IV. l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer
aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour, qui leur a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 374.000 (trois cent soixante-
quatorze mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros) à un montant de
EUR 405.000 (quatre cent cinq mille euros) par l'émission de 14,960 (quatorze mille neuf cent soixante) nouvelles actions,
ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
Toutes les 14,960 (quatorze mille neuf cent soixante) nouvelles actions ordinaires à émettre ont été intégralement
souscrites et libérées en numéraire par Monsieur Stephen JAMES, de sorte que la somme de EUR 374.000 (trois cent
soixante-quatorze mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les 14,960 (quatorze mille neuf cent soixante) nouvelles actions ordinaires à émettre ont été intégralement
souscrites et libérées en numéraire par Monsieur Stephen JAMES.
<i>Troisième résolutioni>
L'actionnaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 840.000 (huit cent quarante mille
euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 405.000 (quatre cent cinq mille euros) à un montant de EUR 1.245.000
(un million deux cent quarante-cinq mille euros) par l'émission de 33,600 (trente-trois mille six cents) nouvelles actions,
ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
Toutes les 33,600 (trente-trois mille six cents) nouvelles actions ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites
et libérées par un apport en nature consistant dans l'apport d'une créance sur la Société par Monsieur Stephen JAMES,
de sorte que la somme de EUR 840.000 (huit cent quarante mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il
a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les 33,600 (trente-trois mille six cents) nouvelles actions ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites
et libérées par un apport en nature par Monsieur Stephen JAMES.
97449
<i>Expertisei>
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l'apport en nature ci-dessus décrit a
fait l'objet d'un rapport établi le 11 septembre 2009 par Grant Thornton Lux Audit, réviseur d'entreprises, ayant son
siège social au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen R.C.S. Luxembourg numéro B 43.298, lequel rapport, après signature "ne
varietur" par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
La valeur des créances ci-dessus mentionnées est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes.
<i>"Conclusion:i>
Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de
l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
Ce rapport est uniquement émis conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales et destiné au Conseil d'Administration, aux Actionnaires et au Notaires actant l'opération. Ce rapport ne
peut être utilisé à d'autres fins, ne peut être transmis à des tiers et ne peut être inclut ou référencé dans d'autres document
que ceux de l'Assemblée des Actionnaires décidant l'augmentation de capital de la Société, sans notre autorisation pré-
alable."
<i>Quatrième résolutioni>
A la suite de la deuxième et la troisième résolution, l'Actionnaire décide de modifier l'article 3, alinéa 1
er
des statuts
de la Société qui prendra dorénavant, dans sa version française, la teneur suivante:
" Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à un million deux cent quarante-cinq mille (EUR 1.245.000.-) divisé en
quarante-neuf mille huit cents (49.800) actions de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, entièrement libérées."
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 2.900 (deux mille neuf cents euros).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève l'Assemblée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties, le texte anglais fera foi
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d'eux connue, donnée aux parties comparantes,
agissant ès-qualités, connues du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, celles-ci ont signé
ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Smith, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 septembre 2009. LAC/2009/39358. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck Schneider.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009125612/226.
(090151216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
GuardOne International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 60.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2009.
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2009126887/12.
(090152579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97450
GuardOne International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 60.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2009.
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2009126889/12.
(090152577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Grand Banquet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 110.031.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 août 2009.
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2009126891/12.
(090152575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Punta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 11.241.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 15 avril 2009i>
- Les mandats d'Administrateur de Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant professionnellement
au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Christian FRANÇOIS, employé privé, demeurant profession-
nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, et de Monsieur Marino MANCUSO, Administrateur de société,
demeurant au 1, Ruelle du Temple, CH-1096 Cully et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CON-
TROLE S.A., Société Anonyme ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2015.
Fait à Luxembourg, le 15 avril 2009.
Certifié sincère et conforme
PUNTA S.A.
F. DUMONT / Ch. FRANCOIS
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2009126721/20.
(090152661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Participation Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 62.370.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2009.
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2009126881/12.
(090152584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97451
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 12.324.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2009.
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2009126882/12.
(090152583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 108.922.
In the year two thousand and nine.
On the eleventh day of September at 09.35 a.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED:
The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. having its registered office in L-1611 Luxembourg,
55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,
here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,
avenue de la Gare,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed
to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandité par actions PARTNERS
GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., S1CAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on December 22, 2008 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I.- The company PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having
its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B108922, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 30
th
of June 2005,
published in the Memorial C number 688 of the 13
th
of July 2005, and whose articles of incorporation have been amended
by deed of the undersigned notary on this day, not yet formalized.
II.- The Company has a share capital of thirteen million nine hundred and eighty thousand seven hundred and twenty-
four Euro and sixty-six cents (13,980,724.66.- EUR), represented by forty-six thousand one hundred and four point ninety-
nine (46,104.99) Manager Shares and two hundred and thirty-three thousand five hundred and nine point fifty-three
(233,509.53) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.
III.- The Company has an authorized capital of fifty million Euro (50,000,000.- EUR) divided into:
- nine hundred thousand (900,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- one hundred thousand (100,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as
follows:
Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising
the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and
- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined
by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).
The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are
referred to as "Contributions".
97452
The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of
the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.
The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,
drawdowns and payments upon drawdown.
V.- Pursuant to a resolution taken on December 22, 2008 the General Manager has decided to increase, within the
limits of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of three hundred and thirty-four
thousand two hundred and forty-six Euro and thirty-four cents (334,246.34.- EUR), in order to raise it from its present
amount of thirteen million nine hundred and eighty thousand seven hundred and twenty-four Euro and sixty-six cents
(13.980,724.66.- EUR) to the amount of fourteen million three hundred and fourteen thousand nine hundred and seventy-
one Euro (14,314,971.- EUR) by issuing:
- five thousand five hundred and ninety-five (5,595) new Ordinary Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR)
each, issued with a total share premium of five million three hundred and fifteen thousand two hundred and fifty Euro
(5,315,250.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;
- one thousand and eighty-nine point ninety (1,089.90) Manager Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR) each,
issued without share premium.
VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment
delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of three hundred and
thirty-four thousand two hundred and forty-six Euro and thirty-four cents (334,246.34.- EUR) as well as the amount of
five million three hundred and fifteen thousand two hundred and fifty Euro (5,315,250.- EUR) as share premium.
The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.
VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)
of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital. (paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of fourteen million three hundred and fourteen thousand nine hundred and
seventy-one Euro (14,314,971.EUR), represented by forty-seven thousand one hundred ninety-four point eighty-nine
(47,194.89) Manager Shares and two hundred and thirty-nine thousand one hundred and four point fifty-three (239,104.53)
Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."
<i>Declarationi>
The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,
1915 on commercial companies.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately three thousand three hundred and fifty Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil
status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zwei tausend und neun.
Den elften September um 09.35 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,
avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,
hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,
55, avenue de la Gare,
auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
97453
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-
kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP
GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 22. Dezember 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP GLO-
BAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-
kunden:
I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit
Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B108922, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 30. Juni 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 688 vom 13. Juli 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.
II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von dreizehn Millionen neun hundert achtzig tausend sieben hundert vier und
zwanzig Euro und sechs und sechzig Cents (13.980.724,66.- EUR), eingeteilt in sechs und vierzig tausend ein hundert vier
Komma neun und neunzig (46.104,99) Manager-Aktien und zwei hundert drei und dreissig tausend fünf hundert neun
Komma drei und fünfzig (233.509,53) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfzig Millionen Euro (50.000.000.- EUR) und ist aufgeteilt
in:
- neun hundert tausend (900.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie; und
- ein hundert tausend (100.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-
dienliche Angaben:
Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt
auszugeben:
- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000.- EUR) ausgegeben (d.h.
Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950.- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager
festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50.- EUR).
Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-
onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.
Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen
Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.
Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme
von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.
V.- Gemäss eines am 22. Dezember 2008 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des
genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um drei hundert vier und dreissig tausend zwei hundert sechs und vierzig
Euro und vier und dreissig Cents (334.246,34.- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von dreizehn Millionen
neun hundert achtzig tausend sieben hundert vier und zwanzig Euro und sechs und sechzig Cents (13.980.724,66.- EUR)
auf vierzehn Millionen drei hundert vierzehn tausend neun hundert ein und siebzig Euro (14.314.971.- EUR) zu bringen
durch die Ausgabe von:
- fünf tausend fünf hundert fünf und neunzig (5.595) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro
(50.- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von fünf Millionen drei hundert fünfzehn tausend zwei hundert
fünfzig Euro (5.315.250.- EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;
- ein tausend neun und achtzig Komma neunzig (1.089,90) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro
(50.- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.
VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen
übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von drei hundert vier und
dreissig tausend zwei hundert sechs und vierzig Euro und vier und dreissig Cents (334.246,34.- EUR) erhalten hat, so wie
den Betrag von fünf Millionen drei hundert fünfzehn tausend zwei hundert fünfzig Euro (5.315.250.- EUR) als Emissionsagio.
Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-
drücklich von ihm festgestellt wird.
VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von
Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
97454
" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von vierzehn Millionen drei hundert vierzehn tausend neun hundert ein und
siebzig Euro (14.314.971.- EUR), eingeteilt in sieben und vierzig tausend ein hundert vier und neunzig Komma neun und
achtzig (47.194,89) Manager-Aktien und zwei hundert neun und dreissig tausend ein hundert vier Komma drei und fünfzig
(239.104,53) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr drei
tausend drei hundert fünfzig Euro abgeschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige
Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: RÖSSLER; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2009. Relation GRE/2009/3331. Reçu soixante quinze euros 75 €
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial;
Junglinster, den 29. September 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009125628/174.
(090151668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
GuardOne International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 60.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2009.
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2009126883/12.
(090152582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Luxembourg Corporation Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 37.974.
<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenu le 1 i>
<i>eri>
<i> septembre 2009i>
A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Luxembourg Corporation Company SA (la "Société"), tenue
le 1
er
septembre 2009 il a été décidé comme suit:
- d'accepter la démission de M. Doeke van der Molen, de sa fonction d'administrateur et administrateur délégué avec
effet rétroactif au 28 Août 2009;
- d'accepter la démission de M. Mark Weeden, de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat
- de nommer Mme Christelle Ferry ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-
xembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet rétroactif au 28 Août 2009, son mandat prenant fin lors
de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.
Luxembourg, le 1
er
Septembre 2009.
Christelle Ferry
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2009126665/19.
(090153146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97455
Right Choice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 118.731.
Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la
présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs:
Mme Christelle ferry, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommé
en date du 29 Septembre 2009 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. et TCG
Gestion S.A. avec effet immédiat.
La Société informe également par la présente de la démission de la personne suivante en tant que représentant per-
manent de son administrateur:
Mr Doeke van der Molen a démissionné en date du 29 septembre 2009 de sa fonction de représentant permanent de
Luxembourg Corporation Company S.A. et TCG Gestion S.A. avec effet immédiat.
Luxembourg, le 29 septembre 2009.
Luxembourg Corporation Company SA / TCG Gestion SA
Par Christelle Ferry / Par Christelle Ferry
<i>Représentant Permanent / Représentant Permanenti>
Référence de publication: 2009126666/20.
(090153140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
BELUXOIL Handel und Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 42.885.
Le bilan arrêté au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 2 octobre 2009.
<i>Pour BELUXOIL HANDEL UND TRANSPORT SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman
Référence de publication: 2009126901/13.
(090152737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Klenke Schifffahrt S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5480 Wormeldange, 143, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 143.487.
Le bilan arrêté au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 2 octobre 2009.
<i>Pour KLENKE SCHIFFFAHRT SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman
Référence de publication: 2009126902/13.
(090152733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Schomburg-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 23, Potaschberg.
R.C.S. Luxembourg B 41.714.
Le bilan arrêté au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
97456
Ehnen, le 2 octobre 2009.
<i>Pour SCHOMBURG-LUX SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman
Référence de publication: 2009126903/13.
(090152732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Rainbow Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 94.865.
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 17 novembre 2008i>
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Harald CHARBON. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2013.
Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2008.
Certifié sincère et conforme
RAINBOW INVESTMENTS S.A.
S. BAERT / H. CHARBON
<i>Administrateur / Administrateur, Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2009126720/17.
(090152652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
EPP Suresnes Curie (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 105.392.
EXTRAIT
Il résulte, qu'en date du 6 février 2006 la société EPP THETA HOLDINGS (LUX), S.à r.l., ayant son siège social au 7,
Val Sainte-Croix, L- 1371 Luxembourg a changé sa dénomination sociale en celle de EPP SURESNES CURIE HOLDINGS
(LUX), S.à r.l.
Désormais l'associé unique de EPP Suresnes Curie (Lux) S.àr.l. se nomme EPP SURESNES CURIE HOLDINGS (LUX),
S.à r.l.
Luxembourg, le 28 septembre 2009.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2009126723/18.
(090152711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Tersicore Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8282 Kehlen, 12, rue de Keispelt.
R.C.S. Luxembourg B 137.767.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2009.
SG AUDIT SARL
Signatures
Référence de publication: 2009126875/12.
(090152599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97457
Soparef S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 96.715.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2009.
SG AUDIT SARL
Signatures
Référence de publication: 2009126876/12.
(090152595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 108.922.
In the year two thousand and nine.
On the eleventh day of September at 09.30 a.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED:
The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,
55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,
here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,
avenue de la Gare,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed
to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS
GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on August 28, 2008 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I.- The company PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having
its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B108922, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 30
th
of June 2005,
published in the Memorial C number 688 of the 13
th
of July 2005, and whose articles of incorporation have been amended
by deed of the undersigned notary on this day, not yet formalized.
II.- The Company has a share capital of thirteen million one hundred and forty-five thousand one hundred and twelve
Euro and thirty cents (13,145,112.30.- EUR) represented by forty-three thousand three hundred and eighty point twenty-
four (43,380.24) Manager Shares and two hundred and nineteen thousand five hundred and twenty-two point zero three
(219,522.03) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.
III.- The Company has an authorized capital of fifty million Euro (50,000,000.- EUR) divided into:
- nine hundred thousand (900,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- one hundred thousand (100,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as
follows:
Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising
the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and
- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined
by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).
The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are
referred to as "Contributions".
97458
The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of
the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.
The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,
drawdowns and payments upon drawdown.
V.- Pursuant to a resolution taken on August 28, 2008 the General Manager has decided to increase, within the limits
of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of eight hundred and thirty-five thousand
six hundred and twelve Euro and thirty-six cents (835,612.36.- EUR), in order to raise it from its present amount of
thirteen million one hundred and forty-five thousand one hundred and twelve Euro and thirty cents (13,145,112.30.- EUR)
to the amount of thirteen million nine hundred and eighty thousand seven hundred and twenty-four Euro and sixty-six
cents (13,980,724.66.- EUR) by issuing:
- thirteen thousand nine hundred and eighty-seven point fifty (13,987.50) new Ordinary Shares having a par value of
fifty Euro (50.- EUR) each, issued with a total share premium of thirteen million two hundred and eighty-eight thousand
one hundred and twenty-five Euro (13,288,125.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;
- two thousand seven hundred and twenty-four point seventy-five (2,724.75) Manager Shares having a par value of fifty
Euro (50.- EUR) each, issued without share premium.
VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment
delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of eight hundred and
thirty-five thousand six hundred and twelve Euro and thirty-six cents (835,612.36.- EUR) as well as the amount of thirteen
million two hundred and eighty-eight thousand one hundred and twenty-five Euro (13,288,125.- EUR) as share premium.
The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.
VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)
of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital. (Paragraph b) .
(b) The Corporation has a share capital of thirteen million nine hundred and eighty thousand seven hundred and
twenty-four Euro and sixty-six cents (13,980,724.66.- EUR), represented by forty-six thousand one hundred and four
point ninety-nine (46,104.99) Manager Shares and two hundred and thirty-three thousand five hundred and nine point
fifty-three (233,509.53) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."
<i>Declarationi>
The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,
1915 on commercial companies.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately five thousand and fifty Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil
status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zwei tausend und neun.
Den elften September um 09.30 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,
avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,
hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,
55, avenue de la Gare,
auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
97459
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-
kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP
GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 28. August 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP GLOBAL
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-
kunden:
I. - Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit
Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B108922, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 30. Juni 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 688 vom 13. Juli 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.
II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von dreizehn Millionen ein hundert fünf und vierzig tausend ein hundert zwölf
Euro und dreissig Cents (13.145.112,30.- EUR), eingeteilt in drei und vierzig tausend drei hundert achtzig Komma vier
und zwanzig (43.380,24) Manager-Aktien und zwei hundert neunzehn tausend fünf hundert zwei und zwanzig Komma null
drei (219.522,03) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfzig Millionen Euro (50.000.000.- EUR) und ist aufgeteilt
in:
- neun hundert tausend (900.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie; und
- ein hundert tausend (100.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-
dienliche Angaben:
Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt
auszugeben:
- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000.- EUR) ausgegeben (d.h.
Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950.- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager
festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50.- EUR).
Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-
onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.
Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen
Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.
Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme
von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.
V.- Gemäss eines am 28. August 2008 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des ge-
nehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um acht hundert fünf und dreissig tausend sechs hundert zwölf Euro und
sechs und dreissig Cents (835.612,36.- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von dreizehn Millionen ein
hundert fünf und vierzig tausend ein hundert zwölf Euro und dreissig Cents (13.145.112,30.- EUR) auf dreizehn Millionen
neun hundert achtzig tausend sieben hundert vier und zwanzig Euro und sechs und sechzig Cents (13.980.724,66.- EUR)
zu bringen durch die Ausgabe von:
- dreizehn tausend neun hundert sieben und achtzig Komma fünfzig (13.987,50) neuen Vorzugsaktien mit einem No-
minalwert von je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von dreizehn Millionen zwei
hundert acht und achtzig tausend ein hundert fünf und zwanzig Euro (13.288.125.- EUR) welcher gänzlich der Spezial
Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;
- zwei tausend sieben hundert vier und zwanzig Komma fünf und siebzig (2.724,75) Manager-Aktien mit einem Nomi-
nalwert von je fünfzig Euro (50.-EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.
VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen
übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von acht hundert fünf und
dreissig tausend sechs hundert zwölf Euro und sechs und dreissig Cents (835.612,36.- EUR) erhalten hat, so wie den
Betrag von dreizehn Millionen zwei hundert acht und achtzig tausend ein hundert fünf und zwanzig Euro (13.288.125.-
EUR) als Emissionsagio.
Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-
drücklich von ihm festgestellt wird.
VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von
Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
97460
" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von dreizehn Millionen neun hundert achtzig tausend sieben hundert vier
und zwanzig Euro und sechs und sechzig Cents (13.980.724,66.- EUR), eingeteilt in sechs und vierzig tausend ein hundert
vier Komma neun und neunzig (46.104,99) Manager-Aktien und zwei hundert drei und dreissig tausend fünf hundert neun
Komma drei und fünfzig (233.509,53) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf
tausend und fünfzig Euro abgeschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige
Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: RÖSSLER; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2009. Relation GRE/2009/3330. Reçu soixante quinze euros 75 €
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial.
Junglinster, den 29. September 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009125629/176.
(090151668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
AIM Group International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 60.279.
Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AIM GROUP INTERNATIONAL S.A.
DONATI Régis / DE BERNARDI Alexis
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009126935/12.
(090152480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Craft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 92.190.
Il résulte d'une assemblée générale ordinaire en date du 30.05.2009 que:
- Madame Mariette Schifferings, née le 01.02.1963 à Grevenmacher, demeurant à L-1481 Luxembourg, 8, rue Ee-
cherschmelz est nommée nouvel administrateur en remplacement de G.T. Fiduciaires SA, démissionnaire.
- Le commissaire aux comptes Fiduciaires Hellers, Kos & Associés, sàrl a changé de dénomination, la nouvelle déno-
mination étant G.T. Experts Comptables S.à r.l.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui
se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
G.T. Experts Comptables s.à r.l.
Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2009126960/19.
(090152817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97461
B-Lux G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 1D, Waïstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 140.991.
Le bilan arrêté au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 2 octobre 2009.
<i>Pour B-Lux GMBH
i>Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman
Référence de publication: 2009126936/13.
(090152727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Atto Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 180.000,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 102.748.
Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ATTO HOLDING S.A.R.L.
Alexis DE BERNARDI
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009126940/13.
(090152481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Polyval Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 19.692.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
POLYVAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009126942/13.
(090152486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Beim Kabouter Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5495 Wintrange, 16, am Pesch.
R.C.S. Luxembourg B 124.104.
Le bilan arrêté au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 2 octobre 2009.
<i>Pour BEIM KABOUTER SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman
Référence de publication: 2009126959/13.
(090152671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97462
Office Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 72.261.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire rectificative du 21 septembre 2009i>
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Michele Antonini, administrateur de sociétés, avec
adresse professionnelle 2, via Marconi à CH-6901 Lugano, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A.,
ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2009.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Un mandataire
Référence de publication: 2009126961/20.
(090153214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
ASK Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 99.111.
Par la présente, la société Crown Corporate Services déclare avoir démissionné de ses fonctions de Commissaire de
Ask Investments S.A., avec effet immédiat.
Luxembourg, le 25 septembre 2009.
CrownCorporate Services, s.à r.l.
Phillip van der Westhuizen
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009126966/13.
(090153087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Santarem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 86.912.
Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SANTAREM S.A.
DE BERNARDI Alexis / ROSSI Jacopo
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009126941/12.
(090152482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
LMT LUX SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 112.921.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
97463
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2009126967/12.
(090152935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Lambert Sport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 111.606.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2009126968/13.
(090152924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 108.922.
In the year two thousand and nine.
On the eleventh day of September at 09.25 a.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster. Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED:
The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,
55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,
here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,
avenue de la Gare,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed
to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS
GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on March 31, 2008 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I. - The company PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having
its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B108922, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 30
th
of June 2005,
published in the Memorial C number 688 of the 13
th
of July 2005, and whose articles of incorporation have been amended
by deed of the undersigned notary on this day, not yet formalized.
II.- The Company has a share capital of twelve million seven hundred and twenty-seven thousand three hundred and
six Euro and twelve cents (12,727,306.12.- EUR) represented by forty-two thousand and seventeen point eighty-seven
(42,017.87) Manager Shares and two hundred and twelve thousand five hundred and twenty-eight point twenty-eight
(212,528.28) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.
III.- The Company has an authorized capital of fifty million Euro (50,000,000.- EUR) divided into:
- nine hundred thousand (900,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- one hundred thousand (100,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as
follows:
Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising
the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and
97464
- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined
by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).
The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are
referred to as "Contributions".
The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of
the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.
The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,
drawdowns and payments upon drawdown.
V.- Pursuant to a resolution taken on March 31, 2008 the General Manager has decided to increase, within the limits
of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of four hundred and seventeen thousand
eight hundred and six Euro and eighteen cents (417,806.18.- EUR), in order to raise it from its present amount of twelve
million seven hundred and twenty-seven thousand three hundred and six Euro and twelve cents (12,727,306.12.- EUR)
to the amount of thirteen million one hundred and forty-five thousand one hundred and twelve Euro and thirty cents
(13,145,112.30.- EUR) by issuing:
- six thousand nine hundred and ninety-three point seventy-five (6,993.75) new Ordinary Shares having a par value of
fifty Euro (50.- EUR) each, issued with a total share premium of six million six hundred and forty-four thousand and sixty-
two Euro and fifty cents (6,644,062.50.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;
- one thousand three hundred and sixty-two point thirty-seven (1,362.37) Manager Shares having a par value of fifty
Euro (50.- EUR) each, issued without share premium.
VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment
delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of four hundred and
seventeen thousand eight hundred and six Euro and eighteen cents (417,806.18.- EUR) as well as the amount of six million
six hundred and forty-four thousand and sixty-two Euro and fifty cents (6,644,062.50.- EUR) as share premium.
The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.
VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)
of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital. (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of thirteen million one hundred and forty-five thousand one hundred and
twelve Euro and thirty cents (13,145,112.30.- EUR) represented by forty-three thousand three hundred and eighty point
twenty-four (43,380.24) Manager Shares and two hundred and nineteen thousand five hundred and twenty-two point
zero three (219,522.03) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."
<i>Declarationi>
The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,
1915 on commercial companies.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately three thousand six hundred and fifty Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil
status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zwei tausend und neun.
Den elften September um 09.25 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,
avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,
97465
hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,
55, avenue de la Gare,
auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-
kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP
GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR. mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches. gemäss eines
Beschlusses vom 31. März 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP GLOBAL
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-
kunden:
I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit
Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B108922, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 30. Juni 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 688 vom 13. Juli 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.
II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zwölf Millionen sieben hundert sieben und zwanzig tausend drei hundert
sechs Euro und zwölf Cents (12.727.306,12.- EUR), eingeteilt in zwei und vierzig tausend siebzehn Komma sieben und
achtzig (42.017,87) Manager-Aktien und zwei hundert zwölf tausend fünf hundert acht und zwanzig Komma acht und
zwanzig (212.528,28) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfzig Millionen Euro (50.000.000.- EUR) und ist aufgeteilt
in:
- neun hundert tausend (900.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie; und
- ein hundert tausend (100.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-
dienliche Angaben:
Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt
auszugeben:
- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000.- EUR) ausgegeben (d.h.
Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950.- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager
festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50.- EUR).
Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-
onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.
Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen
Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.
Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme
von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.
V.- Gemäss eines am 31. März 2008 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des geneh-
migten Kapitals, das Gesellschaftskapital um vier hundert siebzehn tausend acht hundert sechs Euro und achtzehn Cents
(417.806,18.- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölf Millionen sieben hundert sieben und zwanzig
tausend drei hundert sechs Euro und zwölf Cents (12.727.306,12.- EUR) auf dreizehn Millionen ein hundert fünf und
vierzig tausend ein hundert zwölf Euro und dreissig Cents (13.145.112,30.- EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:
- sechs tausend neun hundert drei und neunzig Komma fünf und siebzig (6.993,75) neuen Vorzugsaktien mit einem
Nominalwert von je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von sechs Millionen sechs
hundert vier und vierzig tausend zwei und sechzig Euro und fünfzig Cents (6.644.062,50.- EUR) welcher gänzlich der
Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;
- ein tausend drei hundert zwei und sechzig Komma sieben und dreissig (1.362,37) Manager-Aktien mit einem Nomi-
nalwert von je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.
VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen
übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von vier hundert siebzehn
tausend acht hundert sechs Euro und achtzehn Cents (417.806,18.- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von sechs
Millionen sechs hundert vier und vierzig tausend zwei und sechzig Euro und fünfzig Cents (6.644.062,50.- EUR) als Emis-
sionsagio.
Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-
drücklich von ihm festgestellt wird.
97466
VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von
Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von dreizehn Millionen ein hundert fünf und vierzig tausend ein hundert zwölf
Euro und dreissig Cents (13.145.112,30.- EUR), eingeteilt in drei und vierzig tausend drei hundert achtzig Komma vier
und zwanzig (43.380,24) Manager-Aktien und zwei hundert neunzehn tausend fünf hundert zwei und zwanzig Komma null
drei (219.522,03) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.-EUR) pro Aktie."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr drei
tausend sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige
Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: RÖSSLER; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2009. Relation GRE/2009/3329. Reçu soixante quinze euros 75 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Junglinster, den 29. September 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009125630/175.
(090151668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Patron Eurosail Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 142.148.
RECTIFICATIF
Suite à une erreur matérielle, le dépôt relatif au transfert de parts sociales du 27 novembre 2008, déposé au Registre
du Commerce en date du 18 décembre 2008 sous la référence L.080186862.05 doit être lue de la manière suivante:
- Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 27 novembre 2008 que la société PATRON
INVESTMENTS S.à r.l. a cédé les 500 parts sociales qu'elle détenait à la société PATRON CAPITAL GP III Limited, ayant
son siège social au 7B & 8, 50 Town Range, GIBRALTAR, actant pour le compte de Patron Capital L.P. III, ayant son
principal établissement à Suite 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar.
Pour extrait
La société
Signature
Référence de publication: 2009126660/18.
(090152474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
T2 Capital Finance Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 124.383.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2009:i>
- Est nommée administrateur de la société Mme. Rachel Aguirre, employé privée, résidant professionnellement au 2,
boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement de l'administrateur démissionnaire M. Rolf Caspers
avec effet du 1
er
octobre 2009.
- Le nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 statuant sur les comptes
annuels de 2009.
97467
Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
<i>Pour le conseil d'administration
i>Signatures
Référence de publication: 2009126535/16.
(090152339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
YNVENYTYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 76.925.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126566/10.
(090151968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 108.922.
In the year two thousand and nine.
On the eleventh day of September at 09.15 a.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED:
The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,
55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,
here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,
avenue de la Gare,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed
to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS
GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on December 3, 2007 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I - The company PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having
its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B108922, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 30
th
of June 2005,
published in the Memorial C number 688 of the 13
th
of July 2005, and whose articles of incorporation have been amended
by deed of the undersigned notary on this day, not yet formalized.
II.- The Company has a share capital of eleven million four hundred and twelve thousand and forty Euro and sixty cents
(11,412,040.60.- EUR) represented by thirty-seven thousand seven hundred and twenty-nine point zero eight (37,729.08)
Manager Shares and one hundred and ninety thousand five hundred and eleven point seventy-six (190,511.76) Ordinary
Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.
III.- The Company has an authorized capital of fifty million Euro (50,000,000.- EUR) divided into:
- nine hundred thousand (900,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- one hundred thousand (100.000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as
follows:
Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising
the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and
- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined
by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).
97468
The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are
referred to as "Contributions".
The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of
the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.
The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,
drawdowns and payments upon drawdown.
V.- Pursuant to a resolution taken on December 3, 2007 the General Manager has decided to increase, within the
limits of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of one million and nineteen thousand
four hundred and forty-seven Euro and ten cents (1,019,447.10.- EUR), in order to raise it from its present amount of
eleven million four hundred and twelve thousand and forty Euro and sixty cents (11,412,040.60.- EUR) to the amount of
twelve million four hundred and thirty-one thousand four hundred and eighty-seven Euro and seventy cents
(12,431,487,70.- EUR) by issuing:
- seventeen thousand and sixty-four point seventy-five (17,064.75) new Ordinary Shares having a par value of fifty Euro
(50.- EUR) each, issued with a total share premium of sixteen million two hundred and eleven thousand five hundred and
twelve Euro and fifty cents (16,211,512.50.-EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;
- three thousand three hundred and twenty-four point nineteen (3,324.19) Manager Shares having a par value of fifty
Euro (50.- EUR) each, issued without share premium.
VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment
delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of one million and
nineteen thousand four hundred and forty-seven Euro and ten cents (1,019,447.10.- EUR) as well as the amount of sixteen
million two hundred and eleven thousand five hundred and twelve Euro and fifty cents (16,211,512.50.- EUR) as share
premium.
The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.
VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)
of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital. (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of twelve million four hundred and thirty-one thousand four hundred and
eighty-seven Euro and seventy cents (12,431,487.70.- EUR) represented by forty-one thousand and fifty-three point
twenty-seven (41,053.27) Manager Shares and two hundred and seven thousand five hundred and seventy-six point fifty-
one (207,576.51) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."
<i>Declarationi>
The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,
1915 on commercial companies.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately five thousand four hundred Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil
status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zwei tausend und neun.
Den elften September um 09.15 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,
avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,
97469
hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,
55, avenue de la Gare,
auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-
kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP
GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 3. Dezember 2007 bezüglich einer Erhöhung des Gesell Schaftskapitals der PARTNERS GROUP GLO-
BAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.
Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-
kunden:
I. - Die Gesellschaft PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit
Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B108922, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 30. Juni 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 688 vom 13. Juli 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.
II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von elf Millionen vier hundert zwölf tausend und vierzig Euro und sechzig
Cents (11.412.040,60.- EUR), eingeteilt in sieben und dreissig tausend sieben hundert neun und zwanzig Komma null acht
(37.729,08) Manager-Aktien und ein hundert neunzig tausend fünf hundert elf Komma sechs und siebzig (190.511,76)
Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfzig Millionen Euro (50.000.000.- EUR) und ist aufgeteilt
in:
- neun hundert tausend (900.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie; und
- ein hundert tausend (100.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-
dienliche Angaben:
Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt
auszugeben:
- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000.- EUR) ausgegeben (d.h.
Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950.- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager
festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50.- EUR).
Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-
onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.
Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen
Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.
Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme
von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.
V.- Gemäss eines am 3. Dezember 2007 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des
genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um eine Million neunzehn tausend vier hundert sieben und vierzig Euro
zehn Cents (1.019.447,10.- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von elf Millionen vier hundert zwölf
tausend und vierzig Euro und sechzig Cents (11.412.040,60.- EUR) auf zwölf Millionen vier hundert ein und dreissig tausend
vier hundert sieben und achtzig Euro und siebzig Cents (12.431.487,70.- EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:
- siebzehn tausend vier und sechzig Komma fünf und siebzig (17.064,75) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert
von je fünfzig Euro (50.-EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von sechzehn Millionen zwei hundert elf
tausend fünf hundert zwölf Euro und fünfzig Cents (16.211.512,50.- EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Ge-
sellschaft zugeteilt wird;
- drei tausend drei hundert vier und zwanzig Komma neunzehn (3.324,19) Manager-Aktien mit einem Nominalwert
von je fünfzig Euro (50.- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.
VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen
übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von einer Million neunzehn
tausend vier hundert sieben und vierzig Euro zehn Cents (1.019.447,10.- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von
sechzehn Millionen zwei hundert elf tausend fünf hundert zwölf Euro und fünfzig Cents (16.211.512,50.- EUR) als Emis-
sionsagio.
Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-
drücklich von ihm festgestellt wird.
97470
VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von
Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zwölf Millionen vier hundert ein und dreissig tausend vier hundert sieben
und achtzig Euro und siebzig Cents (12.431.487,70.- EUR), eingeteilt in ein und vierzig tausend drei und fünfzig Komma
sieben und zwanzig (41.053,27) Manager-Aktien und zwei hundert sieben tausend fünf hundert sechs und siebzig Komma
ein und fünfzig (207.576,51) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50.- EUR) pro Aktie."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf
tausend vier hundert Euro abgeschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige
Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: RÖSSLER; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2009. Relation GRE/2009/3327. Reçu soixante quinze euros 75 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial;
Junglinster, den 29. September 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009125632/176.
(090151668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Investrand Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 115.401.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 juillet 2009i>
1) Monsieur Sébastien ANDRE a démissionné de son mandat de gérant.
2) Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant.
3) Monsieur Gérard BIRCHEN a démissionné de son mandat de gérant.
4) Monsieur Sinan SAR, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 juin 1980,
demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée.
5) Monsieur Dennis BOSJE, administrateur de sociétés, né à Amsterdam, (Pays-Bas), le 20 novembre 1965, demeurant
professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée.
6) Le nombre des gérants a été réduit de 3 (trois) à 2 (deux).
7) Le siège social de la Société à été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au
5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Investrand Investments I S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009125909/25.
(090151289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
97471
Jemco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 101.825.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 3 août 2009i>
Il a été décidé ce qui suit:
- Le Conseil après délibération, le Conseil d'Administration approuve la démission de Madame Natacha Steuermann
en sa qualité d'administrateur de catégorie B de la Société et décide de coopter en remplacement Madame Cristina
Floroiu, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.
- Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance en date du 22 juin 2010.
- Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
<i>Catégorie Ai>
* Monsieur Jean Douvre
* Monsieur Michel Reybier
<i>Catégorie Bi>
* Madame Véronique Wauthier
* Madame Cristina Floroiu
Extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur Bi>
Référence de publication: 2009126281/23.
(090151999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
RWZ Lux GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R.C.S. Luxembourg B 44.551.
Le bilan arrêté au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 2 octobre 2009.
<i>Pour RWZ LUX GMBH
i>Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman
Référence de publication: 2009126907/13.
(090152730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Volja Lux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 255.200,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 138.116.
<i>Extrait de la résolution prise lors du Conseil de gérance de la Société en date du 2 juillet 2009i>
En date du 2 juillet 2009, le Conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 51,
avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au:
- 5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 8 juillet 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Volja Lux, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2009126951/16.
(090152887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97472
International Power Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 86.755.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126911/11.
(090152949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 114.787.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009126912/11.
(090152943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
United First Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 148.341.
STATUTES
In the year two thousand nine, on the sixteenth day of September.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
(A) M. Michael Simon Maklouf HADJEDJ, company's director residing at 10-12 Hans Crescent London, SW1X OLJ
United Kingdom;
(B) M. Nagi Michel GHAWI, company's director, residing at 67 Earls Court Square, Flat A London SW5 9DG United
Kingdom;
(C) STA HOLDINGS LTD, a company incorporated in England and Wales (company number 04936333), having its
registered office at 4
th
Floor, 25 Copthall Avenue, London EC2R 7BP;
all here represented by M
e
Bertrand MOUPFOUMA, lawyer, residing professionally in Luxembourg;
by virtue of three proxies dated on 13 August 2009.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain attached to
the present deed in order to be registered with it.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a société anonyme which they form:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and these articles of incorporation.
The company exists under the name of "United First Partners".
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.
97473
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-
cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
The purpose of the corporation is also the acquisition and management of all kinds of intellectual property rights
including, without limitation, trade marks, patents, service marks, trade names, design rights, copyrights, database rights
and to grant licenses on this intellectual property rights.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at SEVENTY-FIVE THOUSAND POUND STERLING (75,000.- GBP) represented
by SEVENTY-FIVE THOUSAND (75,000) shares with a par value of ONE POUND STERLING (1.- GBP) each divided in
THIRTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY (33,750) class A shares, THIRTY-THREE THOUSAND SEVEN
HUNDRED FIFTY (33,750) class B shares and SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED (7,500) class C shares having all
the same rights (except what is provided in article 6).
Shares may be evidenced at the owner's option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. In case of plurality of shareholders, there shall at all times be no less than three directors who need not be
shareholders. Each class of shares shall be entitled to designate one director to be appointed by the General meeting of
shareholders,
In the case where the company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of
shareholders, it is established that the company has only one shareholder left, the composition of the board of directors
may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the board of directors or may be the
Sole Director of the company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.
The directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
Although no director appointed pursuant to the first paragraph may be removed from his or her post except in accordance
with the following provisions:
an A director may be removed at any time by the general meeting of shareholders only at the initiative of class A
shareholders;
a B director may be removed at any time by the general meeting of shareholders only at the initiative of class B
shareholders; and
a C director may be removed at any time by the general meeting of shareholders only at the initiative of class C
shareholders,
The directors will remain in function until their successors have been appointed. In case a director is elected without
mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
In the event of vacancy of a member of the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting
of shareholders which will be asked to ratify such election.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It
must be convened each time two directors so request.
The quorum at any meeting of the directors (including adjourned meetings) is one A director, one B director and one
C director. No business shall be conducted at any meeting of directors unless a quorum is present at the beginning of
the meeting and at the time when there is to be voting on any business.
97474
If a quorum is not present within 30 minutes after the time specified for a directors' meeting in the notice of the
meeting then it shall be adjourned for ten business days at the same time and place ("First Adjourned Meeting"). If at the
First Adjourned Meeting a quorum is not present within 30 minutes after the time specified for the directors' meeting in
the adjourned notice of the meeting, then the First Adjourned Meeting shall be adjourned for a further [ten] business
days at the same time and place ("Second Adjourned Meeting"). If at the Second Adjourned Meeting a quorum is not
present within 30 minutes after the time specified for the directors' meeting in the adjourned notice of the meeting, then
this meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.
All decisions of the board of directors require at least the approval of the A director and a B director.
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with that
of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.
If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the company and
its Sole Director having an interest conflicting with the one of the company.
Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole
signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors or the Sole
Director of the company, but only within the limits of such power.
Towards third parties, in all circumstances, the company shall also be, in case if a managing director has been appointed
in order to conduct the daily management and affairs of the company and the representation of the company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
However, the first managing director may be appointed by the general meeting of shareholders.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,
and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.
Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to
be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.
If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of share-
holders and takes the decisions in writing.
In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of shareholders
of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
company.
Any general meeting shall be convened in compliance with the Law. The general meeting shall be convened by means
of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate capital.
In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the
agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.
At any general meeting, the general meeting shall not validly deliberate unless at least three-fourths of the capital is
represented. All decisions by general meeting of shareholders shall be taken by at least three-fourths of the votes cast.
When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
97475
However, the nationality of the company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title IV.- Supervision
Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening
notices on the first Wednesday of June at 15.30 o'clock.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1
st
of April and shall terminate on the 31
st
of
March of the following year.
Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will
be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General provisions
Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10
th
1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end on the 31
st
of March
2010.
2) The first annual general meeting shall be held on 2010.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
Subscriber
Number
of shares
Share ca-
pital In
GBP
Class of
shares
%
Michael Simon Maklouf Hadjedj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,750
33,750.-
A
45
Nagi Michel Ghawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,750
33,750.-
B
45
STA HOLDINGS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,500
7,500.-
C
10
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75,000
75,000.-
100
All the shares have been paid up to the extent of twenty five percent (25%) by payment in cash, so that the amount
of EIGHTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY POUND STERLING (18,750.- GBP) is now available to the com-
pany, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10
th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
euro (1,400.- EUR).
97476
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at 3 and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
- M. Michael Simon Maklouf HADJEDJ, company's director, born in Vitry-sur-Seine (F) on 6 February 1979, residing
at 10-12, Hans Crescent London, SW1X OLJ (UK), as A Director
- M. Stéphane MARDEL, company's director, born in Paris (F) 12e arrondissement on 12 January 1976, residing at Flat
3 20 Upper Wimpole Street London W1G 61Z United Kingdom, as B Director
- M. John CALVERT, company's director, born in Harvington on 19 December 1955, residing at Tudor House, Bridge
End, Newport, Essex, CB11 3TH (UK), as C Director
3.- Has been appointed statutory auditor:
- M. Ronny MUNSTER, chartered accountant, born in London (UK) on 4 May 1959, residing at 4th Floor 25 Copthall
Avenue London EC2R 7BP (UK)
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2013.
5.- The registered office of the company is established in L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le seize septembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
(A) M. Michael Simon Maklouf HADJEDJ, administrateur de sociétés, résidant au 10-12, Hans Crescent Londres, SW1X
OLJ Royaume Uni;
(B) M. Nagi Michel GHAWI, administrateur de sociétés, résidant au 67, Earls Court Square, Flat A Londres SW5 9DG
Royaume Uni;
(C) STA HOLDINGS LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à 4
th
Floor, 25 Copthall Avenue, Londres
EC2R 7BP, immatriculée sous le numéro 04936333;
tous ici représentés par M
e
Bertrand MOUPFOUMA, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg;
en vertu de trois (3) procurations sous seing privé, données le 13 août 2009
Les dites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants, et par le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi
modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par les présents statuts.
La société existe sous la dénomination de "United First Partners".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par
simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
97477
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société a également pour objet l'acquisition et la gestion de toutes sortes de droits intellectuels, y inclus et sans y
être limité, les marques de fabrique, les brevets d'invention, les marques de service, les dénominations commerciales, les
dessins ou modèles, les droits d'auteur, les droits sur les bases de données et d'accorder des licences sur ces droits
intellectuels.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à SOIXANTE-QUINZE MILLE LIVRES STERLING (75.000,- GBP) représenté par
SOIXANTE-QUINZE MILLE (75.000) actions d'une valeur nominale d'une LIVRE STERLING (1,- GBP) chacune, réparties
en TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE (33.750) actions de catégorie A, TRENTE-TROIS MILLE SEPT
CENT CINQUANTE (33.750) actions de catégorie B et SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) actions de catégorie C
conférant toutes les mêmes droits (sauf ce qui est dit à l'article 6).
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non. Chaque catégorie d'actions pourra désigner un administrateur devant être
nommé par l'assemblée générale des actionnaires.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, le conseil d'administration peut être réduit à un administrateur
(L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un
actionnaire. Une personne morale peut être membre du conseil d'administration ou peut être l'Administrateur Unique
de la société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la loi.
Les administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Toutefois, les administrateurs nommés conformément au paragraphe premier ne pourront être révoqués
que conformément à la procédure qui suit:
Un administrateur de catégorie A ne pourra être révoqué par l'Assemblée générale des actionnaires qu'à l'initiative
des actionnaires de catégorie A;
Un administrateur de catégorie B ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires qu'à l'initiative des
actionnaires de catégorie B; et
Un administrateur de catégorie C ne pourra être révoqué par l'Assemblée générale des actionnaires qu'à l'initiative
des actionnaires de catégorie C.
Les administrateurs restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Dans le cas où un adminis-
trateur est élu sans indication de la durée de son mandat, il est réputé avoir été élu pour un terme de six ans.
En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. A toute réunion du conseil d'administration
(en ce compris les réunions tenues sur ajournement), le quorum de présence est de un administrateur de la classe A, un
administrateur de classe B et un administrateur de classe C. Aucune décision ne pourra être prise si le quorum de présence
n'est rempli au commencement de la réunion ainsi qu'au moment du vote. Si le quorum devait ne pas être atteint dans
les 30 minutes du début de la réunion telle que prévue dans la convocation, celle-ci sera ajournée et une nouvelle réunion
se tiendra au dixième jour ouvrable aux mêmes temps et lieu que prévus dans la convocation initiale. Si à cette seconde
réunion, le quorum n'est toujours pas atteint, la réunion sera à nouveau ajournée et une nouvelle réunion se tiendra au
97478
dixième jour ouvrable aux mêmes temps et lieu que prévus dans la convocation précédente sans qu'aucun quorum ne
soit requis.
Toutes les décisions du conseil d'administration requièrent au moins l'approbation d'un administrateur A et d'un
administrateur B.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil
d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la
séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres
résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt
opposé à celui de la société.
En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre
la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature
unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d'administration ou par l'Administrateur Unique de la société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la société sera engagée, en cas d'administrateur-délégué nommé pour la
gestion et les opérations courantes de la société et pour la représentation de la société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'administrateur délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Art. 12. La société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de
toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la société.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de
l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.
Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par
e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.
Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
A toute assemblée des actionnaires, l'assemblée ne délibérera valablement que si les trois-quarts au moins du capital
sont représentés. Toute décision de l'assemblée requérera pour être valable de réunir les trois-quarts au moins des votes
exprimés
Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Cependant, la nationalité de la société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.
97479
Titre IV. Surveillance
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V. Assemblée Générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier mercredi du mois de juin à 15.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
avril et finit le 31 mars de l'année suivante.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 mars 2010.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Souscripteur
Nombre
d'actions
Capital
social en
GBP
Classe
d'Actions
%
Michael Simon Maklouf Hadjedj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.750
33.750,-
A
45
Nagi Michel Ghawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.750
33.750,-
B
45
STA HOLDINGS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.500
7.500,-
C
10
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000
75.000,-
100
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%), de sorte que la somme de dix huit
mille sept cent cinquante LIVRES STERLING (18.750,- GBP) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros (1.400,-
EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
97480
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
- M. Michael Simon Maklouf HADJEDJ, administrateur de sociétés, né à Vitry-sur-Seine le 6 février 1979, résidant à
10-12, Hans Crescent Londres, SW1X OLJ Royaume Uni, en tant qu'administrateur de classe A
- M. Stéphane MARDEL, administrateur de sociétés, né à Paris (F) 12
e
arrondissement le 12 janvier 1976, résidant à
Flat 3 20 Upper Wimpole Street Londres W1G 61Z Royaume Uni, en tant qu'administrateur de classe B
- M. John CALVERT, administrateur de sociétés, né à Harvington le 19 décembre 1955, résidant à Tudor House, Bridge
End, Newport, Essex, CB11 3TH Royaume Uni, en tant qu'administrateur de classe C.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- M. Ronny MUNSTER, expert-comptable, né à Londres le 4 mai 1959, résidant à 4th Floor 25, Copthall Avenue
Londres EC2R 7BP Royaume Uni
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire de l'année 2013.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: B. Moupfouma, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 septembre 2009. Relation: ALC/2009/38085. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Fr. Schneider.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009126638/435.
(090152720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 114.787.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009126913/11.
(090152940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Mahe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 140.398.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 28 septembre 2009i>
La démission de Monsieur Lorenzo GIANELLO de son poste d'administrateur de la société est acceptée.
Monsieur Louis VEGAS-PIERONI, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel ad-
ministrateur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.
Pour extrait sincère et conforme
MAHE S.A.
Daniele MARIANI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009127011/15.
(090152835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97481
Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investis-
sement Spécialisé.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 100.893.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009126916/11.
(090152936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
CELSIUS EUROPEAN Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.026.800,00.
Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 134.347.
In the year two thousand and nine, on the twenty-third of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Clerical Medical Non Sterling Property Company S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of EUR 13,000, having its registered office at 23, route
d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 130.857, represented by Mr Simon Friend, here represented by Ms Aline Giersch, employee, with
professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 23 September 2009,
(the Sole Member).
Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Member, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the
entire share capital of CELSIUS EUROPEAN Lux 2 S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of EUR 3,026,700, having its registered office at 23,
route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 134.347 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary
residing in Sanem dated 10 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N°86
dated 12 January 2008, amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg dated 24 September 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 2602
dated 24 October 2008.
The Sole Member acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted. This having
been declared, the Sole Member, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 3,026,700
(three million twenty-six thousand seven hundred euro), represented by 30,267 (thirty thousand two hundred sixty-
seven) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each, by an amount of EUR 100 (hundred euro) to
an amount of EUR 3,026,800 (three million twenty-six thousand eight hundred euro), represented by 30,268 (thirty
thousand two hundred sixty-eight) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each, by way of the
issuance of 1 (one) share with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each.
<i>Subscription - Paymenti>
The new share to be issued has been fully subscribed and paid up by the Sole Member in cash together with a share
premium of EUR 1,799,900 (one million seven hundred ninety-nine thousand nine hundred euro) so that the amount of
EUR 1,800,000 (one million eight hundred thousand euro) is at the free disposal of the Company as has been proved to
the undersigned notary who expressly bears witness to it.
As a consequence of the share capital increase, the Sole Member holds all the 30,268 (thirty thousand two hundred
sixty-eight) shares of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Sole Member resolves to amend article 5, first paragraph of the articles
of association of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:
97482
" Art. 5. Corporate capital. The issued capital of the Company is fixed at EUR 3,026,800 (three million twenty-six
thousand eight hundred Euro) divided into 30,268 (thirty thousand two hundred sixty-eight) shares. Each issued share
has a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) and is fully paid up".
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove
mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mil neuf, le vingt-trois septembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Clerical Medical Non Sterling Property Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
avec un capital social de EUR 13,000, ayant son siège social au 23, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.857,
représentée par M. Simon Friend, ici représentée par Mme Aline Giersch, employée, ayant son adresse professionnelle
au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 23 septembre 2009,
(l'Associé Unique).
Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social
de la société à responsabilité limitée dénommée CELSIUS EUROPEAN Lux 2 S.à r.l. (la Société), société de droit luxem-
bourgeois, avec un capital social de EUR 3,026,700, ayant son siège social à 23, route d'Arlon, L-8009 Strassen,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B134.347, constituée selon un acte de
Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem du 10 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C-?86 en date du 12 janvier 2008, modifié la dernière fois selon un acte de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg du 24 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
C-N° 2602 en date du 24 octobre 2008.
L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée. Ceci ayant
été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR
3.026.700 (trois millions vingt-six mille sept cents euros) représenté par 30.267 (trente mille deux cent soixante-sept)
parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, par le biais d'une augmentation de EUR 100
(cent euros) à un montant de EUR 3.026.800 (trois millions vingt-six mille huit cents euros) représenté par 30.268 (trente
mille deux cent soixante-huit) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, par voie
d'émission d'une (1) nouvelle parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
<i>Souscription - Paiementi>
La nouvelle part sociale à émettre a été intégralement souscrite et libérée en numéraire par l'Associé Unique avec
une prime d'émission d'un montant de EUR 1.799.900 (un million sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent euros),
de sorte que la somme de EUR 1.800.000 (un million huit cent mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Suite à cette augmentation de capital, l'Associé Unique détient toutes les 30.268 (trente mille deux cent soixante-huit)
parts sociales de la Société.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la première résolution, l'Associé Unique de la Société décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5
des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 3.026.800 (trois millions vingt-six
mille huit cents euros) représenté par 30.268 (trente mille deux cent soixante-huit) parts sociales. Chaque part sociale
a une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) et est entièrement libérée."
97483
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'ont requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: A. Giersch et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 septembre 2009. LAC/2009/39360. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Franck Schneider.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009125613/113.
(090151156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
BREDA et Fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 62, rue Hiehl.
R.C.S. Luxembourg B 113.184.
Le bilan arrêté au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 2 octobre 2009.
<i>Pour BREDA ET FILS SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p. d. Viviane Roman
Référence de publication: 2009126921/13.
(090152757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
INVESCO European Hotel Real Estate II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.239.800,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.600.
In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Richard Kirfel, jurist, residing professionally in Luxembourg as Proxyholder on behalf of Invesco European Hotel
Real Estate Fund, a société d'investissement à capital variable - fonds d'invertissement spécialisé, having its registered
office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
being the sole member of Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg incorporated by deed of the notary Hellinckx on 21
st
October 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2734 of 10
th
November 2008. The
articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 29
th
June 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1532 of 8 August 2009.
The Proxy holder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all the twenty-nine thousand five hundred ninety-two (29,592) shares in issue in the Com-
pany, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Increase of the issued share capital of the Company from seven hundred thirty-nine thousand eight hundred euro
(EUR 739,800) to seven million two hundred thirty-nine thousand eight hundred euro (EUR 7,239,800) by the issue of
two hundred sixty thousand (260,000) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each against the
contribution in cash of six million five hundred thousand Euro (EUR 6,500,000.-); and consequential amendment of the
first sentence of article 5 of the articles of association of the Company.
The decisions taken by the sole member are as follows:
97484
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital of the Company from seven hundred thirty-nine thousand eight
hundred euro (EUR 739,800) to seven million two hundred thirty-nine thousand eight hundred euro (EUR 7,239,800) by
the issue of two hundred sixty thousand (260,000) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each
against the contribution in cash of six million five hundred thousand euro (EUR 6,500,000).
<i>Subscription and Paymenti>
All new shares will be subscribed by the sole shareholder of the Company. The payment has been proved to the notary
by a bank certificate which has been accepted by the undersigned. The money has been unblocked by the notary.
<i>Second resolutioni>
Consequently of the above, the meeting resolved to amend the first sentence of article 5 of the articles of association
of the Company to read as follows:
" Art. 5. First sentence. The issued share capital of the Company is set at seven million two hundred thirty-nine thousand
eight hundred euro (EUR 7,239,800) divided into two hundred eighty-nine thousand five hundred ninety-two (289,592)
shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each."
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at three thousand six hundred euro (EUR 3,600).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and German version, the English version will prevail.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, the said person appearing signed
together with the notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung
Im Jahre zweitausendundneun, am fünfundzwanzigsten September.
Vor der Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Richard Kirfel, Jurist, beruflich ansässig in Luxemburg, als Bevollmächtigter der Invesco European Hotel Real
Estate Fund, eine société d'investissement à capital variable - fonds d'invertissement spécialisé, mit Gesellschaftsitz in 25C,
boulevard Royal, L-2446 Luxemburg,
alleiniger Gesellschafter der Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, mit
Gesellschaftssitz in 25C, boulevard Royal, L-2446 Luxemburg, gegründet durch die Urkunde des Notars Hellinckx am 21.
Oktober 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétes et Associations, n° 2734 am 10. November 2008. Die
Satzung wurde das letzte Mal abgeändert durch Urkunde der Notarin Schaeffer am 29. Juni 2009, veröffentlicht im Mé-
morial C, Recueil des Sociétes et Associations n° 1532 am 8. August 2009.
Der Bevollmächtigte erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der alleinige Gesellschafter hält alle neunundzwanzigtausendfünfhundertzweiundneunzig (29.592) Gesellschaftsan-
teile, so dass rechtswirksam über alle Punkte der Tagesordnung entschieden werden kann.
2. Die Punkte, über die Beschlüsse gefasst werden soll, sind wie folgt:
- Erhöhung des Stammkapitals von siebenhundertneununddreißigtausendachthundert Euro (EUR 739.800,-) auf sieben
Millionen zweihundertneununddreißigtausendachthundert Euro (EUR 7.239.800,-) durch Ausgabe von zweihundertsech-
zigtausend (260.000) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) gegen Bareinlage von
sechs Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 6.500.000,-) und konsequenterweise Änderung des Artikels 5 Absatz 1
der Gesellschaftssatzung.
Der alleinige Gesellschafter hat folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Es wird beschlossen, das Stammkapital von siebenhundertneununddreißigtausendachthundert Euro (EUR 739.800,-)
auf sieben Millionen zweihundertneununddreißigtausendachthundert Euro (EUR 7.239.800,-) durch Ausgabe von zwei-
hundertsechzigtausend (260.000) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) gegen
Bareinlage von sechs Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 6.500.000,-) gezahlt durch den alleinigen Gesellschafter.
97485
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle neuen Anteile werden vom alleinigen Gesellschafter gezeichnet. Die Zahlung wurde dem Notar durch ein Bank-
zertifikat nachgewiesen, welches der Notar akzeptierte. Die Gelder wurden durch den Notar freigestellt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Konsequenterweise zu dem Vorgenannten, beschließt die Versammlung die Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der
Satzung wie folgt:
„ Art. 5. Absatz 1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt sieben Millionen zweihundertneununddreißigtausen-
dachthundert Euro (EUR 7.239.800,-) geteilt in zweihundertneunundachtzigtausendfünfhundertzweiundneunzig (289.592)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-)."
<i>Kosteni>
Sämtliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf ungefähr
dreitausendsechshundert Euro (EUR 3.600,-) geschätzt.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorn-
amen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: R. Kirfel et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 septembre 2009. LAC/2009/39901. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck Schneider.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009127534/103.
(090153489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2009.
Reybier Développement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 62.947.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 3 août 2009i>
Il a été décidé ce qui suit:
- Le Conseil d'Administration approuve la démission de Madame Natacha Steuermann en sa qualité d'administrateur
de la Société et décide de coopter en remplacement Madame Delphine Goergen, employée privée, demeurant profes-
sionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.
- Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2015.
- Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
<i>Groupe Ai>
* Madame Véronique Wauthier
* Madame Delphine Goergen
<i>Groupe Bi>
* Monsieur Michel Reybier
* Monsieur Gilles Frachon
Extrait certifié conforme
Signature / Signatures
<i>Administrateur A / Administrateur Bi>
Référence de publication: 2009126279/23.
(090152020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
97486
Pesa Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5324 Contern, 1A, rue des Chaux.
R.C.S. Luxembourg B 45.402.
L'an deux mille neuf.
Le onze septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme holding PESA S.A., R.C.S. Luxembourg B 25208, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, domicilié professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de
Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
1.- Que la société à responsabilité limitée PESA TRANSPORTS S.à r.l., ayant son siège social à L-1264 Luxembourg,
2, rue de Bridel, R.C.S. Luxembourg section B numéro 45402, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné,
en date du 27 septembre 1993, publié au Mémorial C numéro 592 du 13 décembre 1993 et que ses statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 décembre 1999, publié au Mémorial
C numéro 297 du 20 avril 2000.
2.- Que la comparante est l'associée unique de la prédite société PESA TRANSPORTS S.à r.l. et qu'elle a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales et d'échanger les six mille (6.000) parts
sociales existantes contre six mille (6.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique constate et, si nécessaire, décide que le capital est fixé à cent quarante-huit mille sept cent trente-
six Euros et onze Cents (EUR 148.736,11), représenté par six mille (6.000) parts sociales sans désignation de valeur
nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts de la Société, qui aura dorénavant la
teneur suivant:
" Art. 6. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à cent quarante-huit mille sept cent trente-six Euros et onze Cents (EUR
148.736,11), représenté par six mille (6.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale."
<i>Quatrième résolutioni>
L'associée unique décide de transférer le siège social de L-1264 Luxembourg, 2, rue de Bridel, à L-5324 Contern, la,
rue des Chaux, et de modifier dès lors le premier alinéa de l'article cinq des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. 1
er
alinéa. Le siège social est établi à Contern."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent vingt-cinq euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 2009. Relation GRE/2009/3358. Reçu soixante quinze euros 75 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Junglinster, le 1
er
octobre 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009126672/51.
(090152923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
97487
Tinerama Investment A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 51.927.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendneun, am einundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitze in Luxemburg,
Ist erschienen:
Die Gesellschaft TELOR INTERNATIONAL LIMITED, mit Gesellschaftssitz in Douglas, Isle of Man,
„die Komparentin",
hier vertreten durch Herrn Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 2,
avenue Charles de Gaulle, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt am 14. September 2009,
„der Bevollmächtigte".
Die vorgenannte Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtieren-
den Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, erklärt und bietet den Notar zu beurkunden:
1. Dass die Holdingaktiengesellschaft TINERAMA INVESTMENT A.G., R.C.S. Luxemburg B 51.927, mit Sitz in Luxem-
burg, 2, avenue Charles de Gaulle, am 8. August 1995 durch Notar Léon Thomas genannt Tom METZLER, mit
Amtswohnsitz in Luxembourg, gegründet wurde, und die Satzung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
Nr. 529 vom 16. Oktober 1995 veröffentlicht wurde.
2. Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf fünfzigtausend US Dollars (USD 500.000,-) beläuft, eingeteilt in fünftausend
(5.000) voll eingezahlte Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert US Dollars (USD 100,-).
3. Dass die Komparentin Eigentümerin aller Aktien der Gesellschaft geworden ist.
4. Dass die Komparentin, in ihrer Eigenschaft als alleinige Aktionärin, ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft, welche ihre
Tätigkeit eingestellt hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liquidieren.
5. Dass die Komparentin erklärt die finanzielle Situation der Gesellschaft bestens zu kennen.
6. Dass die Komparentin, in ihrer Eigenschaft als Liquidator, außerdem erklärt, dass:
- sie alle Aktiva übernommen hat,
- dass alle Passiva (gegenüber Dritten) beglichen sind,
- dass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, unbeschadet der Tatsache, dass die Unterzeichnete persönlich
für die von der Gesellschaft eventuell eingegangenen und zum Zeitpunkt der Liquidation noch nicht bekannten Verbind-
lichkeiten haftet,
- dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu betrachten ist.
6. Dass die Komparentin sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar Entlastung erteilt.
7. Dass der Vollmachtnehmer das Register der Gesellschaft annullieren wird und die Aktien annulliert worden sind.
8. Dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren am früheren Sitz der Gesellschaft aufbewahrt
werden.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form au immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro.
WORUEBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat derselbe mit Uns Notar vorlie-
gende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Pierre LENTZ, Carlo WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2009. LAC/2009/38771. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck SCHNEIDER.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 29. September 2009.
Carlo WERSANDT.
Référence de publication: 2009126280/51.
(090152054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
97488
Aeris Technology Investment Company S.A., SICAR
AIM Group International S.A.
ASK Investments S.A.
Atto Holding S.àr.l.
Beim Kabouter Sàrl
BELUXOIL Handel und Transport S.à r.l.
B-Lux G.m.b.H.
BREDA et Fils s.à r.l.
CELSIUS EUROPEAN Lux 2 S.à r.l.
Craft S.A.
EPP Suresnes Curie (Lux) S.à r.l.
Grand Banquet S.A.
GuardOne International S.A.
GuardOne International S.A.
GuardOne International S.A.
ICO S.à r.l.
International Power Investments S.à r.l.
INVESCO European Hotel Real Estate II S.à r.l.
Investrand Investments I S.à r.l.
Jemco S.A.
Klenke Schifffahrt S. à r. l.
Lambert Sport S.à r.l.
LMT LUX SA
Luxembourg Corporation Company S.A.
Mahe S.A.
Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A.
Office Investments S.A.
Participation Group S.A.
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR
Patron Eurosail Holdings Sàrl
Pesa Transports S.à r.l.
Polyval Holding S.A.
Punta S.A.
Raffaella
Rainbow Investments S.A.
Reybier Développement S.A.
Right Choice S.A.
RWZ Lux GmbH
Salros S.A.
Santarem S.A.
Schomburg-Lux S.à r.l.
Sidint S.A.
Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS
Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS
Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS
Soparef S.A.
Systems Advisers Group S.A.
T2 Capital Finance Company S.A.
Tersicore Invest S.A.
Tinerama Investment A.G.
United First Partners
Volja Lux, S.à r.l.
YNVENYTYS S.A.