This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2018
15 octobre 2009
SOMMAIRE
Amperja S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96861
Aratus Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96837
Biguel Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96864
Broad Point II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96830
Captiva Capital Management S.à r.l. . . . . .
96829
Carihold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96829
Caroline Holdings S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
96848
CNA Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96831
Crèche Tiramisu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96860
CSC Computer Sciences Luxembourg SA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96829
Cube Infrastructure Fund . . . . . . . . . . . . . . .
96821
De La Rue Cash Systems NV . . . . . . . . . . . .
96848
Delilah US Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .
96845
Diversified Ventures GP, S. à r.l. . . . . . . . . .
96843
DNA Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96846
ERE III - No 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96861
Européenne de Participations et de Signa-
lisation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96830
Fin Po S.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96836
FIVEST (Financière d'Investissements)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96844
FIVEST (Financière d'Investissements)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96844
FIVEST (Financière d'Investissements)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96844
FKI Luspartwo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96828
Gipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96829
Ippocrate Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . .
96828
Itaca International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96843
Klammer Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
96860
Kraftsal A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96847
Lampas Royal Participations S.A. . . . . . . . .
96831
LBPOL City S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96828
LIPP 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96861
Lux Participation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96843
Masco Europe INC Financial S.C.S. . . . . . .
96831
Mat Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96848
Mylan Luxembourg 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
96821
Natec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96830
New Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
96830
Nikolaj S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96849
Plock S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96843
Prax Capital China Growth GP, S.àr.l. . . .
96845
Prax Capital Real Estate I GP, S.à r.l. . . . .
96845
Protin Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96847
Purp Holdings Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . .
96861
Remasi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96846
Rigotel Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .
96847
Segro Lux Vimercate S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
96831
Sibelco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96846
Sigma Capital Investments S.A. . . . . . . . . .
96864
SLV Electronik S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96829
SLV Electronik S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96830
Solibra Solar Power Plants S.à r.l. . . . . . . .
96832
Soluprom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96818
Spartex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96848
State Street Bank Luxembourg S.A. . . . . .
96861
Stevin Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96847
Talaris (Belux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96848
Transteeg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96828
Trois Délices S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96846
Ulysses Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96818
Ulysses Participation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
96831
Via Com Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . .
96821
Villa Care S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96837
Whatman Luxembourg Three S.à.r.l. . . . .
96844
Whatman Luxembourg Two S.à r.l. . . . . .
96845
96817
Ulysses Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.300.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 132.623.
<i>Transfert de partsi>
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 25 mars 2009, que ULYSSES FINANCE S.à r.l. a
transféré 5.591.338 parts sociales ordinaires à
- SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2009.
ULYSSES FINANCE S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2009125364/16.
(090150566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Soluprom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf, 56, avenue François Clement.
R.C.S. Luxembourg B 148.277.
STATUTS
L'an deux mil neuf, le vingt-et-un septembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Pascal SIEBENALER, agent immobilier, né le 22 juin 1968 à Hayange (France), demeurant à Rodemack,
12, Rue Christophe 1
er
de Bade (France).
2) La société TOP PARTICIPATIONS S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 juillet
2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1732 du 8 septembre 2009,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 147618,
ici représentée par son administrateur unique, Monsieur Guy LANNERS, expert-comptable, né à Luxembourg le 9
septembre 1965, demeurant à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, pouvant engager la société par sa seule
signature.
Lesquels comparants, agissant ès-qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "SOLUPROM
S.à r.l.".
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Mondorf.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci, à quelque titre que ce soit , la réalisation, l'exploitation et la rénovation en tant que prestataire
de service ainsi que l'achat, la vente, la location, la gestion, la gérance et la mise en valeur d'immeubles, la promotion
immobilière ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Elle peut apporter également son concours commercial, financier, juridique et technique sous toutes formes pour
assister les entreprises et sociétés situées tant au Luxembourg que dans tous les autres pays désirant réaliser à l'extérieur
de leur pays leur objet social.
Cet objet social comprend finalement toutes opérations généralement quelconques industrielles, commerciales, fi-
nancières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ou susceptibles
de le promouvoir.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
96818
Titre II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq (125,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans la distribution des
bénéfices.
Art. 7. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque
héritier au légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux
dispositions de l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas
trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Art. 8. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 9. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à 1a société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
Titre III. Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par décision de l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur mandat.
Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée.
Le ou les gérant(s) peuvent nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société,
dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.
Le ou les gérant(s) sont habilités à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-
Duché qu'à l'étranger.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.
Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Titre IV. Décisions des associés
Art. 12. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée
des associés.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa premier sont inscrites sur un procès-verbal ou
établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est applicable qu'aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Titre V. Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
L'associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
96819
Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, jusqu'à ce
que celui-ci ait atteint le dixième du capital social. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve
légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce
que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de
la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI. Dissolution
Art.15. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article
7 des présents statuts.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en fonction ou à défaut, par
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés et révocables par l'assemblée générale des associés à la majorité
fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif,
après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s'en réfèrent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.
<i>Souscription et Libération du capital sociali>
Les cent (100) parts sociales sont souscrites comme suit:
Actionnaires
Capital souscrit
(EUR)
Nombre
de parts
Montant libéré
(EUR)
Pascal SIEBENALER, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,00
50
6.250,00
TOP PARTICIPATIONS S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,00
50
6.250,00
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,00
100
12.500,00
Toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1. Est nommée gérant technique de la Société pour une durée indéterminée, Monsieur Pascal SIEBENALER, préqualifié.
2. Est nommé gérant administratif de la Société pour une durée indéterminée, Monsieur Guy LANNERS, préqualifié.
3. La Société est valablement engagée par la signature conjointe des gérants administratif et technique.
4. Le siège de la société est établi à l'adresse suivante:
L-5612 Mondorf, 56, avenue François Clement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, respectivement mandataire de la personne comparante,
connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparant et mandataire ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: Pascal SIEBENALER, Guy LANNERS, Carlo WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2009. LAC/2009/38765. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck SCHNEIDER.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
96820
Luxembourg, le 29 septembre 2009.
Carlo WERSANDT.
Référence de publication: 2009124842/145.
(090150519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Cube Infrastructure Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.234.
<i>Extrait des résolutions prisesi>
<i>lors du Conseil d'Administration du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2009i>
En date du 1
er
avril 2009, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission avec effet au 1
er
novembre 2008 de Monsieur Chicco Testa, en qualité d'Administrateur.
- de nommer Monsieur Patrick Zurstrassen, MDO Services, 19, rue de Bitbourg, L-1723 Luxembourg en qualité d'Ad-
ministrateur, en remplacement de Monsieur Chicco Testa, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 septembre 2009.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administration
i>Signatures
Référence de publication: 2009125385/17.
(090150845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Via Com Holding S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 56.945.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2009125466/13.
(090151502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Mylan Luxembourg 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.313.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the eighteenth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Mylan EMEA SAS, a company incorporated under the laws of France, having its registered office at 117, Allée des Parcs,
69792 Saint-Priest Cedex, France, registered with the "Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon" under number 499
944 734 00023, here represented by Ms. Verena Zimmermann, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given on 10 of September 2009 in Saint Priest, France.
The said proxy, initialed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorporation
of which shall be as follows:
96821
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 4. The Company will be incorporated under the name of "Mylan Luxembourg 6 S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution
of the manager or the board of managers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion
to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one class A and
one class B manager or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by one class
A and one class B manager.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and
may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
96822
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the sha-
reholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emer-
gency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be
omitted in case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of
communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without
electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least a majority of its members (ii) including one class
A and one class B managers are present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, including at
least one class A manager and one class B manager. The chairman shall not have a casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two (2) managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective decisions of the Shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general
meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended.
E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits
Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are
sufficient.
The share premium is freely distributable to the shareholders by the shareholders' meeting or by the board of managers.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
96823
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
All of the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Mylan EMEA SAS, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.00) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December
2010.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.00).
<i>Resolutions of the Sole Shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed
capital has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The sole shareholder resolves to elect as class A managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. David Lee Kennedy, business professional, with professional address at 1500 Corporate Drive, Canonsburg,
Pennsylvania 15317, United States of America, born on 27 October 1953 in Morgantown, West Virginia, United States
of America;
- Ms. Kristin Ann Kolesar, attorney, with professional address at 1500 Corporate Drive, Canonsburg, Pennsylvania
15317, United States of America, born on 25 June 1969 in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America;
- Ms. Nadine Guigue, CFO, with professional address at 117, Allée des Parcs, F-69800 Saint-Priest, France, born on 5
November 1958 in Lyon, France.
3. The sole shareholder resolves to elect as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Jean-Marc Ueberecken, with professional address at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, born on 31 May 1972
in Luxembourg-City, Luxembourg;
- Mr. Michel Raffoul, with professional address at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, born on 9 November 1951 in
Accra, Ghana.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
person, this deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said person appearing signed together
with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mil neuf, le dix-huit septembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Mylan EMEA SAS, une société constituée selon les lois de France, ayant son siège social à 117, Allée des Parcs, 69792
Saint-Priest Cedex, France, immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro 499 944
734 00023, ici représentée par Mme Verena Zimmermann, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée en date du 10 septembre 2009 à Saint-Priest, France.
La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
96824
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts, accorder des sûretés en faveur de ou assister autrement des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés
que la Société.
La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures
sociétaires similaires.
La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations
qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement
à cet objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société est constituée sous le nom de "Mylan Luxembourg 6 S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des
associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans
tous autres pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00) représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un Euro (EUR 1,00).
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés
existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numé-
raire.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société et ses affaires sont gérées par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-
ment révocables à tout moment et sans cause.
Aucun gérant ne peut être nommé si, en conséquence, une majorité des gérants serait des personnes avec une rési-
dence fiscale au Royaume-Uni.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant
de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature de toute autre personne à laquelle pareil pouvoir de signature
aura été déléguée par un gérant de classe A et un gérant de classe B.
96825
Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également
choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les
associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de telles réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de
l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier
électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou
d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
D. Décisions de l'Associé unique - Décisions collectives des Associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés
par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des Bénéfices
Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre
de la même année.
Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent
un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communi-
cation au siège social de l'inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.
La prime d'émission est librement distribuable aux associés par l'assemblée générale des associés ou par le conseil de
gérance.
96826
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
L'intégralité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales a été souscrite par Mylan EMEA SAS, pré-qualifiée.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500,00) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Provisions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de
décembre 2010.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300,00).
<i>Résolutions de l'Associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. L'associé unique décide d'élire les personnes suivantes en tant que gérants de classe A de la Société pour une durée
indéterminée:
- M. David Lee Kennedy, né le 27 octobre 1953 à Morgantown, West Virginia, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle à 1500 Corporate Drive, Canonsburg, 15317 Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique;
- Mme Kristin Ann Kolesar, née le 26 juin 1969 à Pittsburgh, Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse pro-
fessionnelle à 1500 Corporate Drive, Canonsburg, 15317 Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique;
- Mme Nadine Guigue, née le 5 novembre 1958 à Lyon, France, avec adresse professionnelle à 117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest, France.
3. L'associé unique décide d'élire les personnes suivantes en tant que gérants de classe B de la Société pour une durée
indéterminée:
- M. Jean-Marc Ueberecken, né le 31 mai 1972 à Luxembourg-Ville, Luxembourg, avec adresse professionnelle à 14,
rue Erasme, L-2082 Luxembourg;
- M. Michel Raffoul, né le 9 novembre 1951 à Accra, Ghana, avec adresse professionnelle à professionnelle à 14, rue
Erasme, L-2082 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce
dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, ce dernier a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: V. Zimmermann et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 septembre 2009. Relation: LAC/2009/38848. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Franck SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009125324/329.
(090151726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96827
Ippocrate Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 596.600,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.959.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
<i>Pour Ippocrate Luxembourg S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2009125495/13.
(090151603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
LBPOL City S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 112.903.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
<i>Pour LBPOL City S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2009125496/13.
(090151601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
FKI Luspartwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 246.016.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 73.137.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
<i>Pour la société
FKI Luspartwo s.à. r.l.
i>99, Grand Rue
L-1661 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2009125651/16.
(090151274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Transteeg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 142.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2009126333/11.
(090152027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96828
SLV Electronik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.900.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 130.420.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126343/12.
(090151937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Gipar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.962.
Les comptes annuels au 30 novembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126338/10.
(090152046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Carihold S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 63.985.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126339/10.
(090152047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
CSC Computer Sciences Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.901.
Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009126340/10.
(090152050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Captiva Capital Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 92.025.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009126341/11.
(090151944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96829
Natec S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 33.445.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126336/10.
(090152041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Européenne de Participations et de Signalisation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 75.916.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009126337/10.
(090152042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Broad Point II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.925.
Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hille Paul Schut
<i>Manageri>
Référence de publication: 2009126342/11.
(090151943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
SLV Electronik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.900.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 130.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126344/11.
(090151935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
New Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 106.556.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126345/11.
(090151934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96830
Lampas Royal Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 85.779.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 août 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126328/10.
(090152009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
CNA Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.341.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126335/10.
(090152035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Masco Europe INC Financial S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 326.964.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 114.183.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126346/11.
(090151932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Ulysses Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.050.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 136.220.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126347/11.
(090151931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Segro Lux Vimercate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.585.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.358.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126348/11.
(090151927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96831
Solibra Solar Power Plants S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 148.308.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twenty-first of September.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- Mr Ashton Johann FRUHLING, residing at 87 Hohenrhein, D-56112 Lahnstein,
here represented by Mr Sebastien PHILIPPI, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 17 September 2009.
2.- Mr Benjamin Frank STÜTZEL, residing at 26 Neustädter Weg, D-40229 Dusseldorf,
here represented by Mr Sebastien PHILIPPI, previously named, by virtue of a proxy, given on 17 September 2009.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").
Art. 2. The object of the company is to run, to purchase and to sell companies, and solar power plants or parts of it,
producing solar energy.
The object of the Company is also the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg
or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "SOLIBRA SOLAR POWER PLANTS S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) represented by ten thousand (10,000) shares of
five Euro (EUR 5.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
96832
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The corporation will be committed by the individual signature of the sole manager.
In case of plurality of managers, the corporation will be committed by the individual signature of any of the managers.
If the Shareholders' Meeting decides to create 2 categories of managers (managers A and managers B) the company will
be committed by the joint signatures of two managers A or by the joint signatures of a manager A and a manager B.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders representing at
least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on the second Monday of May at 10 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholders) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31
st
of December 2009.
<i>Subscription - Paymenti>
The ten thousand (10,000) shares have been entirely subscribed by
1. Mr Ashton Johann FRUHLING, prenamed, five thousand two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,200
2. Mr Benjamin Frank STÜTZEL, prenamed, four thousand eight hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,800
Total: ten thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of fifty thousand Euro (EUR 50.000.-) is at the disposal
of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand euro.
96833
<i>Resolutions of the shareholdersi>
1) The following are appointed Managers of the company:
- Mr Ashton Johann FRUHLING, born on 1
st
January 1967 in Koblenz, Manager, with address at 87 Hohenrhein,
D-56112 Lahnstein.
- Mr Benjamin Frank STÜTZEL, born on 15 December 1977 in Neuwied, Director, with address at 26 Neustädter
Weg, D-40229 Dusseldorf.
The duration of their mandate is unlimited.
The Company will be bound by the individual signature of any of the aforesaid Managers.
2) The address of the Company is fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Monsieur Ashton Johann FRUHLING, demeurant au 87 Hohenrhein, D-56112 Lahnstein,
ici représenté par Monsieur Sébastien PHILIPPI, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 17 septembre 2009.
2. Monsieur Benjamin Frank STÜTZEL, demeurant au 26 Neustadter Weg, D-40229 Dusseldorf,
ici représenté par Monsieur Sébastien PHILIPPI, prénommé,
en vertu d'une procuration donnée le 17 septembre 2009.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après "la Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "la Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après "les Statuts").
Art. 2. La Société a pour objet d'exploiter, d'acquérir et de vendre des sociétés, des installations photovoltaïques ou
des parties d'installations, ayant pour but la production d'énergie solaire.
La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination "SOLIBRA SOLAR POWER PLANTS S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales
d'une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5,-) chacune.
96834
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement associé(s). Le(s) gérant(s) est (sont) révocable(s) ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par la signature individuelle de n'importe quel gérant. Si l'as-
semblée générale des associés décide de créer 2 catégories de gérants (gérants A et gérants B), la société sera engagée
par les signatures conjointes de 2 gérants A ou par les signatures conjointes d'un gérant A et d'un gérant B.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il
y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés
représentant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois de mai à 10 heures à Luxembourg au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
96835
<i>Souscription - Libérationi>
L'ensemble des parts sociales ont été souscrites par
1. Monsieur Ashton Johann FRUHLING, prénommé cinq mille deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .
5.200
2. Monsieur Benjamin Frank STÜTZEL, prénommé quatre mille huit cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .
4.800
Total: dix mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en numéraire, de sorte que la somme de cinquante
mille Euros (EUR 50.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros.
<i>Décision des associési>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Ashton Johann FRUHLING, né le 1
er
janvier 1967 à Koblenz, gérant, demeurant au 87 Hohenrhein,
D-56112 Lahnstein.
- Monsieur Benjamin Frank STÜTZEL, né le 15 décembre 1977 à Neuwied, directeur, demeurant au 26 Neustädter
Weg, D-40229 Düsseldorf.
La durée de leur mandat est illimitée.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle de n'importe quel gérant susmentionné.
2) L'adresse du siège social est fixée au 180, rue des Aubépines, L -1145 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: S. PHILIPPI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-AIzette A.C., le 23 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11209. Reçu soixante-quinze Euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 28 SEP. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009125362/243.
(090151646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Fin Po S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 117.676.
Le bilan rectificatif au 31-03-2009 (Rectificatif du dépôt de bilan déposé le 25-09-2009 sous la référence L090148431.04
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FIN PO S.A., SICAR
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009125475/13.
(090151301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96836
Villa Care S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 95.572.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2009125491/13.
(090151535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Aratus Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 148.306.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twenty-first of September.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
"LANNAGE S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63130),
here represented by:
Mrs. Christine COULON-RACOT, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 21
st
, 2009.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the under-
signed notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a public limited company (société anonyme) which he declares organize and the articles of incorporation
of which shall be as follows:
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of
"ARATUS INVESTMENT S.A."
The registered office is established in Luxembourg-City.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand five
hundred (15,500) shares of two euro (EUR 2.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law
prescribes the registered form.
96837
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed
by the old shares.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not
be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more that
one shareholders in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the
board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revo-
cation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board
of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on
the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic
proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation's financial year shall begin on 1
st
January and shall end on 31
st
December of the same year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on the second Wednesday of April at 11.00 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
96838
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositionsi>
1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2009.
2. The first annual general meeting shall be held in 2010.
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares have been subscribed by "LANNAGE S.A.", above-mentioned.
All the shares have been entirely paid-in so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is as of now
available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is set at THREE (3) and that of the auditors at ONE (1).
<i>Second resolutioni>
The following are appointed directors:
1.- "LANNAGE S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63130); Mr Jean BODONI, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxem-
bourg, will act as permanent representative.
2.- "VALON S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63143); Mr Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, will act as permanent representative.
3.- "KOFFOUR S.A.", a "société anonyme", established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 86086); Mr Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépinese, L-1145 Luxembourg,
will act as permanent representative.
The company "LANNAGE S.A." has been appointed as President of the Board of Directors.
<i>Third resolutioni>
Has been appointed as auditor:
"AUDIT TRUST S.A.", a "société anonyme", with registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B 63115).
<i>Fourth resolutioni>
The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2015.
<i>Fifth resolutioni>
The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,
the present original deed.
96839
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
"LANNAGE S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 63130),
ici représentée par:
Madame Christine COULON-RACOT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 21 septembre 2009.
La procuration signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte
d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de
"ARATUS INVESTMENT S.A."
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.-EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)
actions d'une valeur nominale de deux euros (2.- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
96840
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.
Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois d'avril à 11 heures au siège social ou à
tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2009.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les actions ont été souscrites par la société "LANNAGE S.A.", pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
96841
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1.- "LANNAGE S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 63130); Monsieur Jean BODONI, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira en
tant que représentant permanent.
2.- "VALON S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 63143); Monsieur Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira
en tant que représentant permanent.
3.- "KOFFOUR S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 86086); Monsieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira
en tant que représentant permanent.
La société "LANNAGE S.A." est nommée Président du conseil d'administration.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
"AUDIT TRUST S.A." une société anonyme, avec siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 63115).
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. COULON-RACOT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-AIzette A.C., le 23 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11212. Reçu soixante-quinze Euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 28 SEP. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009125381/293.
(090151623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96842
Lux Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 86.653.
<i>Auszug aus dem Protokolli>
<i>der Ordentlichen Hauptversammlung vom 14. August 2009i>
An Stelle von Frau Kerstin KLEUDGEN wird Frau Tanja FELLMANN mit Berufsanschrift in L-2430 Luxembourg, 36,
rue Michel Rodange zum neuen Verwaltungsratsmitglied ernannt.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlußprüfers werden verlängert bis zur Hauptversammlung
welche im Jahr 2014 stattfindet.
<i>VERWALTUNGSRATi>
- Frau Ellen PHILIPPI, mit Berufsanschrift zu L-2430 LUXEMBOURG, 36, rue Michel Rodange
- Frau Tanja FELLMANN, mit Berufsanschrift zu L-2430 LUXEMBOURG, 36, rue Michel Rodange
- Herr Andreas FELLMANN, mit Berufsanschrift zu L-2430 LUXEMBOURG, 36, rue Michel Rodange
<i>PRÜFUNGSKOMMISSARi>
- UCI UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A. mit Sitz in L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange
Unterschrift.
Référence de publication: 2009125388/20.
(090150724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Plock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.576.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2009.
Isabelle Rosseneu.
Référence de publication: 2009125972/10.
(090151080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Diversified Ventures GP, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 124.957.
Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 et la distribution de dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2009.
Grégory MAGHE / Christoph LANZ
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeuri>
Référence de publication: 2009125973/13.
(090151304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Itaca International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 82.792.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009126049/10.
(090151324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96843
FIVEST (Financière d'Investissements) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 23.479.
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILSON ASSOCIATES
11, boulevard Royal
B.P. 742
L-2017 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2009126012/14.
(090150995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
FIVEST (Financière d'Investissements) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 23.479.
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILSON ASSOCIATES
11, Boulevard Royal
B.P. 742
L-2017 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2009126013/14.
(090150992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
FIVEST (Financière d'Investissements) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 23.479.
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILSON ASSOCIATES
11, Boulevard Royal
B.P. 742
L-2017 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2009126014/14.
(090150991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Whatman Luxembourg Three S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.955,96.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 97.735.
Les comptes annuels au 11 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126349/11.
(090151926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96844
Whatman Luxembourg Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.955,93.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 97.793.
Les comptes annuels au 11 avril 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009126350/11.
(090151925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Delilah US Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 147.738.
Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société datée du 22 sep-
tembre 2009 que l'associé unique de la Société a dorénavant la dénomination sociale suivante:
Samsonite IP Holdings S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2009125872/16.
(090151166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Prax Capital Real Estate I GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 123.687.
Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 et la distribution de dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2009.
Grégory MAGHE / Christoph LANZ
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeuri>
Référence de publication: 2009125817/13.
(090151339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Prax Capital China Growth GP, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 118.739.
Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 et la distribution de dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2009.
Grégory MAGHE / Christoph Lanz
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeuri>
Référence de publication: 2009125818/13.
(090151334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96845
Trois Délices S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5899 Syren, 9, rue Maeshiel.
R.C.S. Luxembourg B 134.505.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 30 septembre 2009.
<i>Pour TROIS DELICES S.A R.L.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L
Signature
Référence de publication: 2009125829/13.
(090151455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Sibelco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 66.294.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009125830/13.
(090151530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Remasi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 121.932.
Les comptes annuels au 31 septembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009125834/13.
(090151520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
DNA Investments S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 105.147.
Avec effet au 01.09.2009, le siège de la société DNA INVESTMENTS S.A. est dénoncé en ce qui concerne l'adresse
suivante:
19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.
Luxembourg, le 01.09.2009.
Fiduciaire Di Fino & associés S.à r.l.
19, rue Sigismond
L-2537 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2009125893/14.
(090151711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96846
Rigotel Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 143.363.
Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Rigotel Development S.A.
Signature
Référence de publication: 2009125881/12.
(090150976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Protin Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 142.408.
Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Protin Finance S.A.
Signature
Référence de publication: 2009125882/12.
(090150973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Stevin Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 136.701.
Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Stevin Investment S.A.
Signature
Référence de publication: 2009125883/12.
(090150971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Kraftsal A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 147.287.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue en date du 28 septembre
2009, à 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, que:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la
société du 31, Grand-Rue, L-1661 à Luxembourg au 51, rue de Strasbourg, L-2561 à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009125884/17.
(090151675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96847
Caroline Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 137.051.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009125887/10.
(090150967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Mat Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 99.529.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue en date du 28 septembre
2009, à 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, que:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la
société du 31, Grand-Rue, L-1661 à Luxembourg, au 51, rue de Strasbourg, L-2561 à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009125888/17.
(090151684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Talaris (Belux), Succursale d'une société de droit étranger,
(anc. De La Rue Cash Systems NV).
Adresse de la succursale: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.
R.C.S. Luxembourg B 82.774.
Il résulte de la réunion du procès-verbal du Conseil d'Administration de la Société tenue le 15 juin 2009 que:
- Monsieur Vincent Nakache, demeurant à 92200 Neuilly-sur-Seine (France), 5, boulevard du Château, a été nommé
représentant permanent pour l'activité de la succursale, en remplacement de Monsieur Geert van den Bosch et ce avec
effet à partir du 15 juin 2009
- La dénomination de la succursale à Luxembourg est modifiée en «TALARIS (BELUX)».
Paris, le 1
er
septembre 2009.
<i>Pour TALARIS (BELUX) S.A., société anonyme de droit belge
i>Vincent Nakache
Référence de publication: 2009125891/16.
(090151677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Spartex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 37.434.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009125952/10.
(090151345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96848
Nikolaj S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 148.305.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twenty-first of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared the following:
"2217626 ONTARIO INC.", an Ontario Corporation with registered office at 337 Magna Drive, Aurora, ON, Canada
L4G 7K1, registered at the Ministry of Consumer and Commercial Relations, Province of Ontario, Canada under number
2217626,
represented by Me Carolin WEIRAUCH, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 17 September
2009;
such proxy, signed by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the
purpose of registration. The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form. Name. There is established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the
"Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles
of Incorporation").
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of "Nikolaj S.à r.l.".
Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or
in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other
kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights.
The Company may invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in
any kind or form.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the shareholders or by a decision of the general meeting voting with the quorum
and majority rules provided by law.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Capital. The issued capital of the Company is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) divided into fifteen
thousand (15,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
96849
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Chapter III. - Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the "Manager(s)").
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or
class B Managers (the "Class B Managers").
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of powers - Representation of the company. The Manager(s) may delegate special powers or
proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the board of managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the "Secretary").
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.
96850
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers
holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers' liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Manager(s) are only liable for the performance
of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if
applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which
the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
96851
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.
The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number
of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may,
as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.
Chapter IV. - Shareholders
Art. 18. Powers of the shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to
the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general
meeting of shareholders.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on 29 June of each year at 11.00 a.m.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 20. Other general meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of general meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a
general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders re-
presenting more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated
by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of
amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
96852
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be a
majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. - Financial year, Financial statement, Distribution of profits
Art. 26. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 27. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions. Subject to the
conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an
advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such
advance payment.
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium has been one hundred per cent (100%)
paid in cash as follows:
Shareholders
subscribed capital number of shares
amount paid-in
2217626 Ontario Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 15,000.-
15,000
EUR 59.950.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 15,000.-
15,000
EUR 59.950.-
The amount of fifty-nine thousand nine hundred fifty Euro (EUR 59,950.-) was thus as from that moment at the disposal
of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions
provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred euro.
96853
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the 31
st
of December of 2009.
<i>Shareholders resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 15, rue du Fort Bourbon L-1249
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at two the number of Managers and further resolved to appoint
the following for an unlimited duration:
- Mr. Alexej Seitz, with professional address at c/o Magna Management AG, Baarerstrasse 16, CH-6300 Zug, Switzer-
land;
- Mr. Thomas Schultheiss, with professional address at c/o Magna Management AG, Baarerstrasse 16, CH-6300 Zug,
Switzerland.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present
deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und neun, am einundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Luxem-
burg,
ist erschienen:
„2217626 ONTARIO INC.", eine Gesellschaft unter dem Recht des kanadischen Bundesstaates Ontario, mit Gesell-
schaftssitz in 337 Magna Drive, Aurora, ON, Kanada L4G 7K1, einregistriert beim Ministerium für Verbraucher- und
Handelsverbindungen, Provinz Ontario, Kanada, unter Nummer 2217626,
vertreten durch Frau Carolin WEIRAUCH, avocat, mit Wohnsitz in Luxemburg, kraft der am 17. September 2009
erteilten Vollmacht.
Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet
wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.
Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:
Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft") gegründet, die
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, besonders dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften,
wie abgeändert, und Artikel 1832 des bürgerlichen Gesetzbuches (Code Civil) und den Bestimmungen der vorliegenden
Satzung (die „Satzung") unterliegt.
Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, Eigentümer aller Anteile, oder aus mehreren Gesellschaftern,
deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen, insbesondere in Folge einer Anteilsübertragung oder
der Ausgabe von neuen Gesellschaftsanteilen.
Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Nikolaj S.á r.l." firmieren.
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der
Stadt Luxemburg verlegt werden.
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) ent-
weder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
Sollte(n) die (der) Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse
politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale
Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen
könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen
96854
Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unter-
liegt. Die genannten vorübergehenden Maßnahmen sind von der Geschäftsführung zu beschließen und den hiervon
betroffenen Dritten mitzuteilen.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von
Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreu-
ung solcher Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-
terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.
Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder
ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.
Die Gesellschaft kann in Immobilien, geistiges Eigentum und Urheberrechte oder jedwede bewegliche oder unbeweg-
liche Güter jeglicher Art, investieren, Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle
Tätigkeit ausführen, welche für die Ausführung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter oder durch einen Beschluß der Generalver-
sammlung, der in Übereinstimmung mit dem nach dem Gesetz erforderlichen Quorum und den erforderlichen Mehrheiten
gefasst wird.
Kapitel II. Kapital, Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000,-),
und ist in fünfzehntausend (15.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind
vollständig eingezahlt.
Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissionsaufgelder, die
auf einen Anteil, zusätzlich zu seinem Nominalwert, eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeld-
kontos kann zur Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich von
realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen
Rücklage bereitzustellen, verwendet werden.
Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Be-
vollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.
Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile
können nur dann an NichtGesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.
Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.
Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft und Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser ange-
nommen worden ist. Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung
zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-
fenen Beschlüsse mit sich.
Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-
sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs
oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer Umstand, der den Alleingesellschafter oder einen anderen Gesellschafter
betrifft, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.
Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer
Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-
ter sein müssen, geführt (die ,,Geschäftsführer").
Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat")
gegründet.
96855
Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats
festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch
einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (die „Ge-
schäftsführer A") oder als Geschäftsführer B (die „Geschäftsführer B") zu qualifizieren.
Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.
Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,
um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-
prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).
Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle
Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit
bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, ge-
bunden.
Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben
(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen
gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.
Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende
Regeln:
Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende"). Er kann auch einen
Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer").
Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-
rungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit
des Geschäftsführungsrates ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des
Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungs-
gemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort
in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrich-
tigung erforderlich.
Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-
führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-
schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden.
Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner
amtierenden Mitglieder, wobei im Falle einer der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Ge-
schäftsführer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend sein muss.
Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrates gefasst.
Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung
oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellt, teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.
Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in
einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem oder
mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.
Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
96856
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.
Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-
weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.
Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die
(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.
Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.
Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-
schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-
bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.
Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder
irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder einem solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmen sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte
tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu
handeln.
Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung
hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.
Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-
lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-
schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer, welche
nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.
Die statutorischen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter
ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und
können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in
Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der unabhängige Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund
abberufen werden kann.
Kapitel IV. Gesellschafter
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz
zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.
Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.
Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden
muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am 29. Juni eines jdeden Jahres um
11:00 Uhr abgehalten.
Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-
genden Werktag abgehalten.
96857
Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-
zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.
Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-
halten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können im Ausland abgehalten werden, wenn
Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt, dies erforderlich
machen.
Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die
Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-
schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.
Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über
die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-
und Rederecht.
Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.
Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu
von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-
versammlung anwesend sind, gewählt wird. Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen
den Vorstand der Gesellschafterversammlung.
Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von
Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden
Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-
schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der
Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse den Mehrheit der Anzahl
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-
zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.
Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter
unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls
der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
96858
Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die
Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr
als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der
gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage"). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-
winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste
Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien
an die Aktionäre ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung
berechtigt.
Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-
henden Bestimmungen, können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Aktionäre auszahlen. Die Geschäfts-
führer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 29. Auflösung. Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst
werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-
liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-
quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.
Kapitel VII. Geltendes Recht
Art. 30. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen
sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt
geltenden Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und das
Emmissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:
Gesellschafter
gezeichnetes
Kapital
Anzahl der
Anteile
eingezahlter
Betrag
2217626 Ontario Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 15.000.-
15.000
EUR 59.950.-
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 15.000.-
15.000
EUR 59.950.-
Die Summe von neunundfünfzigtausendneunhundertfünfzig Euro (EUR 59.950.-) stand der Gesellschaft daher von dem
Moment an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die
Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt
geltenden Fassung, gewahrt wurden.
<i>Kosteni>
Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr tausendfünfhundert Euro geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
<i>Gesellschafterbeschlüssei>
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lu-
xemburg Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.
96859
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit als
Geschäftsführer ernannt:
- Herr Alexej Seitz, mit Geschäftsadresse in c/o Magna Management AG, Baarerstrasse 16, CH-6300 Zug, Schweiz;
- Herr Thomas Schultheiss, mit Geschäftsadresse in c/o Magna Management AG, Baarerstrasse 16, CH-6300 Zug,
Schweiz.
Der unterzeichnende Notar, der Englischen spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten
Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.
Woraufhin vorliegende Urkunde, am eingangs erwähnten, Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg
aufgenommen wurde.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-
nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: C. WEIRAUCH, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 23. September 2009. Relation: EAC/2009/11214. Erhalten fünfundsiebzig Euro
(75.- EUR).
<i>Der Einnehmeri>
(gezeichnet): SANTIONI.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Sondersammlung für Ge-
sellschaften und Vereinigungen.
Beles, den 28 SEP. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009125384/624.
(090151581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Klammer Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 115.319.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2009i>
Conformément à la Loi du 25 Août 2006 - "Art. 51 & 51 bis", publié au MEMORIAL, Journal Officiel du Grand-Duché
de Luxembourg (Recueil de Législation) sous le n° A-N°152 du 31 août 2006, l'assemblée générale accepte de désigner
comme représentant permanent pour une durée indéterminée en remplacement de Mme Sandrine ANTONELLI, avec
prise d'effet au 16 avril 2008:
Mlle Claire SABBATUCCI, employée privée, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), demeurant professionnellement
207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Mademoiselle Claire SABBATUCCI exécutera sa mission de représentant permanent au nom et pour le compte de la
société EDIFAC S.A.
L'Assemblée Générale constate le changement de forme juridique de la société TrustAudit Sàrl, Commissaire aux
Comptes, suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue devant Maître Karine REUTER le 3 décembre 2008
Extrait sincère et conforme
KLAMMER INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009125720/22.
(090151221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Crèche Tiramisu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 46, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 112.539.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009125943/10.
(090151547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96860
LIPP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ERE III - No 7 S.à r.l.).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 139.279.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 21 septembre 2009.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009125654/13.
(090151089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Amperja S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 39.270.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2009i>
L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux
comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termi-
neront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
Luxembourg, le 25 septembre 2009.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009125728/19.
(090151098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Purp Holdings Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 95.262.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 septembre 2009.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009125582/12.
(090151058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
State Street Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 32.771.
In the year two thousand and nine,
on the twenty-second of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Mr Rachel HAMEN, Vice President, Head of Finance, and Mr Rudi DICKHOFF, Vice President, Counsel, both residing
professionally in Luxembourg,
96861
acting in their capacity as a special attorneys (the "Special Attorneys") of State Street Bank Luxembourg S.A., a société
anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 49, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 19 January 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, n° 265 of 6 August 1990, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B-32771, and whose articles of incorporation have been amended for the last time on 7 January 2009 pursuant
to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 517 of 10
March 2009 (the "Company").
by virtue of the power granted to them pursuant to the resolutions adopted by the Company's board of directors on
25 August 2009.
An excerpt of these resolutions will be signed "ne varietur" by the Special Attorneys and the undersigned notary and
will remain attached to the present deed.
The appearing persons, acting in their capacity as Special Attorneys of the Company, have requested the undersigned
notary to record the following statements and declarations:
I. The issued share capital of the Company is currently set at sixty-five million one hundred sixty-two Euro and fifty
Cents (EUR 65,000,162.50) divided into four hundred thousand and one (400,001) shares without par value, each fully
paid-up.
II. The authorized share capital of the Company is fixed at one hundred thirty million Euro (EUR 130,000,000) divided
into eight hundred thousand (800,000) shares without par value. The Board of Directors is authorized, with authority to
sub-delegate to one of the Company's Directors or two members of the Company's senior management (Vice-Presidents
and above) during a period ending five (5) years after the publication of the minutes of the extraordinary general held on
17 December 2008 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (i) to realise any increase of the corporate
capital within the limits of the authorised capital in one or several tranches by the issue of new shares with or without
share premium, in consideration for a payment in cash or in kind, following the exercise of the subscription and/or
conversion rights granted by the Board of Directors under the terms of warrants (which may be separate or attached to
shares, notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments issued from time to time by the Company,
by conversion of claims or in any other manner; (ii) to determine the place and date of the issue, the issue price, the
terms and conditions of the subscription and the payment of the newly issued shares; and (iii) to withdraw or restrict
the preferential subscription right of the shareholders in case the new shares are subscribed for in cash.
III. The Company's board of directors, in its resolutions taken with effect on 25 August 2009 decided to increase the
issued share capital by an amount of one hundred sixty-two Euro and fifty Cents (162.50) to raise it from its present
amount of sixty-five million one hundred sixty-two Euro and fifty Cents (EUR 65,000,162.50) to sixty-five million three
hundred twenty-five Euro (EUR 65,000,325) by the issuance, with cancellation of the shareholders' preferential subscrip-
tion right, of one (1) new share without par value (the "New Share") and to accept the subscription of the New Share
with payment of the accounting par value and a share premium of an amount of one hundred four million five hundred
thousand Euro (EUR 104,500,000) in cash by State Street International Holdings Switzerland GmbH, with registered office
at Sumpfstrasse 15, 6312 Steinhausen, Switzerland, registered with the Trade Register of the Canton of Zug under number
CH-170.4.008.537-7 ("SSIHS").
The New Share has been subscribed by SSIHS and fully paid up by a contribution in cash to the Company.
As a consequence of the above, the New Share has been issued and allotted to SSIHS on 25 August 2009.
IV. As a consequence of the above mentioned capital increase with effect as of 25 August 2009, paragraph one of
Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:
Art. 5. "The corporate capital is set at sixty-five million three hundred twenty-five Euro (EUR 65,000,325), divided into
four hundred thousand and two (400,002) shares without par value, each fully paid-up."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at six thousand three hundred euro.
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred
to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille neuf,
le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, (Grand-Duché du Luxembourg),
96862
ont comparu:
Madame Rachel HAMEN, Vice President, Head of Finance et Monsieur Rudi DICKHOFF, Vice President, Counsel,
tous deux demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataires spéciaux (les "Mandataires Spéciaux") de State Street Bank Luxembourg S.A., une
société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 49, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, constituée suivant acte notarié du 19 janvier 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
n° 265 du 6 août 1990, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B- 32771, et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 7 janvier 2009 par un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 517 du 10 mars 2009 (la "Société"),
en vertu d'une procuration qui leur a été donnée suivant les résolutions du conseil d'administration de la Société prises
le 25 août 2009.
Un extrait de ces résolutions sera signé "ne varietur" par les Mandataires Spéciaux et le notaire soussigné et restera
annexé au présent acte.
Les comparants, agissant en leur qualité de Mandataires Spéciaux de la Société, ont requis le notaire instrumentant de
documenter les déclarations et constatations suivantes:
I. Le capital social émis par la Société est actuellement fixé à soixante-cinq millions cent soixante-deux euros et cin-
quante cents (EUR 65.000.162,50) divisé en quatre cent mille une (400.001) actions sans valeur nominale, chacune
entièrement libérée.
II. Le capital autorisé de la Société est fixé à cent trente millions d'euros (EUR 130.000.000) divisé en huit cent mille
(800.000) actions sans valeur nominale. Le conseil d'administration est autorisé, avec pouvoir de sous-déléguer à un
administrateur de la Société ou deux membres du senior management de la Société (Vice-présidents et au-dessus) pendant
une période se terminant cinq (5) ans après la publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue
le 17 décembre 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à (i) réaliser toute augmentation du capital
social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois par l'émission de nouvelles actions avec ou sans prime
d'émission, contre apport en numéraire ou en nature, à la suite de l'exercice de droits de souscription et/ou de droits
de conversion accordés par le conseil d'administration conformément aux termes des bons de souscription (qui peuvent
être séparés ou attachés aux actions, obligations ou instruments similaires), obligations convertibles ou instruments si-
milaires émis occasionnellement par la Société, par conversion de créances ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et
la date de l'émission, le prix d'émission, les termes et conditions de la souscription et le paiement des actions nouvellement
émises; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires contre apport en numéraire.
III. Le conseil d'administration de la Société, dans sa résolution prise avec effet au 25 août 2009, a décidé d'augmenter
le capital social émis d'un montant de cent soixante-deux euros et cinquante cents (EUR 162,50) pour le porter de son
montant actuel de soixante-cinq millions cent soixante-deux euros et cinquante cents (EUR 65.000.162,50) à soixante-
cinq millions trois cent vingt-cinq euros (EUR 65.000.325) par l'émission, avec annulation du droit de souscription
préférentiel, d'une (1) action nouvelle sans valeur nominale (la "Nouvelle Action") et d'accepter la souscription de cette
Nouvelle Action, avec paiement de la valeur nominale et d'une prime d'émission d'un montant de cent quatre millions
cinq cent mille euros (EUR 104.500.000), en cash par State Street International Holdings Switzerland GmbH, ayant son
siège social à Sumpfstrasse 15, 6312 Steinhausen, Suisse, enregistré au Registre de Commerce du Canton de Zug sous le
numéro CH-170.4.008.537-7 ("SSIHS").
La Nouvelle Action a été entièrement souscrite par SSIHS, et entièrement libérée par un apport en cash à la Société.
En conséquence de ce qui précède, la Nouvelle Action a été émise et allouée à SSIHS le 25 août 2009.
IV. En conséquence de l'augmentation de capital avec effet au 25 août 2009 précédemment mentionnée, le paragraphe
un de l'article 5 des Statuts de la Société est modifié et sera dorénavant rédigé comme suit:
Art. 5. "Le capital social est fixé à soixante-cinq millions trois cent vingt-cinq euros (EUR 65.000.325), divisé en quatre
cent mille deux (400.002) actions sans valeur nominale, chacune entièrement libérée".
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette augmentation
de capital sont estimés à six mille trois cents euros.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: R. HAMEN, R. DICKHOFF, J.J. WAGNER.
96863
Enregistré à Esch-sur-AIzette A.C., le 24 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11268. Reçu soixante-quinze Euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 28 SEP. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009125523/131.
(090151019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Biguel Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 132.530.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2009i>
L'Assemblée Générale procède à compter de ce jour à la démission de Catherine GUFFANTI, comptable, né le 20
janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement 207, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, en remplacement de Madame Catherine GUFFANTI,
Madame Claudine BOULAIN, Chef comptable, née le 02 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant profession-
nellement 207, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.
Conformément à la Loi du 25 Août 2006 - "Art. 51 & 51 bis", publié au MEMORIAL, Journal Officiel du Grand-Duché
de Luxembourg (Recueil de Législation) sous le n° A-N°152 du 31 août 2006, l'assemblée générale accepte de désigner
comme représentant permanent pour une durée indéterminée en remplacement de Mme Sandrine ANTONELLI, avec
prise d'effet au 16 avril 2008:
Mlle Claire SABBATUCCI, employée privée, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), demeurant professionnellement
207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Mademoiselle Claire SABBATUCCI exécutera sa mission de représentant permanent au nom et pour le compte de la
société ADVISA S.A.
L'Assemblée Générale constate le changement de forme juridique de la société TrustAudit Sàrl, Commissaire aux
Comptes, suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue devant Maître Karine REUTER le 3 décembre 2008.
Extrait sincère et conforme
BIGUEL INVEST S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009125721/28.
(090151209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Sigma Capital Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.335.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises le 23 mars 2009i>
Le 23 mars 2009, le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:
- de transférer le siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 2-8, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 septembre 2009.
Luxembourg Corporation Company S.A.
<i>Mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009125873/15.
(090151279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
96864
Amperja S.A.
Aratus Investment S.A.
Biguel Invest S.A.
Broad Point II S.à r.l.
Captiva Capital Management S.à r.l.
Carihold S.A.
Caroline Holdings S. à r.l.
CNA Corporation S.A.
Crèche Tiramisu S.A.
CSC Computer Sciences Luxembourg SA
Cube Infrastructure Fund
De La Rue Cash Systems NV
Delilah US Investments S.à r.l.
Diversified Ventures GP, S. à r.l.
DNA Investments S.A.
ERE III - No 7 S.à r.l.
Européenne de Participations et de Signalisation S.A.
Fin Po S.A., SICAR
FIVEST (Financière d'Investissements) S.A.
FIVEST (Financière d'Investissements) S.A.
FIVEST (Financière d'Investissements) S.A.
FKI Luspartwo S.à r.l.
Gipar S.A.
Ippocrate Luxembourg S. à r.l.
Itaca International S.A.
Klammer Investments S.A.
Kraftsal A.G.
Lampas Royal Participations S.A.
LBPOL City S.à r.l.
LIPP 1 S.à r.l.
Lux Participation S.A.
Masco Europe INC Financial S.C.S.
Mat Invest S.A.
Mylan Luxembourg 6 S.à r.l.
Natec S.A.
New Europe Holdings S.à r.l.
Nikolaj S.à r.l.
Plock S.à r.l.
Prax Capital China Growth GP, S.àr.l.
Prax Capital Real Estate I GP, S.à r.l.
Protin Finance S.A.
Purp Holdings Luxembourg 1 S.à r.l.
Remasi S.A.
Rigotel Development S.A.
Segro Lux Vimercate S.à r.l.
Sibelco S.à r.l.
Sigma Capital Investments S.A.
SLV Electronik S.à r.l.
SLV Electronik S.à r.l.
Solibra Solar Power Plants S.à r.l.
Soluprom S.à r.l.
Spartex S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
Stevin Investment S.A.
Talaris (Belux)
Transteeg S.A.
Trois Délices S.à r.l.
Ulysses Finance S.à r.l.
Ulysses Participation S.à r.l.
Via Com Holding S.A.H.
Villa Care S.à.r.l.
Whatman Luxembourg Three S.à.r.l.
Whatman Luxembourg Two S.à r.l.