This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2013
15 octobre 2009
SOMMAIRE
Abelton Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96580
ACMBernstein - India Growth Fund . . . . .
96582
AL DWS Global Aktiv+ . . . . . . . . . . . . . . . . .
96589
AL DWS Global Aktiv+ . . . . . . . . . . . . . . . . .
96589
Alma Mater S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96606
Altera Security Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96589
A.N.G.'Immobilier S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
96603
Aristolux Investment Fund . . . . . . . . . . . . . .
96603
Best Way Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96578
Black & Decker Asia Manufacturing Hol-
dings 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96606
BRE/Europe 3-B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96598
BRE/Europe 3-C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96598
BRE/Europe 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96598
BRE/French Holdco 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
96598
BRE/French Hotel Holding I S.à r.l. . . . . . .
96607
Carrera Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96579
DB Valence S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96622
Deka-Flex: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96590
Deka-Flex: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96591
Doll S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96624
DWS Cashback Garant 2014 . . . . . . . . . . . .
96584
DWS Cashback Garant 2014 . . . . . . . . . . . .
96585
DWS China A-Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96586
DWS Corporate Bond Basket 2014 . . . . . .
96588
DWS Dollarchance Garant . . . . . . . . . . . . . .
96603
DWS Emerging New Deal Fund . . . . . . . . .
96586
DWS Flex Aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96589
DWS Flex Aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96589
DWS Zinssprinter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96603
DWS Zinssprinter (2016) . . . . . . . . . . . . . . .
96603
DWS Zinswunder (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96603
Emde Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96584
Euronimbus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96606
European Geophysical Services S.A. . . . . .
96586
Financière Stoppato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96590
Finistère SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96584
FKI Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96623
Force-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96583
Franmar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96578
GREIFF «special situations» Fund OP . . . .
96586
IFM-Institutionell Real Estate Plus 1 . . . . .
96603
Jarama Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96604
KHG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96605
KHG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96583
Leptis Magna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96603
LIM Logging S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96586
Lombard Odier Darier Hentsch Invest . . .
96580
Luxprofi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96606
Montebello Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96605
MTCL Jess S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96622
ORONTE S.A., société de gestion de patri-
moine familial, "SPF" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96578
Pizza Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96605
Publi Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96582
Seculux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96623
Selected Strategies Partners . . . . . . . . . . . .
96591
Sophis Manco Luxembourg SA . . . . . . . . . .
96583
Studiofund S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96604
UBS Target Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96579
Winchester JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96605
Yelo Bau SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96604
96577
Franmar Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 28.155.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 novembre 2009i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2009;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2009;
3. affectation des résultats au 30 juin 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009127572/10/19.
Best Way Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 100.283.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 novembre 2009i> à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2009129178/795/15.
ORONTE S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - Société de Gestion
de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 97.351.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue Extraordinairement, qui aura lieu le <i>23 octobre 2009i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2008.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2009126151/1023/18.
96578
UBS Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.795.
Shareholders are kindly convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on <i> November 2 i>
<i>ndi>
<i> 2009 i> at 11.00
a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditor
2. Approval of the financial statements as of 31 May, 2009
3. Decision on allocation of net profits
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year
ended 31 May, 2009
5. Election and Remuneration of the Board Members
6. Appointment of the Auditor
7. Miscellaneous
<i>Voting:i>
Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Notes:i>
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A.,
which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on 28 October 2009.
- by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as
aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS Target
Fund, c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. at the latest on 28 October 2009.
Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009129181/755/31.
Carrera Invest S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 36.955.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>23 octobre 2009i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de Monsieur Pietro LONGO de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration
et décharge.
6. Nomination de Madame Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre
1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme
administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
7. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2009125546/29/21.
96579
Abelton Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 121.731.
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>November 2, 2009i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2009
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009129182/795/15.
Lombard Odier Darier Hentsch Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 25.301.
Le Conseil d'administration de la SICAV susmentionnée a le plaisir de convier ses actionnaires à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui qui se tiendra le <i>26 octobre 2009i> à 10 heures 30 au siège social de la SICAV, avec l'ordre du jour suivant :
Changement du nom de la Société en "Lombard Odier Funds"
<i>Ordre du jour:i>
1. L'article 1 des Statuts de la Société (les "Statuts") sera modifié comme suit:
"Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions, une société sous la forme
d'une société anonyme qualifiée comme société d'investissement à capital variable ("SICAV") sous la dénomination
de Lombard Odier Funds, en abrégé LO Funds. La dénomination Lombard Odier Funds ainsi que la dénomination
LO Funds peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre."
Autres changements apportés aux Statuts
2. Le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts sera modifié comme suit:
"Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil d'admi-
nistration (le "Conseil") peut décider de transférer le siège de la Société à tout autre endroit dans le Grand-Duché
de Luxembourg dans toute la mesure autorisée par la loi. Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis
au Luxembourg ou à l'étranger sur résolution du Conseil."
3. L'article 5 des Statuts sera modifié en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:
"La Société peut imposer des restrictions à l'émission d'Actions de n'importe quel Compartiment (également à
l'émission d'Actions résultant de demandes de conversion) durant une certaine période, restrictions déterminées
par le Conseil."
4. L'article 13 des Statuts sera modifié comme suit:
- la première phrase du deuxième paragraphe sera modifiée afin de clarifier le fait que les Administrateurs peuvent
être élus par les actionnaires lors de toute Assemblée générale.
- le quatrième paragraphe sera modifié comme suit:
"Lors d'une Assemblée générale des actionnaires, une motion en accord avec le paragraphe précédent visant à la
nomination de deux ou plusieurs personnes comme Administrateurs de la Société au moyen d'une résolution unique
ne pourra pas être votée à moins qu'une résolution prévoyant une telle motion n'ait été adoptée par l'Assemblée
sans qu'aucun vote ne s'y oppose."
5. L'article 16 des Statuts sera modifié en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:
"La Société peut recourir à des techniques et instruments relatifs à des valeurs mobilières et à des instruments du
marché monétaire, à condition que ces techniques et instruments puissent être utilisés à des fins de couverture ou
de gestion efficace du portefeuille ou à des fins d'investissement."
6. L'article 21 des Statuts sera modifié comme suit:
- Au deuxième paragraphe, il est indiqué que le Conseil peut imposer des restrictions à l'émission d'Actions résultant
de demandes de conversion durant une certaine période;
- Les nouvelles phrases suivantes seront ajoutées à la fin du troisième paragraphe:
"Toute demande de rachat est irrévocable, hormis dans le cas d'une suspension du calcul de la Valeur Nette
d'Inventaire par Action du Compartiment ou d'ajournement des rachats. Dans tous les autres cas, le Conseil peut
96580
approuver le retrait de demandes de rachat. Cette prérogative peut être déléguée au Gérant. A cet effet, les
conversions seront considérées comme des rachats."
- Le paragraphe relatif au paiement différé du produit des rachats en cas de circonstances spécifiques rendant
impossible le transfert du produit dans le pays où le rachat a été demandé, s'appliquera à toutes les demandes de
rachat et pas uniquement aux rachats d'un Compartiment des marchés émergents.
- L'ordre des paragraphes restants sera modifié et les redondances supprimées.
7. L'article 22 des Statuts sera modifié en ajoutant les trois nouveaux paragraphes suivants, qui décrivent les situations
dans lesquelles la Société peut suspendre la détermination de la Valeur Nette d'Inventaire ainsi que l'émission, le
rachat et la conversion des Actions de la classe concernée:
"(a) pendant toute période au cours de laquelle le négoce de parts ou d'actions d'un véhicule d'investissement dans
lequel est investie une part substantielle des actifs du Compartiment concerné est restreint ou suspendu;"
"(c) pendant tout période au cours de laquelle une part conséquente d'un investissement du Compartiment ne peut
pas, au moyen des procédures d'évaluation standard, être évaluée promptement et avec précision ou n'est pas
valorisée à la juste valeur du marché;"
"(d) pendant toute période au cours de laquelle la Valeur Nette d'Inventaire de toute filiale de la Société ne peut
pas être déterminée précisément;"
8. Dans l'article 23, lettre A, des Statuts, les paragraphes portant sur la détermination de la valeur des actifs seront
modifiés comme suit:
- Un nouveau paragraphe (2) sera ajouté comme suit:
"(2) les actifs liquides et les instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale, aug-
mentée de tous les intérêts courus ou selon la méthode du coût amorti;"
L'actuel paragraphe (4) deviendra le paragraphe (5) et sera modifié comme suit:
"(5) les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont évaluées à leur dernière Valeur Nette d'Inventaire
disponible ou, si ce prix n'est pas représentatif de la juste valeur de marché de ces parts ou actions, le prix sera
déterminé avec prudence, en toute bonne foi et sous la direction des Administrateurs."
- Un nouveau paragraphe (6) sera ajouté comme suit:
"(6) tous les autres actifs sont évalués à la juste valeur de marché, en toute bonne foi et sous la direction des
Administrateurs."
- Un nouveau paragraphe sera ajouté après le paragraphe (6) et s'appliquera aux paragraphes (1) à (6):
"Les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, autoriser l'utilisation de toute autre méthode d'évaluation s'ils
considèrent que cette méthode reflète mieux la valeur de façon générale ou sur des marchés particuliers ou dans
des conditions de marché particulières."
9. L'article 25 des Statuts sera modifié afin de supprimer toutes les références à l'exercice social qui a débuté le 1er
janvier 2007 et a pris fin le 30 septembre 2007.
10. L'article 27 des Statuts sera modifié comme suit:
"La Société conclura un contrat de gestion avec Lombard Odier Darier Hentsch (Jersey) Limited, aux termes duquel
cette société assumera la fonction de Gérant des portefeuilles de la Société. Au cas où ce contrat prendrait fin de
quelque manière que ce soit, la Société, à la demande du Gérant, changera sa dénomination en une autre dénomi-
nation ne comprenant plus les mots "LO" et/ou "Lombard" et/ou "Odier".
11. L'article 28 des Statuts sera modifié comme suit:
- Le paragraphe (c) sera modifié de manière à autoriser le Conseil, s'il considère cette mesure comme appropriée
pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, (i) à racheter la totalité (mais non une partie) des
Actions d'un Compartiment, après en avoir informé les actionnaires concernés par avis, le Jour d'évaluation indiqué
dans l'avis ou (ii) après avoir donné un préavis d'un mois aux actionnaires concernés (durant lequel les actionnaires
peuvent se faire rembourser leurs Actions sans commission de transaction ou de rachat), fusionner ce Comparti-
ment avec un autre Compartiment de la Société ou un autre OPCVM luxembourgeois soumis à la Partie I de la
Loi;
- Un nouveau paragraphe (f) sera ajouté comme suit:
"(f) Si le Conseil détermine que cette décision est dans l'intérêt des actionnaires du Compartiment concerné ou
qu'un changement de la situation économique ou politique relative au Compartiment concerné justifiant cette
décision se produit, un Compartiment peut être réorganisé en étant divisé en deux ou plusieurs Compartiments.
Une telle décision sera notifiée comme requis aux actionnaires. La notification contiendra également des informa-
tions concernant les deux ou plusieurs nouveaux Compartiments. La notification sera envoyée au moins un mois
avant la date à laquelle la réorganisation entre en vigueur, afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat
de leurs Actions, sans commission de transaction ou de rachat, avant que la division en deux ou plusieurs Com-
partiment ne soit effective."
12. Les Statuts seront également modifiés comme suit afin d'harmoniser la terminologie utilisée dans les articles ou
d'utiliser la même terminologie que dans le Prospectus de la Société:
- "US$" ou "Dollars US" seront remplacés par "USD";
- "Fonds" sera remplacé par "Compartiment(s)";
- "Date d'Evaluation" sera remplacé par "Jour d'évaluation";
- "Conseil d'Administration" sera remplacé par "Conseil";
96581
- "in specie distribution" dans l'Article 21 de la version originale anglaise des Statuts sera remplacé par "in kind
distribution" (la traduction française "distribution en nature" reste inchangée).
13. Les points 1 à 12 n'entreront pas en vigueur avant leur approbation par les actionnaires.
Les actionnaires sont également avisés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire sont
soumis à un quorum de cinquante pour cent (50%) des actions existantes.
Si le quorum de cinquante pour cent (50%) des actions existantes n'est pas atteint lors de l'Assemblée générale ex-
traordinaire, une nouvelle Assemblée sera convoquée avec le même ordre du jour. Ses décisions seront adoptées
indépendamment du nombre d'actions représentées.
Les résolutions relatives aux points à l'ordre du jour des deux Assemblées générales extraordinaires seront considé-
rées comme adoptées dès lors qu'elles auront été approuvées aux deux tiers des votes exprimés lors de l'Assemblée
concernée.
Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée en signant une pro-
curation en faveur d'un représentant.
Si vous souhaitez participer à l'Assemblée, nous vous remercions de bien vouloir en informer la SICAV au minimum
deux jours avant l'Assemblée.
Si vous ne pouvez pas participer à l'Assemblée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir retourner la procu-
ration dûment signée par télécopie au 00 352 47 67 75 08 puis par courrier à l'attention de Mme Céline Parmentier,
CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, d'ici au 22 octobre 2009.
Les actionnaires opposés à tout changement proposé ci-dessus peuvent continuer à demander le rachat gratuit de
leurs actions.
Nous profitons de cet avis pour vous informer que les termes "Investment Manager" seront dorénavant traduits par
"Gérant" dans la version française des Statuts.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sincères salutations.
<i>Le Conseil d'administration de la SICAVi>
Référence de publication: 2009125542/755/130.
Publi Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 33.068.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu vendredi <i>30 octobre 2009i> à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2009123138/1267/13.
ACMBernstein - India Growth Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 45.529.
Reference is made to the prior notice dated 8 September 2009 and published on September 14th and September 22nd
2009 regarding the proposed merger of the Fund into ACMBernstein SICAV- India Growth Portfolio (the "Portfolio").
Because the Extraordinary General Meeting of shareholders convened on 30 September 2009 lacked the quorum
necessary to deliberate on the proposed merger, the shareholders of the Fund are hereby notified of a Reconvened
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to be held on <i>30 October 2009i> at 11:00 a.m. (Luxembourg time) at the registered office of the Fund,
18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. The approval of the Merger Proposal;
2. The decision to fix the effective date (hereinafter the "Effective Date") of the merger, as defined in the Merger
Proposal on the date of the extraordinary general meeting of shareholders or on such other date as may be
96582
determined at the extraordinary meeting of shareholders upon suggestion of the chairman of the meeting being
not later than 31 December 2009.
3. The approval that, on the Effective Date, the assets and liabilities of the Fund shall be merged into the Portfolio.
4. The approval that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the respective assets and liabilities of
the Fund, ACMBernstein SICAV issues to shareholders of the Fund the same number of shares in the Portfolio as
they held in the Fund prior to the Effective Date. The new shares in ACMBernstein SICAV will be issued in registered
form with fractions as of the Effective Date; and
5. To state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be
cancelled.
There shall be no quorum requirement at the Reconvened Extraordinary General Meeting. At such meeting, resolu-
tions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes cast.
Shareholders may vote on the merger in person or by proxy. A proxy form for your vote is available from the offices
of the Fund. Proxy forms should be returned duly completed to Victor Buck Services, Z.1. Am Bann, L-3372, Leudelange,
Luxembourg. Please return your proxy before 4.00 p.m. on 28 October 2009 in order for it to be counted.
Shareholders having questions should contact their financial advisor or an AllianceBernstein Investor Services opera-
tions center at + 800.22.63.86.37 or + 352.46.39.36.151
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2009123461/755/34.
KHG S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 63.257.
<i>Dénonciation d'un siège sociali>
Le siège social de la société KHG S.A., à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid, inscrit au R.C. de Luxembourg, section B
numéro 63.257, a été dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Maître Daniel PHONG
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2009126427/12.
(090151851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Sophis Manco Luxembourg SA, Société Anonyme.
Capital social: EUR 154.761,74.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 129.754.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2009.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009126377/14.
(090151847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Force-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 55.930.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009126469/10.
(090152189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96583
Emde Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 53.448.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31.07.2009 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir
Messieurs JACQUEMART Laurent, 3A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ZEIMET Jean-Bernard, 3A, boule-
vard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, GILLET Etienne, 3A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant
qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L., 3A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg en tant que com-
missaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2015
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009126296/16.
(090151794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
DWS Cashback Garant 2014, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung zum 14.08.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de
Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009109730/10.
(090135636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.
Finistère SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 79.369.
L'an deux mil neuf, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de gestion de patrimoine familial sous forme de
société anonyme "FINISTERE SPF S.A.", avec siège social à L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison
constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 30 no-
vembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 497 du 3 juillet 2001
modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19
décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 128 du 21 janvier 2009
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 79.369.
L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Paul WEILER, employé, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges REUTER, expert-comptable, demeurant professionnelle-
ment à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Réduction de capital social par remboursement aux actionnaires d'un montant de treize millions huit cent soixante-
deux mille deux cent cinquante francs suisses (CHF 13.862.250,-) en portant le capital de son montant actuel de trente-
six millions neuf cent soixante-six mille francs suisses (CHF 36.966.000,-) à un montant de vingt-trois millions cent trois
mille sept cent cinquante francs suisses (CHF 23.103.750,-) par réduction de la valeur nominale par action de cent francs
suisses (CHF 100,-) à soixante-deux virgule cinquante francs suisses (CHF 62,50) sans annulation d'actions.
2.- Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts.
3.- Divers.
96584
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société par remboursement aux actionnaires d'un montant
de treize millions huit cent soixante-deux mille deux cent cinquante francs suisses (CHF 13.862.250,-) en portant le capital
de son montant actuel de trente-six millions neuf cent soixante-six mille francs suisses (CHF 36.966.000,-) à un montant
de vingt-trois millions cent trois mille sept cent cinquante francs suisses (CHF 23.103.750,-) par réduction de la valeur
nominale par action de cent francs suisses (CHF 100,-) à soixante-deux virgule cinquante francs suisses (CHF 62,50) sans
annulation d'actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide en conséquence de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts comme suit:
«Art. 5. (1
er
paragraphe). Le capital souscrit est fixé à vingt-trois millions cent trois mille sept cent cinquante francs
suisses (CHF 23.103.750,-), représenté par trois cent soixante-neuf mille six cent soixante (369.660) actions d'une valeur
nominale de soixante-deux virgule cinquante francs suisses (CHF 62,50) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale confère au conseil d'administration tous pouvoirs pour donner effet à la résolution ci-dessus,
notamment de prendre toutes mesures indiquées aux fins de remboursement du capital aux actionnaires toutefois en
respectant les dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales et de prendre toutes mesures né-
cessaires et utiles en relation avec la réduction du capital social.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.45 heures.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 1.100,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. WEILER, M. MAYER, G. REUTER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
octobre 2009. Relation: LAC/2009/40454. - Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2009127659/74.
(090155857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
DWS Cashback Garant 2014, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung zum 14.08.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil wurde beim Registre de
Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009109731/10.
(090135633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.
96585
DWS China A-Fund, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung zum 07.08.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des
Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009109735/10.
(090135648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.
DWS Emerging New Deal Fund, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung zum 07.08.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des
Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009109737/10.
(090135651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.
GREIFF «special situations» Fund OP, Fonds Commun de Placement.
La partie spécifique du règlement de gestion modifié au 30 septembre 2009 a été déposé au Registre de commerce et
des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2009111845/10.
(090137978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.
European Geophysical Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 43.973.
LIM Logging S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 99.647.
PROJET DE FUSION
L'an deux mille neuf, le dix-sept septembre - N°418.
Par-devant Maître Nous, Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxem-
bourg), soussigné.
ONT COMPARU:
I.- Monsieur Serge, Guillaume, Marcel LAURENT, administrateur de sociétés, demeurant à (B) Seraing, voie Bernstein,
1,
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme EUROPEAN GEOPHYSICAL SER-
VICES, (ci-après la «société absorbante»), établie et ayant son siège social L-4801 Rodange, 1, rue de l'Industrie, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 43.973, suivant résolution du conseil
d'administration en date du 17 septembre 2009,
laquelle reste annexée en copie au présent acte,
constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Differdange, en date du 21 mai 1993, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 375 du 18 août 1993 et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 juillet
2009, en cours de publication au Mémorial.
II.- Monsieur Frédéric MALINET, demeurant Chalet des Brossettes, à F-43200 LAPTE,
agissant en tant que gérant unique de la société à responsabilité limitée LIM LOGGING (anciennement LIM NORDEN
EUROPA SARL) (ci-après la «société absorbée»), établie et ayant son siège social à L-4801 Rodange, 1, rue de l'Industrie,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 99.647,
96586
constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, le 4 février 2004, publié
au Mémorial C n° 475 du 6 mai 2004, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu
par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 avril 2008, publié au Mémorial C n° 1321 du 29
mai 2008.
Lesquels, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter:
Le conseil d'administration de la société absorbante et le gérant de la société absorbée ont approuvé, en date de ce
jour, le projet de fusion entre European Geophysical Services SA et LIM Logging SARL.
La société absorbante, titulaire de 100% des parts sociales de la société absorbée, est dispensée de la tenue d'une
assemblée générale, les conditions de l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales étant remplies, étant entendu
qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont le
droit de requérir, dans un délai d'un mois à partir de la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'appro-
bation de la fusion. Cette assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
Conformément à l'article 271(1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes
en la forme notariée.
Les termes du projet de fusion sont les suivants:
Le projet de fusion ci-après:
1. La société EUROPEAN GEOPHYSICAL SERVICES («EGS»), une société anonyme de droit luxembourgeois, avec
siège social à L-4801 Rodange, 1, Rue de l'Industrie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 43.973, au capital social de 150.000,- Euros représenté par 6.000 actions d'une valeur nominale
de 25,- Euros chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées, détient l'intégralité (100%) des parts sociales,
représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, de la société LIM Logging S.àr.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi à L-4801 Rodange, 1, Rue de l'Industrie, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 99.647, au capital social de EUR
50.000,- représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, intégralement souscrites et
entièrement libérées. Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés
prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).
2. La société anonyme EUROPEAN GEOPHYSICAL SERVICES («EGS») (encore appelée la société absorbante) entend
fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et les textes subséquents avec la société à responsabilité limitée LIM Logging S.àr.l. (encore appelée la société absorbée)
par absorption de cette dernière.
3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1
er
janvier 2009.
4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, gérant, commissaires ou réviseurs des sociétés qui
fusionnent.
5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C
du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur
les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.
7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour-cent) des actions du
capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer
sur l'approbation de la fusion.
8. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive
comme indiqué ci-avant au point 5. et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).
9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations
à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits
au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.
10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.
11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
12. Formalités - La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
96587
13. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante
les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comp-
tables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations
réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents
quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.
14. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
15. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Formalitési>
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
<i>Remise de titresi>
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quelconques
relatifs aux éléments et droits apportés.
<i>Frais et droitsi>
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicilei>
Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour
toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et
faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article
271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. G. M. LAURENT, F. MALINET, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils, le 21 septembre 2009, LAC/2009/38395. - Reçu douze Euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. SCHNEIDER.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2009.
Jacques DELVAUX.
Référence de publication: 2009127273/127.
(090153437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2009.
DWS Corporate Bond Basket 2014, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung zum 01.09.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de
Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009114891/10.
(090140631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.
96588
DWS Flex Aktiv, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung zum 26.08.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil wurde beim Registre de
Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009114892/10.
(090140635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.
DWS Flex Aktiv, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung zum 26.08.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de
Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009114893/10.
(090140636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.
AL DWS Global Aktiv+, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung zum 26.08.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil beim Registre de Com-
merce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009114894/10.
(090140642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.
Altera Security Fund, Fonds Commun de Placement.
Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der HSBC Trinkaus &
Burkhardt (International) SA beschlossen, das Verwaltungsreglement des Organismus für gemeinsame Anlagen Altera
Security Fund, der den Bestimmungen des Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für ge-
meinsame Anlagen unterliegt, zu ändern.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 01. September 2009.
Axxion S.A. / HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009122492/16.
(090145250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2009.
AL DWS Global Aktiv+, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung zum 26.08.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de
Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009114896/10.
(090140644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.
96589
Deka-Flex:, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion modifié au 30.09.2009 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009122801/10.
(090149179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.
Financière Stoppato, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 133.411.
L'an deux mille neuf, le premier octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
1) Monsieur Alessandro STOPPATO, dirigeant de sociétés, né à Florence (Italie), le 16 mai 1953, demeurant à I-50132
Florence, Via Benedetto Varchi N° 56 (Italie).
2) La société de droit italien "DYER & DYER, s.r.l.", établie et ayant son siège social à I-50122 Florence, Via Della
Condotta(Italie).
Tous sont ici représentés par Monsieur Alexandre MARGUET, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-
lement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse, en vertu de 2 procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations,
après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
afin d'être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
* Que la société à responsabilité limitée "FINANCIERE STOPPATO", (la "Société"), établie et ayant son siège social à
L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 133411, a été constituée originairement sous l'empire de la législation française,
et que la nationalité luxembourgeoise a été adoptée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de
résidence à Sanem, en date du 31 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2843 du 7 décembre 2007.
* Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire (l'"Assemblée") et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse, et de modifier en
conséquence le premier alinéa de l'article 2 afin de lui donner la teneur suivante:
"Article 2. (premier alinéa)
Le siège social est établi à Steinsel (Grand-Duché de Luxembourg)."
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Christophe BLONDEAU, employé privé, né à Anvers (Belgique), le 28
février 1954, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de sa fonction de gérant et lui accorde
décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des six cent quatre-vingt-quatre mille cent dix-huit (684.118)
parts sociales représentatives du capital social.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un million six cent quatre-vingt-seize
mille huit cent soixante-huit virgule cinquante-six euros (1.696.868,56 EUR) en vue de porter son montant actuel de six
millions huit cent quarante et un mille cent quatre-vingts euros (6.841.180,- EUR) à cinq millions cent quarante-quatre
mille trois cent onze virgule quarante-quatre euros (5.144.311,44 EUR).
Cette réduction de capital est réalisée par absorption de l'intégralité des pertes réalisées au 31 décembre 2008, à
concurrence de 1.696.868,56 EUR, sans annulation de parts sociales, mais par la simple réduction du pair comptable des
684.118 parts sociales représentatives du capital social.
96590
La preuve de l'existence desdites pertes a été rapportée au notaire instrumentant sur base du bilan arrêté au 31
décembre 2008, une copie dudit bilan, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Tous pouvoirs sont conférés au gérant pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de quatre millions cent quarante-quatre
mille trois cent onze virgule quarante-quatre euros (4.144.311,44 EUR) en vue de porter son montant actuel de cinq
millions cent quarante-quatre mille trois cent onze virgule quarante-quatre euros (5.144.311,44 EUR) à un million d'euros
(1.000.000,- EUR).
Cette réduction de capital est réalisée sans annulation de parts sociales, mais par la réduction du pair comptable des
684.118 parts sociales représentatives du capital social et par le remboursement aux associés d'un montant de
4.144.311,44 EUR au prorata des parts sociales détenues actuellement dans la Société.
Tous pouvoirs sont conférés au gérant pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi
modifié du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éven-
tuels de la Société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur
part que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Sixième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
"Article 5. Le capital social est fixé à un million d'euros (1.000.000,- EUR) représenté par six cent quatre-vingt-quatre
mille cent dix-huit (684.118) parts sociales sans désignation de valeur nominale chacune, entièrement libérées."
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ès qualités qu'il agit, connu du notaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
(signé): MARGUET - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 5 octobre 2009, Relation GRE/2009/3529. - Reçu soixante quinze euros - 75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 octobre 2009.
J. SECKLER.
Référence de publication: 2009127472/81.
(090155995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Deka-Flex:, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion modifié au 01.11.2009 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009122803/10.
(090149183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.
Selected Strategies Partners, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.395.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the nineteenth day of the month of August.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
96591
There appeared:
BANQUE LEONARDO, a credit institution existing under the laws of France, licensed as a bank by the Banque de
France under bank code 21990, having its registered office at 68, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France,
registered with the Greffe du Tribunal de commerce de Paris under number 353755788, represented by Mr Victor-Régis
de Pampelonne, professionally residing at 68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France;
hereby represented by Mrs Juliete Joachim, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Paris, France on 17 August 2009.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as aforementioned, has required the officiating notary to enact the deed of incor-
poration of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which shall be governed by
the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorpo-
ration under the name of "Selected Strategies Partners" (hereinafter the "Company").
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interest, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies- and in particular, in Selected Strategies Limited, Selected Strategies Advanced, Selected Strategies European
and any subsequent entity which will result from the merger of the three above-mentioned companies- all being companies
under the form of société d'investissement à capital variable organized as sociétés en commandite par actions, existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and qualified as specialised investment funds in accordance with the
law of 13 February 2007 on specialised investment funds and to act as general partner and shareholder with unlimited
liability. The Company may further hold any other form of investment, acquire by purchase, subscription or in any other
manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise securities of any kind and administrate, control and develop
its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the
manager or, in the case of several managers, the board of managers. Within the same municipality, the registered office
may be transferred through simple resolution of the manager or, in the case of several managers, the board of managers.
In the event that the manager or, in the case of several managers, the board of managers determine(s) that extraor-
dinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
(3/4) of the share capital at least. The shares to be subscribed shall be offered preferably to the existing partner(s), in
proportion to the share in the capital represented by his/their shares.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
96592
Art. 8. The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to new
partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three
quarters (3/4) of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters (3/4) of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-
lution of the Company.
Art. 10. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners. In dealings with
third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the general
meeting of partners which sets the term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole
partner, or as the case may be, the partners.
The Company shall be bound in all circumstances by the signature of its manager or, in case of several managers, by
the joint signatures of any two managers or by the signature or any person to whom such signatory power has been
delegated by the sole manager, or as the case may be, the board of managers.
Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by its board of managers which shall choose among its
members a chairman, and may choose among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram or facsimile,
e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than
one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution is equal,
the chairman of the meeting shall have a casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two (2) managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two (2) managers or by any person duly appointed to that
effect by the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
96593
Art. 15. The manager(s) does/do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. He is/they are authorised agent(s) only and are therefore
merely responsible for the execution of his/their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 16. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Except if a higher majority is provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The amendment of these articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 18. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of
section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company's financial year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of
the same year.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager or, in the case of several
managers the board of managers, prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The balance is available
for distribution by the general meeting of partners. The manager or, in the case of several managers, the board of managers
may distribute interim dividends to the extent sufficient funds are available therefore.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
Banque Leonardo, prenamed, subscribes for the twelve thousand five hundred (12,500) shares and pays them fully up
in cash for an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-).
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2009.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutions of sole partneri>
The appearing party, representing the entire subscribed share capital has immediately proceeded to pass the following
resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the board of managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Victor-Régis de Pampelonne, born in Saint-Mandé, France, on February 5, 1952, with professional address at 68,
rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France;
- Mr Bertrand de Villeneuve-Bargemont, born in Boulogne-Billancourt, France, on December 9, 1954, with professional
address at 68, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France; and
96594
- Mr Jacques Falzon born in Sfax, Tunisia on December 17, 1953, with professional address at 68, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris, France.
The managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to
bind the Company by the joint signatures of any two of them.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above appearing
party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in
case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
BANQUE LEONARDO, un établissement de crédit existant sous la loi française, agréé en tant que banque par la
Banque de France, code interbancaire 21990, ayant son siège social au 68, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, France,
enregistré auprès du Greffe du Tribunal de Commerce sous le numéro 353755788, représenté par Monsieur Victor-
Régis de Pampelonne, né à Saint-Mandé, France, le 5 février 1952, ayant son adresse professionnelle au 68, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris, France;
ici représentée par Madame Juliette Joachim, maître ne droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée à Paris, France, le 17 août 2009.
Laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée
au présent acte et soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
Ladite partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'établir l'acte de
constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare organiser et d'arrêter les statuts tels que stipulés ci-
après:
A. Objet - Durée - Nom - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui deviendront associés, une société à responsabilité
limitée, qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les
présents statuts sous la dénomination de "Selected Strategies Partners" (ci-après la "Société").
Art. 2. L'objet de la Société est de détenir une participation de quelque forme qu'elle soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères -et en particulier dans Selected Strategies Limited, Selected Strategies Advanced, Selected
Strategies European et toute entité subséquente qui résultera de la fusion des trois sociétés ci-avant nommées, toutes
étant des sociétés d'investissement à capital variable sous la forme de sociétés en commandite par actions selon les lois
du Grand-Duché de Luxembourg et organisées comme fonds d'investissement spécialisés conformément à la loi du 13
février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés- et d'agir comme associé commandité et associé avec une respon-
sabilité illimitée. La Société peut entreprendre toute forme d'investissement, acquérir par achat, souscription ou par toute
autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou autre valeurs mobilières de toute nature et administrer,
contrôler et développer son portefeuille.
La Société peut également garantir, accorder des prêts, accorder des sûretés à ou autrement assister les sociétés dans
lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de société que la Société.
La Société peut également agir en tant que associé avec ou sans responsabilité limitée pour toutes les dettes et obli-
gations de sociétés en commandite ou entités similaires.
La Société peut également pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, exécuter toutes les opérations
utiles ou nécessaires pour l'accomplissement de son objet ou qui sont liées directement ou indirectement à son objet.
La Société peut procéder à des emprunts, de quelque nature ou forme, ainsi qu'émettre des obligations.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, sur
décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou autres bureaux
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Le siège social pourra être transféré dans la même commune sur
simple décision du gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Si le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance estime que des événements politiques ou militaires
extraordinaires, ayant des conséquences sur les activités normales de la Société à son siège social ou sur la facilité de
communication entre ce siège social et des personnes à l'étranger, ont lieu ou sont imminents, le siège social peut,
96595
temporairement, être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales ; de telles
mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré ce transfert provisoire, restera une
société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
Chaque part donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence à l'associé
ou aux associés existant(s), en proportion à la part du capital social que représentent ses/leurs parts sociales.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis devront désigner
un mandataire unique qui les représentera à l'égard de la Société.
Art. 8. Les parts de la Société sont librement cessibles entre les associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des
nouveaux associés qu'avec l'approbation des autres associés donnée en assemblée générale, à la majorité des trois-quarts
(3/4) du capital social.
En cas de décès, les parts sociales du défunt ne peuvent être transférées à de nouveaux associés qu'avec l'approbation
des autres associés donnée en assemblée générale, à la majorité des trois-quarts (3/4) du capital social. Une telle appro-
bation n'est cependant pas requise au cas où les parts sont transférées aux ascendants, descendants ou au conjoint
survivant.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 10. Ni les créanciers, ni les ayants-droit, ni les héritiers ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, faire apposer
des scellés sur les avoirs ou les documents de la Société.
<i>C. Gérancei>
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), qui n'a (ont) pas besoin d'être associé(s). Dans les relations
avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circons-
tances et autoriser toutes les transactions en rapport avec l'objet de la Société. Le(s) gérant(s) est (sont) désigné(s) par
l'assemblée générale des associés qui détermine la durée de son (leur) mandat. Le(s) gérants sont librement et à tout
moment révocable(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.
La Société sera engagée, dans tous les cas, par la signature de son gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par les
signatures conjointes de deux gérants, ou par la signature de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le gérant ou par le conseil de gérance le cas échéant.
Art. 12. En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par son conseil de gérance qui devra désigner un président
en son sein, et pourra désigner un vice-président parmi ses membres. Il peut également choisir un secrétaire, qui n'a pas
besoin d'être gérant et qui aura pour mission de conserver les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur décision du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la société à moins qu'il n'en soit autrement indiqué
dans l'avis de convocation. Le président préside toutes les réunions du conseil de gérance, mais, en son absence, le conseil
de gérance peut désigner un autre gérant comme président pro tempore par un vote à la majorité des membres présents
à une telle réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt quatre (24) heures avant
la date prévue pour cette réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de l'urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à l'avis de convocation par consentement écrit, câble, télégramme, fac-
simile, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale n'est pas requise pour une
réunion se tenant à un moment et un lieu déterminé dans une résolution précédente adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une
réunion du conseil de gérance ou en cas de résolutions écrites, approuvées et signées par l'ensemble des membres du
conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter à une réunion du conseil de gérance en désignant, par écrit ou par câble,
télégramme, fac-similé, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son mandataire.
Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues.
Chaque gérant peut participer à chaque réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes présentes à l'assemblée de
s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne
à une telle réunion.
96596
Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si une majorité au moins de ses membres est
présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à une telle réunion. Si, au cours d'une réunion, le nombre de voix pour ou contre une résolution
sont à égalité, le président de l'assemblée aura une voix prépondérante.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par circulaire lorsqu'il exprime son approbation par
écrit, par câble, télégramme, fac-similé, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble formera le
procès-verbal prouvant la résolution.
Art. 13. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil de gérance sont signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux qui peuvent être produits dans
le cadre de procédures judiciaires ou autre, sont signés par le président ou par deux (2) gérants ou par toute personne
dûment désignée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 15. Le(s) gérant(s) n'assume(nt), en raison de sa (leur) position, aucune responsabilité personnelle en relation avec
les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simple(s) mandataire(s), il(s) n'est/ne sont responsable
(s) que pour l'exécution de leur mandat.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient ou représente.
Art. 17. A l'exception d'une majorité plus importante décidée par les présents statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
La modification de ces statuts ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par la majorité
des associés représentant au moins trois-quarts du capital social.
Art. 18. L'associé unique exerce les pouvoirs accordés à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la
section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Exercice social - Comptes annuels - Distribution de bénéfices
Art. 19. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le
conseil de gérance, dresse un inventaire indiquant les valeurs de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé a accès
à cet inventaire et au bilan au siège social de la Société.
Art. 21. Cinq pourcent (5%) du bénéfice net sont réservés pour l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que la
réserve atteigne dix pourcent (10%) du capital social de la Société. Le solde peut être librement utilisé par les associés.
Le solde peut être distribué sur décision de l'assemblée générale des associés. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants,
le conseil de gérance, peut distribuer des dividendes intérimaires lorsque des fond suffisants sont disponibles pour dis-
tribution.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin
d'être associés, et qui sont désignés par l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rému-
nération. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation
de l'actif et le paiement du passif de la Société.
Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes, sera partagé entre les associés en proportion
de leurs parts sociales détenues dans la Société.
Art. 23. Pour toute question qui n'est pas réglée par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Banque Leonardo, prénommée, souscrit les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales et les libère intégralement
contre un paiement en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
La preuve de tels paiements a été donnée au notaire soussigné qui déclare que les conditions prévues à l'article 183
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2009.
96597
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison de sa constitution, sont estimés approximativement à EUR 1.200,-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
La partie comparante, représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du conseil de gérance de la Société, pour une durée illimitée:
- M. Victor-Régis de Pampelonne, né à Saint-Mandé, France, le 5 février 1952, ayant son adresse professionnelle au 68,
rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France;
- M. Bertrand de Villeneuve-Bargemont, né à Boulogne-Billancourt, France, le 9 décembre 1954, ayant son adresse
professionnelle au 68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France; et
- M. Jacques Falzon, né à Sfax, Tunisie, le 17 décembre 1953, ayant son adresse professionnelle au 68, rue du Faubourg
Saint-Honoré 75008 Paris, France.
Les gérants sont investis des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et
d'engager la Société par la signature conjointe de deux d'entre eux.
Dont acte, passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes que, à la demande de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi de sa traduction française; en cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état civil et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. JOACHIM - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 août 2009. Relation: LAC/2009/34753. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le vingt-neuf septembre de l'an deux mille neuf.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009127406/356.
(090154334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.
BRE/Europe 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 595.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 114.911.
BRE/Europe 3-B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 116.319.
BRE/Europe 3-C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 122.200.
BRE/French Holdco 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 118.148.
In the year two thousand nine, on the eleventh day of September.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
1) BRE/Europe 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
96598
and Companies Register under section B number 114.911, having a share capital of EUR 595,000.00, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary dated 23 February 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial") number 1029 of 26 May 2006. The articles of incorporation have been amended for the
last time to a deed before the undersigned notary dated 2 February 2007, published in the Mémorial number 464 of 22
February 2008,
here represented by Ms Patricia Sondhi, avocat, residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole
manager of BRE/Europe 3 S.à r.l. (the "Sole Manager 1"), pursuant to resolutions taken by the Sole Manager 1 on 8
September 2009 (the "Resolution 1").
2) BRE/Europe 3-B S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under section B number 116.319, having a share capital of EUR 12,500.-, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary dated 3 May 2006, published in the Mémorial number 1341 of 12 July 2006.
The articles of incorporation have been amended for the last time to a deed before the undersigned notary dated 16
November 2006, published in the Mémorial number 154 of 9 February 2007,
here represented by Ms Patricia Sondhi, avocat, residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole
manager of BRE/Europe 3-B S.à r.l. (the "Sole Manager 2"), pursuant to resolutions taken by the Sole Manager 2 on 8
September 2009 (the "Resolution 2").
3) BRE/Europe 3-C S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under section B number 122.200, having a share capital of EUR 12,500.-, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary dated 20 November 2006, published in the Mémorial number 141 of 8
February 2007,
here represented by Ms Patricia Sondhi, avocat, residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole
manager of BRE/ Europe 3-C S.à r.l. (the "Sole Manager 3"), pursuant to resolutions taken by the Sole Manager 3 on 8
September 2009 (the "Resolution 3").
4) BRE/French Holdco 5 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 118.148, having a share capital
of EUR 12,500.-, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 19 July 2006 published in the Mémorial
number 1846 of 3 October 2006,
here represented by Ms Patricia Sondhi, avocat, residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole
manager of BRE/French Holdco 5 S.à r.l. (the "Sole Manager 4"), pursuant to resolutions taken by the Sole Manager 4 on
8 September 2009 (the "Resolution 4").
Hereinafter, the Resolution 1, the Resolution 2, the Resolution 3, and the Resolution 4, are collectively referred to as
the "Resolutions".
An excerpt of the Resolutions, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have required the undersigned notary to record the
following:
MERGER PROJECT
1) Merging Parties
- BRE/Europe 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under section B number 114.911, having a share capital of EUR 595,000.00 as absorbing company
(hereinafter referred to as "Absorbing Company"),
- BRE/Europe 3-B S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under section B number 116.319, having a share capital of EUR 12,500.-, as absorbed
company 1 (hereinafter referred to as "Absorbed Company 1"), and
- BRE/Europe 3-C S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under section B number 122.200, having a share capital of EUR 12,500.-, as absorbed
company 2 (hereinafter referred to as "Absorbed Company 2"),
- BRE/French Holdco 5 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 118.148, having a share capital of EUR
12,500.-, as absorbed company 3 (hereinafter referred to as "Absorbed Company 3"),
The Absorbed Company 1, the Absorbed Company 2, and the Absorbed Company 3, are collectively referred to as
"Absorbed Companies".
96599
The Absorbing Company and the Absorbed Companies are collectively referred to as the "Merging Companies".
2) The Absorbing Company holds 500 shares of the Absorbed Company 1, representing the entire share capital and
all of the voting rights of the Absorbed Company 1.
3) The Absorbing Company holds 500 shares of the Absorbed Company 2, representing the entire share capital and
all of the voting rights of the Absorbed Company 2.
4) The Absorbing Company holds 500 shares of the Absorbed Company 3, representing the entire share capital and
all of the voting rights of the Absorbed Company 3.
5) The Absorbing Company proposes to concurrently absorb the Absorbed Companies by way of transfer of all assets
and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company, pursuant to the provisions of articles 278 through
280 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").
6) As from 31 August 2009, all operations and transactions of the Absorbed Companies are considered for accounting
purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.
7) As of the Effective Date (as defined below), all rights and obligations of the Absorbed Companies vis-à-vis third
parties shall be taken over by the Absorbing Company. The Absorbing Company will in particular take over debts as own
debts and all payment obligations of the Absorbed Companies. The rights and claims comprised in the assets of the
Absorbed Companies shall be transferred to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal,
attached thereto.
8) The Absorbing Company shall from the Effective Date (as defined below) carry out all agreements and obligations
of whatever kind of the Absorbed Companies such as these agreements and obligations exist on the Effective Date (as
defined below) and in particular carry out all agreements existing, if any, with the creditors of the Absorbed Companies
and shall be subrogated to all rights and obligations from such agreements.
9) No special rights or advantages have been granted to the sole manager of the Merging Companies.
10) The shareholders of the Absorbing Company have, within one month from the publication of this merger project
in the Mémorial, access at the registered office of the Absorbing Company to all documents listed in article 267 paragraph
(1) a), b) and c) of the Law and may obtain copies thereof, free of charge.
11) One or more shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the subscribed share capital of the
Absorbing Company may within the time period set out in 10) above request the convening of a shareholders' meeting
of the Absorbing Company to decide whether to approve the proposed merger.
12) Full discharge is granted to the sole manager of each of the Absorbed Companies the exercise of its mandate.
13) Subject to the rights of the shareholders of the Absorbing Company set out in 11) above, the dissolution of the
Absorbed Companies shall become effective and final one month after the publication of this merger project in the
Mémorial (the "Effective Date") and will lead simultaneously to the effects set out in article 274 of the Law.
14) The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by
law, which are necessary or useful to carry into effect the merger and the transfer and assignment of the assets and
liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company. Insofar as required by law or deemed necessary or
useful, appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets
and liabilities transferred by the Absorbed Companies to the Absorbing Company.
15) The books and records of the Absorbed Companies will be held at the registered office of the Absorbing Company
for the period legally prescribed.
16) As a result of the merger, the Absorbed Companies shall cease to exist and all their respective issued shares shall
be cancelled.
The undersigned notary public hereby certifies the existence and legality of the merger project and of all acts, docu-
ments and formalities incumbent upon the merging parties pursuant to the Law.
In accordance with article 271 (2) of the law of August 10th 1915, the undersigned notary certifies the legality of the
present merger proposal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary by name, first
name, civil status and residence, the said the proxy holder of the appearing parties signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le onzième jour du mois de septembre,
Par-devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
96600
1) BRE/Europe 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.911, ayant un capital social de
EUR 595.000,-, constituée suivant acte reçu du notaire soussigné le 23 février 2006 publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le "Mémorial") N° 1029 en date du 26 mai 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu du notaire soussigné le 2 Février 2007, publié au Mémorial N° 464 daté du 22 Février
2008,
ici représentée par Mademoiselle Patricia Sondhi, avocat, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire
au nom et pour compte du gérant unique de BRE/Europe 3 S.à r.l. (le "Gérant Unique 1"), en vertu d'un pouvoir qui lui
a été conféré par une résolution prise par le Gérant Unique 1 le 8 septembre 2009 (la "Résolution 1");
2) BRE/Europe 3-B S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.319, ayant un capital social
de EUR 12.500,-, constituée suivant acte reçu du notaire soussigné le 12 juillet 2006, publié au Mémorial N° 154 daté du
9 février 2007,
ici représentée par Mademoiselle Patricia Sondhi, avocat, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire
au nom et pour compte du gérant unique de BRE/Europe 3-B S.à r.l. (le "Gérant Unique 2"), en vertu d'un pouvoir qui
lui a été conféré par une résolution prise par le Gérant Unique 2 le 8 septembre 2009 (la "Résolution 2");
3) BRE/Europe 3-C S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.200, ayant un capital social
de EUR 12.500,-, constituée suivant acte reçu du notaire soussigné le 20 novembre 2006, publié au Mémorial N° 141
daté du 8 février 2007,
ici représentée par Mademoiselle Patricia Sondhi, avocat, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire
au nom et pour compte du gérant unique de BRE/Europe 3-C S.à r.l. (le "Gérant Unique 3"), en vertu d'un pouvoir qui
lui a été conféré par une résolution prise par le Gérant Unique 3 le 8 septembre 2009 (la "Résolution 3");
4) BRE/French Holdco 5 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.148, ayant un capital social
de EUR 12.500,-, constituée suivant acte reçu du notaire soussigné le 19 juillet 2006, publié au Mémorial N° 1846 daté
du 3 octobre 2006,
ici représentée par Mademoiselle Patricia Sondhi, avocat, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire
au nom et pour compte du gérant unique de BRE/French Holdco 5 S.à r.l. (le "Gérant Unique 4"), en vertu d'un pouvoir
qui lui a été conféré par une résolution prise par le Gérant Unique 4 le 8 septembre 2009 (la "Résolution 4").
Ci-après, la Résolution 1, la Résolution 2, la Résolution 3, et la Résolution 4, sont collectivement dénommées les
"Résolutions".
Les dites Résolutions, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
PROJET DE FUSION
1) Parties à la fusion:
- BRE/Europe 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.911, ayant un capital social de
EUR 595.000,-, comme société absorbante (la "Société Absorbante");
- BRE/Europe 3-B S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.319, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, comme société absorbée 1 (la "Société Absorbée 1") ;
- BRE/Europe 3-C S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.319, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, comme société absorbée 2 (la "Société Absorbée 2") ;
- BRE/French Holdco 5 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.148, ayant un capital social
de EUR 12.500,-, comme société absorbée 3 (la "Société Absorbée 3") .
La Société Absorbée 1, la Société Absorbée 2, et la Société Absorbée 3, sont collectivement dénommées (les "Sociétés
Absorbées").
96601
La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées sont collectivement dénommées les ("Sociétés Fusionnantes").
2) La Société Absorbante détient 500 parts sociales dans la Société Absorbée 1, représentant l'intégralité du capital
social et tous les droits de vote dans la Société Absorbée 1.
3) La Société Absorbante détient 500 parts sociales dans la Société Absorbée 2, représentant l'intégralité du capital
social et tous les droits de vote dans la Société Absorbée 2.
4) La Société Absorbante détient 500 parts sociales dans la Société Absorbée 3, représentant l'intégralité du capital
social et tous les droits de vote dans la Société Absorbée 3.
5) La Société Absorbante propose d'absorber concurremment les Sociétés Absorbées 1 par voie de fusion par acqui-
sition suivant les dispositions des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la "Loi").
6) A partir du 31 août 2009, toutes les opérations et les transactions des Sociétés Absorbées sont considérées du
point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
7) A partir de la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous), tous les droits et obligations des Sociétés Absorbées
vis-à-vis des tiers seront pris en charge par la Société Absorbante. La Société Absorbante assumera en particulier toutes
les dettes comme ses dettes propres et toutes les obligations de paiement des Sociétés Absorbées. Les droits et créances
des Sociétés Absorbées seront transférés à la Société Absorbante avec l'intégralité des sûretés, soit in rem soit person-
nelles, y attachées.
8) La Société Absorbante exécutera à partir de la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous) tous les contrats
et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, des Sociétés Absorbées tels que ces contrats et obligations existent à
la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous) et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers
des Sociétés Absorbées et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats.
9) Aucun droit ou avantage particulier n'a été attribué aux gérants des Sociétés Fusionnantes.
10) Les associés de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication de ce projet de
fusion au Mémorial, de prendre connaissance au siège social des Sociétés Absorbées de tous les documents énumérés à
l'article 267, alinéa (1) a), b) et c) de la Loi et peut en obtenir copie intégrale, sans frais.
11) Un ou plusieurs associé de la Société Absorbante disposant au moins de 5% du capital souscrit de la Société
Absorbante a/ont le droit, pendant le délai indiqué sous le point 10) ci-dessus, de requérir la convocation d'une assemblée
générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.
12) Décharge pleine et entière est accordée au gérant unique des Sociétés Absorbées pour l'exercice de leur mandat.
13) Sous réserve des droits des associés de la Société Absorbante tels que décrits sous le point 11) ci-dessous, la
dissolution des Sociétés Absorbées deviendra effective et définitive un mois après la publication de ce projet de fusion
dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Date de Réalisation") et conduira simultanément aux effets
tels que prévus par l'article 274 de la Loi.
14) La Société Absorbante devra elle-même accomplir toutes les formalités, y compris les publications telles que
prévues par la loi, qui sont nécessaires ou utiles à l'entrée en vigueur de la fusion et au transfert et cession des actifs et
passifs des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante. Dans la mesure où la loi le prévoit, ou lorsque jugé nécessaire
ou utile, des actes de transfert appropriés seront exécutés par les Sociétés Fusionnant afin de réaliser la transmission des
actifs et passifs des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante.
15) Les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant
la période prescrite par la loi.
16) Par effet de la fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d'exister de plein droit et leurs parts sociales émises seront
annulées.
Le notaire soussigné déclare attester de l'existante et de la légalité du projet de fusion et de tous actes, documents et
formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la Loi.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article
271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente que sur demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par nom,
prénom usuel, état et demeure, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. SONDHI - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36918. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck SCHNEIDER.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
96602
Luxembourg, le vingt et un septembre de l'an deux mille neuf.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009127274/257.
(090154430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.
Aristolux Investment Fund, Fonds Commun de Placement.
By resolutions of the Board of Directors taken by circular resolutions of 11 September 2009, Aristolux Investment
Fund Management Company S.A., acting as management company of "Aristolux Investment Fund" (the "Fund"), has de-
clared the closure of the Fund with immediate effect.
Référence de publication: 2009127502/1210/7.
IFM-Institutionell Real Estate Plus 1, Fonds Commun de Placement.
Die International Fund Management S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil II des luxemburgischen
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten Investmentfonds (fonds com-
mun de placement) teilt hierdurch mit, dass das Liquidationsverfahren des Fonds IFM-Institutionell Real Estate Plus 1
abgeschlossen ist.
Luxemburg, im Oktober 2009.
International Fund Management S.A.
<i>Die Geschäftsführungi>
Référence de publication: 2009129179/1202/11.
Leptis Magna, Fonds Commun de Placement.
DWS Zinswunder (a), Fonds Commun de Placement.
DWS Zinssprinter (2016), Fonds Commun de Placement.
DWS Dollarchance Garant, Fonds Commun de Placement.
DWS Zinssprinter, Fonds Commun de Placement.
Der Investmentfonds Leptis Magna wurde in Übereinstimmung mit den Regelungen in Artikel 14 des Verwaltungsre-
glements - Allgemeiner Teil zum 03.04.2006 aufgelöst. Die Investmentfonds DWS Zinswunder (a), DWS Zinssprinter
2016, DWS Dollarchance Garant und DWS Zinssprinter wurden in Übereinstimmung mit den Regelungen in Artikel 14
des Verwaltungsreglements - Allgemeiner Teil des jeweiligen Fonds zum 01.08.2006 aufgelöst.
Luxemburg, im Oktober 2009.
DWS Investment S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2009129180/755/15.
A.N.G.'Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.
R.C.S. Luxembourg B 133.846.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2009i>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 février 2009 que:
- La démission de Mademoiselle Alexandra DELAHAYE, 1, rue Roeser, L-1898 KOCKELSCHEUER, en qualité de
gérante administrative est acceptée.
- Madame Nathalie GRANDJEAN, demeurant 24, rue Charles Bernhoeft, L-1240 LUXEMBOURG est nommée en
qualité de gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
- La société est désormais engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2009.
<i>Pour A.N.G.'Immobiler S.à r.l.
i>Nathalie GRANDJEAN
Référence de publication: 2009125871/18.
(090151245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
96603
Yelo Bau SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9678 Nothum, 7, Beiwenerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 93.917.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 1
er
septembre 2009 de la société YELO-BAU
SA tenue à Nothum que:
1) - Mme Hübsch Myriam a donné sa démission comme commissaire au comptes.
2) L'assemblée décide de nommer comme nouveaux commissaire au comptes:
- Monsieur Leunessen Michel, domicilié à L-9636 Berle, 4, Duerfstrooss
3) le mandat du nouveau commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuaire de
l'an 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nothum, le 07 septembre 2009.
Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE-COMPTABLE LUCIEN FUNCK SARL
FIDUCIAIRE FUNCK s.àr.l.
<i>Service Compt. & Bilans
i>L-9519 WILTZ
Mme REMICHE Diane
Référence de publication: 2009126057/22.
(090151042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Studiofund S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 131.057.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 25/09/2009i>
L'assemblée, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
La société révoque Maître Vanessa MOROLLI, titulaire d'une signature A de son poste d'administrateur.
<i>Deuxième Résolutioni>
La société nomme Madame Myriam SCHNARCH née le 22/11/1946 à Gura Humorului (Roumanie) et demeurant à
L-8266 Mamer, 25 rue des Thermes Romains, au poste d'administrateur.
<i>Troisième Résolutioni>
La société attribue à Monsieur Alexandre GRUMBERG né le 01/04/1944 à Bucarest (Roumanie) et demeurant à L-8266
Mamer, 25 rue des Thermes Romains, une signature A.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Luxembourg, le 25/09/2009.
La société Studiofund S.A.
Signature
Référence de publication: 2009126525/21.
(090152162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Jarama Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 49.235.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009126547/10.
(090152300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96604
Winchester JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 121.104.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, (Grande-Duché de Luxembourg) en date du 05 août 2009, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 17 août 2009.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009126305/14.
(090152297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
KHG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 63.257.
Nous vous prions de bien vouloir accepter notre démission avec effet immédiat de la fonction de commissaire aux
comptes au sein de votre société.
Bertrange, le 2 octobre 2009.
ARTEFACTO SARL
Signature
Référence de publication: 2009126306/12.
(090151848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Pizza Toscana, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 29, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 128.021.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 20 juillet 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 12 août 2009.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009126307/13.
(090152288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Montebello Finances, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 81.805.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2009 a accepté la démission présentée par Monsieur Jean-Pierre
CEDELLE de son mandat d'administrateur.
L'Assemblée a constaté dès lors que le nombre des administrateurs de la Société a été ramené de quatre à trois.
Pour extrait conforme
MONTEBELLO FINANCES
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2009126522/15.
(090152079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96605
Alma Mater S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.393.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 24 juin 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 juillet 2009.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009126303/13.
(090152302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Black & Decker Asia Manufacturing Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.801.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 05 août 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 17 août 2009.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009126304/13.
(090152299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Luxprofi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 147.105.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 07 août 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 17 août 2009.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009126308/13.
(090152283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
Euronimbus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.
R.C.S. Luxembourg B 58.075.
<i>Notice rectificativei>
Il est porté à l'attention du public que Messieurs Robert Sweet et Roy Fossett demeurent désormais professionnel-
lement à GB-W4 5BY London, 566, Chiswick High Road.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009126311/14.
(090151861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96606
BRE/French Hotel Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 121.165.
In the year two thousand and nine, on the third day of September.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
There appeared:
BRE/ Europe 3-P S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under the number B129751, with a share capital of EUR 12,500,
here represented by Mrs Patricia Sondhi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given
on 24 August 2009, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
and
Art Hotel Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and having its registered office at 18-24, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 115744, with a share capital of EUR 12,500,
here represented by Mrs Patricia Sondhi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given
on 24 August 2009, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties are the shareholders of the Company, representing the entire share capital (the "Shareholders")
of BRE/French Hotel Holding I S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 17 October 2006, published in the
Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2364 of 19 December 2006, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under section B number 121165 (the "Company") and have required the undersigned
notary to state his declarations as follows:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of the purpose of the Company and of article 2 of the Company's articles of association which shall
henceforth have the following wording:
"The purpose of the Company is the acquiring, improving, operating and disposing of Abeau I ere Classe, Amiens
Kyriad, Bourges Mr Bed, Bron Kyriad, Cachan Mr Bed City, Cergy I ere Classe, Chilly Mr Bed City, Coigniéres Mr Bed,
Coquelles Kyriad, Exupéry Kyriad, Fresnes Campanile, Goussainville Mr Bed City, Henin Campanile, Herblain I ere Classe,
Igny Mr Bed City, Ivry Kyriad, Lomme K Kyriad, Lomme NH Nuit d'Hotel, Longvic Kyriad, Longwy Mr Bed, Ludres I ere
Classe, Mans MB Mr Bed, Mans PC I ere Classe, Marseille I ere Classe, Massieux I ere Classe, Massy Comfort Inn, Meaux
Comfort Inn, Metz Nuit d'Hotel, Meylan Kyriad, Montluçon Kyriad, Nancy C Campanile, Nemours Mr Bed, Nice Comfort
Inn, Olivet Nuit d'Hotel, Quimper Nuit d'Hotel, Ramonville Comfort Inn, Rochelle I ere Classe, Rouen Comfort Inn,
Rousse Kyriad, Rungis Kyriad, Rungis Business Kyriad, Saran K Kyriad, Saran NH Nuit d'Hotel, Strasbourg Mr Bed,
Toulouse Kyriad, Tours Mr Bed, Valence Nuit d'Hotel and Vlg Kyriad (each a "Property" and all together the "Properties").
The purpose of the Company is furthermore the holding of direct or indirect participations, in any form whatsoever,
in Société Civile Les Crêtes, Tenotel SAS, Amiens Hotel Sàrl, Sàrl HMB Bourges, Climinvest Sàrl, MB Cachan SNC, Cergy
Hotel Sàrl, SHVLG Sàrl, Sàrl HMBCL, Calais Hotel Sàrl, Sopaclif 1 SA, Fresnotel Sàrl, SNC MBC Goussainville, BSF (Bertin
Services France), MB Igny Hotel Sàrl, Soprohest SAS, FIH SAS, HMB LST Sàrl, Mans Hotel Sàrl, Société Civile Balafon,
Massy City Sàrl, Klemeaux Sàrl, SNC Nemours, MBC Nice Sàrl, Société Civile Tolosane, Rouen Hotel Sàrl, Rungis Hotel
SAS, SCI Toulouse-Bermudes, and in the French SAS companies BRE/Opera SAS, BRE/Bertin SAS and BRE/Sidhole SAS
(each a "Subsidiary" and all together the "Subsidiaries") the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of the above-mentioned companies.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the above-mentioned companies and their direct
and indirect subsidiaries.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-
plishment of its purpose.
In particular, the Company will provide the above-mentioned companies and their direct and indirect subsidiaries with
the services necessary to their administration, control and development. For that purpose the Company may require and
retain the assistance of other advisors.";
2. Creation of two classes of shares and replacement of the existing 500 shares of the Company by 450 shares of Class
A and 50 shares of Class B;
96607
3. Amendment of article 9, paragraph 1 of the articles of association of the Company;
4. Amendment of article 12 of the articles of association of the Company;
5. Amendment of article 13, paragraph 1, sentence 1 of the articles of association of the Company;
6. Amendment of article 13, paragraph 7 of the articles of association of the Company;
7. Amendment of article 13, paragraph 8 of the articles of association of the Company;
8. Amendment of article 13, paragraph 9 of the articles of association of the Company;
9. Amendment of article 14 of the articles of association of the Company;
10. Insertion of a new article 15 in the articles of association of the Company;
11. Insertion of a new article 19 in the articles of association of the Company;
12. Insertion of a supplemental sentence to article 20 (new numbering) in the articles of association of the Company;
13. Insertion of a new article 21 in the articles of association of the Company in relation to reserved matters of the
shareholders;
14. Amendment of article 26 (new numbering) of the articles of association of the Company in relation to the creation
of a preference dividend;
15. Insertion of a new article 27 in the articles of association of the Company in relation to the creation of the possibility
to pay interim dividends;
16. Amendment of article 28 (new numbering) of the articles of association of the Company in relation to the creation
of a preference liquidation dividend;
17. Amendment of article 29 (new numbering) of the articles of association of the Company;
18. Resignation of the sole manager, BRE/Management S.A. and granting full discharge;
19. Fixing of the number of the managers at four;
20. Appointment of new managers and;
21. Miscellaneous;
II. - That the entire share capital being represented at the present meeting and the general meeting represented
declaring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.
Then the general meeting (the "General Meeting") takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolved to amend article 2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth
have the following wording:
"The purpose of the Company is the acquiring, improving, operating and disposing of Abeau I ere Classe, Amiens
Kyriad, Bourges Mr Bed, Bron Kyriad, Cachan Mr Bed City, Cergy I ere Classe, Chilly Mr Bed City, Coigniéres Mr Bed,
Coquelles Kyriad, Exupéry Kyriad, Fresnes Campanile, Goussainville Mr Bed City, Henin Campanile, Herblain I ere Classe,
Igny Mr Bed City, Ivry Kyriad, Lomme K Kyriad, Lomme NH Nuit d'Hotel, Longvic Kyriad, Longwy Mr Bed, Ludres I ere
Classe, Mans MB Mr Bed, Mans PC I ere Classe, Marseille I ere Classe, Massieux I ere Classe, Massy Comfort Inn, Meaux
Comfort Inn, Metz Nuit d'Hotel, Meylan Kyriad, Montluçon Kyriad, Nancy C Campanile, Nemours Mr Bed, Nice Comfort
Inn, Olivet Nuit d'Hotel, Quimper Nuit d'Hotel, Ramonville Comfort Inn, Rochelle I ere Classe, Rouen Comfort Inn,
Rousse Kyriad, Rungis Kyriad, Rungis Business Kyriad, Saran K Kyriad, Saran NH Nuit d'Hotel, Strasbourg Mr Bed,
Toulouse Kyriad, Tours Mr Bed, Valence Nuit d'Hotel and Vlg Kyriad (each a "Property" and all together the "Properties").
The purpose of the Company is furthermore the holding of direct or indirect participations, in any form whatsoever,
in Société Civile Les Crêtes, Tenotel SAS, Amiens Hotel Sàrl, Sàrl HMB Bourges, Climinvest Sàrl, MB Cachan SNC, Cergy
Hotel Sàrl, SHVLG Sàrl, Sàrl HMBCL, Calais Hotel Sàrl, Sopaclif 1 SA, Fresnotel Sàrl, SNC MBC Goussainville, Société
Civile BSF, MB Igny Hotel Sàrl, Soprohest SAS, FIH SAS, HMB LST Sàrl, Mans Hotel Sàrl, Société Civile Balafon, Massy
City Sàrl, Klemeaux Sàrl, SNC Nemours, MBC Nice Sàrl, Société Civile Tolosane, Rouen Hotel Sàrl, Rungis HotelSAS,
SCI Toulouse-Bermudes, and in the French SAS companies BRE/Opera SAS, BRE/Bertin SAS and BRE/Sidhole SAS (each
a "Subsidiary" and all together the "Subsidiaries") the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of the above-mentioned companies.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the above-mentioned companies and their direct
and indirect subsidiaries.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-
plishment of its purpose.
In particular, the Company will provide the above-mentioned companies and their direct and indirect subsidiaries with
the services necessary to their administration, control and development. For that purpose the Company may require and
retain the assistance of other advisors."
96608
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolved to create two classes of shares and to convert the existing five hundred (500) shares
with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, into four hundred fifty (450) shares of Class A with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each and fifty (50) shares of Class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The shares of Class A and the shares of Class B have the same rights and obligations except as stated to the contrary
in the articles of association of the Company.
The General Meeting noted that as a consequence, the four hundred fifty (450) shares of Class A and the fifty (50)
shares of Class B are held as follows:
- four hundred fifty (450) shares of Class A are held by BRE/Europe 3-P S.à r.l.; and
- fifty (50) shares of Class B are held by Art Hotel Holding S.à r.l.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting resolved to amend article 9, paragraph 1 of the articles of association of the Company, which
shall henceforth have the following wording:
"The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, no shareholder may, directly or indi-
rectly, assign, sell, exchange, transfer, pledge or otherwise dispose of all or any part of the shares he holds in the Company
to any third party without obtaining the prior consent of the shareholders representing three quarters of the share capital
of the Company. Such transfer may only be performed to a transferee who has given prior to the transfer written
acceptance and adoption of all terms and conditions of any shareholders agreement which may have been entered into
between the shareholders (the "Shareholders Agreement")."
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting resolved to amend article 12 of the articles of association of the Company, which article shall
henceforth have the following wording:
"The Company is managed by at least three managers.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two members of the board of managers.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument."
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting resolved to amend article 13, paragraph 1, sentence 1, of the articles of association of the
Company, which shall henceforth have the following wording:
"The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
a vice-chairman."
<i>Sixth resolutioni>
The General Meeting resolved to add the following sentence to article 13, paragraph 7, of the articles of association
of the Company:
"If any manager is prevented from participating in a meeting or a vote of the board of managers, he may request that
the matter be discussed or voted again in his presence."
<i>Seventh resolutioni>
The General Meeting resolved to add the following sentence to article 13, paragraph 8, of the articles of association
of the Company:
"No decisions shall be taken as to matters falling into the field of responsibility of any absent manager unless such
decision would be necessary in order to avoid negative consequences for the Company."
<i>Eighth resolutioni>
The General Meeting resolved to amend article 13, paragraph 9, of the articles of association of the Company, which
shall henceforth have the following wording:
"Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. Any decisions
not being passed unanimously shall without delay be brought to the attention of the shareholders meeting which will
resolve upon the matter at a majority of shares present or represented."
<i>Ninth resolutioni>
The General Meeting resolved to add the following sentence to article 14 of the articles of association of the Company:
"All managers shall receive copies of the minutes."
96609
<i>Tenth resolutioni>
The General Meeting resolved to insert a new article 15 in the articles of association of the Company, which shall have
the following wording:
"The board of managers has to report regularly to the shareholders meeting on the conduct of the business and on
any other matters requested by the shareholders meeting.
The board of managers shall on or before November 15th of each year prepare and submit to the shareholders meeting
for approval a proposed business plan for the ensuing calendar year. The business plan shall include, without limitation,
each of the following items containing the most current information with regard thereto then available: (i) a comprehensive
survey of the market in which the Properties are competing, (ii) a detailed description of the renovation, refurbishment,
maintenance, repair and management of the Properties; including without limitation, any planned or required improve-
ments to the Properties, (iii) a pro forma income and expense statement for the Properties over the entire anticipated
term of ownership by the Company, but not less than five years, (iii) a detailed operating budget, as defined in the
Shareholders Agreement, and (iv) a detailed marketing report.
Not later than twenty (20) days after receipt by the shareholders meeting of the proposed business plan (or such
longer period as any shareholder may reasonably request by notice to the board of managers), the shareholders holding
the shares of Class A may deliver a notice to the board of managers stating that such shareholder objects to any infor-
mation contained in or omitted from such business plan and setting forth the nature of such objection. Upon receipt of
such notice, the board of managers shall within five (5) days modify the proposed business plan and resubmit it to the
shareholders meeting for the shareholders meeting's approval. Within ten (10) days of receipt of the resubmitted business
plan, the shareholders holding the shares of Class A may deliver a further objection notice (in which event the resubmission
and review process described above shall continue until the business plan in question is accepted and consented to by
the shareholders meeting). Notwithstanding anything to the contrary set forth herein, the shareholders meeting shall
have the right at any time subsequent to the acceptance and consent with respect to any business plan, by notice to the
board of managers, to revise such business plan or to request that the board of managers prepare for the shareholders
meeting's approval a revised business plan, taking into account such circumstances as the shareholders meeting deems
appropriate, provided, however, the revision of a business plan shall not be deemed a revocation of the board of managers
authority with respect to such actions that the board of managers may have already taken prior to such revision in
implementing such business plan, and the board of managers shall, with the prior approval of the shareholders meeting
(which approval shall not be unreasonably withheld), have the right to complete such transactions to which the board of
managers has already been committed.
If a business plan for any calendar year has not been approved by January 1st of that year, the Company shall continue
to operate under the business plan for the previous year until a new business plan is approved by the shareholders meeting,
with such adjustments to the operating budget contained therein as may be necessary to reflect approved contracts or
leases, deletion of non recurring expense items set forth on the previous operating budget and increased insurance costs,
taxes, utility costs, and debt service payments.
The Company shall operate under annual operating budgets which shall be prepared and submitted by the board of
managers to the shareholders meeting for approval. The board of managers shall implement each operating budget on
behalf of the Company and may incur the expenditures and obligations therein provided.
The board of managers shall submit to the shareholders meeting, within fifteen (15) days after the end of each month,
a monthly update of the then-applicable operating budget and the business plan, so as to inform the shareholders meeting
of:
(1) any variances from the operating budget or the business plan, including (A) cost overruns in any line item in the
operating budget to date, or any unforeseen costs or expenses which may have arisen and which, when added to all other
costs and expenses, will cause the operating budget total (or any operating budget category or line item) to be exceeded
or, otherwise cause budgeted results to differ from actual results and (B) any cost savings in any operating budget line
item or budget category realized to date;
(2) all expenditures under any contingency amounts in the operating budget showing the amount and operating budget
line item to which said expenditure was made, and all applications to date of cost offsets showing the amount and operating
budget line item to which such application was made;
(3) all cost overrun payments made to date, showing the amount and operating budget line item to which such cost
overrun payment was applied; and
(4) any variances from the operating budget or the business plan.
The board of managers shall submit to the shareholders any reports and budgets received under any hotel management
agreement which may be entered into by the Company (the "Hotel Management Agreement") and may refer to these
reports and budgets. In case of disputes on reports and budgets to be provided under the Hotel Management Agreement,
the board of managers shall inform the shareholders thereof without delay."
Thus, after the insertion of a new article 15, the former article 15 becomes the new article 16, the former article 16
becomes the new article 17 and the former article 17 becomes the new article 18.
96610
<i>Eleventh resolutioni>
The General Meeting resolved to insert a new article 19 (new numbering) in the articles of association of the Company,
which shall have the following wording:
"The general meeting of shareholders shall not validly deliberate unless the entire share capital of the Company is
represented. If this condition is not satisfied, the shareholder(s) present may not pass any resolutions other than ad-
journing such meeting to the same time of the day and place on a date as determined by the shareholder(s) present, which
date shall be at least five days following the date of the adjourned meeting.
Notice of such adjournment and the reconvened meeting date, time and place shall be sent to the shareholders within
five days of such adjournment.
The reconvened meeting shall not validly deliberate unless at least half of the share capital of the Company is repre-
sented."
<i>Twelfth resolutioni>
The General Meeting resolved to add the following sentence to article 20 (new numbering) of the articles of association
of the Company:
"Resolutions for the issuance of shares by the Company and decisions on the acquisition of investments require
unanimous consent of the general meeting of shareholders provided that no consent of a shareholder who failed to make
the capital contribution required by the Company is required for the issuance of shares."
<i>Thirteenth resolutioni>
The General Meeting resolved to insert a new article 21 (new numbering) in the articles of association of the Company
which shall have the following wording:
"No action shall be taken, sum expended, or obligation incurred by any manager regarding the matters described below
unless such specific action or expenditure is included in a business plan or operating budget approved by the shareholders
meeting or otherwise has been approved or proposed by the shareholders meeting:
(i) the acquisition, sale, transfer, exchange, mortgage, financing, hypothecation or encumbrance of all or any part of a
Property;
(ii) the determination of the terms and conditions of all Company borrowings and the identity of the lender thereof,
any determination to amend any approved loan documents, and the granting of any guaranties or indemnities by the
Company;
(iii) the approval of each business plan and operating budget, and any amendments thereto;
(iv) establishing any capital or operating reserves of the Company, other than as set forth in the then-current operating
budget;
(v) the making of any expenditure or incurrence of any obligation by or for the Company in excess of 110% of the
applicable line item in the then-current operating budget; however, if emergency repairs to a Property are necessary to
avoid imminent danger of injury to a Property or to an individual, the board of managers may make such expenditures
as may be necessary to alleviate such situation and shall promptly notify the shareholders meeting of the event giving rise
to such repairs and the actions taken with respect thereto;
(vi) the making of any distributions to shareholders or of any payments under shareholder loans;
(vii) the approval of any lease (or amendment or extension of any existing lease) demising more than 500 net rentable
square meters of space in any Property or providing for annual rental income in excess of thirty thousand Euro (EUR
30,000.-) or the termination or acceptance of cancellation or surrender of any lease other than in accordance with the
terms of the lease or the forgiveness or release of any lease covenant or requirement;
(viii) the approval of any third party agreements not included in the business plan or operating budget providing for
annual payment in excess of ten thousand Euro (EUR 10,000.-) in the aggregate;
(ix) material pricing decisions regarding the Properties;
(x) the determination of accounting policies, including selection of depreciation schedules, accounting methods and
making various decisions regarding treatment and allocation of transactions for income tax, franchise or other tax pur-
poses;
(xi) the selection of banks for deposit of Company funds, and the designation of persons with signatory authority over
withdrawal of such funds;
(xii) the taking of any legal action and any determination to settle any legal action involving in excess of one hundred
thousand Euro (EUR 100,000);
(xiii) the selection of attorneys, accountants, engineers, environmental consultants, or other professionals for the
Properties or the Company;
(xiv) the disclosure of confidential information and the issuance of any press release regarding the activities of the
Company and its Subsidiaries or an Holdco;
(xv) moving the administration of the Company outside the Grand Duchy of Luxembourg;
96611
(xvi) any change in the business of the Company which takes the focus of the Company's business away from the
corporate purpose specified in the articles of association of the Company;
(xvii) any agreement entered into with, any elections, consents, acknowledgments and waiver of rights given towards,
or any business passed with, (i) the shareholders holding the shares of Class B or Art Management S.à r.l., (ii) any other
person who controls, is controlled by or is under common control with such person, (iii) any manager, director, officer,
partner or employee of such person or any person specified in clause (i) or (ii) above or (iv) any immediate family member
of any person specified in clause (i), (ii) or (iii) above;
(xviii) the exercise of shareholder rights of the Company when possible in the Subsidiaries, including shareholder
approvals, insofar as they are of the same or similar importance to the Subsidiaries as any of the matters referred to
under items (i) through (xvi) with respect to the Company."
As a result of the insertion of a new article 19 and a new article 21, the former article 19 becomes the new article 22,
the former article 20 becomes the new article 23, the former article 21 becomes the new article 24, the former article
22 becomes the new article 25 and the former article 23 becomes the new article 26.
<i>Fourteenth resolutioni>
The General Meeting resolved to amend article 26 (new numbering) of the articles of association of the Company,
which shall henceforth have the following wording:
"Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders subject to the
provisions of a shareholder agreement and the following provisions:
In case of a disposal, i.e. a sale, in a single transaction or multiple transactions, to one or more third party purchasers
for cash of (i) the entirety of the Properties or any of them, (ii) a controlling interest in the Company's Subsidiaries or in
a HoldCo or any of them (iii) following the sale of a controlling interest under (ii) hereof (but not all of the shares in the
Company's Subsidiaries or in a HoldCo or any of them) the sale of further shares in the Company's Subsidiaries or any
of them, provided, that (x) for avoidance of doubt, if the Properties or the controlling interest in the Company's Subsi-
diaries or in a HoldCo is sold to more than one third party purchaser or in more than one transaction, the disposal means
the collective reference to all such sales and shall be deemed to occur on the last of such sales, and (y) a controlling
interest in the Company's Subsidiaries shall mean ownership, directly or indirectly, of more than fifty per cent (50%) of
the share capital of such companies, the shares of Class B are entitled to a preference dividend as follows:
(i) First, one hundred per cent (100%) of the proceeds, as defined in the Shareholders Agreement, to the shareholders
until the aggregate amount of the proceeds received by the shareholders is equal to the aggregate capital contributions
and shareholders loans made by the shareholders;
(ii) Second, one hundred per cent (100%) of the proceeds to the shareholders until such time as the shareholders
holding the shares of Class A have received a twenty per cent (20%) internal rate of return, as defined in the Shareholders
Agreement;
(iii) Third, eighty-five per cent (85%) of the proceeds to the shareholders and fifteen per cent (15%) to the shareholders
holding the shares of Class B until such time as the shareholders holding the shares of Class A have received a twenty-
five per cent (25%) internal rate of return;
(iv) Fourth, eighty per cent (80%) of the proceeds to the shareholders and twenty per cent (20%) to the shareholders
holding the shares of Class B until such time as the shareholders holding the shares of Class A have received a thirty per
cent (30%) internal rate of return; and
(v) Thereafter, seventy-five per cent (75%) of the proceeds to the shareholders and twenty-five per cent (25%) to the
shareholders holding the shares of Class B;
provided, that, for avoidance of doubt, the foregoing provision shall only be applicable for the purposes of calculating
the preference dividend and no shareholder or other person shall have any rights as a result of the foregoing provision.
As a result of a sale of the entirety of the Properties and in the event that the preference dividend is higher than the
amount available for distribution under applicable laws, the Company will distribute to the shareholders holding the shares
of Class B that portion of the preference dividend that may be distributed under applicable laws and the balance of the
preference dividend will be distributed upon the earlier of (i) the next date of the completion of a disposal, whereupon
the balance of such preference dividend shall first be distributed to the shareholders holding the shares of Class B prior
to making any distributions of any additional preference dividend due to the shareholders holding the shares of Class B
on such date and (ii) the liquidation of the Company.
The shareholders holding the shares of Class A may by written notice to the shareholders holding the shares of Class
B terminate such shareholders' entitlement to the preference dividend upon (1) the occurrence of any event set forth in
clause 10.2 (c)(i),(iii) and (iv) of the Hotel Management Agreement, (2) any material breach by the shareholders holding
the shares of Class B of their obligations under Article VIII of the Shareholders Agreement, (3) a change in majority
beneficial ownership and controlling interest in the shareholders holding the shares of Class B or the manager under the
Hotel Management Agreement, and, if capable of remedy, the shareholders holding the shares of Class B or any of their
affiliates have failed, within fifteen (15) business days of the date of a written notice served by the shareholders holding
the shares of Class A on the shareholders holding the shares of Class B confirming that the shareholders holding the
96612
shares of Class B or their affiliates have breached materially the Shareholders Agreement and requiring remedial action,
to so remedy such breach. Upon service of such written notice the shareholders holding the shares of Class B's entitlement
to the preference dividend shall immediately terminate and neither the Company nor the shareholders holding the shares
of Class A shall have any further obligations in this respect.
For the purpose of articles 21 and 26 (new numbering)
"HoldCo means any direct of indirect subsidiary of the Company other than the Subsidiaries"
<i>Fifteenth resolutioni>
The General Meeting resolved to insert a new article 27 (new numbering) in the articles of association of the Company
which shall have the following wording:
"Interim dividends may be paid subject to the following terms and conditions:
(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the general meeting
of the shareholders;
(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the management of interim
accounts showing that sufficient profits are available for such distribution;
(iii) the preference dividend to which the shares of Class B are entitled has to be respected;
(iv) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the shareholders.
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the shareholders according to the annual general
meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the shareholders.
The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of shareholders to distribute at any
moment to the shareholders any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts."
As a result of the insertion of a new article 27, the former article 24, becomes the new article 28 and the former
article 25 becomes the new article 29.
<i>Sixteenth resolutioni>
The General Meeting resolved to change the second paragraph of new article 28 as follows:
"Unless the shareholders unanimously decide otherwise, the surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed
among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them subject to the provisions of the
Shareholders Agreement and the following provisions: the shares of Class B are entitled to a preference liquidation
dividend under the same terms and conditions than the preference dividend as organized in article 26."
<i>Seventeenth resolutioni>
The General Meeting resolved to change the new article 29 as follows:
"All matters not governed by these articles of incorporation and the terms and conditions of any shareholders agree-
ment that may have been entered into between shareholders shall be determined in accordance with the law of 10 August
1915 regarding commercial companies, as amended.
In case of divergence between these articles of incorporation and the Shareholders Agreement, the Shareholders
Agreement shall be prevailing among the shareholders of the Company."
<i>Eighteenth resolutioni>
The General Meeting resolved to accept the resignation of BRE/Management S.A. from its duties as sole manager of
the Company with immediate effect:
The General Meeting resolved to grant full discharge to BRE/Management S.A. for the exercise of its mandate.
<i>Nineteenth resolutioni>
The General Meeting resolved to fix the number of managers at four.
<i>Twentieth resolutioni>
The General Meeting resolved to appoint with immediate effect for an indefinite period as new managers:
- Mr Anders Braks, jurist, born on 21 September 1959 in Landskrona (Sweden), residing at 41, Am Botanischen Garten,
50668 Köln, (Germany),
- Mr Robert Simon, director, born on 20 February 1929, in Wiesbaden (Germany) and residing at 28, rue JP Brasseur,
L-1258 Luxembourg,
- Mrs Cornelia M.W. van den Broek, director, born on 26 June 1968 in Oosterhout (the Netherlands), residing pro-
fessionally at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
- Mr Gary Sumers, managing director, born on 12 December 1952 in New York, United States of America, residing
at 888 Park Avenue, Apt. 11#, New York, NY 10021, United States of America.
96613
With no outstanding points on the agenda the chairman brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendneun, den dritten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
BRE/Europe 3-P S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 129751, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500,
hier vertreten durch Frau Patricia Sondhi, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, durch privatschriftliche Vollmacht, erteilt
am 24. August 2009, die nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegen-
wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben registriert zu werden,
Art Hotel Holding S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach dem Recht des Groß-
herzogtums Luxemburg, mit Sitz in 18-24, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 115744, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500,
hier vertreten durch Frau Patricia Sondhi, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, durch privatschriftliche Vollmacht, erteilt
am 24. August 2009, die nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegen-
wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben registriert zu werden.
Die erschienenen Parteien sind die Gesellschafter der Gesellschaft und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital (die
„Gesellschafter") von BRE/French Hotel Holding I S.à r.l., einer société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, gegründet am 17.
Oktober 2006 gemäß einer Urkunde des unterzeichneten Notars, die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 2364 vom 19. Dezember 2006 veröffentlicht wurde, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg unter der Nummer B121165 (die „Gesellschaft") und ersuchen den unterzeichneten Notar Folgendes zu
beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung des Gesellschaftszweckes und des Artikels 2 der Gesellschaftssatzung, der von nun an wie folgt lauten
soll:
„Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erneuerung, der Betrieb und der Verkauf des Abeau I ere Classe,
Amiens Kyriad, Bourges Mr Bed, Bron Kyriad, Cachan Mr Bed City, Cergy I ere Classe, Chilly Mr Bed City, Coigniéres
Mr Bed, Coquelles Kyriad, Exupéry Kyriad, Fresnes Campanile, Goussainville Mr Bed City, Henin Campanile, Herblain I
ere Classe, Igny Mr Bed City, Ivry Kyriad, Lomme K Kyriad, Lomme NH Nuit d'Hotel, Longvic Kyriad, Longwy Mr Bed,
Ludres I ere Classe, Mans MB Mr Bed, Mans PC I ere Classe, Marseille I ere Classe, Massieux I ere Classe, Massy Comfort
Inn, Meaux Comfort Inn, Metz Nuit d'Hotel, Meylan Kyriad, Montluçon Kyriad, Nancy C Campanile, Nemours Mr Bed,
Nice Comfort Inn, Olivet Nuit d'Hotel, Quimper Nuit d'Hotel, Ramonville Comfort Inn, Rochelle I ere Classe, Rouen
Comfort Inn, Rousse Kyriad, Rungis Kyriad, Rungis Business Kyriad, Saran K Kyriad, Saran NH Nuit d'Hotel, Strasbourg
Mr Bed, Toulouse Kyriad, Tours Mr Bed, Valence Nuit d'Hotel und Vlg Kyriad (jede einzelne eine „Immobilie" und alle
zusammen die "Immobilien").
Der Zweck der Gesellschaft ist zudem das direkte oder indirekte Halten von Beteiligungen jeglicher Art, in Société
Civile Les Crêtes, Tenotel SAS, Amiens Hotel Sàrl, Sàrl HMB Bourges, Climinvest Sàrl, MB Cachan SNC, Cergy Hotel
Sàrl, SHVLG Sàrl, Sàrl HMBCL, Calais Hotel Sàrl, Sopaclif 1 SA, Fresnotel Sàrl, SNC MBC Goussainville, Société Civile
BSF, MB Igny Hotel Sàrl, Soprohest SAS, FIH SAS, HMB LST Sàrl, Mans Hotel Sàrl, Société Civile Balafon, Massy City Sàrl,
Klemeaux Sàrl, SNC Nemours, MBC Nice Sàrl, Société Civile Tolosane, Rouen Hotel Sàrl, Rungis Hotel SAS, SCI Tou-
louse-Bermudes, und in den französischen SAS Gesellschaften BRE/Opera SAS, BRE/Bertin SAS und BRE/Sidhole SAS
(jede einzelne eine „Filiale" und alle zusammen die "Filialen"), der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise,
die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren jeglicher Art sowie die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung der oben genannten Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann zudem den oben genannten Gesellschaften sowie ihren direkten und indirekten Filialen Bürg-
schaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
96614
Die Gesellschaft wird insbesondere die oben genannten Gesellschaften sowie ihre direkten und indirekten Filialen mit
den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung versorgen. Zu diesem Zweck
kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen."
2. Einführung von zwei Anteilsklassen und Ersetzen der bestehenden 500 Anteile der Gesellschaft durch 450 Anteile
der Klasse A und 50 Anteile der Klasse B;
3. Abänderung von Artikel 9, Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung;
4. Abänderung von Artikel 12 der Gesellschaftssatzung;
5. Abänderung von Artikel 13 Paragraph 1, Satz 1 der Gesellschaftssatzung;
6. Abänderung von Artikel 13, Paragraph 7 der Gesellschaftssatzung;
7. Abänderung von Artikel 13, Paragraph 8 der Gesellschaftssatzung;
8. Abänderung von Artikel 13, Paragraph 9 der Gesellschaftssatzung;
9. Abänderung von Artikel 14 der Gesellschaftssatzung;
10. Einfügung eines neuen Artikels 15 in die Gesellschaftssatzung;
11. Einfügung eines neuen Artikels 19 in die Gesellschaftssatzung;
12. Einfügung eines neuen Satzes in Artikel 20 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung;
13. Einfügung eines neuen Artikels 21 in die Gesellschaftssatzung für die Festlegung der Gesellschafter vorbehaltenen
Angelegenheiten;
14. Abänderung von Artikel 26 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung für die Schaffung einer Vorzugsdivi-
dende;
15. Einfügung eines neuen Artikels 27 in die Gesellschaftssatzung für die Einführung der Möglichkeit Abschlagsdivid-
enden auszuzahlen;
16. Abänderung des Artikels 28 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung für die Schaffung einer Vorzugsdivi-
dende im Falle der Liquidation;
17. Abänderung von Artikel 29 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung;
18. Abberufung und volle Entlastung des alleinigen Geschäftsführers, BRE/Management S.A.;
19. Festlegung der Anzahl der Geschäftsführer auf vier;
20. Ernennung neuer Geschäftsführer;
21. Verschiedenes.
II. Dass das gesamte Gesellschaftskapital bei der vorliegenden Versammlung vertreten ist und die vertretenen Gesell-
schafter erklären, dass sie vor der Versammlung über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt wurden, so dass keine
Einberufungsschreiben notwendig waren.
Die Hauptversammlung (die „Hauptversammlung") fasst im Anschluss folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den Artikel 2 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun an wie folgt lauten
wird:
„Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erneuerung, der Betrieb und der Verkauf des Abeau I ere Classe,
Amiens Kyriad, Bourges Mr Bed, Bron Kyriad, Cachan Mr Bed City, Cergy I ere Classe, Chilly Mr Bed City, Coigniéres
Mr Bed, Coquelles Kyriad, Exupéry Kyriad, Fresnes Campanile, Goussainville Mr Bed City, Henin Campanile, Herblain I
ere Classe, Igny Mr Bed City, Ivry Kyriad, Lomme K Kyriad, Lomme NH Nuit d'Hotel, Longvic Kyriad, Longwy Mr Bed,
Ludres I ere Classe, Mans MB Mr Bed, Mans PC I ere Classe, Marseille I ere Classe, Massieux I ere Classe, Massy Comfort
Inn, Meaux Comfort Inn, Metz Nuit d'Hotel, Meylan Kyriad, Montluçon Kyriad, Nancy C Campanile, Nemours Mr Bed,
Nice Comfort Inn, Olivet Nuit d'Hotel, Quimper Nuit d'Hotel, Ramonville Comfort Inn, Rochelle I ere Classe, Rouen
Comfort Inn, Rousse Kyriad, Rungis Kyriad, Rungis Business Kyriad, Saran K Kyriad, Saran NH Nuit d'Hotel, Strasbourg
Mr Bed, Toulouse Kyriad, Tours Mr Bed, Valence Nuit d'Hotel, Vlg Kyriad (jede einzelne eine „Immobilie" und alle
zusammen die "Immobilien").
Der Zweck der Gesellschaft ist zudem das direkte oder indirekte Halten von Beteiligungen jeglicher Art, in Société
Civile Les Crêtes, Tenotel SAS, Amiens Hotel Sàrl, Sàrl HMB Bourges, Climinvest Sàrl, MB Cachan SNC, Cergy Hotel
Sàrl, SHVLG Sàrl, Sàrl HMBCL, Calais Hotel Sàrl, Sopaclif 1 SA, Fresnotel Sàrl, SNC MBC Goussainville, BSF (Bertin
Services France), MB Igny Hotel Sàrl, Soprohest SAS, FIH SAS, HMB LST Sàrl, Mans Hotel Sàrl, Société Civile Balafon,
Massy City Sàrl, Klemeaux Sàrl, SNC Nemours, MBC Nice Sàrl, Société Civile Tolosane, Rouen Hotel Sàrl, Rungis Hotel
SAS, SCI Toulouse-Bermudes, und in den französischen SAS Gesellschaften BRE/Opera SAS, BRE/Bertin SAS und BRE/
Sidhole SAS (jede einzelne eine „Filiale" und alle zusammen die "Filialen"), der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren jeglicher Art sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung der oben genannten Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann zudem den oben genannten Gesellschaften sowie ihren direkten und indirekten Filialen Bürg-
schaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.
96615
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die oben genannten Gesellschaften sowie ihre direkten und indirekten Filialen mit
den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung versorgen. Zu diesem Zweck
kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen."
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, zwei Anteilsklassen einzuführen und die bestehenden fünfhundert (500) Anteile
mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) in vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A mit einem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) und in fünfzig (50) Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig Euro (EUR 25) umzuwandeln.
Die Anteile der Klasse A und die Anteile der Klasse B haben die gleichen Rechte und Pflichten, es sei denn die vor-
liegende Satzung sehe etwas anderes vor.
Die Hauptversammlung hält fest, dass die vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A und die fünfzig (50) Anteile
der Klasse B wie folgt gehalten werden:
- vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A werden von BRE/Europe 3-P S.ä r.l. gehalten; und
- fünfzig (50) Anteile der Klasse B werden von Art Hotel Holding S.ä r.l. gehalten.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den ersten Absatz des Artikels 9 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun
an wie folgt lauten soll:
„Die Anteile der Gesellschaft können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Zuweisung, der Ver-
kauf, der Tausch, die Übertragung, die Verpfändung sowie jegliche andere Art der Veräußerung, sei es auf direkte oder
indirekte Art und Weise, aller oder eines Teils der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedürfen der vorherigen
Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Eine solche Übertragung kann lediglich
an einen Erwerber erfolgen, der vor der Übertragung sein schriftliches Einverständnis zu den Bestimmungen eines jeglichen
Gesellschaftervertrags, der möglicherweise zwischen den Gesellschaftern abgeschlossen wurde (der „Gesellschafterver-
trag"), gegeben hat."
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den Artikel 12 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun an wie folgt lauten
soll:
„Die Gesellschaft wird von mindestens drei Geschäftsführern verwaltet.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, welche die Dauer ihres Mandates
bestimmt. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihrem Amt entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
pflichtet.
Der Geschäftsführerrat kann Sondervollmachten durch notariell beglaubigte oder privatschriftliche Urkunde erteilen."
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den ersten Satz des ersten Absatzes von Artikel 13 der Gesellschaftssatzung ab-
zuändern, der von nun an wie folgt lauten soll:
„Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen
stellvertretenden Vorsitzenden."
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den folgenden Satz in dem siebten Absatz des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung
hinzuzufügen:
„Falls ein Geschäftsführer nicht an einer Versammlung oder an einer Beschlussfassung des Geschäftsführerrates teil-
nehmen kann, kann dieser verlangen, dass erneut in seiner Anwesenheit über diese Angelegenheit diskutiert und
abgestimmt wird."
<i>Siebter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den folgenden Satz in dem achten Absatz des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung
hinzuzufügen:
„Es können keine Beschlüsse gefasst werden bezüglich Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich eines abwe-
senden Geschäftsführers fallen, es sei denn ein solcher Beschluss wäre notwendig, um negative Auswirkungen auf die
Gesellschaft zu vermeiden."
96616
<i>Achter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den neunten Absatz des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der nun
wie folgt lauten soll:
„Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Jegliche Beschlüsse, die nicht einstimmig gefasst wurden, werden
unverzüglich der Gesellschafterversammlung vorgelegt, die einen Beschluss bezüglich der jeweiligen Angelegenheit mit
einer Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile fasst."
<i>Neunter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den folgenden Satz in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung hinzuzufügen:
„Alle Geschäftsführer erhalten Kopien der Protokolle."
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt einen neuen Artikel 15 in die Gesellschaftssatzung einzufügen, der wie folgt lauten
soll:
„Der Geschäftsführerrat ist verpflichtet, der Hauptversammlung der Gesellschafter regelmäßig über die Führung der
Geschäfte und jegliche andere Angelegenheiten, die von der Hauptversammlung der Gesellschafter angefragt werden,
Bericht zu erstatten.
Der Geschäftsführerrat bereitet am oder vor dem 15. November eines jeden Jahres einen Entwurf des Geschäftsplans
für das folgende Kalenderjahr vor, den er der Hauptversammlung der Gesellschafter vorlegt. Der Geschäftsplan sollte
unter anderem jeden der folgenden Punkte und in Bezug auf diese Punkte die aktuellsten Informationen, insofern verfügbar,
umfassen: (i) eine umfassende Studie des Marktes, auf dem die Immobilien tätig sind, (ii) eine ausführliche Beschreibung
der Renovierung, Modernisierung, Wartung, Reparaturen und Verwaltung der Immobilien, einschließlich aber nicht aus-
schließlich jeglicher geplanter oder erforderlicher Umänderungen der Immobilien, (iii) eine vorläufige Einnahmen- und
Ausgabenrechnung für die Immobilien für die voraussichtliche Zeit des Besitzes durch die Gesellschaft, jedoch nicht
weniger als fünf Jahre, (iv) ein ausführliches Betriebsbudget, wie es im Gesellschaftervertrag definiert ist, und (v) einen
ausführlichen Marketingbericht.
Spätestens zwanzig (20) Tage nach Erhalt des Entwurfs des Geschäftsplans durch die Hauptversammlung der Gesell-
schafter (oder nach einem längeren Zeitraum, der von einem Gesellschafter durch Mitteilung an den Geschäftsführerrat
nach vernünftigem Ermessen beantragt wird) können die Inhaber der Anteile der Klasse A dem Geschäftsführerrat eine
Mitteilung zukommen lassen, in der der jeweilige Gesellschafter erklärt, dass er mit den in dem Geschäftsplan enthaltenen
Informationen beziehungsweise mit den Informationen, die nicht in dem Geschäftsplan enthalten sind, nicht einverstanden
ist, und in der er den Grund für seinen Einwand angibt. Nach Erhalt einer solchen Mitteilung ändert der Geschäftsführerrat
innerhalb von fünf (5) Tagen den Entwurf des Geschäftsplans ab und legt ihn erneut der Hauptversammlung der Gesell-
schafter zur Genehmigung vor. Innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt des neuen Entwurfes des Geschäftsplans haben
die Inhaber der Anteile der Klasse A die Möglichkeit eine weitere Einwandserklärung einzureichen (in diesem Fall wie-
derholen sich die Vorgänge der Unterbreitung und Überprüfung solange bis der Geschäftsplan von der Hauptversammlung
der Gesellschafter genehmigt wird). Ungeachtet jeglicher anderslautender Bestimmungen in der vorliegenden Satzung hat
die Hauptversammlung der Gesellschafter das Recht zu jedem Zeitpunkt nach der Genehmigung eines Geschäftsplanes,
durch Mitteilung an den Geschäftsführerrat, den Geschäftsplan zu überarbeiten oder den Geschäftsführerrat zu bitten,
einen überarbeiteten Geschäftsplan vorzubereiten und ihr diesen zur Genehmigung vorzulegen, unter Berücksichtigung
solcher Umstände, die die Hauptversammlung der Gesellschafter für angemessen hält, jedoch unter der Voraussetzung,
dass die Überarbeitung des Geschäftsplans nicht als eine Aufhebung der Befugnisse des Geschäftsführerrates im Hinblick
auf Maßnahmen, die der Geschäftsführerrat bereits vor einer solchen Überarbeitung zur Umsetzung des Geschäftsplans
ergriffen hat, betrachtet wird und dass der Geschäftsführerrat befugt ist, mit der vorherigen Zustimmung der Hauptver-
sammlung der Gesellschafter (die nicht ohne angemessenen Grund verweigert werden darf), die Transaktionen, für deren
Durchführung der Geschäftsführerrat sich bereits verpflichtet hat, zu vollenden.
Falls ein Geschäftsplan für ein Kalenderjahr am 1. Januar des jeweiligen Jahres noch nicht genehmigt wurde, handelt
die Gesellschaft weiterhin unter dem Geschäftsplan des vorhergehenden Jahres bis ein neuer Geschäftsplan von der
Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt wurde, mit den darin enthaltenen Anpassungen des Betriebsbudgets,
die notwendig sind, um die genehmigten Abkommen oder Mietverträge, die Streichung der nicht wiederkehrenden Aus-
gabenposten, die in dem vorherigen Betriebsbudget enthalten waren, sowie erhöhte Versicherungskosten, Steuern,
Nutzungskosten und Schuldendienstkosten widerzuspiegeln.
Die Gesellschaft handelt gemäß jährlichen Betriebsbudgets, die von dem Geschäftsführerrat vorbereitet werden und
der Hauptversammlung der Gesellschafter zur Genehmigung vorgelegt werden. Der Geschäftsführerrat setzt jedes Be-
triebsbudget im Namen der Gesellschaft um und kann in diesem Zusammenhang Auslagen machen und Verpflichtungen
eingehen.
Der Geschäftsführerrat legt der Hauptversammlung der Gesellschafter innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Ende
eines jeden Monats eine monatliche Aktualisierung des jeweils zutreffenden Betriebsbudgets und Geschäftsplans vor, um
die Hauptversammlung der Gesellschafter über Folgendes zu informieren:
96617
(1) jegliche Abweichungen von dem Betriebsbudget oder dem Geschäftsplan, einschließlich (A) der Kostenüberschrei-
tungen in Bezug auf jegliche Einzelposten in dem jeweils aktuellen Betriebsbudget oder jeglicher unvorhergesehener
Unkosten oder Ausgaben, die entstanden sind und die, wenn sie zu allen anderen Kosten und Ausgaben hinzugefügt
werden, dazu führen, dass der Gesamtbetrag des Betriebsbudgets (oder einer Kategorie des Betriebsbudgets oder eines
Einzelpostens) überschritten wird oder dazu führen, dass die im Budget vorgesehenen Resultate nicht mit den wirklichen
Resultaten übereinstimmen und (B) jeglicher Kosteneinsparungen in jeglichem Einzelposten des Budgets oder jeglicher
Budgetkategorie, die bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt erzielt wurden,
(2) jegliche Ausgaben unvorhergesehener Beträge in dem Betriebsbudget, unter Angabe des Betrages und des Einzel-
postens des Betriebsbudgets, dem die Ausgaben zugeordnet wurden, und jeglichen Kostenausgleich unter Angabe des
Betrages und des Einzelpostens des Betriebsbudgets, dem der Ausgleich zugeordnet wurde;
(3) jegliche Mehrkostenzahlungen, die bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorgenommen wurden, unter Angabe des Be-
trages und des Einzelpostens des Betriebsbudgets, auf die sich die Mehrkostenzahlung bezieht; und
(4) jegliche Abweichungen von dem Betriebsbudget oder Geschäftsplan.
Der Geschäftsführerrat legt den Gesellschaftern jegliche Berichte und Budgets vor, die er im Rahmen eines jeglichen
Hotelführungsvertrags, den die Gesellschaft abschließt (der „Hotelführungsvertrag"), erhält, und kann auf diese Berichte
und Budgets verweisen. Im Falle von Streitigkeiten bezüglich der Berichte oder Budgets, die im Rahmen des Hotelfüh-
rungsvertrags vorzulegen sind, informiert der Geschäftsführerrat die Gesellschafter unverzüglich darüber."
Demnach, wird nach der Einfügung eines neuen Artikels 15, der frühere Artikel 15 zum neuen Artikel 16, der frühere
Artikel 16 zum neuen Artikel 17 und der frühere Artikel 17 zum neuen Artikel 18.
<i>Elfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, einen neuen Artikel 19 (neue Nummerierung) in die Gesellschaftssatzung einzufü-
gen, der wie folgt lauten soll:
„Die Hauptversammlung der Gesellschafter ist nur beschlussfähig, wenn das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist.
Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dürfen die anwesenden Gesellschafter keine anderen Beschlüsse fassen als den
Beschluss, die Hauptversammlung auf ein anderes Datum zu verlegen, das von den anwesenden Gesellschaftern festgelegt
wird, aber mindestens fünf (5) Tage nach dem Datum der vertagten Versammlung sein muss. Die neu einberufene Ver-
sammlung muss an dem gleichen Ort und zu der gleichen Tageszeit wie die ursprüngliche Versammlung stattfinden.
Die Mitteilungen einer solchen Vertagung sowie das Datum, der Zeitpunkt und der Ort, an dem die Versammlung
stattfinden soll, werden den Gesellschaftern innerhalb von fünf Tagen ab dem Beschluss der Vertagung zugeschickt.
Die neu einberufene Versammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten ist."
<i>Zwölfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, folgenden Satz in den Artikel 20 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung
einzufügen:
„Beschlüsse in Bezug auf die Ausgabe von Anteilen durch die Gesellschaft und Entscheidungen über den Erwerb von
Beteiligungen erfordern die einstimmige Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, vorausgesetzt, dass kei-
ne Zustimmung eines Gesellschafters, der es unterließ, die von der Gesellschaft erforderte Kapitaleinlage zu machen, für
die Ausgabe von Anteilen notwendig ist."
<i>Dreizehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, einen neuen Artikel 21 (neue Nummerierung) in die Gesellschaftssatzung einzufü-
gen, der wie folgt lauten soll:
„Die Geschäftsführer ergreifen keine Maßnahmen, machen keine Auslagen und gehen keine Verpflichtungen ein in
Bezug auf die unten stehenden Angelegenheiten, es sei denn diese spezifischen Maßnahmen oder Ausgaben sind in einem
Geschäftsplan oder Betriebsbudget enthalten, die von der Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt werden oder
anderweitig von der Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt oder vorgeschlagen wurden:
(i) der Erwerb, der Verkauf, die Übertragung, der Tausch, die Verpfändung, die Finanzierung, die Beleihung oder
Belastung der gesamten oder eines Teils einer Immobilie;
(ii) die Festlegung der Bedingungen für alle Gesellschaftsanleihen und Bestimmung der Identität des Kreditgebers,
jeglicher Beschluss genehmigte Kreditdokumente abzuändern sowie die Gewährung von Garantien oder Entschädigungen
durch die Gesellschaft;
(iii) die Genehmigung eines jeden Geschäftsplans und Betriebsbudgets sowie jegliche Änderungen dieser Dokumente;
(iv) Gründung von Kapitalreserven oder Betriebsreserven der Gesellschaft, die nicht in dem jeweils aktuellen Be-
triebsbudget vorgesehen sind;
(v) die Verursachung von Kosten oder die Übernahme von Verpflichtungen durch oder für die Gesellschaft, die 110%
des anwendbaren Einzelpostens in dem jeweils aktuellen Betriebsbudget überschreiten; wenn allerdings dringende Re-
paraturen an einer Immobilie notwendig sind, um eine drohende Gefahr der Beschädigung einer Immobilie oder
96618
Verletzungsgefahren für Personen zu vermeiden, kann der Geschäftsführerrat solche Ausgaben machen, die notwendig
sind, um die Situation zu verbessern, wobei der Geschäftsführerrat unverzüglich die Hauptversammlung der Gesellschafter
über den Vorfall, der solche Reparaturarbeiten und die getroffenen Maßnahmen verursacht hat, informiert;
(vi) jegliche Auszahlungen an die Gesellschafter oder jegliche Zahlungen im Rahmen von Gesellschafterkrediten;
(vii) die Genehmigung von Mietverträgen (oder Änderungen oder Erweiterungen von bestehenden Mietverträgen)
gemäß derer mehr als 500 m2 Mietfläche einer Immobilie vermietet werden oder die jährliche Mieteinnahmen von über
dreißigtausend Euro (EUR 30.000) umfassen, sowie die Beendigung oder Zustimmung zur Annullierung oder Abtretung
eines Mietvertrags, die nicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Mietvertrags erfolgen, oder der Nachlass
oder die Freigabe eines Mietabkommens oder einer Forderung;
(viii) die Genehmigung jeglicher Verträge mit Drittparteien, die nicht in dem Geschäftsplan oder Betriebsbudget ent-
halten sind und jährliche Zahlungen von insgesamt mehr als zehntausend Euro (EUR 10.000) umfassen;
(ix) Entscheidungen bezüglich wichtiger Preiskalkulationen für die Immobilien;
(x) die Festlegung der Bilanzierungsregeln einschließlich der Auswahl von Abschreibungstabellen, Buchhaltungsverfah-
ren und des Treffens von unterschiedlichen Entscheidungen in Bezug auf die Handhabung und die Zuteilung von
Transaktionen für Einkommensteuer, Lizenzgebühren oder andere Steuerzwecke;
(xi) die Auswahl von Banken für die Einzahlung des Gesellschaftsvermögens und Bestimmung der Personen, die be-
vollmächtigt sind, dieses Vermögen abzuheben;
(xii) das Ergreifen gerichtlicher Maßnahmen und die Entscheidung ein Gerichtsverfahren, das Kosten in Höhe von mehr
als einhunderttausend Euro (EUR 100.000) mit sich bringt, einzuleiten;
(xiii) die Auswahl von Anwälten, Buchhaltern, Ingenieuren, Umweltberatern und anderen Fachleuten für die Immobilien
oder die Gesellschaft;
(xiv) die Bekanntmachung von vertraulichen Informationen und die Herausgabe einer Pressemitteilung in Bezug auf die
Tätigkeiten der Gesellschaft und ihrer Filialen oder einer Holdco;
(xv) die Verlegung der Verwaltung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg;
(xvi) jegliche Änderung des Geschäftsbereiches der Gesellschaft, die das Hauptaugenmerk der Tätigkeiten der Gesell-
schaft weg von dem in der Satzung der Gesellschaft genannten Gesellschaftszweck richtet;
(xvii) jeglicher Vertrag mit, jegliche Wahl, Genehmigung, Vereinbarung und jeglicher Verzicht auf Rechte zu Gunsten
von oder jegliches Geschäft mit (i) den Gesellschaftern, die Anteile der Klasse B halten oder Art Management S.ä r.l., (ii)
jeglichen anderen Personen, die diese Person kontrollieren, von ihr kontrolliert werden oder mit ihr unter gemeinsamer
Kontrolle stehen, (iii) jeglichem Geschäftsführer, Direktor, Mitarbeiter, Angestellten oder Partner dieser Person oder
jeglicher Person, die in den oben stehenden Punkten (i) oder (ii) beschrieben ist, oder (iv) jeglichem direkten Familien-
mitglied einer in den oben stehenden Punkten (i), (ii) und (iii) beschriebenen Person;
(xviii) die Ausübung der Rechte der Gesellschafter in ihren Filialen, wenn möglich, einschließlich der Gesellschafter-
zustimmungen, insofern diese für die Filialen von gleicher oder ähnlicher Bedeutung sind wie jegliche Angelegenheit, die
unter Punkt (i) bis (xvi) in Bezug auf die Gesellschaft genannt werden."
Als Folge der Einfügung eines neuen Artikels 19, und eines neuen Artikels 21, wird der frühere Artikel 19 zum neuen
Artikel 22, der frühere Artikel 20 zum neuen Artikel 23, der frühere Artikel 21 zum neuen Artikel 24, der frühere Artikel
22 zum neuen Artikel 25 und der frühere Artikel 23 zum neuen Artikel 26.
<i>Vierzehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den Artikel 26 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung abzuändern, der
von nun an wie folgt lauten soll:
„Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen eines Gesellschaftervertrags und der folgenden Bestimmungen zur freien Verfügung:
Im Falle einer Veräußerung, d.h. eines Verkaufs, in einer einzelnen Transaktion oder in mehreren Transaktionen, an
einen oder mehrere Drittkäufer gegen einen Barbetrag, (i) der Immobilien oder einer einzelnen von ihnen, (ii) einer
Mehrheitsbeteiligung in den Filialen der Gesellschaft oder in einer Holdco oder in einer einzelnen von ihnen (iii) im
Anschluss an den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung gemäß Punkt (ii) (jedoch nicht aller Anteile an den Filialen der
Gesellschaft oder an einer Holdco oder an einer von ihnen) der Verkauf von weiteren Anteilen an den Filialen der
Gesellschaft oder von einer von ihnen, unter der Voraussetzung, dass, um Missverständnisse auszuschließen, (x) wenn
die Immobilien oder eine Mehrheitsbeteiligung an den Filialen der Gesellschaft oder an einer Holdco an mehr als einen
Drittkäufer in mehr als einer Transaktion verkauft wird, die Veräußerung die Gesamtheit aller Verweise auf solche Ver-
käufe bedeutet und zu dem Zeitpunkt des letzten Verkaufs eintritt, und (y) eine Mehrheitsbeteiligung an den Filialen der
Gesellschaft der Besitz, direkt oder indirekt, von mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals solcher Ge-
sellschaften bedeutet, haben die Anteile der Klasse B wie folgt Anrecht auf eine Vorzugsdividende:
(i) Zunächst, einhundert Prozent (100%) der Einnahmen, wie in dem Gesellschaftervertrag definiert, an die Gesell-
schafter bis der Gesamtbetrag der Einnahmen, der von den Gesellschaftern erhalten wurde, dem Gesamtbetrag der
Kapitaleinlagen und Gesellschafterkredite, die von den Gesellschaftern gemacht wurden, entspricht;
96619
(ii) Zweitens, einhundert Prozent (100%) der Einnahmen an die Gesellschafter solange bis die Gesellschafter, die die
Anteile der Klasse A halten, zwanzig Prozent (20%) einer internen Ertragsrate erhalten haben, wie in dem Gesellschaf-
tervertrag definiert;
(iii) Drittens, fünfundachtzig Prozent (85%) der Einnahmen an die Gesellschafter und fünfzehn Prozent (15%) an die
Gesellschafter, die die Anteile der Klasse B halten, solange bis die Gesellschafter, die die Anteile der Klasse A halten,
fünfundzwanzig Prozent (25%) einer internen Ertragsrate erhalten haben;
(iv) Viertens, achtzig Prozent (80%) der Einnahmen an die Gesellschafter und zwanzig Prozent (20%) an die Gesell-
schafter, die die Anteile der Klasse B halten, solange bis die Gesellschafter, die die Anteile der Klasse A halten, dreißig
Prozent (30%) einer internen Ertragsrate erhalten haben; und
(v) Anschließend fünfundsiebzig Prozent (75%) der Einnahmen an die Gesellschafter und fünfundzwanzig Prozent (25%)
an die Gesellschafter, die die Anteile der Klasse B halten;
vorausgesetzt, um Missverständnisse auszuschließen, dass, die vorhergehende Bestimmung nur für die Berechnung der
Vorzugsdividende anwendbar ist und dass kein Gesellschafter und keine andere Person durch diese Bestimmung irgend-
welche Rechte erhält.
Als Folge eines Verkaufs der gesamten Immobilien und falls die Vorzugsdividende höher ist als der Betrag, der gesetzlich
zur Ausschüttung zur Verfügung steht, zahlt die Gesellschaft den Inhabern der Anteile der Klasse B den Anteil der Vor-
zugsdividende, der gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden darf, und der Restbetrag der
Vorzugsdividende wird am Datum des von den beiden nachstehenden Ereignissen zuerst stattfindenden Ereignisses aus-
gezahlt: (i) am Datum des nächsten Verkaufsabschlusses, wobei der Restbetrag der Vorzugsdividende zunächst an die
Inhaber der Anteile der Klasse B ausgezahlt wird, bevor jegliche zusätzliche Vorzugsdividende an die Inhaber der Anteile
der Klasse B an diesem Datum ausgezahlt wird, oder (ii) zum Zeitpunkt der Liquidierung der Gesellschaft.
Die Inhaber der Anteile der Klasse A können durch schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Anteile der Klasse B den
Anspruch dieser Gesellschafter auf die Vorzugsdividende in folgenden Fällen aufheben: (1) bei dem Auftreten eines in
Absatz 10.2 (c) (i), (iii) und (iv) des Hotelführungsvertrag beschriebenen Ereignisses, (2) bei erheblichen Verletzungen der
in Artikel VIII des Gesellschaftervertrags beschriebenen Verpflichtungen durch einen Inhaber der Anteile der Klasse B,
(3) bei einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse in Bezug auf die Nießbrauchberechtigung und die Kapitalbeteiligung
unter den Inhabern der Anteile der Klasse B oder des Geschäftsführers im Rahmen des Hotelführungsvertrags, und, falls
entschuldbar, wenn die Inhaber der Anteile B oder ihre Filialen es versäumt haben, innerhalb von fünfzehn (15) Werktagen
ab dem Datum der schriftlichen Mitteilung, die den Inhabern der Anteile der Klasse B durch die Inhaber der Anteile der
Klasse A zugestellt wird und bestätigt, dass die Inhaber der Anteile der Klasse B oder ihre Filialen gegen den Gesellschaf-
tervertrag verstoßen haben, und Abhilfemaßnahmen verlangt, diesen Verstoß zu beheben. Nach der Zustellung einer
solchen schriftlichen Mitteilung wird das Anrecht der Inhaber der Anteile der Klasse B auf eine Vorzugsdividende unver-
züglich aufgehoben und sowohl die Pflichten der Gesellschaft als auch die Pflichten der Inhaber der Anteile der Klasse A
in diesem Zusammenhang sind aufgehoben."
Für den Zweck der Artikel 21 und 26 (neue Nummerierung):
Bedeutet Holdco jegliche andere direkte oder indirekte Filiale der Gesellschaft als die Filialen wie sie in Artikel 1
definiert sind.
<i>Fünfzehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt einen neuen Artikel 27 (neue Nummerierung) in die Gesellschaftssatzung einzufü-
gen, der wie folgt lauten soll:
„Abschlagsdividenden werden unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet:
(i) der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Ge-
sellschafter genehmigt;
(ii) die Abschlagsdividenden werden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Erstellung durch die Geschäftsführung
der Zwischenbilanz, aus der hervorgeht, dass ausreichend Gewinne zur Verteilung zur Verfügung stehen, ausgeschüttet;
(iii) die Vorzugsdividende, auf die die Inhaber der Anteile der Klasse B Anrecht haben, muss berücksichtigt werden;
(iv) die Entscheidung Abschlagsdividenden auszuschütten wird von der Hauptversammlung der Gesellschafter getrof-
fen.
Falls die ausgeschüttete Abschlagsdividende höher ist als der Betrag, der schließlich laut der Hauptversammlung der
Gesellschafter zur Verteilung unter den Gesellschaftern zur Verfügung steht, wird der Überschuss nicht als Abschlagsdi-
vidende betrachtet, sondern als eine unverzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.
Die oben stehenden Bestimmungen berühren nicht das Recht der Hauptversammlung der Gesellschafter, zu jedem
Zeitpunkt übertragene Gewinne aus dem vorherigen Geschäftsjahr oder Beträge aus den Konten für verteilbare Reserven
an die Gesellschafter zu verteilen."
Als Folge der Einfügung eines neuen Artikels 27, wird der frühere Artikel 24 zum neuen Artikel 28 und der frühere
Artikel 25 zum neuen Artikel 29.
96620
<i>Sechzehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den zweiten Absatz des neuen Artikels 28 wie folgt abzuändern:
„Insofern es keine anderslautende einstimmige Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern gibt, wird der nach Beglei-
chung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem
ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt, und zwar unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesellschaftervertrags
und folgender Bestimmungen: die Anteile der Klasse B haben Anrecht auf eine Vorzugsdividende bei einer Liquidation,
unter den Bedingungen, die auch die Ausschüttung einer Vorzugsdividende regeln und in Artikel 26 beschrieben sind."
<i>Siebzehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den neuen Artikel 29 wie folgt abzuändern:
„Für alle Punkte, die nicht durch diese Satzung oder durch die Bestimmungen eines Gesellschaftervertrages, der mög-
licherweise zwischen den Gesellschaftern abgeschlossen wurde, geregelt werden, verweisen die Erschienenen auf die
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
Im Falle von Abweichungen zwischen der vorliegenden Satzung und dem Gesellschaftervertrag ist der Gesellschafter-
vertrag im Hinblick auf Angelegenheiten zwischen den Gesellschaftern maßgebend."
<i>Achtzehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den Rücktritt von BRE/Management S.A. von ihrem Mandat als alleinige Geschäfts-
führerin der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzunehmen.
Die Hauptversammlung beschließt. BRE/Management S.A. für die Erfüllung ihres Mandates voll zu entlasten.
<i>Neunzehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf vier festzulegen.
<i>Zwanzigster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, folgende Personen mit sofortiger Wirkung und für einen unbestimmten Zeitraum
zu Geschäftsführern der Gesellschaft zu ernennen:
- Herrn Anders Braks, Jurist, geboren am 21. September 1959 in Landskrona (Schweden), wohnhaft in 41, Am Bota-
nischen Garten, 50668 Köln, Deutschland.
- Herrn Robert Simon, director, geboren am 20. Februar 1929 in Wiesbaden (Deutschland), wohnhaft in 28, rue JP
Brasseur, L-1258 Luxembourg,
- Frau Cornelia M.W. van den Broek, director, geboren am 26. Juni 1968 in Oosterhout (Niederlande), mit Berufsad-
resse in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.,
- Herrn Gary Summers, verwaltender Geschäftsführer, geboren am 12. Dezember in New York, Vereinigte Staaten
von Amerika, wohnhaft in 888 Park Avenue, Apt. 11#, New York, NY 10021, Vereinigte Staaten von Amerika.
Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber, Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, haben die Erschienenen mit dem Notar ge-
genwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: P. SONDHI und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36549. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.
Luxemburg, den 16. September 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009126268/828.
(090151975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.
96621
MTCL Jess S.àr.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DB Valence S.à r.l.).
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 111.378.
Im Jahre zweitausendundneun, am einundzwanzigsten September.
Vor Maître Paul BETTINGEN, Notar mit dem Amtssitz in Niederanven (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Deutsche Bank Luxembourg S.A., eine nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesell-
schaft, mit Sitz in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter
Nummer B 9.164 der "Gesellschafter"),
vertreten durch Sabine Hinz, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-
wärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Gesellschafter hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass er der Alleingesellschafter der nach dem Recht
des Grossherzogtums Luxemburg gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „DB Valence S.à r.l." ist, dessen
Sitz sich in 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg befindet, und welche im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsre-
gister unter der Nummer B 111.378 eingetragen ist (die „Gesellschaft"), gegründet durch notarielle Urkunde des Notars
Gérard Lecuit, mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 13. Oktober 2005, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 230 vom 1. Februar 2006,
abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Gérard Lecuit am 3. November 2005,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 469 vom 3. März 2006.
Der Gesellschafter erklärt, ausführlich über die Beschlüsse informiert zu sein, die aufgrund der folgenden Agenda zu
fassen sind:
<i>Agendai>
1. Abänderung der Firma der Gesellschaft in „MTCL Jess S.à r.l." mit Wirkung ab dem 28. September 2009.
2. Neufassung entsprechend des unter Punkt 1. gefassten Beschlusses von Artikel 1, Absatz 3 des Gesellschafterver-
trages der Gesellschaft, der nunmehr folgenden Wortlaut annehmen wird: „Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet
„MTCL Jess S.à r.l.".
3. Kenntnisnahme des Rücktritts aller Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung ab dem 28. September 2009.
4. Nach Rücktritt der Geschäftsführer, Verringerung mit Wirkung ab dem 28. September 2009 der Anzahl der Ge-
schäftsführer von derzeit vier (4) auf einen (1) und Bestellung mit Wirkung ab dem 28. September 2009 des folgenden
Herren als neuen Geschäftsführer für eine Dauer von sechs (6) Jahren: Herrn Jean-Michel Hamelle, Manager, geboren
am 13. September 1962 in Reims (Frankreich), geschäftsansässig in 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.
Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt die Abänderung der Firma der Gesellschaft in „MTCL Jess S.à r.l." mit Wirkung ab dem
28. September 2009.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt die Neufassung entsprechend des unter Punkt 1. gefassten Beschlusses von Artikel 1,
Absatz 3 des Gesellschaftervertrages der Gesellschaft, der nunmehr folgenden Wortlaut annehmen wird:
Art. 1. Rechtsform, Firma (Absatz 3). „Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet, MTCL Jess S.à r.l.'."
<i>Dritter Beschlussi>
Der Gesellschafter nimmt den Rücktritt aller Geschäftsführer mit Wirkung ab dem 28. September 2009 an.
<i>Vierter Beschlussi>
Nach Rücktritt der Geschäftsführer beschließt der Gesellschafter die Verringerung der Anzahl der Geschäftsführer
mit Wirkung ab dem 28. September 2009 von derzeit vier (4) auf einen (1) und bestellt mit Wirkung ab dem 28. September
2009 folgenden Herren als neuen Geschäftsführer für eine Dauer von sechs (6) Jahren: Herrn Jean-Michel Hamelle,
Manager, geboren am 13. September 1962 in Reims (Frankreich), geschäftsansässig in 1 rue Nicolas Simmer, L-2538
Luxemburg.
96622
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) geschätzt.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Er-
schienenen hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: Sabine Hinz, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 24 septembre 2009. LAC / 2009 / 38997. Reçu 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Franck Schneider.
Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 30. September 2009.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2009125597/66.
(090151260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
FKI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 193.582.225,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 70.557.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
<i>Pour la société
FKI Luxembourg s.à. r.l.
i>99, Grand Rue
L-1661 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2009125652/16.
(090151275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
Seculux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6650 Wasserbillig, 16-18, rue des Vignes.
R.C.S. Luxembourg B 87.913.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendneun,
Den siebzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,
Ist erschienen:
Frau Beate FELL, Kauffrau, wohnhaft in D-34497 Korbach, Bahnhofstrasse 5,
Welche Komparentin den amtierenden Notar ersucht, zu beurkunden:
Dass sie die einzige Gesellschafterin ist der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SECULUX SARL", mit Sitz in L-6650
Wasserbillig, 16-18, rue des Vignes, gegründet unter dem Namen "FELL INFORMATIQUE SARL" gemäss Urkunde, auf-
genommen durch den amtierenden Notar am 13. Juni 2002, veröffentlicht im Memorial, "Recueil des Sociétés et
Associations" C, Nummer 1280 vom 4. September 2002, abgeändert gemäss Urkunde vom 22. Oktober 2002, aufge-
nommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im Memorial, "Recueil des Sociétés et Associations" C, Nummer
1709 vom 29. November 2002, abgeändert gemäss Urkunde vom 10. Juni 2005, aufgenommen durch den amtierenden
Notar, veröffentlicht im Memorial, "Recueil des Sociétés et Associations" C, Nummer 1223 vom 17. November 2005,
abgeändert gemäss Urkunde vom 18. Oktober 2005, aufgenommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im
Memorial, "Recueil des Sociétés et Associations" C, Nummer 322 vom 14. Februar 2006, und zum letzten Mal abgeändert
gemäss Urkunde vom 13. Juli 2007, aufgenommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im Memorial, "Recueil
des Sociétés et Associations" C, Nummer 1929 vom 16. Oktober 2007, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 87.913, mit einem Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,00), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00).
96623
Dass die Gesellschaft am heutigen Tag aufgelöst wird,
Dass zum selben Datum die Liquidation den Rechten der Gesellschafterin entsprechend erfolgt ist,
Dass infolgedessen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SECULUX SARL" nicht mehr besteht,
Dass die Gesellschafterin sich ausdrücklich verpflichtet, alle etwa noch verbleibenden und zum gegenwärtigen Zeit-
punkt unbekannten Schulden der Gesellschaft zu übernehmen,
Dass die Bücher der Gesellschaft während fünf Jahren in D-34497 Korbach, Bahnhofstrasse 5, aufbewahrt werden.
Worüber Urkunde, Aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienene, hat dieselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: B. Fell, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 septembre 2009. Relation: LAC / 2009/ 38078. Reçu soixante-quinze euros
75,00€
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Franck Schneider.
Für gleichlautende Abschrift.
Luxemburg, den 5. Oktober 2009.
Emile SCHLESSER.
Référence de publication: 2009127249/42.
(090153223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2009.
Doll S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 147.924.
<i>Transfert de partsi>
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 11 septembre 2009, que Change Capital (Guern-
sey) Il Limited a transféré
3.715.327 parts sociales à
- Change Capital Fund II LP Inc., une société constituée et régie selon les lois de Guernesey, ayant son siège social au
13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD Channel Islands, enregistrée auprès du Guernsey Registry sous
le numéro 990;
193.578 parts sociales à
- Change Capital Co-Invest II LP Inc., une société constituée et régie selon les lois de Guernesey, ayant son siège social
au 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD Channel Islands, enregistrée auprès du Guernsey Registry
sous le numéro 988;
91.095 parts sociales à
- Change Capital Co-Invest IIB LP, une société constituée et régie selon les lois de Guernesey, ayant son siège social
au 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD Channel Islands, enregistrée auprès du Guernsey Registry
sous le numéro 989.
Depuis cette date, les parts de la Société sont réparties comme suit:
Change Capital Fund II LP Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.715.327 parts sociales
Change Capital Co-Invest II LP Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193.578 parts sociales
Change Capital Co-Invest IIB LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.095 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2009.
DOLL S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2009127162/31.
(090152932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
96624
Abelton Invest S.A.
ACMBernstein - India Growth Fund
AL DWS Global Aktiv+
AL DWS Global Aktiv+
Alma Mater S.A.
Altera Security Fund
A.N.G.'Immobilier S.à r.l.
Aristolux Investment Fund
Best Way Invest S.A.
Black & Decker Asia Manufacturing Holdings 1 S.à r.l.
BRE/Europe 3-B S.à r.l.
BRE/Europe 3-C S.à r.l.
BRE/Europe 3 S.à r.l.
BRE/French Holdco 5 S.à r.l.
BRE/French Hotel Holding I S.à r.l.
Carrera Invest S.A.
DB Valence S.à r.l.
Deka-Flex:
Deka-Flex:
Doll S.à r.l.
DWS Cashback Garant 2014
DWS Cashback Garant 2014
DWS China A-Fund
DWS Corporate Bond Basket 2014
DWS Dollarchance Garant
DWS Emerging New Deal Fund
DWS Flex Aktiv
DWS Flex Aktiv
DWS Zinssprinter
DWS Zinssprinter (2016)
DWS Zinswunder (a)
Emde Finances S.A.
Euronimbus S.A.
European Geophysical Services S.A.
Financière Stoppato
Finistère SPF S.A.
FKI Luxembourg S.à r.l.
Force-Lux S.A.
Franmar Holding S.A.
GREIFF «special situations» Fund OP
IFM-Institutionell Real Estate Plus 1
Jarama Holding S.A.
KHG S.A.
KHG S.A.
Leptis Magna
LIM Logging S. à r.l.
Lombard Odier Darier Hentsch Invest
Luxprofi S.à r.l.
Montebello Finances
MTCL Jess S.àr.l.
ORONTE S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"
Pizza Toscana
Publi Europe S.A.
Seculux Sàrl
Selected Strategies Partners
Sophis Manco Luxembourg SA
Studiofund S.A.
UBS Target Fund
Winchester JV S.à r.l.
Yelo Bau SA