logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1989

13 octobre 2009

SOMMAIRE

Advent Pawlux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

95443

Agence Générale de Marques et de Brevets

S.E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95458

Agence Générale de Marques et de Bre-

vets, Soparfi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95458

Alias Mustang International  . . . . . . . . . . . . .

95431

Altera Security Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95435

Amyrtee Investissement S.A.  . . . . . . . . . . .

95432

Beech Tree S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95437

Belfil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95434

C 5 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95457

Camilia Holding BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95437

Coiffure Paulo Machado Sàrl  . . . . . . . . . . . .

95455

Comodot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95469

Courtignac S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95432

Delanceau Strategies S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

95432

EF Cultural Tours S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

95444

Eurizon Multimanager Stars Fund  . . . . . . .

95439

Fili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95457

Financière VLH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95445

Fortis LDI Solution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95438

Fortis Solutions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95439

GLL Real Estate Selection Fund  . . . . . . . . .

95435

Heralda S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95441

I.B.T. International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95446

Immo 777 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95472

Infrastructure JVCo (Lime) S.à r.l.  . . . . . . .

95457

Ingenium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95433

Kauri Capital 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95456

Kauri Capital 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95456

Kauri Capital Gewerbepark Alt-West . . . .

95441

Lacombe Investissement S.A.  . . . . . . . . . . .

95431

La Iolla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95439

Libo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95444

Lighting Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95446

Lirvest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95472

LSF Hotels Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

95444

LSF Hotels Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

95442

Lux-Tex Investissements S.A.  . . . . . . . . . . .

95426

Magellan Management & Consulting S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95470

Manus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95438

Mobileo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95434

Mont Blanc Investment S.A.  . . . . . . . . . . . .

95438

Moseltank A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95426

MOV'IT International  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95447

NEP Prievidza S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95445

Northam Property Funds Management S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95455

Olivia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95435

Opus Strategic Value  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95435

Orascom Telecom Finance  . . . . . . . . . . . . .

95443

Orco Germany S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95433

Orco Germany S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95426

Palor Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

95446

Pluton Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

95445

Sargos Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

95442

SBF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95443

Sesa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95441

SF Motta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95435

Société Internationale de Travaux Publics

S.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95470

Sokrates S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95469

Suisse Alpine Energie Nouvelle S.A.  . . . . .

95435

Tanarive Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

95440

Tasman Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

95440

Valamoun S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95443

Waterl'Eau International S.A.  . . . . . . . . . . .

95434

Xaro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95442

95425

Moseltank A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 73.435.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Moseltank A.G., welche am <i>29. Oktober 2009 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfol-

genden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

<i>Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2008
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Mandatsänderungen
6. Verschiedenes

<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2009126414/18.

Lux-Tex Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 83.062.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu, de façon extraordinaire le <i>3 novembre 2009 à 11.00 heures, au siège social de la société,

avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver

les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 juillet 2009.

- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle

du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31 juillet 2009.

- Approbation du bilan arrêté au 31 juillet 2009 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice clôturé au

31 juillet 2009.

- Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009126448/565/20.

Orco Germany S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 102.254.

Further to the request received by shareholders holding more than 10% of the issued share capital, you are invited to

attend to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company to be held before notary public Me Henri Hellinckx (or such other notary as appropriate) at the

registered office of the Company, Parc d'Activités Capellen, 40, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>October
30, 2009 at 14.00 Central European time ("CET") (the "Meeting"). The Meeting will be held in order to consider the
following agenda (as requested by said shareholders):

<i>Agenda:

1. Amendment of the provisions of the articles with respect to the composition of the Board of Directors of the

Company by amending article 6 to read as follows:
Art. 6.
6.1. The Company is managed by a board of directors (the "Board of Directors" or the "Board") appointed as a
collegiate body by the general meeting of shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The

95426

members of the Board of Directors (each a "Director" or a "Board Member") may but do not need to be share-
holders.
6.2. The Board of Directors shall be composed of the number of members determined by the general meeting of
shareholders up to the limit of six (6) members, unless there are more than six (6) shareholders holding ten percent
(10%) of all issued shares in which case the number of Board Members shall be increased (with a maximum of ten
(10)) to enable each such shareholder to exercise his rights under 6.3). The Directors are elected by the General
Meeting of shareholders for a period of maximum six (6) years. Any Director may be removed with or without
cause (ad nutum) by a general meeting of shareholders.
6.3. Directors are eligible for re-election. In the event of a vacancy in the office of a Director because of death,
retirement or otherwise, the remaining Directors may proceed to the cooptation of a new Director in replacement
to fill such vacancy, provided that if the vacant seat is that of a Director appointed out of candidates proposed by
a shareholder in exercise of such shareholder's Proposal Rights (as referred to below) then the cooptation may
only be made out of candidates proposed by such shareholder (subject to such shareholder then still holding 10%
of the issued share capital).
6.4. Each shareholder holding ten per cent (10%) of the issued share capital (i) at the time of the convening of a
general meeting having as an agenda item the election and appointment of one or more Board Members, and, (ii)
at the time of the relevant general meeting, shall have the right to propose candidates for the election of one (1)
board seat (the "Proposal Right"). The Proposal Right may not be validly exercised by shareholders that are already
represented on the Board by at least one candidate proposed by them, unless such board member's mandate shall
terminate/be terminated at the relevant general meeting. In any event, the Board shall only be validly composed
and be able to act if it includes one member appointed out of the candidates of each of the shareholders that held
ten per cent (10%) of the issued share capital (i) at the time of the convening of a general meeting having as an
agenda item the removal and/or election and appointment of one or more Board Members, and, (ii) at the time of
the relevant general meeting, with the exception of such shareholders that waived (or are deemed to have waived)
their Proposal Right.
Shareholders having made due disclosure in accordance with the Luxembourg law of 11 January 2008 on transpa-
rency of their holding of at least 10% of the issued share capital shall, prior to the convening of the relevant general
meeting, be asked in good time (but at least ten (10) days before the first convening notice of the meeting) to
provide candidates. If no candidates are proposed by a shareholder entitled thereto pursuant to the present Article,
within ten (10) days from having been asked to propose candidates, such shareholder shall be deemed to have
waived but only until the next general meeting his right.

2. Amendment of the provisions of the articles with respect to the majority required to pass extraordinary resolutions

(including without limitation, amendments of articles, mergers, scission or liquidations) by amending article 13 to
read as follows:
Art. 13.
13.1. Convening Notice to all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all share-
holders are present or represented and if they declare having had knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without previous convening notice.
13.2. The board of directors may decide that shareholders desiring to attend the meeting must deposit their shares
five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy who
need not be a shareholder.
13.3. Each share gives right to one vote.
13.4. Resolutions of the general meeting shall be passed with such quorum and with such majorities as required by
law provided however that during the Increased Majority Period, any Extraordinary Resolutions may only be validly
passed at (i) the quorum and qualified majority provided for by law and (ii) the favourable vote of the shares held
by OPG and of the shares held by MSREF.
For the purposes hereof,
"Increased Majority Period" means the period starting on the [date of EGM] and ending at midnight CET on the
last day of the Exercise Period.
"Exercise Period" means the period starting on the date of issue of the Warrants referred to under article 5.2.3.1
and ending (and including) the last day of a period of 18 months from the last day of the calendar month of such
issue date, provided that in the event the Exercise Period is suspended by decision of a court with jurisdiction or
other competent authority or regulator, the time of suspension shall be added to the above mentioned 18 months
period.
"Extraordinary Resolutions" any shareholders resolutions requiring under Luxembourg laws or pursuant to the
articles of association of the Company a majority higher than simple majority of votes to be passed.
"OPG" means Orco Property Group S.A. (RCS Luxembourg B 44.996).
"MSREF" means MSREF V Turtle B.V., (no. 34244758).

3. Amendment of the authorised share capital of the Company in order to provide for an additional authorised share

capital of 23,647,722.5 (represented by 18,918,178 shares of an accounting par value of €1.25 each) (the "Reserved

95427

Authorised Share Capital"), while waiving the pre-emptive subscription rights of the shareholders, reserved for the
concomitant issue of:
3.1. 7,926,428 warrants giving the holder thereof the right to subscribe to one (1) share of the Company for an
issue price of € 1.60 per share and having the following main terms (the "Warrants") (and the Warrant Shares upon
exercise of the Warrants):

Reserved Issue

On the Issue Date, the Company shall create, allocate and
issue free of charge to each holder of shares of the Com-
pany at the close of business (18.00 CET) on the Refe-
rence Date other than Orco Property Group S.A. (the
"Warrantholders"), one (1) Warrant for every 2.578014
shares of the Company held (in accordance with the
Warrant Formula), each such Warrant giving the holder
the right to subscribe to one (1) share being a total of up
to 7,926,428 shares.
No Warrants shall be issued to Orco Property Group
S.A. (holding 28,336,889 shares of the total outstanding
48,771,333 shares).

Issue Date

The Warrants shall be issued on the same day than the
Conversion Shares (the "Issue Date").

Reference Date

The close of business (18.00 CET) of the day prior to
EGM convened by the present convening notice.

Form of the Warrants

The Warrants are in registered form.

Exercise Ratio of the Warrants

Each Warrant entitles its holder to subscribe to one (1)
new share of the Company with an accounting par value
of EUR 1.25 issued upon exercise of the Warrant at the
Exercise Price (as defined below) (the "Warrant Share").

Exercise Price of the Warrants

EUR 1.60 per Warrant Share to be paid in cash to the
Company (being EUR 1.25 accounting par value and EUR
0.35 premium).

Exercise Period of the Warrants

Means the period starting on and including the Issue Date
(subject to the below) up to (and including) the last day
of a period of 18 months from the last day of the calendar
month of the Issue Date. In the event the Exercise Period
is suspended by decision of a court with jurisdiction or
other competent authority or regulator, the time of sus-
pension shall be added the above 18 months period.

Exercise of Warrants

The Warrants may be exercised at any time during the
Exercise Period (until 00.00 CET of the last day of the
Exercise Period).

Transferability of the Warrants

The Warrants may not be transferred and traded from
the Issue Date.

Number of Warrants

7,926,428 Warrants are issued and allocated for free to
the holders of shares of the Company as at the Reference
Date, except OPG, in accordance with the Warrant For-
mula.

Warrant Formula

The number of Warrants which each holder of shares,
other than OPG, shall be allocated is calculated as follows:
X = NSH / R
whereby
X means the umber of Warrants allocated to a given hol-
der rounded down to the nearest full number;
NSH means the number of shares in the Company held
by the relevant holder (other than OPG) on the Refe-
rence Date and for which such holding is evidenced;
R means the ratio being 2.578014;

Warrant Anti Dilution Protection

New Securities may only be issued by the Company dur-
ing the Exercise Period if each Warrantholder is given the
right to subscribe for a portion of the New Securities at
same time and upon the same terms and conditions so
that following the issue of the New Securities and exer-

95428

cise of all such subscription right the Warrantholders'
Fully Diluted Shareholding remains unchanged. No issue
of New Securities may be made against contributions
other than cash.
For the purpose hereof,
"Warrantholders' Fully Diluted Shareholding" means, for
any Warrantholder, the proportion of such holder's par-
ticipation in the shares of the Company (calculated on a
fully diluted basis as if all of its Warrants were exercised
or converted into shares of the Company, even where
such conversion is not yet exercisable or has not yet oc-
curred) relative to the total participation of all of the
holders of shares of the Company and/or Warrants in the
voting rights of the Company (calculated on a fully diluted
basis as if all of the Warrants are exercised or converted
into shares of the Company, even where such conversion
right is not yet exercisable or has not yet occurred);
"New Securities" means any shares (except the Conver-
sion Shares and except the Bond Rights), or other equity
securities or warrants, options, bonds or other rights to
subscribe for the foregoing issued while the Warrants are
in issue; and
"Bond Rights" means the redeemable warrants issued in
relation with and attached to the EUR 100,100,052 five
year bonds issued by the Company in May 2007 (and sha-
res to be issued upon due exercise thereof subject to the
terms of the bonds and related redeemable warrants)
(XS0302623953-030260395//
XS0302626889-030262689).

And
3.2. up to 10,991,750 shares of an accounting par of EUR 1.25 and an issue price of EUR 1.60 per share (being EUR
1.25 accounting par and EUR 0.35 share premium) to Orco Property Group S.A. ("OPG") against contribution in
kind by OPG to the Company of claims against the Company held by OPG in a total aggregate face amount of EUR
17,586,800 (principal and interest) and all and any rights relating thereto;
3.3. acknowledgement of the report by the board of directors as to the waiver and suppression of pre-emptive
subscription rights of shareholders with respect to the Reserved Authorised Share Capital and the issue of the
Warrants, the Warrant Shares and the Conversion Shares; waiver and suppression of pre-emptive subscription
rights of all shareholders with respect to the Reserved Authorised Share Capital and the issue of the Warrants,
the Warrant Shares and the Conversion Shares in accordance with and subject to the provisions above;
3.4. Authorisation to the Board of Directors:
3.4.1. to determine accessory terms of the Warrants as may be appropriate provided that the main terms set forth
above may not be adversely impacted thereby and to take such steps and actions, including the preparation of a
prospectus, to implement the issue of the Warrants on the Issue Date (and upon exercise thereof, the issue of the
Warrant Shares);
3.4.2. to take such steps and actions to implement the issue of the Conversion Shares on the Issue Date;
provided that the issue of the Warrants and the issue of the Conversion Shares are one dependent on the other
and may only happen at the same time;
3.5. Amendment of the provisions under the header "Authorised Share Capital" of article 5 to read as set forth
below, addition of the heading "5.1 Issued Share Capital" at the beginning of article 5:
Art. 5.
5.1. Issued Share Capital
[...]
5.2. Authorised capital
5.2.1. The corporate share capital may be increased from its present amount to EUR 173,647,722.5 (one seventy
three million six hundred forty seven thousand seven hundred twenty two euros and fifty cents) (subject to the
Warrant Anti Dilution Protection) (the "Authorised Share Capital"), as the case may be by the creation and the
issue of new shares, entitling to the same rights and advantages as the existing shares. Out of the Authorised Share
Capital an amount of up to twenty three million six hundred forty seven thousand seven hundred twenty two euros
fifty  cents  (EUR  23,647,722.5)  (represented  by  eighteen  million  nine  hundred  eighteen  thousand  one  hundred
seventy eight (18,918,178) shares shall be reserved for, and may not be used for any other purpose, (the "Reserved
Authorised Share Capital") the concomitant issue of (i) seven million nine hundred twenty six thousand four hun-

95429

dred twenty eight (7,926,428) Warrants (as referred under 5.2.3.1 below, and the issue of shares upon exercise
thereof) and (ii) the Conversion Shares (as referred to in 5.2.3.2 below).

5.2.2 Subject to the Reserved Authorised Share Capital and the provisions of article 5.2.3, the board of directors

is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues

of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims (other than the
OPG Claims), or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or
reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of

subscription and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of

supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period ending on 19 

th

 March 2012 and may be renewed by a general meeting

of shareholders with respect to the shares of the Authorized Capital which at that time has not yet been issued,
subject however to the Reserved Authorised Share Capital and the provisions of article 5.2.3.

5.2.3 The Reserved Authorised Share Capital shall be expressly reserved and only be available for the conco-

mitant issue of:

5.2.3.1 seven million nine hundred twenty six thousand four hundred twenty eight (7,926,428) warrants giving

the holder thereof the right to subscribe to one (1) share of the Company (each a "Warrant Share") for an issue
price of one euro and sixty cents (€ 1.60) per share (being one euro twenty five cents (€ 1.25) accounting par and
thirty five euro cents (€ 0.35) share premium) and having the main terms as approved by the general meeting at
qualified majority (the "Warrants") on [date EGM] 2009 (and the Warrant Shares upon exercise of the Warrants),
such Warrants only to be issued to holders of shares of the Company, other than Orco Property Group S.A., on
the close of business (18.00 CET) on the day prior to the [EGM date] 2009.

5.2.3.2 up to ten million nine hundred ninety one thousand seven hundred fifty (10,991,750) shares of an ac-

counting par of one euro twenty five cents (€ 1.25) and an issue price of one euro and sixty cents (€ 1.60) per
share (being one euro twenty five cents (€ 1.25) accounting par and thirty five euro cents (€ 0.35) share premium)
(the "Conversion Shares") to Orco Property Group S.A. ("OPG") against contribution in kind by OPG to the
Company of claims against the Company held by OPG in a total aggregate face amount of seventeen million five
hundred eighty six thousand eighty hundred euros (€ 17,586,800) (principal and interest) and all and any rights
relating thereto (the "OPG Claims").

5.2.3.3 Warrant Anti Dilution Protection: New Securities may only be issued by the Company during the Exercise

Period if each Warrantholder is given the right to subscribe for a portion of the New Securities at same time and
upon the same terms and conditions so that following the issue of the New Securities and exercise of all such
subscription right the Warrantholders' Fully Diluted Shareholding remains unchanged. No issue of New Securities
may be made against contributions other than cash.

For the purpose hereof,
"Warrantholders' Fully Diluted Shareholding" means, for any Warrantholder, the proportion of such holder's

participation in shares of the Company (calculated on a fully diluted basis as if all of its Warrants were exercised
or converted into shares of the Company, even where such conversion is not yet exercisable or has not yet
occurred) relative to the total participation of all of the holders of shares of the Company and/or Warrants in the
voting rights of the Company (calculated on a fully diluted basis as if all of the Warrants are exercised or converted
into shares of the Company, even where such conversion right is not yet exercisable or has not yet occurred);

"New Securities" means any shares (except the Conversion Shares and the Bond Rights), or other equity secu-

rities or warrants, options, bonds or other rights to subscribe for the foregoing issued while the Warrants are in
issue; and

"Bond Rights" means the redeemable warrants issued in relation with and attached to the € 100,100,052 five

year bonds issued by the Company in May 2007 (and shares to be issued upon due exercise thereof subject to the
terms of the bonds and related redeemable warrants) (XS0302623953-030260395//XS0302626889-030262689).

5.2.3.4 The Board of Directors is authorised with respect to the Reserve Authorised Share Capital (and the

issue of the Warrants, the Warrant Shares and the Conversion Shares) (i) to determine accessory terms of the
Warrants as may be appropriate provided that the main terms determined by the general meeting may not be
adversely impacted thereby and to take such steps and actions, including the preparation of a prospectus, to im-
plement the issue of the Warrants (and upon exercise thereof, the issue of the Warrant Shares) and (ii) to take
such steps and actions to implement the issue of the Conversion Shares; provided that the issue of the Warrants
and the issue of the Conversion Shares are one dependent on the other and may only happen at the same time.

5.2.4 As a consequence of each duly made increase of capital in accordance with and subject to the provisions

of article 5.2, and duly recorded documented in notarial form, paragraph 5.1 will be amended such as to correspond
to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form.

95430

4. Miscellaneous.
Attendance to the Meeting:
- Shareholders wishing to attend the Meeting shall notify their intent at the latest on October 23, 2009 to the Company

by fax (+352 26 47 67 67) or by email to the following person: olansac@orcogroup.com;

- Shareholders wishing to be represented at the Meeting shall provide the representative of their choice with proxy

including their voting instructions. Such proxy duly filled up with the shareholder name shall be provided to the Company
at the latest on October 23, 2009. This notice and a proxy form will be available either at the registered office of the
Company or by contacting us by fax (+352 26 47 67 67) or on the following website: www.orcogermany.de;

- Shareholders of bearer shares wishing to attend in person or represented at the Meeting shall also provide a statement

of participation (attestation de participation), issued by the financial intermediary holding their securities, such statement
indicating the number of shares held. The Shareholders who do not have this statement may not participate to the vote.

Withholding threshold:
- As reminded in Article 14 of the updated articles of association of the Company, any shareholder is under the

obligation to immediately inform the Company in writing of the crossing either up or down of the thresholds set at 2.5%,
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% and 66%. Shareholders who do not inform the Company will not be able to use their
voting right on the Meeting.

Orco Germany S.A.
Rainer Bormann
<i>Managing Director

Référence de publication: 2009127506/1273/286.

Lacombe Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 135.227.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 novembre 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2009;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2009;
3. affectation des résultats au 30 juin 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009127278/10/18.

Alias Mustang International, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 95.884.

Le conseil d'administration prie les actionnaires de la société anonyme ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL d'assister

à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le jeudi <i>29 octobre 2009 à 10.00 heures à Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,

afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du commissaire aux comptes et du rapport de gestion
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Plan stratégique - Présentation et décision

95431

7. Divers

Les actionnaires sont informés que cette Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement sur les

points à l'ordre du jour.

Pour pouvoir assister à ladite Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur devront présenter leurs certificats d'ac-

tions ou un certificat de blocage bancaire.

Référence de publication: 2009127582/755/23.

Courtignac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 135.228.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 novembre 2009 à 14.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2009;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2009;
3. affectation des résultats au 30 juin 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009127279/10/18.

Amyrtee Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 135.230.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 novembre 2009 à 15.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2009;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2009;
3. affectation des résultats au 30 juin 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009127281/10/18.

Delanceau Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 135.229.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 novembre 2009 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2009;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2009;

95432

3. affectation des résultats au 30 juin 2009;
4. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire;
5. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009127280/10/19.

Orco Germany S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 102.254.

You are invited to attend to an

ORDINARY GENERAL MEETING

of the Company to be held extraordinarily at the registered office of the Company, Parc d'Activités Capellen, 40,

L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>October 30, 2009 at 13.45 Central European time ("CET") (the "Meet-
ing"). The Meeting will be held in order to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Continuation of the activity of the Company based on the statutory accounts of the Company ending on August

31, 2009, notwithstanding the fact that the cumulated losses exceed more than 50% of the share capital of the
Company pursuant to Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies.

2. Miscellaneous.
Attendance to the Meeting:
- Shareholders wishing to attend the Meeting shall notify their intent at the latest on October 23, 2009 to the Company

by fax (+352 26 47 67 67) or by email to the following person: olansac@orcogroup.com;

- Shareholders wishing to be represented at the Meeting shall provide the representative of their choice with proxy

including their voting instructions. Such proxy duly filled up with the shareholder name shall be provided to the Company
at the latest on October 23, 2009. This notice and a proxy form will be available either at the registered office of the
Company or by contacting us by fax (+352 26 47 67 67) or on the following website: www.orcogermany.de;

- Shareholders of bearer shares wishing to attend in person or be represented at the Meeting shall also provide a

statement of participation (attestation de participation), issued by the financial intermediary holding their securities, such
statement indicating the number of shares held. The Shareholders who do not have this statement may not participate
to the vote.

Withholding threshold:
- As reminded in Article 14 of the updated articles of association of the Company, any shareholder is under the

obligation to immediately inform the Company in writing of the crossing either up or down of the thresholds set at 2,5%,
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% and 66%. Shareholders who do not inform the Company will not be able to use their
voting right on the Meeting.

Orco Germany S.A.
Rainer Bormann
<i>Managing Director

Référence de publication: 2009127505/1273/35.

Ingenium, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.032.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2009 n'ayant pu délibérer valablement sur les points 1 à 3 de l'ordre du

jour; le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav INGENIUM à une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le <i>2 novembre 2009 à 11.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats

95433

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009127584/7/18.

Belfil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 86.819.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>12 novembre 2009 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915

2. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009127586/788/15.

Waterl'Eau International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 83.924.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>12 novembre 2009 à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915

2. Divers
Référence de publication: 2009127587/788/14.

Mobileo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

R.C.S. Luxembourg B 113.127.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on <i>November 2, 2009 at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2008.
3. Appropriation of results as of December 31, 2008.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related

fiscal year.

5. Sundry.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2009127589/29/17.

95434

Altera Security Fund, Fonds Commun de Placement.

Die Axxion S.A. H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der HSBC Trinkaus &amp;

Burkhardt (International) SA beschlossen, das Verwaltungsreglement des Organismus für gemeinsame Anlagen Altera
Security Fund, der den Bestimmungen des Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für ge-
meinsame Anlagen unterliegt, zu ändern.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesell-

schaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 02. September 2009.

Axxion S.A. / HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt (International) SA.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
Unterschrift / Unterschrift

Référence de publication: 2009122491/16.
(090145249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2009.

Olivia, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé,

(anc. Opus Strategic Value).

La partie spécifique du règlement de gestion modifié au 17 avril 2009 a été déposée au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009127282/11.
(090152096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.

GLL Real Estate Selection Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 21 septembre 2009 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

GLL Management Company S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009127283/9.
(090154129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.

SF Motta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.705.

Suisse Alpine Energie Nouvelle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.842.

L'an deux mille neuf, le seizième jour du mois de septembre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Fabienne Perusini, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard

du Prince Henri agissant en sa qualité de mandataire/représentant de la société anonyme Société Européenne de Banque,
ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 13859, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 28 août 2009 à Luxembourg, elle-même agissant en sa qualité de
mandataire:

(i) du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SF MOTTA S.A., ayant son

siège social à Luxembourg au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 97.705, au capital social de EUR 150.000,- représenté par
15.000 actions d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune, entièrement libéré, d'une part; et

95435

(ii) du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SUISSE ALPINE ENERGIE

NOUVELLE S.A., ayant son siège social à Luxembourg au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 106.842, au capital social de EUR
50.000,- représenté par 5.000 actions d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune, entièrement libéré, d'autre part,

Société européenne de Banque, préqualifiée, est habilitée aux fins des présentes par décision du Conseil d'adminis-

tration de la société absorbante et de la société absorbée en date du 28 août 2009.

La procuration et les deux procès-verbaux du conseil d'administration de la société absorbante et de la société ab-

sorbée après avoir été signés ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés
au présent acte pour être formalisés avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet

de fusion qui suit:

<i>Projet de fusion

La société absorbante, SF MOTTA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 97.705,
constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 8 décembre 2003 publié au
mémorial C numéro 67 du 17 janvier 2004 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés à la date de ce jour, au capital
social de EUR 150.000,- représenté par 15.000 actions d'une valeur nominale de 10,- chacune, entièrement libérées,
dénommée ci-après "la société absorbante",

détient l'intégralité (100%) des actions à savoir 5.000 actions de EUR 10,- chacune et donnant droit de vote repré-

sentant la totalité du capital social de SUISSE ALPINE ENERGIE NOUVELLE S.A., une société de droit luxembourgeois,
dont le siège social est établi à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée par acte
du notaire instrumentant en date du 8 février 2005 publié au mémorial C numéro 768 du 2 août 2005 et dont les statuts
n'ont jamais été modifiés à la date de ce jour et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la
section B et le numéro 106.842, dénommée ci-après "la société absorbée",

1. Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées

(encore appelées sociétés fusionnantes).

2. La société anonyme SF MOTTA S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux

dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et les textes
subséquentes avec la société anonyme SUISSE ALPINE ENERGIE NOUVELLE S.A. (encore appelée la société absorbée)
par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme

accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1 

er

 janvier 2009.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.
5. La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.

6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C

du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et
sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du

capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer
sur l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

8. A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive,

comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales telle que modifiée et notamment sous son littera a).

9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les dé-

clarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des
apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.
11.  Les  documents  sociaux  de  la  société  absorbée  seront  conservés  pendant  le  délai  légal  au  siège  de  la  société

absorbante.

<i>Formalités

La société absorbante:
* effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
* fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-

viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,

95436

* effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

<i>Remise de titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous

ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs
aux éléments et droits apportés.

<i>Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

<i>Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour

toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et

faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés

commerciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'art. 278 de la loi sur les sociétés.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant et interprétation lui donnée en une langue de lui connue, le mandataire des parties

comparantes, es qualité qu'il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom état et demeure, a signé avec le
notaire le présent acte.

Signé: Fabienne Perusini, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., LAC/2009.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 septembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009127439/107.
(090154369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Beech Tree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.829.275,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 85.327.

Camilia Holding BV, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 113.750,00.

Siège de direction effectif: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 87.531.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 1248 du 30 juin 2009, page 59880, la publication de l'acte de

projet de fusion passé devant le notaire Martine Schaeffer en date du 26 juin 2009:

1) L'en-tête doit être complété par la désignation de la société absorbée:
«Camilia Holding BV, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 113.750.
Siège de direction effectif: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 87.531.»
2) Sous l'en-tête doit être ajouté le titre «PROJET DE FUSION».
Référence de publication: 2009127559/5770/20.

95437

Manus S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 28.954.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>22 octobre 2009 à 10.00 heures, pour

délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice

clos au 30 juin 2009,

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009123823/17.

Mont Blanc Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 99.782.

Les actionnaires sont convoqués à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>29 octobre 2009 à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 21 septembre 2009, les conditions de quorum de présence requises

par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de
la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009122103/29/18.

Fortis LDI Solution, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46B, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 108.079.

The

STATUTORY GENERAL MEETING

will be held on Monday <i>26th October, 2009 at 10 a.m., in the Premises of FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT

LUXEMBOURG S.A., located at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, in order to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and the report from the Company Auditor;
2. Approval of the accounts for the financial period closed as at 30th June 2009 and the appropriation of the results

from the financial period;

3. Discharge to the Directors for the performance of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares,

at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned
in the prospectus.

95438

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of

their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the
Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will

be taken by a simple majority of the shares present or represented. Every share, whatever its unit value, gives the right
to one vote.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009123141/755/27.

Eurizon Multimanager Stars Fund, Fonds Commun de Placement.

Le Règlement de Gestion du fonds commun de placement de droit luxembourgeois, EURIZON MULTIMANAGER

STARS FUND, signé par la société de gestion EURIZON CAPITAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté, n. RC B 28.536, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURIZON CAPITAL S.A.
Jérome Debertolis
<i>Head of Legal &amp; Finance

Référence de publication: 2009127446/12.
(090152308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2009.

La Iolla S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 64.106.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>26 octobre 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009123639/534/16.

Fortis Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46B, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.580.

The

STATUTORY GENERAL MEETING

will be held on Monday <i>26th October, 2009 at 11 a.m., in the Premises of FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT

LUXEMBOURG S.A., located at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange., in order to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and the report from the Company Auditor;
2. Approval of the accounts for the financial period closed as at June 30, 2009 and the appropriation of the results

from the financial period;

3. Discharge to the Directors for the performance of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares,

at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned
in the prospectus.

95439

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of

their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the
Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will

be taken by a simple majority of the shares present or represented. Every share, whatever its unit value, gives the right
to one vote.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009123143/755/27.

Tasman Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.681.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises le 1 

<i>er

<i> septembre 2009

L'unique Associé de Tasman Properties S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Doeke van der Molen, né le 1 

er

 mars 1968 à Hengelo (Pays-Bas), avec adresse profes-

sionnelle, au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15
septembre 2009,

- de nommer Christelle Ferry, née le 10 octobre 1970 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 2-8 Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15 septembre 2009.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Fabrice Geimer
Christelle Ferry

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

Fabrice Geimer
<i>Gérant

Référence de publication: 2009122273/22.
(090147059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Tanarive Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.844.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises le 1 

<i>er

<i> septembre 2009

L'unique Associé de Tanarive Properties S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Doeke van der Molen, né le 1 

er

 mars 1968 à Hengelo (Pays-Bas), avec adresse profes-

sionnelle, au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15
septembre 2009,

- de nommer Christelle Ferry, née le 10 octobre 1970 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 2-8 Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15 septembre 2009.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Fabrice Geimer
Christelle Ferry

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

Fabrice Geimer
<i>Gérant

Référence de publication: 2009122274/22.
(090147052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

95440

Sesa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 73.872.

Veuillez prendre note du changement d'adresse du commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée Kohnen

&amp; Associés S.à r.l., qui se situe désormais à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SESA S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009122348/14.
(090147060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Heralda S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 15.872.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 octobre 2009 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2009.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009123640/1023/16.

Kauri Capital Gewerbepark Alt-West, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 440.250,00.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 119.755.

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 24 juillet 2009 que:
- Madame Geneviève Blauen-Arendt, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- Monsieur Peter Dickinson, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg,

- Monsieur Paul Le Marquand, directeur de sociétés, domicilié à Les Jours, La Grande Route de St Jean, St John, Jersey,

JE3 4FL, Channel Islands, United Kingdom,

- Monsieur Colin Borman, directeur de sociétés, domicilié à La Franchette, La Petite Route des Miellés, St Brelade,

Jersey, JE3 8FA, Channel Islands, United Kingdom,

ont été reconduits dans leurs fonctions de gérants jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour KAURI CAPITAL GEWERBEPARK ALT-WEST
Signatures

Référence de publication: 2009122290/23.
(090147662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

95441

Sargos Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.456.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises le 1 

<i>er

<i> septembre 2009

L'unique Associé de Sargos Properties S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Doeke van der Molen, né le 1 

er

 mars 1968 à Hengelo (Pays-Bas), avec adresse profes-

sionnelle, au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15
septembre 2009,

- de nommer Christelle Ferry, née le 10 octobre 1970 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 2-8 Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15 septembre 2009.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Fabrice Geimer
Christelle Ferry

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

Fabrice Geimer
<i>Gérant

Référence de publication: 2009122275/22.
(090147048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Xaro S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 70.698.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le vendredi 4 septembre 2009

<i>à 11.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Cosafin S.A., représentée par Jacques

Bordet, 10 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Monsieur Koen LOZIE, 18 rue des sacrifiés, L-8356 Garnich, ainsi que
le mandat de Pierre SCHILL, 18A boulevard de la foire, L-1528 Luxembourg, comme Commissaire aux Comptes. L'As-
semblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Joseph WINANDY, 92 rue de l'horizon L-5960 ITZIG, au poste de
Président du Conseil d'Administration et Administrateur en remplacement de Monsieur Jean QUINTUS.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.03.2010.

Extrait certifiée conforme
FIDUPAR
10, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009122538/21.
(090147345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

LSF Hotels Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 70.478.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009123512/10.
(090148499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

95442

Advent Pawlux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 166.407,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.399.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009123446/14.
(090148831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Valamoun S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 38.880.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VALAMOUN S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009123499/12.
(090148475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

SBF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 108.036.

Les comptes annuels au 31/12/2008 régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée

du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009123532/15.
(090148436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Orascom Telecom Finance, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.862.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orascom Telecom Finance
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009123498/12.
(090148471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

95443

Libo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 59.814.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2008

Le mandat du réviseur d'entreprise, B.D.O compagnie Fiduciaire arrive à terme, et l'assemblée générale confie le

contrôle des comptes annuels des exercices 2008, 2009 et 2010 à la société PricewaterhouseCoopers, réviseur d'en-
treprise, ayant son siège à Luxembourg, 400 route d'Esch. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se
tiendra en 2011.

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Géraldine WEBER.
L'assemblée générale décide de renouveler les autres mandats des administrateurs, qui viennent à échéance, à savoir:
M. Egon SEYWERT, président, demeurant à 1, rue de l'Eglise, L-3378 Livange
M. Jean-Paul TERNES, administrateur, demeurant à 43, Domaine op Hals, L-3376 Leudelange
M. Dirk SUMKÖTTER, administrateur, demeurant à 1, rue Aloyse Ludovissy, L-5898 Syren
pour une nouvelle période de trois (3) ans, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2009.

Egon SEYWERT
<i>Président du conseil d'administration

Référence de publication: 2009123545/22.
(090148649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

EF Cultural Tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 360.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 65.074.

<i>Extrait du contrat de vente de parts sociales du 7 mai 2009

Entre:
Hantera Management Sàrl, société de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxem-

bourg

Ci-après "l'Acheteur"
Et:
Mme Louise Jullian,, Haldenstrasse 4, CH-6006 Lucerne, propriétaire de 288 parts sociales
Ci-après "le Vendeur"
Le Vendeur vend et transfère irrévocablement à l'Acheteur, qui accepte, avec effet au 7 mai 2009, un total de 288

parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EF Cultural Tours Sàrl
Signature

Référence de publication: 2009123546/21.
(090148665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

LSF Hotels Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 70.478.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009123511/10.
(090148498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2009.

95444

Pluton Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.859.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises le 1 

<i>er

<i> septembre 2009

L'unique Associé de Pluton Properties S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Doeke van der Molen, né le 1 

er

 mars 1968 à Hengelo (Pays-Bas), avec adresse profes-

sionnelle, au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15
septembre 2009,

- de nommer Christelle Ferry, née le 10 octobre 1970 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 2-8 Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15 septembre 2009.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Fabrice Geimer
Christelle Ferry

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

Fabrice Geimer
<i>Gérant

Référence de publication: 2009122276/22.
(090147035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Financière VLH, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 90.555.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation conclu et signé entre:
Société domiciliée: Financière VLH S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
R.C.S. Luxembourg B 90 555
et
Domiciliataire: Maitland Luxembourg S.A.
Société Anonyme
58, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 13583
en date du 30 décembre 2002 est terminé à partir du 17 septembre 2009.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Maitland Luxembourg S.A.
John Kleynhans
<i>Day-to-day manager

Référence de publication: 2009122585/21.
(090147395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

NEP Prievidza S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 141.257.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009123151/10.
(090147880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2009.

95445

Palor Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.458.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique de la société prises le 1 

<i>er

<i> septembre 2009

L'unique Associé de Palor Properties S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Doeke van der Molen, né le 1 

er

 mars 1968 à Hengelo (Pays-Bas), avec adresse profes-

sionnelle, au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15
septembre 2009,

- de nommer Christelle Ferry, née le 10 octobre 1970 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 2-8, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 15 septembre 2009.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Fabrice Geimer
Christelle Ferry

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

Fabrice Geimer
<i>Gérant

Référence de publication: 2009122277/22.
(090147028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Lighting Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 92.881.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 9 septembre 2009, enregistré à Luxembourg AC, le 11 septembre 2009, LAC/2009/36858, aux droits de soixante-
quinze euros (75.- EUR), que la société "LIGHTING HOLDINGS S.A. (en liquidation)", R.C.S Luxembourg Numéro B
92.881 ayant son siège social à L-1746 Luxembourg au 2, rue J. Hackin, constituée par acte du notaire Paul BETTINGEN,
de résidence à Niederanven, en date du 19 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
485 du 6 mai 2003, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du même notaire,
en date du 23 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 873 du 9 septembre 2005,

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents de la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans après la clôture de liquidation chez

Equity Trust Co.(Luxembourg) S.A., L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F.Kennedy.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de radiation au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009122572/21.
(090147394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

I.B.T. International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 80.817.

Le bilan de clôture au 04/09/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009123058/10.
(090147863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2009.

95446

MOV'IT International, Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 77, Ceinture Um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 148.249.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the third of September.
Before the undersigned Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);

APPEARED:

Mr. Guido FRENSEMEYER, engineer, professionally residing in D-77855 Achern, Rennwiese 4, (Federal Republic of

Germany),

here represented by Mr. Christian DOSTERT, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster, 3, route

de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the
proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing person, represented as said before, has required the officiating notary to enact the articles of association

of a public limited company ("Aktiengesellschaft"), which he deems to incorporate, as follows:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art.  1.  There  exists  a  public  limited  company  ("Aktiengesellschaft")  under  the  name  of  "MOV'IT

INTERNATIONAL" (hereafter the "Company"), governed by the relevant legal dispositions as well as by these articles
of association (the "Articles").

Art. 2. The registered office of the Company is established in the municipality of Hesperange.
By a simple decision of the board of directors, branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be esta-

blished in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision

of the shareholders' meeting.

Art. 3. The duration of the Company is unlimited.

Art. 4. The main purpose of the Company is the production and distribution of brake systems as well as the trading

of any vehicle spare parts and other related products and services, owned or licensed from others.

The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated

companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same
group of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and
without carrying on a bank business or of the financial sector.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security

for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are

in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at two hundred thousand Euros (200,000.- EUR), divided into

twenty thousand (20,000) shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) each.

The board of directors or the single director, as the case may be, is authorised to create such capital reserves from

time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in
surplus from funds received by the Company as issue premiums on the issue and sale of its shares, which reserves or
paid in surplus may be used by the board of directors to provide for setting off any realized or unrealized capital losses
or for the payment of any dividend or other distribution.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the shareholders, except for those shares for which

the law prescribes the registered form.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates re-

presenting two or more shares.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

95447

Title III. - Management

Art. 6. The Company is managed by a board of directors comprising at least three (3) members, whether shareholders

or not.

In the situation of the Company only having one single shareholder, only one (1) director may administer the Company,

regardless whether being a natural person or a legal entity.

Unless otherwise specified herein, all powers given to the board of directors in these Articles shall also apply to the

single director in case of appointment of only one director by the single shareholder.

If a director is a legal entity, it shall designate a permanent representative (the "Permanent Representative") residing

in Luxembourg.

Members of the board of directors or the single director are appointed for a period not exceeding six (6) years by

the general meeting of shareholder(s) which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholder(s).
The office of a director shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the Company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the shareholder(s).
Insofar as the law allows, every present or former director of the Company shall be indemnified out of the assets of

the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

Art. 7. If existing, the board of directors elects from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It

must be convened each time one (1) director so requests.

All meetings of the board of directors shall be held in Luxembourg.
The board of directors shall validly resolve on any matters if a majority of its members is present or represented.
In the event of an emergency, resolutions signed by all members of the board of directors or by the single director,

as the case may be, will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may
appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar
communication. Written resolutions will be delivered to and kept at the registered office of the Company.

In addition and generally in cases of emergency decision-finding, any member of the board of directors who participates

in the proceedings of a meeting of the board of directors by means of a communication device (including a telephone),
which allows all the other members of the board of directors present at such meeting (whether in person or by proxy
or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be
deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on
matters considered at such meeting.

Art. 8. The single director or the board of directors, as the case may be, is/are vested with the broadest powers to

perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholder

(s) fall within the competence of the board of directors or the single director, as the case may be.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. If a board of directors is existing, the Company will be validly bound by the sole signature of the delegate of

the board of directors of the Company or by the joint signature of two directors.

If only one director exists, the Company will be bound by the signature of such director. If the single director is a legal

entity, the signature shall be considered if given in accordance with the corporate documents and authorisation in place
for such legal entity. The legal entity being director may authorise the Permanent Representative to sign for the Company.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or

more directors, who will be called managing directors.

The board of directors or the single director, as the case may be, may also commit the management of all the affairs

of the Company or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one
or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

Company by the board of directors or the single director, as the case may be, represented by its chairman or by the
director delegated for this purpose.

95448

Title IV. - Supervision

Art. 12. The Company is supervised by one or several statutory auditors. The general meeting of shareholder or the

single shareholder, as the case may be, will appoint the auditor(s) and fix their number and their remuneration, as well
as the term of their office, which shall not exceed six (6) years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual general meeting is held on the third Monday of the month of April at 12.00 o'clock at the registered

office or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
All other general meetings of shareholder(s) shall also be held in the Grand-Duchy of Luxembourg.
The general meeting may validly resolve by the vote of the majority of present or represented shares at the annual or

an extraordinary general meeting unless Luxembourg law or these Articles stipulate different quorum and voting requi-
rements.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the 1 

st

 of January of each year and shall terminate on the

31 

st

 of December of the same year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the Company.

Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve
is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the capital of the
Company.

The remainder amount after deduction of the legal reserve is at the disposal of the general meeting of shareholders

or the single shareholder, as the case may be.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders or by decision of the

single shareholder, as the case may be. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more
liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholder(s) which will specify their powers
and fix their remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory dispositions

1. The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and ends on the 31 

st

 of December

2009.

2. The first annual general meeting will be held in the year 2010.
3. Exceptionally, the first chairman and the first delegate of the board of directors may be nominated by the first

General Meeting of the shareholders.

<i>Subscription and Payment of the shares

The Articles having thus been established, the twenty thousand (20,000) shares have been subscribed by the sole

shareholder Mr. Guido FRENSEMEYER, prenamed, and fully paid up by the transfer of all the shares (the "Shares") of the
private limited company of German law "mov'it GmbH", with registered office in D-77855 Achern, Rennwiese 4, inscribed
in the Trade Registry of the district court of Mannheim under the number HRB 220791.

<i>Report of the independent auditor

In accordance with article 26-1 and 32-1 of the amended law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, the

valuation of the contribution in kind has been confirmed by a report dated September 1 

st

 , 2009 and established by the

independent auditor "PKF Abax Audit", with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, which concludes
as follows:

<i>Conclusion

"On the basis of our diligences, no fact was carried to our attention which lets us believe that the total value of the

contribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value of the shares to be emitted as a
counterpart.

95449

This report is produced solely for the purpose of reporting on the description and valuation of the contribution in

kind as if the requirements of Articles 26-1 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently
modified were to apply. It should not be used for any other purpose without our express written consent."

This report, signed "ne varietur" by the mandatory of the appearing person and the officiating notary, will remain

attached to the present deed in order to be recorded with it.

<i>Effective implementation of the contribution

The aforesaid subscriber Mr. Guido FRENSEMEYER declares as contributor:
- that the Shares is fully paid up;
- that he is the legal owner of all of the Shares being contributed, which are unencumbered and legally and conventionally

freely transferable to the Company;

- that all the transfer formalities have been complied with and there are no pre-emption rights nor any other rights

attached to the Shares by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be
transferred to him;

- that he has all corporate powers to accomplish and execute all documents necessary to the present transfer of shares;
- that all formalities shall be carried out in Germany in order to formalise the present contribution in kind and to

render it effective as at the date indicated at the beginning of the document anywhere and towards any third party.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10 

th

 ,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand six hundred Euros.

<i>Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of

the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The registered office of the Company is established at 77, Ceinture Um Schlass at L-5880 Hesperange.
2. The number of directors is fixed at four (4) and that of the auditors at one (1).
3. The following persons have been appointed as directors of the Company:
a) Mr. Guido FRENSEMEYER, engineer, bom in Buhl, on the 19 March 1973, professionally residing in D-77855 Achern,

Rennwiese 4, (Federal Republic of Germany);

b) Mr. Frank SCHERER, Business Development Manager, born in Bühl, on the 22 January 1971, residing in D-77815

Bühl, Karl-Reinfriedstrasse 8, (Federal Republic of Germany);

c) Mr. Gérard LOPEZ FOJACA, companies' director, born in Luxembourg, on the 27 

th

 of December 1971, residing

in L-4039 Esch/Alzette, 17, rue du Bourgrund;

d) Mr. Eric LUX, companies' director, born in Luxembourg, on the 19 

th

 of December 1967, residing in L-5880 Hes-

perange, 77, Ceinture um Schlass.

4. The public limited company "PKF Abax Audit", with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,

inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 142867, is appointed as
statutory auditor.

5. Following the faculty offered by point 3) of the transitory dispositions, the meeting appoints Mr. Guido FRENSE-

MEYER, prenamed:

- as chairman of the board of directors, and
- as managing director, with power to bind validly of the Company by his individual signature within the daily mana-

gement of the Company.

6. The mandates of the directors, the managing director and the statutory auditor will expire at the general annual

meeting in the year 2015, unless they previously resign or are revoked.

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English and German, states herewith that the present deed is

worded in English followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between
the English and the German version, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the mandatory of the appearing person, acting as said before, known to the notary by

first and last name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present original deed.

95450

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendneun, den dritten September.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr  Guido  FRENSEMEYER,  Ingenieur,  beruflich  wohnhaft  in  D-77855  Achern,  Rennwiese  4,  (Bundesrepublik

Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de

Luxembourg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer Aktien-

gesellschaft, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "MOV'IT INTERNATIONAL", (hiernach die "Gesell-

schaft"), geregelt durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen sowie die gegenwärtigen Statuten (die "Statuten").

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Hesperingen festgelegt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im

Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der  Gesellschaftssitz  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum

verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Hauptzweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Bremssystemen sowie Handel mit

Kraftfahrzeugen  und  KFZ-Ersatzteilen,  und  allen  untergeordneten  und  ähnlichen  selbst  gehaltenen  oder  lizenzierten
Dienstleistungen oder Produkten.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Un-

ternehmen,  die  zu  der  gleichen  Gruppe  gehören,  unter  Vorbehalt  und  Beachtung  der  diesbezüglich  zur  Anwendung
gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des
Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unter-
stützen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR), eingeteilt in

zwanzigtausend (20.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,- EUR).

Der Verwaltungsrat oder der Einzelvorstand, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er

es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte Über-
schüsse, welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder nicht
realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.

Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder

mehrere Aktien umfassen können.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

95451

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche

Aktionäre sein können.

Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Einzelvorstand die Geschäfte der Ge-

sellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.

Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat

zugewiesen werden, auch dem Einzelvorstand zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.

Sollte ein Vorstandsmitglied oder Einzelvorstand eine juristische Person sein, so ernennt dieser Vorstand einen per-

manenten Vertreter (der "Permanente Vertreter"), welcher in Luxemburg residiert.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand werden durch die Generalversammlung der Aktionäre

für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen
kann.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Ge-

neralversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:
- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist

oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;

- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft,

oder

- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.
Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der

Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats
als Mitglied entstanden sind.

Art. 7. Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft

notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Vorstandsmitglied dies verlangt.

Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Be-

schlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abge-
haltenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand sie unterzeichnet
haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren
Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommu-
nikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort
aufbewahrt werden.

In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommuni-

kationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich
eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder
anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von
diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels
bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam
über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.

Art. 8. Der Einzelvorstand oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle

Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen

in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Einzelvorstandes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 9. Wenn ein Verwaltungsrat besteht, wird die Gesellschaft rechtmäßig durch die Einzelunterschrift des Delegierten

des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder durch die Kollektivunterschrift von Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters wirksam

gebunden. Ist der Alleinverwalters eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Gesellschafts-
dokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden. Diese juristische Person, welche Alleinverwalter ist,
kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner

Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.

95452

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten

eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten
Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft
sein müssen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des

Verwaltungsrates, oder der Einzelvorstand, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Na-
men der Gesellschaft.

Titel IV. - Aufsicht

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare

werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r)
auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf, bestimmt.

Titel V. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung wird am dritten Montag des Monats April um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz

oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.

Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag

stattfinden.

Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls im Großherzogtum Luxemburg statt.
Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertre-

tenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz
oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.

Titel VI. - Geschäftsjahr / Gewinnverwertung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren

Nettogewinn aus.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet

sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht
hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen
werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.

Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vor-

handen, frei verfügen.

Titel VII. - Auflösung und Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des

Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren
Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt
werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.

Titel VIII. - Allgemeine Vorschriften

Art. 17. Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes

vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen zu diesem Gesetz.

<i>Vorübergehende Bestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2010 statt.
3. Ausnahmsweise können der erste Vorsitzende und der erste Delegierte des Verwaltungsrates von der ersten Ge-

neralversammlung der Aktionäre ernannt werden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die zwanzigtausend (20.000) Aktien durch den alleinigen

Gesellschafter  Herrn  Guido  FRENSEMEYER,  vorgenannt,  gezeichnet  und  voll  eingezahlt  durch  Einbringen  sämtlicher
Anteile (die "Anteile") der Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechtes "mov'it GmbH", mit Sitz in D-77855
Achern, Rennwiese 4, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter der Nummer HRB 220791.

95453

<i>Bericht des unabhängigen

<i>Wirtschaftsprüfers

Gemäß Artikel 26-1 und 32-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wird

dieses Einbringen durch ein auf den 1. September 2009 Gutachten des unabhängigen Wirtschaftsprüfers "PKF Abax Audit",
mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy, bescheinigt, dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

<i>Schlussfolgerung

"On the basis of our diligences, no fact was carried to our attention which lets us believe that the total value of the

contribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value of the shares to be emitted as a
counterpart.

This report is produced solely for the purpose of reporting on the description and valuation of the contribution in

kind as if the requirements of Articles 26-1 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently
modified were to apply. It should not be used for any other purpose without our express written consent."

Dieses Gutachten, vom Bevollmächtigten des Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet,

bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Tatsächliche Ausführung der Sacheinlage

Der vorgenannte Zeichner Herr Guido FRENSEMEYER erklärt in seiner Eigenschaft als Einbringer:
- dass die Anteile voll eingezahlt sind;
- dass er der der rechtliche Eigentümer der einzubringenden Anteile ist, welche unbelastet und der Gesellschaft ge-

setzlich und vertraglich frei übertragbar sind;

- dass alle Übertragungsformalitäten erfüllt wurden und dass weder Vorkaufsrechte, noch andere Rechte den Anteile

anhaften, die eine Person berechtigen würden, zu verlangen, dass eine oder mehrere Anteile an ihn übertragen werden;

- dass er alle gesellschaftlichrechtlichen Berechtigungen besitzt um alle notwendigen Dokumente für die vorliegende

Übertragung der Anteile auszuführen;

- dass alle Formalitäten bezüglich vorliegender Sacheinlage in Deutschland durchgeführt werden und sie damit überall

and gegenüber Drittparteien rechtskräftig zu machen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie

abgeändert, beachtet und erläutert wurden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendsechshundert
Euro.

<i>Beschlussfassung des alleinigen

<i>Gesellschafters

Unverzüglich  nach  der  Gründung  der  Gesellschaft,  hat  der  Komparent,  welcher  das  gesamte  gezeichnete  Gesell-

schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft wird auf 77, Ceinture Um Schlass in L-5880 Hesperingen, festgelegt.
2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier (4) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
3. Folgende Personen sind zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannt worden:
a) Herr Guido FRENSEMEYER, Ingenieur, geboren in Bühl, am 19. März 1973, beruflich wohnhaft in D-77855 Achern,

Rennwiese 4, (Bundesrepublik Deutschland);

b) Herr Frank SCHERER, Business Development Manager, geboren in Bühl, am 22. Januar 1971, wohnhaft in D-77815

Bühl, Karl-Reinfriedstrasse 8;

c) Herr Gerard LOPEZ FOJACA, Gesellschaftsverwalter, geboren in Luxemburg, am 27. Dezember 1971, wohnhaft

in L-4039 Esch/Alzette, 17, rue du Bourgrund;

d) Herr Eric LUX, Gesellschaftsverwalter, geboren in Luxemburg, am 19. Dezember 1967, wohnhaft in L-5880 Hes-

peringen, 77, Ceinture um Schlass.

4. Die Aktiengesellschaft "PKF Abax Audit", mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy, eingetragen im Han-

delsund  Gesellschaftsregister  von  Luxemburg,  Sektion,  unter  der  Nummer  142867,  wird  zum  Rechnungskommissar
bestellt.

5. Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht, ernennt die General-

versammlung Herrn Guido FRENSEMEYER, vorgenannt, zum:

- Vorsitzenden des Verwaltungsrates, und

95454

- Delegierten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis die Gesellschaft, im Rahmen der täglichen Geschäftsführung,

rechtmäßig durch seine Einzelunterschrift zu verpflichten.

6. Die Mandate des Verwaltungsratsmitglieder, des Delegierten des Verwaltungsrates und Rechnungskommissars en-

den beim Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2015, es sei denn, sie treten vorher zurück oder
werden abgewählt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische und deutsche Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die

vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag des Kom-
parenten und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
massgebend.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, handelnd wie hiervor erwähnt,

dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat der besagte Bevoll-
mächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: DOSTERT; J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 2009. Relation GRE/2009/3216. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur ff.

 (signé): HIRTT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial;

Junglinster, den 24. September 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009124020/443.
(090149292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Coiffure Paulo Machado Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3650 Kayl, 15, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.807.

EXTRAIT

Monsieur Paulo Jorge MEIRELES MACHADO, associé et gérant unique, déclare par la présente, que son adresse est

la suivante:

35, an der Soibelkaul, L-3583 DUDELANGE.

Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Pour servir et valoir ce que de droit
Paulo Jorge MEIRELES MACHADO

Référence de publication: 2009122380/14.
(090147537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Northam Property Funds Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 140.838.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de

<i>Northam Property Funds Management S.à r.l. (la "Société") prise en date du 17 août 2009

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société que les mandats de M. Patrick W.A. Handreke, M. Jean-

Conrad Hottinger, M. Thomas Melchior et Son Altesse Royale Guillaume de Luxembourg en tant que gérants de la Société
sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- M. Patrick W.A. Handreke;
- M. Jean-Conrad Hottinger;
- M. Thomas Melchior; et
- Son Altesse Royale Guillaume de Luxembourg.
Par ailleurs, l'actionnaire unique a décidé de renouveler le mandat de BDO Compagnie Fiduciaire S.A. comme réviseur

agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

95455

Luxembourg, le 18 septembre 2009.

<i>Pour Northam Property Funds Management S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009122282/25.
(090147634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Kauri Capital 5, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 324.900,00.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 123.781.

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 24 juillet 2009 que:
- Madame Geneviève Blauen-Arendt, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- Monsieur Peter Dickinson, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg,

- Monsieur Paul Le Marquand, directeur de sociétés, domicilié à Les Jours, La Grande Route de St Jean, St John, Jersey,

JE3 4FL, Channel Islands, United Kingdom,

- Monsieur Colin Borman, directeur de sociétés, domicilié à La Franchette, La Petite Route des Mielles, St Brelade,

Jersey, JE3 8FA, Channel Islands, United Kingdom,

ont été reconduits dans leurs fonctions de gérants jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour KAURI CAPITAL 5
Signatures

Référence de publication: 2009122293/23.
(090147643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Kauri Capital 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 753.200,00.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 119.751.

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 24 juillet 2009 que:
- Madame Geneviève Blauen-Arendt, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- Monsieur Peter Dickinson, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg,

- Monsieur Paul Le Marquand, directeur de sociétés, domicilié à Les Jours, La Grande Route de St Jean, St John, Jersey,

JE3 4FL, Channel Islands, United Kingdom,

- Monsieur Colin Borman, directeur de sociétés, domicilié à La Franchette, La Petite Route des Mielles, St Brelade,

Jersey, JE3 8FA, Channel Islands, United Kingdom,

ont été reconduits dans leurs fonctions de gérants jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour KAURI CAPITAL 1
Signatures

Référence de publication: 2009122297/23.
(090147626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

95456

Fili, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.594.

<i>Résolutions prises par l'Assemblée Générale

<i>Ordinaire qui s'est tenue de façon extraordinaire le 16 juin 2009

<i>Cinquième Résolution

L'Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Kurt JAIS NIELSEN de sa fonction d'administrateur

au sein de la société.

L'Assemblée DECIDE de réélire les Administrateurs de la Société, à savoir:
- Monsieur Idriss KOUNTA, Administrateur des Sociétés, demeurant professionnellement 41, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg;

- Monsieur Roger GREDEN, Administrateur de Sociétés, demeurant 4A, rue l'Ouest, L-2273 Luxembourg;
- Monsieur Alain DEVRESSE, demeurant professionnellement 41, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs susmentionnés de la Société expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des

Actionnaires de la Société devant se tenir le 10 juin 2010 pour statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour FILI
Signature

Référence de publication: 2009122299/22.
(090147620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

C 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 117.894.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009122778/11.
(090147383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Infrastructure JVCo (Lime) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 120.541.

Suite au contrat intervenu le 7 juillet 2009 entre RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.121.621 et
RREEF Pan-European Infrastructure Co-investment Two Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 130.844, l'actionnariat de la Société est composé de la
manière suivante:

- RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l. détient 83116 parts sociales de la Société; et
- RREEF Pan-European Infrastructure Co-investment Two Lux S.à r.l. détient 16884 parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Infrastructure JVCO (Lime) S.àr.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009122973/20.
(090147977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2009.

95457

Agence Générale de Marques et de Brevets S.E., Société Européenne,

(anc. Agence Générale de Marques et de Brevets, Soparfi).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 15.898.

In the year two thousand nine, on twentieth day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of AGENCE GENERALE DE MARQUES ET DE

BREVETS, Soparfi, a public limited liability company (société anonyme), with a share capital of four hundred fifty-six
thousand United States dollars (USD 456,000), having its registered office at 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 15.898 (the Company), incor-
porated by a notarial deed dated May, 8, 1978, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations,
number 150 of July, 14, 1978. The articles of association of the Company were amended for the last time by a deed of
Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, dated October 16, 2001, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations, number 336 of February 28, 2002.

The meeting is opened at by Ms Sylwia Zdon, jurist, professionally residing in Luxembourg in the chair, who appointed

as secretary Mrs Rachel UHL, jurist, professionally residing in Luxembourg,

The meeting elected as scrutineer Ms Lucie Orard, jurist, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Presentation and approval of the conversion proposal and of the report issued by the sole director of the Company

in compliance with article 31-3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and of article 37 of
the EC regulation ? 2157/2001 of October 8, 2001 on the statute for a European company (société européenne) in order
to convert a public limited liability company into a European company (société européenne);

2. Change of the legal form of the Company from its current form of a public limited liability company (société anonyme)

into a European company (société européenne);

3. Conversion of the subscribed share capital of the Company into euro;
4. Approval of the draft articles of association of the Company as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations number 1390 of July 18, 2009;

5. Confirmation of the mandate of the statutory auditor of the Company;
II. That the sole shareholder represented, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares is

shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented shareholder and by the bureau
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.  That  the  whole  share  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  the  sole  shareholder  represented

declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notice was
necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

A certified copy of the share register of Clarke, Modet &amp; Companhia, Sociedade Unipessoal LDA, a company governed

by the laws of Portugal, having its registered office at 50, 9°, rua Castilho, Lisboa Concelho, Lisboa Freguesia, Coraçao
de Jesus 1250 68, Lisbon, Portugal, registered with the trade register of Portugal under number 36.826 has been provided
to the notary who expressly declares that according to this copy, the Company has been for more than two (2) years
the sole shareholder of Clarke, Modet &amp; Companhia, Sociedade Unipessoal LDA, prequalified, which is thus the Com-
pany's subsidiary. Thereafter, the meeting takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting, after presentation of the conversion proposal of the Company into a European company (société eu-

ropéenne) dated June 25, 2009 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1390 of
July 18, 2009 and of the report issued on April 30, 2009 in execution of article 31-3 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended and of article 37 of the EC regulation N° 2157/2001 of October 8, 2001 on the
statute for a European company (société européenne) in order to convert a public limited liability company into a European
company (société européenne) approves the conversion proposal and the report of the sole director of the Company
explaining and justifying the legal and economic aspects of the conversion and the consequences of the adoption of the
form of a European company (société européenne) for the sole shareholder and employees.

95458

<i>Second resolution

The meeting decides to change the legal form of the Company in order to transform it from its current form of a

public limited liability company (société anonyme) into a European company (société européenne) named "AGENCE
GENERALE DE MARQUES ET DE BREVETS S.E.".

In accordance with article 31-3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and of article 37

of the EC regulation N°2157/2001 of October 8, 2001 on the statute for a European company (société européenne) in
order to convert a public limited liability company into a European company (société européenne), a report from Alter
Audit S.àr.l., a company having its registered office at L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 110.675, independent auditor, member of the
Institut des Réviseurs d'Entreprises was established on August 10, 2009, a copy thereof is attached to present deed.

The conclusion of the report is the following:
"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim

financial statements reflecting a net asset value of USD 7,863,150 do not give a true and fair view in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of financial statements."

<i>Third resolution

The meeting approves (i) the decrease of the subscribed share capital from four hundred fifty-six thousand United

States dollars (USD 456,000) to four hundred fifty-five thousand United States dollars (USD 455,000) by cancellation of
one (1) share with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000), (ii) the conversion of the subscribed
share capital of the Company into euro at the exchange rate of one euro (EUR 1) for one United States dollar and forty
cents (USD 1.40) so that the subscribed share capital shall be set at three hundred twenty-five thousand euro (EUR
325,000) represented by four hundred fifty-five (455) shares with a par value of seven hundred fourteen euro and twenty-
eight cents (EUR 714.28) each and (iii) the decrease of subscribed share capital from three hundred twenty-five thousand
euro (EUR 325,000) to three hundred twenty-three thousand fifty euro (EUR 323,050) by reducing the par value of the
shares in the share capital of the Company from seven hundred fourteen euro and twenty-eight cents (EUR 714.28) to
seven hundred and ten euro (EUR 710) so that the subscribed share capital is set at three hundred twenty-three thousand
fifty euro (EUR 323,050) by four hundred fifty-five (455) shares with a par value of seven hundred and ten euro (EUR
710).

As a consequence of the above capital reduction, the amounts of one thousand United States dollars (USD 1,000) and

one thousand nine hundred fifty euro (EUR 1,950) will be paid to the sole shareholder.

<i>Fourth resolution

The meeting approves the draft articles of association of the Company as a result of its conversion into a European

company (société européenne) as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1390 of July
18, 2009 and decides that such articles of association will read as follows:

1. "Form and Name. There exists a European company (société européenne) under the name AGENCE GENÉRALE

DE MARQUES ET DE BREVETS S.E. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), the Council Regulation
(EC) n° 2157/2001 of October 8, 2001 on the statutes for a European company (SE) (the Regulation), as well as by these
articles of association (the Articles).

2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors,
of the board of directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
2.3. The registered office of the Company may be transferred within the European Union in accordance with the

provisions of the Law.

3. Duration.
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the

Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death or dissolution of the single shareholder.

4. Corporate object.
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments

95459

issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities
to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests
in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
risks related to credits, currency exchange and interest rate fluctuations as well as other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose. In the performance of
its financial activities, the Company shall however not carry out and, for the avoidance of doubt, shall refrain from carrying
out, any financial activities that are subject to a license or authorization, unless the Company has obtained such license
or authorization from the financial supervisory authorities.

5. Capital.
5.1. The subscribed share capital is set at three hundred twenty-three thousand fifty euro (EUR 323,050) divided into

four hundred fifty-five (455) shares with a par value of seven hundred and ten euro (EUR 710) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting

of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

6. Shares.
6.1. The shares are in registered form (actions nominatives) or bearer form (action au porteur) at the option of the

shareholder(s).

6.2. For shares in registered form, a shareholders register of the Company shall be kept at the registered office of the

Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each
shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share,
and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in the
shareholders register of the Company.

6.3. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

7. Transfer of shares. Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the shareholders

register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer
satisfactory to the Company.

8. Shareholders' meetings.
8.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The

decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

8.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to all the operations of the Company.

8.3. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company shall be held, in accordance with the Law, in

Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the
registered office as may be specified in the convening notice of such meeting, at 11:00 a.m. on the second Wednesday of
May of each year. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following business day.

8.4. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgment of the sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company, exceptional
circumstances so requires.

8.5. Other meetings of the shareholder(s) of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

9. Notice - Quorum - Powers of attorney - Convening notices.
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.

95460

9.3. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the

Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by

the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Luxembourg official gazette, the Memorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall repro-
duce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his

proxy in writing whether in original, by telefax or cable.

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,

and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.

10. Management.
10.1. The Company shall be managed by a sole director where the Company has only one shareholder and by a board

of directors composed of at least three members in any other cases. The sole director or the members of the board of
directors need(s) not be shareholder(s) of the Company. Any director shall be elected for a term not exceeding six years
and shall be re-eligible.

Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate

a permanent representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf (the Representative). The
Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing
such director's mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity may
only revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.

10.2. The sole director, and in case of plurality of directors, the members of the board of directors shall be elected

by the shareholder(s) of the Company at the general meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine
the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without
cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company.

10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining

directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholder(s) of
the Company.

11. Board meetings.
11.1. In case of plurality of directors, the board of directors of the Company must appoint a chairman among its

members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholder(s)
of the Company.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place

indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least

24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors
of the Company.

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or

represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda,
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or cable, of
each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that
are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the
Company.

11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the

Company by appointing, in writing whether in original, by telefax or cable, another director as his or her proxy.

95461

11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the

Company's directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall
be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any
meeting the number of votes for and against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

11.8. Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

12. Minutes of the board meetings.
12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the

board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any director of the Company.

13. Decisions of the sole director. The decisions of the sole director of the Company are drawn in writing.

14. Powers of the sole director or of the board of directors. The sole director, and in case of plurality of directors,

the board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts
of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law, the Regulation
or by the Articles to the general meeting of shareholder(s) of the Company fall within the competence of the sole director,
and in case of plurality of directors, the board of directors.

15. Delegation of powers. The sole director and in case of plurality of directors, the board of directors of the Company

is authorised to appoint a person, either director or not, without the prior authorisation of the general meeting of the
shareholder(s) of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company. The
board of directors may thus delegate its powers for the conduct of the daily management of the Company, to one or
more agents.

16. Binding signatures.
16.1. The Company shall be bound towards third parties by the single signature of the sole director or by the joint

signature of any two directors of the Company or by the single signature of the chairman of the board of directors in all
matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 15 of these Articles.

16.2. Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the sole

signature of any duly appointed agent of the Company.

16.3. Insofar as administrative matters are concerned, the Company shall be legally bound by the single signature of

any director with respect to administrative matters.

17. Conflict of interests.
17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

17.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

17.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholder(s) of the Company which shall ratify
such transaction.

17.4. In case there is only one shareholder in the Company, article 17.3. does not apply and the transactions that are

entered into between the Company and the director having an opposite interest to the one of the Company are simply
to be recorded in minutes.

17.5. Article 17.3. and 17.4. do not apply when the relevant transactions/operations are made in the normal course of

business of the Company and are entered into on arm's length terms.

18. Statutory auditor.
18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)). The

statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

95462

18.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of shareholder(s) of the Company with or without cause.

19. Accounting year.  The  accounting  year  of  the  Company  shall  begin  on  the  first  January  of  each  year  and  shall

terminate on the thirty-first of December of each year.

20. Allocation of profits.
20.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the

Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

20.2. The general meeting of shareholder(s) of the Company shall determine how the remainder of the annual net

profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best
suits the corporate purpose and policy.

20.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the single director, or in case of plurality

of directors, the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined
by the single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company. The single director, or
in case of plurality of directors, the board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the
conditions and within the limits laid down in the Law.

21. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting

of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event the
Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or
legal entities) named by the general meeting of the shareholder(s) of the Company deciding such liquidation. Such general
meeting of shareholder(s) of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the

Law and the Regulation."

<i>Fifth resolution

The meeting decides to confirm the mandate of the statutory auditor of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the

present deed are estimated at approximately four thousand euros.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingtième jour du mois d'août.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de AGENCE GENERALE DE MARQUES

ET DE BREVETS, Soparfi, une société anonyme ayant un capital social de quatre cent cinquante-six mille dollars des Etats-
Unis  (USD  456.000),  ayant  son  siège  social  au  54,  rue  Charles  Martel,  L-2134  Luxembourg,  inscrite  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 15.898 (la Société), constituée en vertu d'un acte daté du 8 mai 1978, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 150 du 14 juillet 1978. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié de Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 16 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 336, du 28 février 2002.

L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Mlle Sylwia Zdon, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

qui à désigné comme secrétaire Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a élu comme scrutateur Mlle Lucie Orard, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

95463

1. Présentation et approbation du projet de transformation et du rapport rendu par l'administrateur unique de la

Société, conformément à l'article 31-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et à
l'article 37 du règlement CE N° 2157/2001 du 8 octobre 2001 sur le statut de société européenne relatif à la transfor-
mation d'une société anonyme en société européenne;

2. Changement de la forme juridique de la Société de sa forme actuelle de société anonyme en société européenne;
3. Conversion du capital souscrit de la Société en euro;
4. Approbation des statuts de la Société tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro

1390 du 18 juillet 2009;

5. Confirmation du mandat du commissaire de la Société.
II. L'actionnaire unique représenté, la procuration de l'actionnaire représenté ainsi que le nombre d'actions détenues

par lui, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence signée par le mandataire de l'actionnaire unique
représenté ainsi que par le bureau de l'assemblée restera annexée à la présente afin d'être enregistrées par les autorités
chargées de l'enregistrement.

III. La totalité du capital social étant représenté à la présente assemblée et l'actionnaire unique représenté déclarant

avoir dûment pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée, aucune convocation n'a été nécessaire.

IV. La présente assemblée, représentant la totalité du capital, est régulièrement constituée et peut valablement déli-

bérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Une copie certifiée du registre des actionnaires de Clarke, Modet &amp; Companhia, Sociedade Unipessoal LDA, une

société régie par les lois du Portugal, ayant son siège social au 50, 9°, rua Castilho, Lisboa Concelho, Lisboa Freguesia,
Coraçao de Jesus 1250 68, Lisbon, Portugal, inscrite au registre du commerce du Portugal sous le numéro 36.826 a été
fournie au notaire qui déclare expressément que selon cette copie, la Société a été pendant plus de deux (2) ans l'ac-
tionnaire unique de Clarke, Modet &amp; Companhia, Sociedade Unipessoal LDA, préqualifiée, qui est donc la filiale de la
Société. L'assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée, après présentation du projet de transformation de la Société en société européenne daté du 25 juin 2009

et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1390 du 18 juillet 2009 et du rapport émis en date
du 30 avril 2009 en application de l'article 31-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
et de l'article 37 du règlement CE ? 2157/2001 du 8 octobre 2001 sur le statut de société européenne relatif à la trans-
formation  d'une  société  anonyme  en  société  européenne,  approuve  le  projet  de  transformation  et  le  rapport  de
l'administrateur unique expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et les consé-
quences de l'adoption de la forme de la société européenne pour l'actionnaire unique et les salariés.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la forme juridique de la Société de sa forme actuelle de société anonyme en société

européenne sous la dénomination "AGENCE GENERALE DE MARQUES ET DE BREVETS S.E.".

En accord avec l'article 31-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, modifié et de l'article 37 de

règlement CE N 

o

 2157/2001 du 8 octobre 2001 sur le statut de société européenne relatif à la transformation d'une

société anonyme en société européenne, un rapport de Alter Audit S.àr.l., une société ayant son siège social au L-2533
Luxembourg, 69, rue de la Semois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés au numéro B 110.675, auditeur
indépendant, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, a été établi le 10 août 2009, une copie duquel est attachée
à la présente. La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Sur la base de notre revue, nous n'avons constaté aucun élément qui pourrait laisser croire que les bilans intérimaires

reflétant une valeur de l'actif net de USD 7.863.150 ne donnent pas une représentation correcte et sincère conformément
aux réglementations et lois luxembourgeoises applicables à la préparation de bilans".

<i>Troisième résolution

L'assemblée approuve (i) la réduction du capital social souscrit de la Société de quatre cent cinquante-six mille dollars

des Etats-Unis (USD 456.000) à quatre cent cinquante-cinq mille dollars des Etats-Unis (USD 455.000) par l'annulation
d'une (1) action ayant une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000), (ii) la conversion du capital souscrit
de la Société en euro, au taux de change d'un euro (EUR 1) pour un dollar des Etats-Unis et quarante cents (USD 1,40),
de telle sorte que le capital souscrit s'élèvera à trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000) représenté par quatre
cent cinquante-cinq (455) actions avec une valeur nominale de sept cent quatorze euros et vingt-huit cents (EUR 714,28)
chacune et (iii) la réduction du capital social souscrit de la Société de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000) à
trois cent vingt-trois mille cinquante euros (EUR 323.050) par la réduction de la valeur nominale des actions de la Société
de sept cent quatorze euros et vingt-huit cents (EUR 714,28) à sept cent dix euros (EUR 710) de telle sorte que le capital
souscrit s'élèvera à trois cent vingt-trois mille cinquante euros (EUR 323.050) représenté par quatre cent cinquante-cinq
(455) actions avec une valeur nominale de sept cent dix euros (EUR 710).

En conséquence des réductions de capital ci-dessus, les sommes de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000) et mille

neuf cent cinquante euros (EUR 1.950) seront payées à l'actionnaire unique.

95464

<i>Quatrième résolution

L'assemblée approuve les statuts de la Société tels qu'ils résultent de la transformation en société européenne et tels

que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1390 du 18 juillet 2009 et décident que lesdits
statuts seront rédigés comme suit:

1. "Forme et Dénomination. Il existe une société européenne, sous la dénomination de AGENCE GENERALE DE

MARQUES ET DE BREVETS S.E (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), le règlement du Conseil (CE) n°
2157/2001 du 8 octobre 2001 sur le statut de société européenne (SE) (le Règlement) ainsi que par les présents Statuts
(les Statuts).

2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans

les limites de la commune par une décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil
d'administration de la Société.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
2.3. Le siège social de la Société pourra être transféré à l'intérieur de l'Union Européenne en accord avec les dispo-

sitions de la Loi.

3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des action-

naires de la Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.

3.3. La mort, la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

4. Objet social.
4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de parts et d'obli-

gations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les
obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder,
grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie
de ses avoirs.

4.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux
crédits ainsi qu'aux fluctuations de change, de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte. Cependant, à l'occasion de l'accomplissement de ses activités financières,
et pour éviter toute incertitude, la Société s'abstiendra de mettre en oeuvre, une quelconque activité financière qui serait
sujette à un permis ou à une autorisation, à moins que la Société ait obtenu un tel permis ou autorisation des autorités
de surveillance financières.

5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trois cent vingt-trois mille cinquante euros (EUR 323.050) repré-

senté par quatre cent cinquante-cinq (455) actions ayant une valeur nominale de sept cent dix euros (EUR 710) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale de(s)/

de l'actionnaire(s) adoptée de la même manière qu'en matière de modification des Statuts.

6. Actions.
6.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l'actionnaire(s).
6.2. Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et

pourra être examiné par tout actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou
domicile élu, le nombre d'actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d'actions

95465

et les dates respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre
des actionnaires de la Société.

6.3. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions et limites prévues par la loi.

7. Cession des actions. La cession d'actions s'effectue par une déclaration écrite de cession inscrite au registre des

actionnaires de la Société, une telle déclaration de transfert sera exécutée par le cédant et le cessionnaire ou par toute
personne les représentant au moyen de procurations valables. La Société peut accepter comme preuve de la cession tout
document qu'elle jugera approprié.

8. Assemblées des actionnaires.
8.1. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi. Les

décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou prises par écrit.

8.2. En cas de pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée repré-

sente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier
tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

8.3. L'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société se réunit, conformément à la Loi, à Luxembourg,

à l'adresse de son siège social ou à tout autre endroit dans la municipalité du siège social tel que spécifié dans la convocation
de l'assemblée, à 11 heures, le deuxième mercredi de mai de chaque année. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire
à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

8.4. L'assemblée générale annuelle de l'actionnaire/des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si l'admi-

nistrateur  unique,  ou  en  cas  de  pluralité  d'administrateurs,  le  conseil  d'administration  de  la  Société,  estime  que  des
circonstances exceptionnelles l'exigent.

8.5. Les autres assemblées de(s) l'actionnaire(s) de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convo-

cations respectives de chaque assemblée.

9. Convocation - Quorum - Procurations - Avis de convocation.
9.1. Les conditions posées par la loi en matière de délai de convocation et de quorum régiront les convocations et la

tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.
9.3. A moins que la Loi ou les Statuts n'en disposent autrement, les résolutions des assemblées des actionnaires de la

Société dûment convoquée seront valablement prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées et
participant au vote.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification des Statuts ne pourra valablement déli-

bérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les propositions de modification
des Statuts.

9.5. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue

par les Statuts, par des avis publiés deux fois à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée dans
le journal officiel de Luxembourg "le Mémorial" et dans deux journaux luxembourgeois,. L'avis de convocation reprend
l'ordre du jour et indique la date et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer
quelque soit le capital représenté. Au cours de chaque assemblée, les résolutions ne peuvent être prises que par une
majorité représentant les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

9.6. La nationalité de la Société peut être modifiée et l'engagement de ses actionnaires augmenté uniquement avec

l'accord unanime des actionnaires et obligataires de la Société.

9.7. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une

autre personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d'une procuration originale ou par télécopie ou
câble.

9.8. Tout actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou

par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation à l'assemblée sera assimilée à une présence
physique.

9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires de la Société

et considèrent avoir été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être
tenue sans avis de convocation.

10. Administration.
10.1. La Société est administrée par un administrateur unique quand la Société n'a qu'un seul actionnaire et par un

conseil d'administration composé d'au moins trois membres dans tous les autres cas. L'administrateur unique ou les
membres du conseil d'administration n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront nom-
més pour un mandat de six ans maximum et seront rééligibles.

Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la Personne Morale), la Personne

Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et

95466

pour son propre compte (le Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même
responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant
simultanément son successeur.

10.2. L'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs, les membres du conseil d'administration seront

élus par l'(les) actionnaire(s) de la Société. L'(les) actionnaire(s) détermine(nt) également leur nombre, leur rémunération
et la durée de leurs mandats. Un administrateur peut être révoqué à tout moment et de manière discrétionnaire par
l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) de la Société.

10.3. En cas de vacance d'un poste d'administrateur suite au décès, à la démission ou autrement de celui-ci, les admi-

nistrateurs restants peuvent élire par un vote à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

11. Réunions du conseil d'administration.
11.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société nomme parmi ses membres un

président et peut nommer un secrétaire, administrateur ou non, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales de l'actionnaire/des actionnaires de la
Société.

11.2. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans la

lettre de convocation, qui sera, en principe, à Luxembourg.

11.3. La lettre de convocation pour toute réunion du conseil d'administration de la Société est donnée à l'ensemble

des administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel
cas la nature de ces circonstances est spécifiée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil d'ad-
ministration de la Société.

11.4. Une lettre de convocation n'est pas requise si tous les membres du conseil d'administration de la Société sont

présents ou représentés au cours de la réunion et s'ils déclarent avoir été valablement informés et avoir pleine connais-
sance de l'ordre du jour de la réunion. Avec l'accord unanime de chacun des membres du conseil d'administration, il peut
être renoncé à la procédure de convocation par écrit soit en original, soit par télécopie ou câble. Aucune convocation
spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution du conseil
d'administration précédemment adoptée.

11.5. Tout membre du conseil d'administration de la Société ne pouvant assister à une réunion du conseil d'adminis-

tration peut mandater un autre administrateur par écrit soit en original, soit par télécopie ou câble.

11.6.  Tout  administrateur  peut  participer  à  une  réunion  du  conseil  d'administration  de  la  Société  par  conférence

téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence
physique.

11.7. Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la moitié des

administrateurs de la Société sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration de la Société. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas d'égalité des
votes, le président aura la voix prépondérante.

11.8. Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une

réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.

12. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration de la Société seront signés par le président

du conseil d'administration de la Société présidant la réunion ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le secrétaire

(le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.

13. Décisions de l'administrateur unique. Les décisions de l'administrateur unique sont prises par écrit.

14. Pouvoirs de l'administrateur unique ou du conseil d'administration. L'administrateur unique et en cas de pluralité

d'administrateurs le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges afin d'accomplir tous les
actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la
Loi, le Règlement ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires sont de la compétence de
l'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

15. Délégation de pouvoirs. L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration

de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir, administrateurs ou non, sans l'autorisation préalable de
l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les
niveaux de la Société. Le conseil d'administration peut ainsi déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs
administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

95467

16. Représentation.
16.1 La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature individuelle de son administrateur unique ou, par la

signature conjointe de deux administrateurs ou la seule signature du président du conseil d'administration dans tous les
cas ou la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été
donné conformément à l'article 15 des Statuts.

16.2 Dans le cadre de la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers les tiers par la signature indi-

viduelle d'un administrateur-délégué de la Société.

16.3 Dans le cadre des affaires administratives, la Société est valablement engagée envers les tiers par la signature

individuelle de tout administrateur pour tout ce qui est du domaine administratif ces affaires administratives.

17. Conflit d'intérêts.
17.1 Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé

du fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société y a un intérêt ou est un administrateur, un collaborateur, un agent
ou un employé de telle autre société ou entreprise.

17.2 Tout administrateur ou agent de la Société remplissant les fonctions d'administrateur, agent ou employé dans une

société ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d'affaires, sera pris en compte,
prendra part au vote et agira par rapport à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction, indépendamment
de son appartenance à telle autre société ou entreprise.

17.3 Au cas où un administrateur de la Société à un intérêt personnel dans, ou contraire à toute transaction de la

Société, celui-ci en informera le conseil d'administration de la Société et ne sera pas pris en compte ni ne votera eu égard
à cette transaction. Un tel conflit d'intérêts devra faire l'objet d'un rapport à la prochaine assemblée générale de l'ac-
tionnaire/des actionnaires qui ratifiera ladite transaction

17.4 Lorsque la Société comprend un actionnaire unique, l'article 17.3. n'est pas applicable et il est seulement fait

mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé
à celui de la Société.

17.5 L'article 17.3. and 17.4. ne sont pas applicables lorsque des décisions du conseil d'administration ou de l'admi-

nistrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

18. Commissaire aux comptes.
18.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les Commissaires

sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires pour un terme n'excédant pas six ans et seront
rééligibles.

18.2 Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui dé-

termine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) en fonction peuvent être
révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la
Société.

19. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de

chaque année.

20. Affectation des bénéfices.
20.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre conformément à l'article 5
des Statuts.

20.2 L'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société décidera souverainement de l'affectation du

solde restant du bénéfice net qui sera disponible afin d'être distribué. L'assemblée peut notamment, de manière discré-
tionnaire, décider de procéder à la distribution de dividendes.

20.3 Les dividendes sont payés en euros ou dans toute autre devise déterminée par l'administrateur unique, et en cas

de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société et sont payés aux lieux et dates déterminés par
l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration. L'administrateur unique, et
en  cas  de  pluralité  d'administrateurs,  le  conseil  d'administration  de  la  Société  peut  décider  de  payer  des  dividendes
intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

21. Dissolution et Liquidation. La Société peut être à tout moment dissoute par une décision de l'assemblée générale

de l'actionnaire/des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts. En cas de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique
ou morale) nommé(s) par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre
la Société. Cette assemblée générale déterminera, le cas échéant, les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées

en application de la Loi et du Règlement."

95468

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de confirmer le mandat du commissaire aux comptes de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont approximativement estimés à la somme de quatre mille euros.

N'ayant plus de sujet à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, certifie par les présentes qu'à la demande de la partie com-

parante, le présent acte a été créé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu aux parties comparantes, lesdites parties ont signé avec le notaire le présent acte
Signé: S. ZDON, R. UHL, L. ORARD, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 août 2009. Relation: LAC/2009/34474. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 28 AOÛT 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009124925/632.
(090150731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2009.

Sokrates S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-5775 Weiler-la-Tour, 32, rue Emile Marx.

R.C.S. Luxembourg E 3.102.

<i>Extrait du procès-verbal de la décision prise par le gérant en date du 16 septembre 2009

Par décision du gérant de la société, le siège social est transféré avec effet immédiat du 66, rue Dr. Welter à L-3879

Schifflange au 32, rue Emile Marx à L-5775 Weiler-la-Tour.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009122700/12.
(090147801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2009.

Comodot, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 131.365.

<i>Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue de façon extraordinaire au siège social le 2 juin 2009

<i>5 

<i>ème

<i> Résolution

Les mandats des Gérants et du Réviseur d'entreprises étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée  Générale  décide  de  renouveler  avec  effet  immédiat  le  mandat  des  Gérants,  Monsieur  Alain  DEVRESSE,
Monsieur Roger GREDEN et Monsieur Jean-Marc RUTILLET, pour une période venant à expiration à l'issue de l'Assem-
blée Générale Statutaire annuelle devant se tenir le jeudi 18 mars 2010 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels
au 31 décembre 2009.

<i>6 

<i>ème

<i> Résolution

Le mandat du Réviseur d'entreprises étant arrivé à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale

décide de renouveler avec effet immédiat le mandat de PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois dont le siège social est sis au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477, pour une période se terminant à l'issue de l'As-
semblée Générale Annuelle des Associés de la Société devant se tenir le jeudi 18 mars 2010 pour statuer sur l'approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

95469

Pour extrait conforme
<i>Pour COMODOT
Signature

Référence de publication: 2009122300/26.
(090147617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Magellan Management &amp; Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 81-83, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 123.784.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 28 mai

2009, que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur les personnes

suivantes:

Monsieur Jean Claude Ramon, Directeur, demeurant à L-8308 Capellen 81/83 Zone d'activités de Capellen
Monsieur Jean Claude Schaeffer, Banquier, demeurant à L-1129 Luxembourg, 40, rue des Anémones.
Madame Karine Variot, Directeur, demeurant à L-8308 Capellen 81/83 Zone d'activités de Capellen
Monsieur Arnaud Bezzina, Directeur, demeurant à L-8308 Capellen 81/83 Zone d'activités de Capellen
Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2010.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
LUX-AUDIT REVISION SARL, ayant son siège social au 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2010.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le

28 mai 2009, que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social, le

28 mai 2008, le Conseil nomme Monsieur Jean-Claude RAMON, élisant domicile au L-8308 Capellen 81/83 Zone d'ac-
tivités de Capellen «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas DIX MILLE
EURO (10.000,- €) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat,
de la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009122391/30.
(090147213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

S.I.T.P., Société Internationale de Travaux Publics S.a., Société Anonyme.

Siège social: L-6562 Echternach, 107, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 91.527.

Im Jahre zweitausend neun, den achten September.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft Société Internationale de Travaux Publics S.A., in Abkürzung S.I.T.P., mit Sitz in L-9231 Diekirch,
3, rue des Fleurs, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 91.527 (NIN
1979 2200 950),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Aloyse BIEL, mit dem damaligen Amtssitze in Hosingen, am 9.

November 1979, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 5 vom 8. Januar 1980, und
deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse LENTZ, mit dem damaligen
Amtssitze in Remich, am 4. Januar 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 215
vom 18. Mai 1995.

Das Gesellschaftskapital beträgt drei hundert einundsiebzig tausend acht hundert vierzig Euro neundundzwanzig Cent

(€ 371.840,29), eingeteilt in drei tausend (3.000) Aktien.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Jürgen KOHL, Unternehmer, wohnhaft in L-6450 Echternach, 67,

route de Luxembourg,

Er beruft zum Schriftführer Frau Eveline GÖRG, Angestellte, wohnhaft in D-54296 Trier, Stefan-Andres-Strasse 48,

95470

und zum Stimmzähler Herrn Burkhard KOHL, Bauingenieur, wohnhaft in D-54675 Körperich, Bitburger Strasse 24.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Diekirch nach Echternach und dementsprechende Abänderung des ersten

Absatzes von Artikel 2 der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten.

Art. 2. (Absatz 1).
(1) Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.
2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-6562 Echternach, 107, route de Luxembourg.
3.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. (Absatz 1).
(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
4.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
5.- Anpassung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Statuten an die Eurokonvertierung um ihm folgenden Wortlaut

zu geben:

Art. 5. (Absatz 1).
(1) Das Gesellschaftskapital beträgt drei hundert einundsiebzig tausend acht hundert vierzig Euro neunundzwanzig

Cent (€ 371.840,29), eingeteilt in drei tausend (3.000) Aktien ohne Nominalwert.

6.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Diekirch nach Echternach zu verlegen und dem-

gemäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. (Absatz 1).
(1) Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-6562 Echternach, 107, route

de Luxembourg.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

Artikel 3. (Absatz 1).
(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuschaffen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 5 der Statuten an die Eurokonvertierung anzu-

passen, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. (Absatz 1).
(1) Das Gesellschaftskapital beträgt drei hundert einundsiebzig tausend acht hundert vierzig Euro neunundzwanzig

Cent (€ 371.840,29), eingeteilt in drei tausend (3.000) Aktien ohne Nominalwert.

<i>Sechster Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

95471

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: J. KOHL, E. GÖRG, B. KOHL, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 septembre 2009. Relation: ECH/2009/1282. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Echternach, den 16. September 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009122573/80.

(090145779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Immo 777 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.764.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009122696/13.

(090147498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Lirvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 471.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 124.761.

Suite à la conclusion d'un contrat de cession en date du 19 juin 2009, la société EMILIANA FIDUCIARIA S.R.L., Société

de droit italien, ayant son siège social au Via P. Torelli, 52, CAP 43100, Parma, détenteur de 1.884 Parts sociales de classe
B dans le capital social de la société LIRVEST S. à R.L., ayant son siège social au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, a cédé
ses 1.884 parts sociales de classe B à la société ILPII S.C.A. SICAR, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.

Dès lors, il y a lieu de procéder aux modifications suivantes relatives à l'identité des associés ainsi qu'au nombre de

parts sociales détenues par chacun d'eux au sein de la société LIRVEST S. à R.L. comme suit:

A biffer: EMILIANA FIDUCIARIA SRL: 1.884 parts sociales de classe B.

A inscrire: ILP II S.C.A. SICAR: 1.884 parts sociales de classe B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2009.

<i>Pour LIRVEST S. à R.L.
Christophe BLONDEAU / Romain THILLENS
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009122302/22.

(090147574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

95472


Document Outline

Advent Pawlux 2 S.à r.l.

Agence Générale de Marques et de Brevets S.E.

Agence Générale de Marques et de Brevets, Soparfi

Alias Mustang International

Altera Security Fund

Amyrtee Investissement S.A.

Beech Tree S.à r.l.

Belfil S.A.

C 5 S.A.

Camilia Holding BV

Coiffure Paulo Machado Sàrl

Comodot

Courtignac S.A.

Delanceau Strategies S.A.

EF Cultural Tours S.à r.l.

Eurizon Multimanager Stars Fund

Fili

Financière VLH

Fortis LDI Solution

Fortis Solutions

GLL Real Estate Selection Fund

Heralda S.A.

I.B.T. International SA

Immo 777 S.A.

Infrastructure JVCo (Lime) S.à r.l.

Ingenium

Kauri Capital 1

Kauri Capital 5

Kauri Capital Gewerbepark Alt-West

Lacombe Investissement S.A.

La Iolla S.A.

Libo S.A.

Lighting Holdings S.A.

Lirvest S.à r.l.

LSF Hotels Luxembourg S.à r.l.

LSF Hotels Luxembourg S.à r.l.

Lux-Tex Investissements S.A.

Magellan Management &amp; Consulting S.A.

Manus S.A.

Mobileo S.A.

Mont Blanc Investment S.A.

Moseltank A.G.

MOV'IT International

NEP Prievidza S.à r.l.

Northam Property Funds Management S.à r.l.

Olivia

Opus Strategic Value

Orascom Telecom Finance

Orco Germany S.A.

Orco Germany S.A.

Palor Properties S.à r.l.

Pluton Properties S.à r.l.

Sargos Properties S.à r.l.

SBF S.A.

Sesa S.A.

SF Motta S.A.

Société Internationale de Travaux Publics S.a.

Sokrates S.C.I.

Suisse Alpine Energie Nouvelle S.A.

Tanarive Properties S.à r.l.

Tasman Properties S.à r.l.

Valamoun S.A.

Waterl'Eau International S.A.

Xaro S.A.