logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1865

25 septembre 2009

SOMMAIRE

A.C. Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89482

Admiral Participations (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89508

Babcock & Brown Retail Portfolio 4 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89507

Bsome S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89477

Colle Développement S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

89483

CRC Breeze Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

89481

EcoNew Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89508

Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l.  . . . . .

89474

Entreprise J.P. Becker S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

89508

Espace Informatique S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

89481

Espace Promotion Holding . . . . . . . . . . . . . .

89474

Euphorbia Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89479

Eurotime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89520

EvrazSecurities S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89480

G.I.TE.N. Groupe International des Tech-

nologies Naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89484

Goodman European Business Park Fund

(Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89506

H Chateau VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89501

H.L. Heavy Load S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89479

ILU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89484

Immobilière D.P. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

89479

Information, Systèmes et Développement

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89478

International Restaurants Group S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89476

Investmarket Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

89478

Julius Baer Multiselect I  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89520

Kairós Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89477

KPI Residential Property 19 S.à.r.l.  . . . . . .

89507

KSM Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89518

Lizo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89480

LSF5 Giga Investments S.àr.l.  . . . . . . . . . . .

89474

Matrix Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89482

Minlam Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

89508

NewWorks Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89477

Oikia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89478

Optivita Securitisation S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

89480

Orbital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89481

Oriflame Cosmetics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

89482

Partners Group European Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89485

Partners Group European Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89488

Partners Group European Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89495

Partners Group European Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89491

Patron Wilanow S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89476

Perseus Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

89478

Postbahnhof an der Spree 1, Berlin S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89484

Pro Sport S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89475

Pro Sport S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89474

Radetzky S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89507

responsAbility BOP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89476

SCOP Poland S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89506

SHCO 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89513

Simply Devine W. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89479

Solufer S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89483

Stern Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89482

Tarnold Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

89498

Tecoh Investissements S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

89477

Trilantic Events Management S.à r.l. . . . . .

89475

Trois Sources Lomont Holdings S.à r.l.  . .

89475

VIII A Chateau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89501

Zigimmo International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

89483

89473

Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.173.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 28 août 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009113241/12.
(090136283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

LSF5 Giga Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 112.581.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009113242/10.
(090136290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Espace Promotion Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 73.552.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ESPACE PROMOTION HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009113250/12.
(090136301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Pro Sport S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 81.155.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 avril 2009

que:

- La démission de La FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l. de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société

a été acceptée;

- La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l, en abrégé BKM ayant son siège social sis 45-47, route

d'Arlon, L-1140 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2009.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009114110/20.
(090137772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89474

Pro Sport S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 81.155.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises parle Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 18 novembre 2008

que:

- M. Claude WAGNER, administrateur de la société, né le 12 mars 1965 à Esch sur Alzette (Luxembourg), demeurant

professionnellement au 22, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg a été nommé Président du Conseil d'Administration
pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des action-
naires qui se tiendra en 2013.

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 décembre

2008 que:

- la démission de M. Marc MULLER de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée;
- La FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l. ayant son siège social sis 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été

nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée
Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009114109/25.
(090137767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Trilantic Events Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.642,80.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 138.170.

Suite à l'assemblée générale des associés tenue le 21 août 2009, il a été décidé de nommer comme commissaire aux

comptes la société Grant Thornton Lux Audit SA, 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, avec effet immédiat, son mandat
prenant fin à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Trilantic Events Management S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2009114114/16.
(090137897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Trois Sources Lomont Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 117.602.

I. En date du 18 juin 2009, Stéphanie Traon, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

a démissionné de son mandat de gérant de classe A avec effet immédiat.

II. L'adresse de Rosa Villalobos a changé et se trouve à présent au 46, place Guillaume II, L-1648 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009114107/13.
(090137885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89475

responsAbility BOP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 132.075.

<i>Auszug aus den Beschlüssen der Gesellschafter der Gesellschaft vom 1. September 2009

Aus den Beschlüssen der Gesellschafter der Gesellschaft vom 1. September 2009 geht hervor, dass Herr Klaus Tisch-

hauser, geboren am 9. August 1964 in Bregenz, Österreich, mit beruflicher Anschrift in 59, Josefstraße, CH-8005 Zürich,
Schweiz, mit Wirkung zum 1. September 2009 für unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. September 2009.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009114108/16.
(090137891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

International Restaurants Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: TRY 663.189,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 136.260.

Suite à l'assemblée générale des associés tenue le 21 août 2009, il a été décidé de remplacer l'actuel commissaire aux

comptes, la société Ernst &amp; Young, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Luxembourg, par la société PriceWaterhouseCoopers,
400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg avec effet immédiat, son mandat prenant fin à l'assemblée générale statuant sur
l'exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

International Restaurants Group S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2009114115/17.
(090137898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Patron Wilanow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 123.337.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 juillet 2009

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte le transfert de siège de la Société du 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 6, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg avec effet au 30 juillet 2009.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée prend note et autorise le changement d'adresse professionnelle des gérants comme suit:
- Eddy DOME du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec

effet immédiat.

- Géraldine SCHMIT du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg

avec effet immédiat.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009114212/21.
(090137318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89476

Tecoh Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 111.560.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 15 juillet 2009

<i>Quatrième résolution

L'Associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg

au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009114217/14.
(090137315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

NewWorks Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 64.955.

<i>Extrait des résolutions circulaires adoptées par tous les membres du conseil d'administration en date du 17 juillet 2009

<i>Résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009114219/14.
(090137313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Bsome S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 108.934.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009114220/12.
(090137171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

Kairós Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 135.905.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 20 août 2009 que:
Madame Maggy KOHL-BIRGET, administrateur de sociétés, demeurant à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheins-

heim, a été nommée administrateur de la société en remplacement de Maître Lydie LORANG démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009114196/14.
(090137406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89477

Investmarket Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 98.219.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 décembre 2007

que:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant arrivés à échéance,
- Maître Charles DURO, avocat, demeurant à Luxembourg, Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxem-

bourg, et Madame Maggy KOHL-BERGET, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg ont été reconduits aux
fonctions d'administrateur de la société,

- la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., établie et ayant son siège social au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Lu-

xembourg, a été reconduite aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009114197/20.
(090137394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

InSyDe, Information, Systèmes et Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.583.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114204/10.
(090137074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

Perseus Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 124.515.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114205/10.
(090137073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

Oikia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 42.417.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 20 août 2009 que:
Madame Karine MASTINU, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, a été nommée adminis-

trateur de la société en remplacement de Maître Lydie LORANG démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009114195/14.
(090137425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89478

Immobilière D.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 113.053.

Le siège social de la société Immobilière D.P. S.à r.l., RCS Luxembourg B 113053 (L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-

Pierre Brasseur), a été dénoncé avec effet au 21 août 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2009.

FELTEN &amp; ASSOCIES
<i>L'agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009114206/13.
(090137467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Simply Devine W. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5236 Sandweiler, 10, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 120.050.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le mercredi 5 août 2009 à 10.30 heures à L-5221 Sandweiler,

<i>12, op der Houscht, suite à la convocation du 28 juillet 2009

1) Le siège social de SIMPLY DEVINE W. SA est transféré avec effet immédiat de L-5221 Sandweiler, 12 op der Houscht

à L-5236 Sandweiler, 10, rue d'Oetrange.

2) Le mandat d'administrateur de Scott PURDUE est révoqué avec effet immédiat.

Signature.

Référence de publication: 2009114210/13.
(090137346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Euphorbia Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 130.744.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009114224/11.
(090137167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

H.L. Heavy Load S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 142.887.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise lors de l'Assemblée générale de la société tenue en date du 7 août 2009 que:
Maître Karine MASTINU, avocat, née le 7 mai 1975 à Villerupt (France) demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de

la Chapelle a été nommée aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Maître Marisa ROBERTO
démissionnaire.

La durée de son mandat est fixée jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009114194/17.
(090137428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89479

EvrazSecurities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 95.437.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 août 2009 que:
- les mandats des administrateurs étant venus à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer:
* Monsieur Robert Jan Schol;
* Monsieur Paul van Baarle; et
* Monsieur Jorge Pérez Lozano
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31

décembre 2009.

- le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer:
* Ernst &amp; Young.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31

décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2009.

<i>Pour la société
Paul van Baarle
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2009114333/23.
(090137596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Lizo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 105.643.

1. Il est pris acte de la modification des adresses professionnelles de deux Administrateurs comme suit:
- Madame Corinne BITTERLICH, Conseiller juridique, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086

Luxembourg

- Monsieur Alain RENARD, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg

Certifié sincère et conforme
LIZO S.A.
C. BITTERLICH / A. RENARD
<i>Administrateur et Présidente du Conseil d'Administration / Administrateur

Référence de publication: 2009114334/15.
(090137311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Optivita Securitisation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 139.399.

<i>Extrait des minutes du conseil de gérance tenu au siège social de la société le 31 août 2009

Le Conseil de gérance décide de nommer KPMG, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (n°

B 103065) en tant que Réviseur Externe de la Société et ce, concernant l'audit des comptes se clôturant le 31 décembre
2008.

Fait à Luxembourg, le 31 août 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009114340/16.
(090137374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89480

Espace Informatique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 96.087.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2009, les mandats des administrateurs VALON S.A., LAN-

NAGE S.A. et KOFFOUR S.A., ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés pour
une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2015.

Par  décision  du  Conseil  d'administration  du  28  mai  2009,  LANNAGE  S.A.,  société  anonyme,  R.C.S.  Luxembourg

B-63130, 283, route d'Arlon, L - 1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société ESPACE INFORMATIQUE S.A.:
Monsieur Jean BODONI, 180, rue des Aubépines, L - 1145 Luxembourg, KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Lu-
xembourg  B-86086,  283,  route  d'Arlon,  L  -1150  Luxembourg,  a  désigné  comme  représentant  permanent  chargé  de
l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société ESPACE INFORMA-
TIQUE S.A.: Monsieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L - 1145 Luxembourg et VALON S.A., société anonyme,
R.C.S. Luxembourg B-63143, 283, route d'Arlon, L - 1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé
de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société ESPACE INFOR-
MATIQUE S.A.: Monsieur Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L - 1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 1 

er

 SEP. 2009.

<i>Pour: ESPACE INFORMATIQUE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner
<i>Vice-Président / -

Référence de publication: 2009114332/27.
(090137533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

CRC Breeze Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 114.853.

Die Bilanz am 31/12/2008 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2009114335/10.
(090137489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Orbital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Bereldange, 66, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 87.374.

<i>Auszug aus der Gesellschaftsversammlung vom 24. August 2009

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Rücktritt von Frau Afsaneh Rafii, Geschäftsführerin, wohnhaft in L-8255

Mamer, 54, rue Mont Royal, an.

Es wird zum neuen Geschäftsführer ernannt mit unbegrenzter Dauer des Mandats:
Herr Weda KHOUB MOHADJER, wohnhaft in L-7217 Bereldange, 66, rue de Bridel.
Er kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig verpflichten.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug
Fiduplan S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2009114311/17.
(090137350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89481

A.C. Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 85.012.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114328/10.
(090137577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Stern Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 129.949.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114329/10.
(090137580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Matrix Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 19.584.

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of July 28 

<i>th

<i> , 2009

- The resignations of the Directors Mr. Charles Stuart HORNBY, Mr. Alan Richard BINNINGTON, and Mrs Sarajane

KEMPSTER are accepted.

- Mr Rafic MANSOUR, civil engineer, with address P.O. Box 46370, ABU DHABI, United Arabic Emirates be appointed

as Sole Director in replacement of the resigning Directors. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of the
year 2011.

Luxembourg, July 28 

th

 , 2007.

Gstaad, Switzerland

For true copy
MATRIX HOLDING
Signature
<i>Sole Director

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 2009

- Les démissions des Administrateurs, Monsieur Charles Stuart HORNBY, Monsieur Alan Richard BINNINGTON, et

Madame Sarajane KEMPSTER sont acceptées.

- Mr Rafic MANSOUR, ingénieur civil, P.O. Box 46370, ABU DHABI, Emirates United Arabic est nommé en tant

qu'Administrateur Unique en leur remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblé Générale Statutaire
de l'an 2011.

Luxembourg, le 28 juillet 2009.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2009114336/26.
(090137316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Oriflame Cosmetics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 8.835.

<i>Avis rectificatif aux extraits de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 19 mai 2009 enregistré et déposés

<i>le 27/08/2009 sous la référence L090134870.05

L'assemblée générale a renouvelé entre autres, le mandat d'administrateur de la personne suivante pour une période

prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31
décembre 2009:

89482

- Monsieur Sven Magnus BRÄNNSTRÖM, demeurant professionnellement à CH-1752 Villars-sur-Glâne, Pré-Henry 8;
L'adresse indiquée n'étant plus la même que l'année passée, il convient également de la modifier lorsqu'il est fait mention

du mandat à durée indéterminée de Monsieur Sven Magnus BRÄNNSTRÖM en tant qu'administrateur à la gestion jour-
nalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009114331/18.
(090137471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Colle Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 152, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 87.703.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRESTACOMPTA SÀRL
Z.I. "Le 2000" - Route de Bettembourg
L-3378 LIVANGE
Signature

Référence de publication: 2009114326/13.
(090137660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Solufer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4833 Rodange, 9A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 42.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRESTACOMPTA SÀRL
Z.I. "Le 2000" - Route de Bettembourg
L-3378 LIVANGE
Signature

Référence de publication: 2009114327/13.
(090137661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Zigimmo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 89.420.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social de la société le 30 juillet 2009 à 10.00 heures

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de l'Administrateur Me Beatriz Garcia et du Commissaire aux comptes

qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

Est renommée Administrateur:
Me Beatriz Garcia, Avocate, demeurant au 5, boulevard Royal, L 2449 Luxembourg;
Est renommée Commissaire aux comptes:
Luxembourg International Consulting S.A. (Interconsult) avec siège social à L-1371 Luxembourg - 7, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009114341/18.
(090137380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89483

G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 41.153.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

<i>tenue le 2 septembre 2009 à 11.00 heures au siège social

Le conseil, après lecture de la lettre de démission datée du 26.08.2009 de Monsieur Marco Montanari de sa fonction

de Président et administrateur, décide d'accepter cette démission.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 26 août 2009, M. Salvatore Desiderio, employé privé

demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.

Le conseil décide de nommer Monsieur Salvatore Desiderio comme Président du conseil d'administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009114946/19.
(090138155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Postbahnhof an der Spree 1, Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Luxembourg, 4, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg B 135.105.

Il résulte de la décision de l'Associé Unique de la Société tenue en date du 10 août 2009 les modifications suivantes:
- Le siège social de la société est transféré du 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 4, rue du Golf, L-1638

Luxembourg

- La nomination de nouveaux gérants pour une durée indéterminée à compter du 12 février 2009 de Mme Catherine

Hellard, résident au 6, rue du Golf, L-1638 Luxembourg et de la société Attis Promotion S.A., ayant son siège social au
East 54th Street, Mossfon Building, Panama City, Panama.

- L'acceptation de la démission de leur poste de gérant de Messieurs Marc Levèbvre et de Ole Hartmann Christensen

avec effet rétroactif au 12 février 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 1 

er

 septembre 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009114949/20.
(090138342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

ILU, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 106.033.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 mai 2009

<i>3 

<i>e

<i> résolution

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Christophe BLONDEAU, demeurant professionnellement au

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Président du conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2010.

<i>Pour ILU
Jean Marc HEYNDERICKX / Christine GEUBELLE
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009114940/15.
(090138266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

89484

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and nine.
On the fourteenth day of August at 04.05 p.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-l611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on July 3, 2006 relatively to an increase of the corporate capital of PARTNERS
GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I - The company PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"),

having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B107564, has
been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 27 

th

 of April

2005, published in the Mémorial C number 433 of the 11 

th

 of May 2005, and whose articles of incorporation have been

amended by deeds of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of six million six hundred and sixty-two thousand six hundred and thirteen Euro

seventy cents (6,662,613.70 EUR), represented by fourteen thousand two hundred and twenty-seven point twenty-eight
(14,227.28) Manager Shares and one hundred and nineteen thousand twenty-five (119.025) Ordinary Shares of a par value
of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of twenty-five million Euro (25,000,000.- EUR) divided into:
- four hundred and fifty thousand (450,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- fifty thousand (50,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on July 3, 2006, the General Manager has decided to increase, within the limits of

the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of one million sixty-six thousand and eighteen
Euro and eighteen cents (1,066,018.18 EUR), in order to raise it from its present amount of six million six hundred and
sixty-two thousand six hundred and thirteen Euro seventy cents (6,662,613.70.-EUR) to the amount of seven million
seven hundred and twenty-eight thousand six hundred and thirty-one Euro and eighty-eight cents (7,728,631.88 EUR) by
issuing:

- nineteen thousand and forty-four (19,044) new Ordinary Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR) each,

issued with a total share premium of eighteen million ninety-one thousand eight hundred Euro (18,091,800.- EUR) to be
allocated entirely to the Special Reserve of the Company;

89485

- two thousand two hundred and seventy-six point thirty-six (2,276.36) Manager Shares having a par value of fifty Euro

(50.- EUR) each, issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of one million sixty-six
thousand and eighteen Euro and eighteen cents (1,066,018.18 EUR) as well as the amount of eighteen million ninety-one
thousand eight hundred Euro (18,091,800.- EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital, (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of seven million seven hundred and twenty-eight thousand six hundred and

thirty-one Euro and eighty-eight cents (7,728,631.88 EUR), represented by sixteen thousand five hundred and three point
sixty-four (16,503.64) Manager Shares and one hundred and thirty-eight thousand and sixty-nine (138,069) Ordinary
Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary slates that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10, 1915

on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand six hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den vierzehnten August um 16.05 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, Financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 3. Juli 2006 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP EUROPEAN
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B107564, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 433 vom 11. Mai 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von sechs Millionen sechs hundert zwei und sechzig tausend sechs hundert

dreizehn Euro siebzig Cents (6.662.613,70 EUR), eingeteilt in vierzehn tausend zwei hundert sieben und zwanzig Komma

89486

acht und zwanzig (14.227,28) Manager-Aktien und ein hundert neunzehn tausend fünf und zwanzig (119.025) Vorzugs-
aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünf und zwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EUR) und

ist aufgeteilt in:

- vier hundert fünfzig tausend (450.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie;

und

- fünfzig tausend (50.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950,- EUR); und

-jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100,- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50,- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 3. Juli 2006 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten

Kapitals, das Gesellschaftskapital um eine Million sechs und sechzig tausend achtzehn Euro achtzehn Cents (1.066.018,18,-
EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von sechs Millionen sechs hundert zwei und sechzig tausend sechs
hundert dreizehn Euro siebzig Cents (66.662.613,70,- EUR) auf siebe Millionen sieben hundert acht und zwanzig tausend
sechs hundert ein und dreissig Euro acht und achtzig Cents (7.728.631,88 EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:

- neunzehn tausend vier und vierzig (19.044) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (50,-

EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von achtzehn Millionen ein und neunzig tausend acht hundert Euro
(18.091.800,- EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- zwei tausend zwei hundert sechs und siebzig Komma sechs und dreissig (2.276,36) Manager-Aktien mit einem No-

minalwert von je fünfzig Euro (50,-EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von einer Million sechs und
sechzig tausend achtzehn Euro achtzehn Cents (1.066.018,18,- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von achtzehn Milli-
onen ein und neunzig tausend acht hundert Euro (18.091.800,- EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von sieben Millionen sieben hundert acht und zwanzig tausend sechs hundert

ein und dreissig Euro acht und achtzig Cents (7.728.631,88 EUR), eingeteilt in sechzehn tausend fünf hundert drei Komma
vier  und  sechzig  (16.503,64)  Manager-Aktien  und  ein  hundert  acht  und  dreissig  tausend  neun  und  sechzig  (138.069)
Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf

tausend sechs hundert Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

89487

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2009. Relation GRE / 2009/2992. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009115232/174.
(090138948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and nine.
On the fourteenth day of August at 03.55 p.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-l611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on December 19, 2005 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I - The company PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"),

having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B107564, has
been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 27 

th

 of April

2005, published in the Mémorial C number 433 of the 11 

th

 of May 2005, and whose articles of incorporation have been

amended by deeds of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of four million two hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-

one Euro ninety-four cents (4,254,421.94 EUR), represented by seven thousand five hundred and eighty-five point sixty-
seven (7,585,67) Manager Shares and seventy-seven thousand five hundred and two point seventy-seven (77,502.77)
Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of twenty-five million Euro (25,000,000.- EUR) divided into:
- four hundred and fifty thousand (450,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- fifty thousand (50,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50,- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

89488

V.- Pursuant to a resolution taken on December 19, 2005. the General Manager has decided to increase, within the

limits of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of one million two hundred and
fourteen thousand three hundred and fifteen Euro and ninety-four cents (1,214,315.94.- EUR), in order to raise it from
its present amount of four million two hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-one Euro ninety-four
cents (4,254,421.94 EUR) to the amount of five million four hundred and eighty-six thousand seven hundred and thirty-
seven Euro eighty-eight cents (5,468,737.88.- EUR) by issuing:

- twenty thousand four hundred and seventy-seven point seventy-seven (20,477.77) new Ordinary Shares having a par

value of fifty Euro (50.- EUR) each,, issued with a total share premium of nineteen million four hundred and fifty-three
thousand eight hundred and eighty-three Euro seventy-eight cents (19,453,883.78 EUR) to be allocated entirely to the
Special Reserve of the Company;

- three thousand eight hundred and eight point fifty-five (3,808.55) Manager Shares having a par value of fifty Euro (50.-

EUR) each, issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of one million two
hundred and fourteen thousand three hundred and fifteen Euro and ninety-four cents (1,214,315.94 EUR) as well as the
amount of nineteen million four hundred and fifty-three thousand eight hundred and eighty-three Euros seventy-eight
(19,453,883.78 EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital, (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of five million four hundred and eighty-six thousand seven hundred and thirty-

seven Euro eighty-eight cents (5,468,737.88 EUR), represented by eleven thousand three hundred and ninety-four point
twenty-two (11,394.22) Manager Shares and ninety-seven thousand nine hundred and eighty point fifty-four (97,980.54)
Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand eight hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname. Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den vierzehnten August um 15.55 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.ä r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines

89489

Beschlusses vom 19. Dezember 2005 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP EU-
ROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B107564, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 433 vom 11. Mai 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von vier Millionen zwei hundert vier und fünfzig tausend vier hundert ein und

zwanzig Euro vier und neunzig Cents (4.254.421,94 EUR), eingeteilt in sieben tausend fünf hundert fünf und achtzig Komma
sieben und sechzig (7.585,67) Manager-Aktien und sieben und siebzig tausend fünfhundert zwei Komma sieben und siebzig
(77.502,77) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünf und zwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EUR) und

ist aufgeteilt in:

- vier hundert fünfzig tausend (450.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie;

und

- fünfzig tausend (50.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50.- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950,- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100.- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50,- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Salzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 19. Dezember 2005 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des

genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um eine Million zwei hundert vierzehn tausend drei hundert fünfzehn Euro
vier und neunzig Cents (1.214.315,94 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von vier Millionen zwei hundert
vier und fünfzig tausend vier hundert ein und zwanzig Euro vier und neunzig Cents (4.254.421,94 EUR) auf fünf Millionen
vier hundert acht und sechzig tausend sieben hundert sieben und dreissig Euro acht und achtzig Cents (5.468.737,88 EUR)
zu bringen durch die Ausgabe von:

- zwanzig tausend vier hundert sieben und siebzig Komma sieben und siebzig (20.477,77) neuen Vorzugsaktien mit

einem Nominalwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von neunzehn Millionen
vier hundert drei und fünfzig tausend acht hundert drei und achtzig Euro acht und siebzig Cents (19.453.883,78 EUR)
welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- drei tausend acht hundert acht Komma fünf unf fünfzig (3.808,55) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je

fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von einer Million zwei
hundert vierzehn tausend drei hundert fünfzehn Euro vier und neunzig Cents (1.214.315,94 EUR) erhalten hat, so wie
den Betrag von neunzehn Millionen vier hundert drei und fünfzig tausend acht hundert drei und achtzig Euro acht und
siebzig Cents (19.453.883,78 EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von fünf Millionen vier hundert acht und sechzig tausend sieben hundert

sieben und dreissig Euro acht und achtzig Cents (5.468.737,88,- EUR), eingeteilt in elf tausend drei hundert vier und

89490

neunzig Komma zwei und zwanzig (11.394,22) Manager-Aktien und sieben und neunzig tausend neun hundert achtzig
Komma vier und fünfzig (97.980,54) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten. Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf

tausend acht hundert Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2009. Relation GRE / 2009/2990. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster. le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009115234/179.
(090138946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and nine.
On the fourteenth day of August at 03.50 p.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on October 31, 2005 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I.- The company PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"),

having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B107564, has
been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 27 

th

 of April

2005, published in the Mémorial C number 433 of the 11 

th

 of May 2005, and whose articles of incorporation have been

amended by deeds of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of three million three hundred and fifteen thousand two hundred and sixty-seven

Euro  eighty-six  cents  (3,315,267.86  EUR),  represented  by  four  thousand  six  hundred  and  fifty-three  point  zero  one
(4,653.01) Manager Shares and sixty-one thousand six hundred and fifty-two point thirty-five (61,652.35) Ordinary Shares
of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of twenty-five million Euro (25,000,000.- EUR) divided into:
- four hundred and fifty thousand (450,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- fifty thousand (50,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.

89491

IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on October 31, 2005, the General Manager has decided to revoke the capital increase

resolved on October 17, 2005 and parts of the capital increase resolved on August 28, 2005, and to decrease the capital
by an amount of three hundred and forty-five thousand six hundred and seventy-six Euro eighty-nine cents (345,676.89
EUR) in order to reduce it from its present amount of three million three hundred and fifteen thousand two hundred
and sixty-seven Euro eighty-six cents (3,315,267.86 EUR) to the amount of two million nine hundred and sixty-nine
thousand five hundred and ninety Euro ninety-seven cents (2,969,590.97 EUR) by cancelling six thousand nine hundred
and thirteen point fifty-four (6,913.54) Ordinary Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR) each, and by repayment
of a total share premium of six million five hundred and sixty-seven thousand eight hundred and sixty Euro ninety cents
(6,567,860.90 EUR) to be taken entirely from the Special Reserve of the Company.

VI.- Pursuant to a resolution taken on October 31, 2005, the General Manager has decided to increase, within the

limits of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of one million two hundred and
eighty-four thousand eight hundred and thirty Euro and ninety-seven cents (1,284,830.97 EUR), in order to raise it from
its present amount of two million nine hundred and sixty-nine thousand five hundred and ninety Euro ninety-seven cents
(2,969,590.97.- EUR) to the amount of four million two hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-one
Euro ninety-four cents (4,254,421.94 EUR) by issuing:

- twenty-two thousand seven hundred and sixty-three point ninety-six (22,763.96) new Ordinary Shares having a par

value of fifty Euro (50.- EUR) each, issued with a total share premium of twenty-one million six hundred twenty five
thousand seven hundred and fifty-seven Euro sixty-nine cents (21,625,757.69 EUR) to be allocated entirely to the Special
Reserve of the Company;

- two thousand nine hundred and thirty-two point sixty-six (2,932.66) Manager Shares having a par value of fifty Euro

(50.- EUR) each, issued without share premium.

VII.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of one million two
hundred and eighty-four thousand eight hundred and thirty Euro and ninety-seven cents (1,284,830.97 EUR) as well as
the amount of twenty-one million six hundred twenty five thousand seven hundred and fifty-seven Euros sixty-nine cents
(21,625,757.69 EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VIII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital. (paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of four million two hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-

one Euro ninety-four cents (4,254,421.94.- EUR), represented by seven thousand five hundred and eighty-five point sixty-
seven (7,585,67) Manager Shares and seventy-seven thousand five hundred and two point seventy-seven (77,502.77)
Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10.

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately six thousand six hundred and fifty Euro.

89492

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den vierzehnten August um 15.50 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.ä r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523.

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg.

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 31. Oktober 2005 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP EURO-
PEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B107564, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 433 vom 11. Mai 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von drei Millionen drei hundert fünfzehn tausend zwei hundert sieben und

sechzig Euro sechs und achtzig Cents (3.315.267,86 EUR), eingeteilt in vier tausend sechs hundert drei und fünfzig Komma
null eins (4.653,01) Manager-Aktien und ein und sechzig tausend sechs hundert zwei und fünfzig Komma fünf und dreissig
(61.652,35) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,-EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünf und zwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EUR) und

ist aufgeteilt in:

- vier hundert fünfzig tausend (450.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie;

und

- fünfzig tausend (50.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950,- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100,- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50,- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 31. Oktober 2005 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden die Kapitalerhöhung

vom 17. Oktober 2005 und Teile der Kapitalerhöhung vom 28. August 2005 zu widerrufen und das Gesellschaftskapital

89493

um den Betrag von drei hundert fünf und vierzig tausend sechs hundert sechs und siebzig Euro neun und achtzig Cents
(345.676,89 EUR) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Betrag von drei Millionen drei hundert fünfzehn tausend
zwei hundert sieben und sechzig Euro sechs und achtzig Cents (3.315.267,86 EUR) auf zwei Millionen neun hundert neun
und sechzig tausend fünf hundert neunzig Euro sieben und neunzig Cents (2.969.590,97 EUR) zu bringen durch die An-
nulierung  von  sechs  tausend  neun  hundert  vierzehn  Komma  vier  und  fünfzig  (6.914,54)  Vorzugsaktien  mit  einem
Nominalwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), und durch die Rückzahlung eines gesamten Emissionsagio von sechs Millionen
fünf hundert sieben und sechzig tausend acht hundert sechzig Euro neunzig Cents (6.567.860,90 EUR) welcher gänzlich
von der Spezial Reserve der Gesellschaft genommen wird.

VI.- Gemäss eines am 31. Oktober 2005 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des

genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um eine Million zwei hundert vier und achtzig tausend acht hundert dreissig
Euro sieben und neunzig Cents (1.284.830,97 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwei Millionen
neun hundert neun und sechzig tausend fünf hundert neunzig Euro sieben und neunzig Cents (2.969.590,97 EUR) auf vier
Millionen zwei hundert vier und fünfzig tausend vier hundert ein und zwanzig Euro vier und neunzig Cents (4.254.421,94
EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:

- zwei und zwanzig tausend sieben hundert drei und sechzig Komma sechs und neunzig (22.763,96) neuen Vorzugsaktien

mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von ein und zwanzig
Millionen  sechs  hundert  fünf  und  zwanzig  tausend  sieben  hundert  sieben  und  fünfzig  Euro  neun  und  sechzig  Cents
(21.625.757,69 EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- zwei tausend neun hundert zwei und dreissig Komma sechs und sechzig (2.932,66) Manager-Aktien mit einem No-

minalwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VII.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von einer Million zwei
hundert vier und achtzig tausend acht hundert dreissig Euro sieben und neunzig Cents (1.284.830.97,- EUR) erhalten hat,
so wie den Betrag von ein und zwanzig Millionen sechs hundert fünf und zwanzig tausend sieben hundert sieben und
fünfzig Euro neun und sechzig Cents (21.625.757,69,- EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VIII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von vier Millionen zwei hundert vier und fünfzig tausend vier hundert ein

und zwanzig Euro vier und neunzig Cents (4.254.421,94 EUR), eingeteilt in sieben tausend fünf hundert fünf und achtzig
Komma sieben und sechzig (7.585,67) Manager-Aktien und sieben und siebzig tausend fünfhundert zwei Komma sieben
und siebzig (77.502,77) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechs tausend sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2009. Relation GRE / 2009/2989. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009115235/198.
(090138945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

89494

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and nine. On the fourteenth day of August, at 03.45 p.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-l611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on October 17, 2005 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I.- The company PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"),

having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B107564, has
been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 27 

th

 of April

2005, published in the Mémorial C number 433 of the 11 

th

 of May 2005, and whose articles of incorporation have been

amended by deeds of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of two million nine hundred and forty thousand two hundred and sixty-seven

Euro eighty-six cents (2,940,267.86 EUR), represented by four thousand one hundred and twenty-six point sixty-nine
(4,126.69) Manager Shares and fifty-four thousand six hundred and seventy-eight point sixty-seven (54,678.67) Ordinary
Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of twenty-five million Euro (25,000,000.- EUR) divided into:
- four hundred and fifty thousand (450,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- fifty thousand (50,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on October 17, 2005, the General Manager has decided to increase, within the

limits of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of three hundred and seventy-five
thousand Euro (375,000.- EUR), in order to raise it from its present amount of two million nine hundred and forty thousand
two hundred and sixty-seven Euro eighty-six cents (2,940,267.86 EUR) to the amount of three million three hundred and
fifteen thousand two hundred and sixty-seven Euro eighty-six cents (3,315,267.86 EUR) by issuing:

- six thousand nine hundred and seventy-three point sixty-eight (6,973.68) new Ordinary Shares having a par value of

fifty Euro (50.- EUR) each, issued with a total share premium of six million six hundred and twenty-five thousand Euro
(6,625,000.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;

- five hundred and twenty-six point thirty-two (526.32) Manager Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR) each,

issued without share premium.

89495

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of three hundred and
seventy-five thousand Euro (375,000.- EUR) as well as the amount of six million six hundred and twenty-five thousand
Euro (6,625,000.- EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital, (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of three million three hundred and fifteen thousand two hundred and sixty-

seven Euro eighty-six cents (3.315,267.86 EUR), represented by four thousand six hundred and fifty-"three point zero
one (4,653.01) Manager Shares and sixty-one thousand six hundred and fifty-two point thirty-five (61,652.35) Ordinary
Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately three thousand six hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den vierzehnten August um 15.45 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-I160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 17. Oktober 2005 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP EURO-
PEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B107564, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 433 vom 11. Mai 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zwei Millionen neun hundert vierzig tausend zwei hundert sieben und

sechzig Euro sechs und achtzig Cents (2.940.267,86,- EUR), eingeteilt in vier tausend ein hundert sechs und zwanzig
Komma neun und sechzig (4.126,69) Manager-Aktien und vier und fünfzig tausend sechs hundert acht und siebzig Komma
sieben und sechzig (54.678,67) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.

89496

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünf und zwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EUR) und

ist aufgeteilt in:

- vier hundert fünfzig tausend (450.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie;

und

- fünfzig tausend (50.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950,- EUR): und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100,- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50,- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.-  Gemäss  eines  am  17.  Oktober  2005  genommenen  Beschlusses  hat  der  Manager  entschieden,  im  Rahmen  des

genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um drei hundert fünf und siebzig tausend Euro (375.000,- EUR) zu erhöhen,
um es von seinem jetzigen Betrag von zwei Millionen neun hundert vierzig tausend zwei hundert sieben und sechzig Euro
sechs und achtzig Cents (2.940.267,86,- EUR) auf drei Millionen drei hundert fünfzehn tausend zwei hundert sieben und
sechzig Euro sechs und achtzig Cents (3.315.267,86,- EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:

- sechs tausend neun hundert drei und siebzig Komma acht und sechzig (6.973.68) neuen Vorzugsaktien mit einem

Nominalwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von sechs Millionen sechs
hundert fünf und zwanzig tausend Euro (6.625.000,- EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt
wird;

- fünf hundert sechs und zwanzig Komma zwei und dreissig (526,32) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je

fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von drei hundert fünf und
siebzig tausend Euro (375.000,- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von sechs Millionen sechs hundert fünf und zwanzig
tausend Euro (6.625.000,- EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von drei Millionen drei hundert fünfzehn tausend zwei hundert sieben und

sechzig Euro sechs und achtzig Cents (3.315.267,86,- EUR), eingeteilt in vier tausend sechs hundert drei und fünfzig Komma
null eins (4.653,01) Manager-Aktien und ein und sechzig tausend sechs hundert zwei und fünfzig Komma fünf und dreissig
(61.652,35) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,-EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr drei

tausend sechs hundert Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER.

89497

Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2009. Relation GRE / 2009/2988. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009115236/173.
(090138944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Tarnold Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.562.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.224.

In the year two thousand nine, on the thirteenth day of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Anglo Irish Assurance Company Limited, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws

of Ireland, having its registered office at Heritage House, 23 St Stephen's Green, Dubin 2, Ireland, registered with the
Company Registrar of Ireland under number 336075, here represented by Mr Wim Rits, private employee, having his
professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, by virtue of a proxy given under private seal in Ireland, on August 12

th

 , 2009,

and
Alanis Capital Nominees Limited, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Ireland,

having its registered office at 60 Fitzwilliam, Dublin 2, Ireland, registered with the Company Registrar of Ireland under
number 371250, here represented by Mr Wim Rits, private employee, having his professional address at 46A, Avenue
J.F. Kennedy, by virtue of a proxy given under private seal, in Ireland, on August 12 

th

 , 2009.

Said proxy with substitution, after signature "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed in the same time with the registration authorities.

The apparing parties, acting in the said capacity, have requested the undersigned notary to state:
- that the corporation of Tarnold Holding S.à r.l. has been incorporated by a notarial deed on the 13 

th

 of June 2007,

published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 1655 of August 6, 2007;

-  that  the incorporation capital  of  Tarnold  Holding  S.à r.l.  was  fixed  at twelve  thousand  five hundred Euro (EUR

12,500.00) represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares with a par value of one Cent
(EUR 0.01) each;

- that on the 14 

th

 of June 2007, Anglo Irish Assurance Company Limited, prenamed, has become owner of one million

two hundred fifty thousand (1,250,000) of the shares, pursuant to a share transfer agreement executed under private seal
and published in the Memorial Recueil des Sociétés et Associations under number 1932 on 10 September 2007;

- that on the 4 

th

 of May 2009, Alanis Capital Nominees Limited., prenamed, has become owner of one hundred twenty

five thousand (125,000) of the shares, pursuant to a share transfer agreement executed under private seal, published in
the Memorial Recueil des Sociétés et Associations and that, as a result of the above, Anglo Irish Assurance Company
Limited is holder of one million one hundred twenty five thousand (1,125,000) shares;

- that on the 6th of May 2009, the capital of Tarnold Holding S.à r.l. was increased from twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500.00) to thirty million twelve thousand five hundred Euro (EUR 30,012,500.00), represented by three
billion one million two hundred fifty thousand (3,001,250,000) shares with a par value of one Cent (EUR 0.01) each and,
as a result of the above, Anglo Irish Assurance Company Limited is holder of two billion seven hundred one million one
hundred twenty five thousand (2,701,125,000) shares and Alanis Capital Nominees Limited is holder of three hundred
million one hundred twenty five thousand (300,125,000) shares;

- that Anglo Irish Assurance Company Limited and Alanis Capital Nominees Limited being the owners of 100% of the

shares of the Company (the "Shareholders") have deliberated upon the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the issued capital of the Company by the following amounts: EUR 2,550,000.00 by way of issuance of

255,000,000 new registered shares with a nominal value of EUR 0.01, against a contribution in cash.

2. To amend the Articles of Association of the Company, in order to reflect the above capital increase.
That Anglo Irish Assurance Company Limited, being owner of 2,701,125,000 shares of the Company and that Alanis

Capital Nominees Limited., being owner of 300,125,000 shares of the Company have taken the following resolutions:

89498

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the issued share capital of the Company by an amount of two million five hundred

and fifty thousand Euro (EUR 2,550,000.00) by payment in cash to bring it from its present amount of thirty million twelve
thousand five hundred Euro (EUR 30,012,500.00) to the amount of thirty-two million five hundred sixty-two thousand
five hundred Euro (EUR 32,562,500.00), by issuance of two hundred fifty-five million (255,000,000) new shares with a
nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, fully subscribed as follows:

- 229,500,000 shares have been subscribed by Anglo Irish Assurance Company Limited and
- 25,500,000 shares have been subscribed by Alanis Capital Nominees Limited.
The shares subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of two million five hundred fifty thousand

Euro (EUR 2,550,000.00) is available to the Company, proof of which was given to the undersigned notary.

The entire share capital of the Company is divided as follows: 2,930,625,000 shares belong to Anglo Irish Assurance

Company Limited and 325,625,000 shares belong to Alanis Capital Nominees Limited.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolutions the Shareholders decide to amend Article 5, paragraph 1 of the Articles

of Incorporation to read as follows:

„The capital of the Company is set at thirty-two million five hundred sixty-two thousand five hundred Euro (EUR 32,

562,500.00) represented by three billion two hundred fifty-six million two hundred fifty thousand (3,256,250,000) shares
with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each. 2,930,625,000 shares belong to Anglo Irish Assurance Company Limited
and 325,625,000 shares belongs to Alanis Capital Nominees Limited"

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Expenses

The amount of the expences, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at approximately three thousand euros (EUR 3,000.-).

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French translation.

On request of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English

version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party who is kown to the notary by his name,

first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le treize août.
Par-devant Nous, Maître SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Anglo Irish Assurance Company Limited, société constituée selon les lois d'Irelande ayant son siège social au Heritage

House, 23 St Stephen's Green, Dubin 2, Irelande enregistrée sous le numéro 336075 du Company Registrar d'lrelande,
ici représentée par M. Wim Rits, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F.
Kennedy, en vertu d'une procuration donné sous seing privé, donné en Irlande le 12 août 2009,

et
Alanis Capital Nominees Limited, société constituée selon les lois d' Irelande ayant son siège social au 60 Fitzwilliam,

Dublin 2, Irelande enregistrée sous le numéro 371250 du Company Registrar d'Irelande, ici représentée par M. Wim Rits,
employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, en vertu d'une procu-
ration donné sous seing privé, donné en Irlande le 12 août 2009.

Laquelle procuration avec substitution, après signature "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire,

demeureront annexée aux présente pour être enregistrées en même temps.

Les parties comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- que la société Tarnold Holding S.à r.l. a été constituée suivant acte notarié, en date du 13 juin 2007, publié au Mémorial,

Recueil Spécial C, numéro 1655 du 6 août 2007;

- que le capital social de la société Tarnold Holding S.à r.l. à été fixé, lors de sa constitution, à douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500) représenté par un million deux cents cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale
d'un cent (EUR 0.01) chacune, entièrement libérées;

- qu'en date du 14 juin 2007, Anglo Irish Assurance Company Limited, sus-nommée, est devenue propriétaire d'un

million deux cent cinquante mille (1.250.000) part sociales dont s'agit suite à un contrat de cession de parts exécuté sous
seing privé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous numéro 1932 en date du 10 septembre 2007;

89499

- qu'en date du 4 mai 2009, Alanis Capital Nominees Limited, susnommée, est devenue propriétaire de cent vingt-cinq

mille (125.000) parts sociales dont s'agit suite à un contrat de cession de parts exécuté sous seing privé, étant en procès
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et que, par conséquence des faits mentionnés ci-
dessus,  Anglo  Irish  Assurance  Company  Limited  est  propriétaire  d'un  million  cent  vingt-cinq  mille  (1.125.000)  parts
sociales;

- qu'en date du 6 mai 2009 le capital social de Tarnol Holding S.à r.l. a été augmenté de trente millions d'euros (EUR

30.000.000) pour le porter de son montant initial de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un montant de trente
millions douze mille cinq cents euros (EUR 30.012.500), par l'émission de trois milliards un million deux cent cinquante
mille (3.001.250.000) de parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0.01) chacune, et que, par con-
séquence des faits mentionnés ci-dessus, Anglo Irish Assurance Company Limited est propriétaire de deux milliards sept
cent un million cent vingt-cinq mille (2,701,125,000) parts sociales et Alanis Capital Nominees Limited est propriétaire
de trois cents millions cent vingt-cinq mille (300,125,000) parts sociales;

- que Anglo Irish Assurance Company Limited et Alanis Capital Nominees Limited étant les propriétaires des 100%

des parts sociales de la Société (les "Associés") ont délibérées sur l'agenda suivant:

<i>Agenda

1. D'augmenter le capital social de la société par le montant suivant: EUR 2.550.000,- par émission de 255,000,000

parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (une cent) par apport en numéraire.

2. De modifier les Statuts de la Société, enfin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus.
Que Anglo Irish Assurance Company Limited, étant propriétaire de 2.701.125.000 parts sociales de la Société, et Alanis

Capital Nominees Limited, étant le propriétaire de 300.125.000 parts sociales de la Société, ont pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions cinq cent cinquante

mille euros (EUR 2.550.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente millions douze cinq cents euros (EUR
30.012.500,-) à un montant de trente-deux millions cinq cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 32.612.500) ,
par l'émission de deux cent cinquante-cinq millions (255.000.000) de parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un
cent (EUR 0,01) chacune, souscrites comme suit:

- 229.500.000 parts sociales sont souscrites par Anglo Irish Assurance Company Limited;
- 25.500.000 parts sociales sont souscrites par Alanis Capital Nominees Limited.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire de sorte que le de montant de deux millions

cinq cent cinquante mille euros (EUR 2.550.000) est maintenant à la disposition de la Société, preuve ayant été donnée
au notaire instrumentant.

Le capital social entier de la Société est divisé comme suit: 2.930.625.000 parts sociales appartiennent à Anglo Irish

Assurance Company Limited et 325.625.000 parts sociales appartiennent à Alanis Capital Nominees Limited.

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions précédentes, les Associés décident d'amender l'article 5, alinéa 1 des Statuts de la Société comme

suit:

"Le  capital  social  souscrit  est  fixé  à  trente-deux  millions  cinq  cent  soixante-deux  mille  cinq  cents  euros  (EUR

32.562.500), divisé en trois milliards deux cent cinquante-six millions deux cent cinquante mille (3.256.250.000) parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune. 2.930.625.000 parts sociales appartiennent à Anglo
Irish Assurance Company Limited et 325.625.000 parts sociales appartiennent à Alanis Capital Nominees Limited."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

sont évalués approximativement à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la personne comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; sur demande de la même personne com-
parante, et en cas divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il/elle a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: W. Rits et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 août 2009. Relation: LAC/2009/33931. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89500

Luxembourg, le 20 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009115240/160.
(090139179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

VIII A Chateau S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. H Chateau VII S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 122.959.

In the year two thousand and nine, on the tenth day of August.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

VIII International Holdings S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) existing under the laws

of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  33,  avenue  Monterey,  L-2163  Luxembourg,  having  a  share  capital  of
EUR91.250 and registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 122.957, here repre-
sented by Ms Josiane Meissener, employee of the law firm Allen &amp; Overy Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given on 6 August 2009,

AND
VIII Co-Investment International Holdings S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) existing

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, having a share
capital of EUR21,250 and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 122.958, here
represented by Ms Josiane Meissener, employee of the law firm Allen &amp; Overy Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given on 6 August 2009,

(the Shareholders).
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent

the entire share capital of the Company, denominated H Chateau VII S.à r.l. (the Company), a private limited company
(société à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies register under number B 122.959, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
dated 15 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 520 dated 3 April
2007.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that they

may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to create two classes of shares: A shares and B shares;
2. Decision to convert the shares held by VIII International Holdings S.à r.l. into A shares;
3. Decision to convert the shares held by VIII Co-Investment International Holdings S.à r.l. into B shares;
4. Decision to change the name of the Company to "VIII A Chateau S.à r.l.";
5. Decision to amend article 4, 6, 13, 17, 23, 24, 25 and 26 of the articles of association of the Company.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolution:

<i>First resolution

The Shareholders of the Company resolve to create two classes of shares, A shares (the A Shares) and B shares (the

B Shares). Among the 500 shares of the Company 450 will be A Shares and 50 will be B Shares.

A Shares shall entitle their holders to 93.78886 % of (i) the dividends distributed by the Company and (ii) the surplus

resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company.
Within the A Shares class each holder of A Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion
to the A Shares held by him.

B Shares shall entitle their holders to 6.21114 % of (i) the dividends distributed by the Company and (ii) the surplus

resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company.
Within the B Shares class each holder of B Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion
to the B Shares held by him.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to convert the 450 shares held by VIII International Holdings S.à r.l into A Shares.

89501

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to convert the 50 shares held by VIII Co-Investment International Holdings S.à r.l into B

Shares.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to change the name of the Company from H Chateau VII S.à r.l. to VIII A Chateau S.à r.l..

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend articles 4, 6, 13, 17, 23, 24, 25 and 26 of the articles of association of the Company.

The English version shall be henceforth reworded as follows:

Art. 4. The Company will exist under the corporate name of VIII A Chateau S.à r.l."

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by four

hundred fifty (450) A shares (the A Shares) and fifty (50) B shares (the B Shares) with a nominal value of twenty-five euro
(EUR 25) each.

A Shares shall entitle their holders to 93.78886% of the dividends distributed by the Company and the surplus resulting

from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within
the A Shares class each holder of A Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to
the A Shares held by him.

B Shares shall entitle their holders to 6.21114% of the dividends distributed by the Company and the surplus resulting

from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within
the B Shares class each holder of B Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to
the B Shares held by him

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

Art. 13. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers
present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 13 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

by the joint signature of one A manager and one B manager.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, one A manager and one B

manager jointly, may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders
meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager or managers will determine this agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by one A manager
and one B manager jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by

89502

other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers,
present or represented at the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed.
Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such
circular resolutions will be deemed to be held in Luxembourg."

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment

of interim dividends in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles."

Art. 23. The Company's financial year begins on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of the same year."

Art. 24. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company's registered office."

Art. 25. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole partner or, as the case may be,
the general meeting of the partners in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article
6 of the present articles of association. Dividend distributions may only be realised in accordance with the rights attributed
to the A Shares and the B Shares by article 6 of the present articles of association."

Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article 6 of the present articles of
association."

<i>Transitory provisions

In accordance with article 23, the current financial year shall end on 31 December 2009.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first here above

mentioned.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix août.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

VIII International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, avec un capital social de EUR91.250 et enregistrée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.957, ici représentée par Mme Josiane Meissener, em-
ployée de l'étude Allen &amp; Overy Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 6 août 2009,

ET
VIII Co-Investment International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, avec un capital social de EUR21.250 et enregistrée auprès
du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.958, ici représentée par Mme Josiane
Meissener, employée de l'étude Allen &amp; Overy Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 6 août 2009,

89503

(les Associés).
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée H Chateau VII S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois,
immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.959, selon acte de
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 15 décembre 2006, publié auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations C-N° 520 en date du 3 avril 2007.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de créer deux classes de parts sociales: les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B;
2. Décision de convertir les parts sociales détenues par VIII International Holdings S.à r.l. en parts sociales de classe

A;

3. Décision de convertir les parts sociales détenues par VIII Co-Investment International Holdings S.à r.l. en parts

sociales de classe B;

4. Décision de procéder au changement de nom de la Société en "VIII A Chateau S.à r.l.";
5. Décision de modifier les articles 4, 6, 13, 17, 23, 24, 25 et 26 des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de créer deux classes de parts sociales, les parts sociales de classe A (les Parts A) et les parts

sociales de classe B (les Parts B). Parmi les 500 parts sociales de la Société 450 seront des Parts A et 50 des Parts B.

Les Parts A donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 93,78886% (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de
la classe des Parts A chaque titulaire de Parts A aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts A détenues par lui.

Les Parts B donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 6,21114% (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de
la classe des Parts B chaque titulaire de Parts B aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts B détenues par lui.

<i>Seconde résolution

Les Associés décident de convertir les 450 parts sociales détenues par VIII International Holdings S.à r.l. en Parts A.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de convertir les 50 parts sociales détenues par VIII Co-Investment International Holdings S.à

r.l. en Parts B.

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier le nom de la Société de H Chateau VII S.à r.l. en VIII A Chateau S.à r.l..

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les articles 4, 6, 13, 17, 23, 24, 25 et 26 des statuts de la Société, dont la version

française aura désormais la teneur suivante:

Art. 4. La Société adopte la dénomination sociale de VIII A Chateau S.à r.l.."

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) représenté par quatre cent

cinquante (450) parts sociales de classe A (les Parts A) et cinquante (50) parts sociales de classe B (les Parts B) d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Les Parts A donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 93,78886% (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de
la classe des Parts A chaque titulaire de Parts A aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts A détenues par lui.

Les Parts B donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 6,21114 % (i) des dividendes distribués par la Société et

(ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de
la classe des Parts B chaque titulaire de Parts B aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction
de la proportion des Parts B détenues par lui."

89504

Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un

conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la
moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer

le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du

conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 13.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant A et un gérant B conjoin-

tement; pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui déléguent détermineront
la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation
et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par un gérant A et un gérant B conjointement. On
pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent
avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de
gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de
gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant

comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du
conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg."

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au

paiement d'acomptes sur dividendes conformément aux droits spécifiques attribués aux Parts A et aux Parts B par l'article
6 des statuts."

Art. 23. L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année."

Art. 24. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de la Société de l'inventaire et du bilan."

Art. 25. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'associé unique ou, le cas échéant,
de l'assemblée générale des associés conformément aux droits spécifiques attribués aux Parts A et aux Parts B par l'article
6 des présents statuts. La distribution de dividendes devra se faire conformément aux droits spécifiques attribués aux
Parts A et aux Parts B par l'article 6 des présents statuts."

89505

Art. 26. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non,  nommé(s)  par  l'assemblée  des  associés  qui  fixera  ses  (leurs)  pouvoirs  et  ses  (leurs)  émoluments.  Sauf  décision
contraire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement
du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés conformément aux droits spécifiques attribués aux

Parts A et aux Parts B par l'article 6 des présents statuts."

<i>Dispositions transitoires

En accord avec l'article 23, le présent exercice social finit le 31 décembre 2009.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge du fait de sa constitution, s'élève à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 août 2009. Relation: LAC/2009/33192. Reçu soixante-quinze euros Eur75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009115267/298.
(090138701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Goodman European Business Park Fund (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.025,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 94.572.

Constituée par-devant Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), en date

du 19 juin 2003, acte publié au Mémorial C no 840 du 14 août 2003.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Goodman Business Park Fund (Lux) S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009113476/15.
(090136206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

SCOP Poland S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 101.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009113481/11.
(090136220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

89506

Radetzky S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 141.555.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 août 2009 a nommé Monsieur Stéphane Sabella, domicilié

professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg comme nouvel administrateur.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2009113465/14.
(090136151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

KPI Residential Property 19 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 116.325.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 6 février 2009 que:
Mr. Wolfgang Barg, né le 26 septembre 1950 à Mühlheim-Rhur (Allemagne), demeurant au Düppelstr. 26, D-24105

Kiel (Allemagne) a cédé l'intégralité des 15 parts sociales qu'il détenait dans le capital social de la société à Babcock &amp;
Brown European Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

Suite à ce transfert, l'actionnariat de la société est composé comme suit:

Babcock &amp; Brown European Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009113828/20.

(090137183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

Babcock &amp; Brown Retail Portfolio 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 119.932.

EXTRAIT

En date du 26 août 2009, le conseil de gérance a pris par voie circulaire la résolution suivante:
- le siège social de la société est transféré du 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg au 12, rue Guillaume

Schneider, L-2522 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

<i>Pour la société
Mark HATHERLY
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009113219/17.
(090135992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

89507

Minlam Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 136.787.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 29 juillet 2009

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Lu-

xembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet au 15 juin 2009.

Les gérants de la société, Christophe DAVEZAC et Alan DUNDON, ont également transféré leur adresse profes-

sionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009113221/17.
(090135620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Admiral Participations (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 141.953.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cessions intitulé Sale and Purchase Agreement daté du 29 juillet 2009 que l'associé unique

de la Société AIF VII Euro Holdings, L.P. résidant à Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street,
George Town, Grand Cayman KY1-9005, les Iles Cayman et enregistrée sous le numéro WK-23416 a cédé ses 12.500
parts sociales à Sand Holdings S.à r.l. domiciliée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg
(en cours d'enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg).

A compter du 29 juillet 2009, Sand Holdings S.à r.l. est devenu l'associé unique de la Société et détient donc l'intégralité

des parts sociales de la Société.

Fait à Luxembourg, le 27 Août 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009113835/20.
(090137262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2009.

Entreprise J.P. Becker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 25, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 20.154.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009113235/10.
(090136276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

EcoNew Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 147.911.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-six août

89508

Par devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son confrère

empêché Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

Ont comparu:

1.- Brundage Corporation, société de droit des îles vierges britanniques, ayant son siège social à Morgan &amp; Morgan

Building, Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Patrick Houbert, juriste, demeurant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 16,

avenue de la Porte-Neuve, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 12 août 2009,et 2. - Sector Investments
Inc., société de droit panaméen, ayant son siège social à Edificio Arango-Orillac, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panama,
République de Panama

ici représentée par Monsieur Patrick Houbert, prénommé
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 19 juin 2009,
lesquelles procurations, paraphées "ne varietur", par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant res-

teront annexées au présent acte.

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société ano-

nyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EcoNew Holding S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières

qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de cent

euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l'Assemblée Générale des actionnaires.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables

par l'Assemblée Générale des actionnaires.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de tous les administrateurs, représentant la totalité des mem-

bres du conseil d'administration, tel que mentionné sur les documents sociaux, y compris lors des résolutions du conseil
d'administration.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner un président. Le Président du Conseil d'Administration organise et

préside les réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la totalité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par l'administrateur absent par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier

89509

électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité des voix.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin de chaque année

à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

neuf.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an deux mille dix.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

1.- Brundage Corporation, prénommée, cent cinquante cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Sector Investments Inc, prénommée, cent cinquante cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Les actions ont été libérées à hauteur de 100% (cent pour cent) par des versements en espèces, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le confirme expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de Mille Six Cent euros (EUR 1.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Sergiy Ganzelyns'kyy, ingénieur en métallurgie, né le 16 janvier 1962 à Lugansk en Ukraine et demeurant

Schutzenmattstrasse 75, CH-4051 Bâle, Suisse,

89510

b) Monsieur Dementiyenko Aleksandr, ingénieur, né le 21 mai 1961 à Dnepropetrovsk en Ukraine et demeurant au

18, Morskaya str., 49010 Dnepropetrovsk, Ukraine

c) Monsieur Patrick Meunier, conseil économique, né à Paris (France), le 9 mai 1960, demeurant professionnellement

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve,

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l'Ecole, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 56.911.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'an deux mille quinze.

5.- Le siège social est établi à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude de Me Martine DECKER, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte

avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and nine, on the twenty sixth day of August
Before,  Maître  Martine  Decker,  notary  residing  in  Hesperange,  acting  in  replacement  of  its  colleague  Maître  Paul

Decker, notary residing in Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed,

There appeared:

1.- Brundage Corporation, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered

office in Morgan &amp; Morgan Building, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Patrick Houbert, jurist, residing professionally in L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-

Neuve,

by virtue of a proxy made under private seal given on August 12 

th

 , 2009, and

2. - Sector Investments Inc., a company incorporated under the laws of Panama, having its registered office in Edificio

Arango-Orillac, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panama, Republic of Panama

here represented by Mr Patrick Houbert, named above
by virtue of a proxy made under private seal given on June 19 

th

 , 2009,

which proxies, initialed "ne varietur", by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed. Said appearing parties, represented as stated here above, have established as follows the Articles of Incor-
poration of a company to be organized between themselves:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of EcoNew Holding S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, in either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The  corporation  may  moreover  carry  out  any  commercial,  industrial  or  financial  operations,  in  respect  of  either

moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into three Hundred ten

(310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

89511

The  shares  may  be  registered  or  bearer  shares,  at  the  option  of  the  holder,  except  those  shares  for  which  Law

prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders and who are appointed by the general assembly of the shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time by the general assembly of the shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by Law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The corporation is committed by the joint signatures of all the directors representing all the members of the board

of directors stated on the documents, including resolutions of the board.

Art. 6. The board of directors may elect a chairman. The chairman of the board of directors organizes meetings of

the board of directors and presides over the meeting of the board of directors.

The board can validly deliberate and act only if all of its members are present or represented, a proxy between

directors, which may be given by the correspondent director by letter, telegram, telex, telefax or e-mail, being permitted.
In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or e-mail.

Resolutions shall require a unanimous vote.

Art. 7. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The corporations's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the third Wednesday of the month of June at 10.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.

Art. 12. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of

Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory disposition

1) The first fiscal year shall begin on the date of formation of the company and will end on the thirty-first of December

two thousand and nine.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and ten.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1.- Brundage Corporation, previously named, one hundred fifty five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Sector Investments Inc, previously named, one hundred fifty five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: Three Hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

89512

These shares have been paid up to one hundred percent (100%) by payments in cash, so that the sum of thirty-one

thousand euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary, who
expessly confirms this.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 1,600.- (One Thousand
Six Hundred Euro)

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Sergiy Ganzelyns'kyy, metallurgical engineer, born 16/01/1962 in Lugansk, Ukraine, residing: Schutzenmattstrasse

75, CH-4051 Basel, Switzerland.

b) Mr Dementiyenko Aleksandr, engineer, born 21/05/1961 in Dnepropetrovsk, Ukraine, residing: 18, Morskaya str.,

49010 Dnepropetrovsk, Ukraine.

c) Mr Patrick Meunier, economic counsel, born in Paris (France), on 9 May 1960, residing professionally in L-2227

Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve,

3) Has been appointed auditor:
MRM CONSULTING S.A., "société anonyme", having its registered office in L-4394 Pontpierre, 5, rue de l'Ecole,

registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 56.911.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year

two thousand and fifteen.

5) The registered office of the company is established in L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Heserange, in the office of M 

e

 Martine DECKER, on the day

named at the beginning of the document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: P. HOUBERT, M. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 août 2009. Relation: LAC/2009/35106. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009115300/260.
(090138938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

SHCO 5, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.929.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the twentieth of August.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

89513

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15 Avenue de la Liberté, registered with the Luxembourg
trade registry under number B 103.123,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, professionally residing in Esch-sur Alzette,

5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy.

The said proxy will remain attached to the present deed.
The appearer announced the formation of a company with limited liability ("société à responsabilité limitée"), governed

by the relevant law and the present articles.

Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to

such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The company will assume the name of "SHCO 5" a private limited liability company.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) represented

by 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering

companies.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the

legal dispositions. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely trans-
ferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the

company to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers

have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager The daily management may be
delegated to one manager by the board of managers.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment

regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each

member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.

89514

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of members owning three quarters of the company's share capital.

If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.

The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18
Septembre 1933) are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and nine.

<i>Subscription and Payment

The 500 (five hundred) shares are subscribed by the sole shareholder as follows:
ATC Corporate Services (Luxembourg) S. A..
prenamed: 500 Five hundred shares
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred

Euro) as has been proved to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The parties estimate the value of formation expenses at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Decisions of the sole shareholder

The shareholder has taken the following decisions.
1) Is appointed as manager of the company for an undetermined period:
ATC Management (Luxembourg) S.à r.l. having its registered office at, 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

registered with the Luxembourg trade registry under number B 103.336,

2) The registered office is established in L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt août.

89515

Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

ATC Corporate Services (Luxembourg) S. A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, enregistrée auprès du
registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 103.123

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE employée, demeurant professionnellement à Esch-

sur-AIzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "SHCO 5", société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité  avec  les  dispositions  légales  afférentes.  Dans  l'hypothèse  où  il  n'y  a  qu'un  seul  associé  les  parts  sociales
détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B. La gestion journalière de la Société pourra être
délégué par le conseil de gérance à un de ses membres.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

89516

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou
la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes

de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le

notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille neuf.

<i>Souscription et Libération

Les 500 (cinq cents) parts sont souscrites par l'associé unique comme suit:
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.,
prédésignée: 500 Cinq cents parts sociales
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq

cents euros), ainsi qu'il en est justifié au au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Décisions de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ATC Management (Luxembourg) S. à r.l., ayant son siège social à 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 103.336.

2) Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

89517

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 août 2009. Relation: EAC/2009/10216. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, par Maître Aloyse BIEL en remplacement de Maître Francis KESSELER,
notaires de résidence à Esch/Alzette.

Esch/Alzette, le 07 septembre 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009116290/228.
(090139499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

KSM Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 120.149.

In the year two thousand and eight, on the thirty-first of January.
Before US Maitre Henri Beck, notary, residing in Echternach.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "KSM Investment S.A.", a joint stock company, having

its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered in the Trade and Company Register of
Luxembourg under section B, number 120.149, incorporated by notarial deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, on August 10 

th

 , 2006 published in the Memorial C of November 21 

st

 , 2006 n° 2168 and whose bylaws

have been amended for the last time on August 24 

th

 , 2007, published in the Memorial C n° 2371 of October 20 

th

 ,

2007.

The meeting is chaired by Mrs Claudine SCHOELLEN, private employee, residing in Roodt/Syre
The chairman appointed as secretary Mr Laurent THEISEN, private employee, residing in Osweiler.
The meeting elected as scrutineer Mrs Peggy SIMON, private employee, residing in Berdorf.
The chairman declares and requests the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, nine hundred (900) shares with a nominal value of one hundred and twenty-

five Euro (€ 125.-) each, out of a total of one thousand (1,000) shares, are present or represented at the present general
meeting. Considering that the remaining one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five
Euro  (€  125.-)  each  are  held  by  the  Corporation  and  thus  have  no  voting  right,  the  shares  present  or  represented
constitute together one hundred per-cent (100%) of the voting share capital of the Corporation, so that the meeting can
validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Decrease of the Corporation's share capital by twelve thousand, five hundred Euro (€ 12,500.-) in order to bring

it from its present amount of one hundred and twenty-five thousand Euro (€ 125,000.-) to one hundred and twelve
thousand, five hundred Euros (€ 112,500.-) by cancellation of one hundred (100) shares with a nominal value of one
hundred and twenty-five Euro (€ 125.-) each currently held by the Corporation.

2. Restatement of article 6.1 of the Corporation's bylaws in order to give it the following content:

6.1. The corporate capital is set at one hundred and twelve thousand, five hundred Euro (€ 112,500.-) represented

by nine hundred (900) shares with a nominal value of one Hundred and twenty-five Euro (€ 125.-) each, fully paid up.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholders.".
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to decrease the Corporation's share capital by twelve thousand, five hundred Euro (€ 12,500.-)

in order to bring it from its present amount of one hundred and twenty-five thousand Euro (€ 125,000.-) to one hundred
and twelve thousand, five hundred Euros (€ 112,500.-) by cancellation of one hundred (100) shares with a nominal value
of one hundred and twenty-five Euro (€ 125.-) each currently held by the Corporation.

<i>Second resolution

The meeting resolves to restate article 6.1 of the Corporation's bylaws in order to give it the following content:

89518

6.1. The corporate capital is set at one hundred and twelve thousand, five hundred Euro (€ 112,500.-) represented

by nine hundred (900) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (€ 125.-) each, fully paid up.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholders.".
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, all of whom are known to the notary

by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the
notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille huit, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KSM Investment S.A.", ayant

son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg section B sous le numéro 120.149, constituée par acte notarié de M 

e

 Joseph Elvinger, Notaire à Luxembourg,

en date du 10 août 2006, publié au Mémorial C du 21 novembre 2006, n° 2168 et dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois par acte notarié du 24 août 2007, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 2371 du 20 octobre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Claudine SCHOELLEN, employé privée, demeurant à Roodt/

Syre.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Laurent THEISEN, demeurant à Osweiler.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf.
La présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que neuf cents (900) actions avec une valeur nominale de cent vingt-cinq

Euros (€ 125,-) chacune, sur un total de mille (1,000) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire. Considérant que les cents (100) autres actions restantes avec une valeur nominale de cent vint-
cinq Euros (€ 125,-) chacune, sont détenues par la Société, et par conséquent que leur droit de vote est suspendu,
l'ensemble des actions présentes ou représentées constituent ensemble cent pour-cent (100%) du capital social avec droit
de vote de la Société, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social d'un montant de douze mille, cinq cents Euros (€ 12.500,-) afin de le ramener de son

montant actuel de cent vingt-cinq mille Euros (€ 125.000,-) à cent douze mille, cinq cents Euros (€ 112.500,-) par annu-
lation de cent (100) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€125,-) chacune, détenues ce jour par la
Société.

2. Modification de l'article 6.1 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

6.1. Le capital social est fixé à cent douze mille, cinq cents Euros (€ 112.500,-) représenté par neuf cents (900) actions

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-) chacune, libérées intégralement.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.".
3. Divers.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de douze mille, cinq cents Euros (€ 12.500,-) afin de le

ramener de son montant actuel de cent vingt-cinq mille Euros (€ 125.000,-) à cent douze mille, cinq cents Euros (€
112.500,-) par annulation de cent (100) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-) chacune, détenues
ce jour par la Société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

6.1. Le capital social est fixé à cent douze mille, cinq cents Euros (€ 112.500,-) représenté par neuf cents (900) actions

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-) chacune, libérées intégralement.

89519

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. SCHOELLEN, L. THEISEN, P. SIMON, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 1 

er

 février 2008. Relation: ECH/2008/134. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): J.- M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 03 septembre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009116323/111.
(090139445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Eurotime S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 56.177.

RECTIFICATIF

Une erreur s'est glissée dans la rédaction de l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de

façon extraordinaire le 25 mars 2009 de la Société Anonyme «EUROTIME S.A.». Ledit extrait a été enregistré à Luxem-
bourg le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08792 et déposé pour le compte de la société au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg le 8 avril 2009, sous le numéro 09005240, publié au Mémorial C n° 868 du 23 avril 2009.

Dans le point 2 des résolutions, il convient de lire «L'Actionnaire unique décide de nommer avec effet immédiat, en

remplacement du Commissaire aux comptes sortant, la société LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège social à
P.O. BOX 3161 Road Town, Tortola, British Virgin Islands. L'Actionnaire unique lui donne pouvoir pour émettre son
rapport sur les comptes clôturés au 30 juin 2008. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes clôturés au 30 juin 2014.»

au lieu de
«L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat, en remplacement du Commissaire aux comptes sor-

tant, LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège social à P.O. BOX 3161 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
L'Assemblée lui donne pouvoir pour émettre son rapport sur les comptes clôturés au 31 décembre 2008. Son mandat
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2014.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>POUR LA SOCIETE EUROTIME S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2009114945/26.
(090138192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Julius Baer Multiselect I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.408.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009114939/13.
(090138258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

89520


Document Outline

A.C. Europe S.A.

Admiral Participations (Luxembourg) S.à r.l.

Babcock &amp; Brown Retail Portfolio 4 S.à r.l.

Bsome S.à r.l.

Colle Développement S.A.

CRC Breeze Finance S.A.

EcoNew Holding S.A.

Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l.

Entreprise J.P. Becker S.A.

Espace Informatique S.A.

Espace Promotion Holding

Euphorbia Invest S.A.

Eurotime S.A.

EvrazSecurities S.A.

G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles

Goodman European Business Park Fund (Lux) S.à r.l.

H Chateau VII S.à r.l.

H.L. Heavy Load S.A.

ILU

Immobilière D.P. S.à r.l.

Information, Systèmes et Développement S.à r.l.

International Restaurants Group S.à r.l.

Investmarket Holding S.A.

Julius Baer Multiselect I

Kairós Estate S.A.

KPI Residential Property 19 S.à.r.l.

KSM Investment S.A.

Lizo S.A.

LSF5 Giga Investments S.àr.l.

Matrix Holdings S.A.

Minlam Luxembourg S.à r.l.

NewWorks Group S.A.

Oikia Holding S.A.

Optivita Securitisation S.à r.l.

Orbital S.à r.l.

Oriflame Cosmetics S.A.

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Patron Wilanow S.à r.l.

Perseus Investments S.A.

Postbahnhof an der Spree 1, Berlin S.à r.l.

Pro Sport S.A.

Pro Sport S.A.

Radetzky S.A.

responsAbility BOP

SCOP Poland S.àr.l.

SHCO 5

Simply Devine W. S.A.

Solufer S.A.

Stern Sàrl

Tarnold Holding S. à r.l.

Tecoh Investissements S.à r.l.

Trilantic Events Management S.à r.l.

Trois Sources Lomont Holdings S.à r.l.

VIII A Chateau S.à r.l.

Zigimmo International S.A.