logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1861

25 septembre 2009

SOMMAIRE

ABR Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

89326

Aicor S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89328

Baustahlarmierung B.S.V. S.A.  . . . . . . . . . .

89328

Brasserie Les Arcades S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

89328

BSL Special Opportunities  . . . . . . . . . . . . . .

89322

Chordia Invest I Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

89302

Cottonita Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

89298

Doka Renovation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

89326

Eikon Invest III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89299

Eikon Invest II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89304

Eikon Invest IV Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

89301

Eikon Invest V Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

89311

Eikon Invest VI Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

89303

Finance et Développement  . . . . . . . . . . . . .

89319

Frolan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89297

Gafi Sports S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89328

IKB International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89295

ING International (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89326

ING (L) Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89322

ING (L) Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89312

ING(L) Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89321

ING(L) Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89312

ING (L) Technix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89312

KBL European Private Bankers S.A.  . . . . .

89299

LBK Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

89300

LBREM II Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

89302

Lourmel Holding S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . .

89303

Luxumbrella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89327

Maiden International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

89300

Maison Seil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89296

Modaven & Co SCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89327

Netcare S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89312

Odyssey Financial Technologies S.A.  . . . . .

89298

Orthodontic Management Service S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89327

Panelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89320

Partners Group European Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89316

Partners Group European Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89304

Partners Group European Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89313

Partners Group European Mezzanine 2005

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89308

Primafina S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89320

Rafico Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89327

Redevco Industrial Düsselburg S.A.  . . . . . .

89298

Sisen International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89326

Skimo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89283

Subtarc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89294

Thore SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89282

Thore S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89282

Transfert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89327

United Intercom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89321

Vision Industries S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89301

Werkstatt A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89284

Werkstatt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89284

WestLB Mellon Compass Fund  . . . . . . . . . .

89295

WW+ architektur & management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89327

89281

Thore S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Thore SA).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.213.

L'an deux mille neuf, le six août.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire de la société THORE S.A. (la Société),

une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 11A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg,  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  du  Luxembourg  sous  le  numéro  B  142.213,
constituée suivant un acte notarié du 22 septembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -
N° 2610 en date du 24 octobre 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg (le

Président).

Le président désigne  en  qualité  de secrétaire  de l'Assemblée Monsieur  Guy DECKER,  employé privé,  demeurant

professionnellement à Luxembourg (le Secrétaire).

L'Assemblée élit Monsieur Jacques-Amaury THOMASSET, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau de l'Assemblée.
L'actionnaire représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de pré-

sences qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le représentant de l'actionnaire ainsi que
par les membres du Bureau.

Les procurations de l'actionnaire représenté à la présente Assemblée resteront également annexées au présent procès-

verbal après avoir été signées par le représentant de l'actionnaire ainsi que par les membres du Bureau.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:
qu'il ressort de la liste de présences établie et certifiée par les membres du Bureau, que l'intégralité du capital social

de la Société est dûment représentée à l'Assemblée, qui est donc considérée comme valablement constituée et apte à
délibérer des points de l'ordre du jour mentionnés ci-dessous;

que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1) Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société de participations financières (SO-

PARFI) mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

2) Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société relative à l'objet social pour lui donner la teneur

suivante:

"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments

financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature
que ce soit détenus en compte. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale. Elle réservera ses actions, soit à des
personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant
exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires
agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation. Les titres qu'elle

émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs. Elle prendra
toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son
objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

3) Modification subséquente de l'article 17 des statuts.
4) Changement de la dénomination de la société en "THORE S.A., SPF" et modification subséquente de l'article 1 

er

des statuts.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués
et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer le statut fiscal de la société d'une société de participations financières (SOPARFI) en

une société de gestion de patrimoine familial (SPF) gouvernée par la loi du 11 mai 2007.

89282

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet social et en conséquence l'article 4 des Statuts, de façon à soumettre la Société

et la rendre compatible avec la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

L'article 4 des Statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale. Elle réservera ses
actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités
patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit
à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation. Les titres qu'elle

émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs. Elle prendra
toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son
objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en "THORE S.A. SPF" et décide en conséquence de

modifier l'alinéa 1 

er

 de l'article 1 

er

 des Statuts comme suit:

 Art. 1 

er

 . Alinéa 1 

er

 .  Il existe une société anonyme prenant la dénomination de "THORE S.A. SPF" (la Société)."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier en conséquence l'article 17 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 17. Les lois du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 11 mai 2007 sur les société de gestion de

patrimoine familial ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts."

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses supportées par la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à

mille euros (EUR 1.000).

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original

du présent acte.

Signé: B. TASSIGNY, G. DECKER, J.-A. THOMASSET.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 août 2009. Relation: LAC/2009/32673. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009114401/95.
(090137568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Skimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 31.527.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009114396/13.
(090137544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

89283

Werkstatt S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Werkstatt A.G.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.605.

L'an deux mil neuf, le onze août.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "WERKSTATT A.G.", ayant son

siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à la
section B sous le numéro 132605, constituée le 2 juin 1971 au Liechtenstein et transférée au Grand-Duché de Luxembourg
en date du 2 octobre 2007 suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2612 du 15 novembre 2007 (ci-après "la Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnel-

lement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Diane VAN AKEN, employée privée, demeurant professionnellement au

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 50 (cinquante) actions représentant l'intégralité du capital

social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre de jour

1. Transformation de la Société de sa forme actuelle de société anonyme de droit luxembourgeois en société à res-

ponsabilité limitée.

2. Changement de la dénomination sociale en "WERKSTATT S.à r.l.".
3. Modification de l'objet social de la société et refonte complète des statuts.
4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonctions, décharge à leur accorder

pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant la transformation de la société en
société à responsabilité limitée.

5. Nomination d'un nouveau gérant unique de la Société, fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat.
6. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 30 juin 2009.
7. Transfert du siège social et statutaire de la société du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 62, Via

del Gesù, 00186 Rome et adoption par la société à responsabilité de la nationalité italienne, sous réserve de l'inscription
de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Rome.

8. Changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera "Immobiliare Zambrini 2008 s.r.l."
9. Démission du gérant en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de

l'assemblée générale décidant le transfert du siège social en Italie.

10. Nomination de Monsieur Alfonso BUONPENSIERE, né à Rome le 17 décembre 1966, domicilié au 3 via della

Fraternità, 53045 Montepulciano (SI), Italie, code fiscal: BNPLNS66T17H501l, en qualité de gérant unique, fixation de ses
pouvoirs et du terme de son mandat.

11. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.
12. Délégation de pouvoirs.
13. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès que la société aura été

inscrite auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Rome.

14. Divers.

89284

Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  prend  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la Société de sa forme actuelle de société anonyme de droit luxembourgeois en

société à responsabilité limitée.

L'assemblée  constate  qu'aucun  emprunt  obligataire  n'a  été  émis  par  la  Société  et  que  dès  lors  aucun  accord  des

obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "WERKSTATT S.à r.l.".

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social actuel de la société et d'adopter les statuts d'une société à responsabilité

limitée comme suit:

 Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée luxembourgeoise régie par la loi et les présents statuts sous

la dénomination "WERKSTATT S. à r. l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle pourra également accomplir toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à l'acquisition, la gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers situés
au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille euros) représenté par 50 (cinquante) parts sociales d'une

valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir individuellement au nom de la société

dans toutes les circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

89285

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur."

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonc-

tion et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de ce jour.

L'assemblée  décide  de  nommer  comme  nouveau  gérant  de  la  Société,  avec  les  pouvoirs  définis  à  l'article  11  des

nouveaux statuts et pour une durée indéterminée, Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, de-
meurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire arrêtée au 30 juin 2009, telle qu'elle a été rédigée

par le gérant unique en fonction avant le transfert du siège social.

Une copie de cette situation, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social et statutaire de la Société du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg au 62, Via del Gesù, 00186 Rome, Italie et d'adopter la nationalité italienne sous réserve de l'inscription de
la Société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Rome.

L'assemblée  constate  qu'aucun  emprunt  obligataire  n'a  été  émis  par  la  Société  et  que  dès  lors  aucun  accord  des

obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement

de la nationalité est donc prise à l'unanimité des associés existants.

Elle constate également:
- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux

autorités compétentes;

- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'auront en aucun cas pour effet,

ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société. Cette résolution est prise en conformité
avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la
Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986,
numéro 131 et toutes dispositions concernées.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en "Immobiliare Zambrini 2008 s.r.l."

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du gérant actuellement en fonction et de lui accorder décharge pleine et

entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée  décide  de  nommer,  en  conformité  avec  la  législation  italienne,  avec  les  pouvoirs  lui  conférés  par  les

nouveaux statuts italiens, pour une durée de trois exercices, sauf révocation ou démission, Monsieur Alfonso BUON-

89286

PENSIERE, né à Rome le 17 décembre 1966, domicilié au 3 via della Fraternità, 53045 Montepulciano (SI), Italie, code
fiscal: BNPLNS66T17H501I, en qualité de gérant unique ("amministratore unico") de la société.

Enfin l'assemblée décide que les émoluments du gérant unique seront fixés en accord avec les tarifs en vigueur en Italie.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire
adopter ces nouveaux statuts devront être accomplies:

Art. 1. Costituzione. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "Immobiliare

Zambrini 2008 S.r.l.".

Art. 2. Sede.
2.1) - La società ha sede nel Comune di Roma.
2.2) - L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio suc-

cursali,  filiali  o  uffici  amministrativi  senza  stabile  rappresentanza),  ovvero  di  trasferire  la  sede  sociale  nell'ambito  del
Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello
indicato sub. 2.1.

Art. 3. Oggetto sociale.
3.1) - La società ha per oggetto le seguenti attività:
a) - la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione, sia per conto proprio, sia per conto terzi enti pubblici o

privati, di fabbricati urbani, residenziali, turistici, industriali, commerciali, alberghieri ed agricoli, nonchè la esecuzione, per
conto proprio o di terzi, di opere edili, stradali, termoidrauliche, elettriche o di bonifica, e l'assunzione o il conferimento
di appalti relativamente alle opere medesime;

b) - la compravendita, la permuta, l'affitto, la stima, la valorizzazione di terreni e fabbricati di qualsiasi natura e desti-

nazione;

c) - la gestione tecnica delle manutenzioni degli immobili e la gestione amministrativa di immobili e terreni di qualsiasi

tipo.

Inoltre la Società, al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale di cui sopra, potrà compiere tutte le operazioni

industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la locazione anche finanziaria di beni mobili ed
immobili, che risulteranno utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale (ad eccezione delle intermediazione
di valori mobiliari e delle attività regolate dal D. Lgs. 58/1998).

Costituirà anche attività sociale l'acquisizione di interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto

analogo e/o affine, o comunque connesso al proprio, purché tale attività sia esercitata in funzione accessoria e/o stru-
mentale al conseguimento del proprio oggetto sociale.

La Società potrà, altresì, prestare fideiussioni e garanzie in genere, anche reali, nell'interesse di terzi, nonchè assumere

finanziamenti con l'obbligo di rimborso, fruttiferi od infruttiferi, presso soci e o terzi.

È tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Art. 4. Durata.
4.1) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione

dell'assemblea dei soci.

Art. 5. Capitale.
5.1) - Il capitale è fissato in Euro 50.000 (Euro cinquantamila), diviso in quote ai sensi di legge.
5.2) - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei

soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

5.3)  -  In  caso  di  decisione  di  aumento  del  capitale  sociale  mediante  nuovi  conferimenti  spetta  ai  soci  il  diritto  di

sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

5.4) - Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo sus-

cettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

5.5) - Gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto il conferimento di prestazione d'opera o di servizi devono essere

garantiti mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui tali obblighi vengono
garantiti per l'intero valore ad essi assegnato in sede di conferimento. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite
dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.6) - La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi

indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.7) - Nei casi previsti dall'art. 2465 comma II, l'acquisto non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

89287

Art. 6. Riduzione del capitale.
6.1) - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci

da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

6.2) - In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale,

almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della
società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti
i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7. Finanziamenti dei soci.
7.1) - I finanziamenti dei soci, che danno luogo a restituzione, andranno fatti esclusivamente dai soci iscritti nel libro

soci da almeno tre mesi e con una quota di partecipazione al capitale sociale di almeno il due per cento riferito all'am-
montare del capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
e in particolare del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 (T. U. in materia creditizia e finanziaria), il tutto facoltativamente per i soci
stessi.

7.2) - In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali

perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assu-
mere in sede assembleare.

7.3) - Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 cod. civ.

Art. 8. Diritti dei soci.
8.1) - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9. Partecipazione e loro trasferimento.
9.1) - Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un

rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2) - Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.
9.3) - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro

soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 9.5).

9.4) - Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti

negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i
contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

9.5) - Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
- il socio che intende trasferire a terzi la propria quota o diritti sulla stessa, dovrà comunicare agli altri soci a mezzo

di lettera raccomandata a mano o con avviso di ricevimento l'intenzione di vendere e le condizioni relative;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccoman-

data e comunicato al venditore per mezzo di lettera raccomandata a mano o con avviso di ricevimento;

- ove più soci dichiarassero di volere esercitare il diritto di prelazione su quanto offerto in vendita, il diritto sarà

riconosciuto in proporzione alle quote possedute al momento dell'offerta;

- qualora la prelazione non sia esercitata nella forma e nei termini sopra descritti, il diritto di prelazione si intenderà

rinunciato;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione;
- il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto in favore di altri soci;
- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto,

l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti
amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente

abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci;

- le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando agli altri soci il diritto di

prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge o di parenti in linea retta del socio, in qualunque grado.

9.6) - L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fidu-

ciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 10. Trasferimento mortis causa delle partecipazioni.
10.1) - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della

società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune, sino a quando gli eredi
stessi non avranno formalmente provveduto con atto dichiarativo al frazionamento della quota e ne avranno dato com-
unicazione alla società.

89288

Art. 11. Decisioni dei soci.
11.1) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sotto-
pongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) - la nomina dell'organo amministrativo;
c) - la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) - la nomina nei casi previsti dalla legge e dallo statuto dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
e) - le modificazioni del presente statuto.
11.2) - Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 11.3) che nelle forme di cui al

successivo art. 12), i soci morosi.

11.3) - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta

ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

11.4) - Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o

astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.
11.5) - Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento

scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i 5 (cinque) giorni successivi dovranno

trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno
esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della
loro contrarietà o astensione.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che

consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11.6) - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura

proporzionale alla sua partecipazione.

11.7) - Le decisioni dei soci sono adottate con i rispettivi quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.
11.8) - Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro

delle decisioni dei soci.

Art. 12. Assemblea.
12.1) - Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.1) ai punti d) ed e), e in tutti gli altri casi espres-

samente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo stabilisca il Presidente del Consiglio di Amminis-
trazione nell'avviso di convocazione, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare
nel rispetto del metodo collegiale.

12.2) - A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dal Comune ove è posta

la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

12.3) - L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amminis-

tratori con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero
con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio
risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve
essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, o allo specifico recapito che siano stati espressamente
comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il
giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.4) - Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui

nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

12.5) - In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone
alla trattazione dell'argomento.

89289

Art. 13. Svolgimento dell'Assemblea.
13.1) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art.

16.1 sub b). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto
della maggioranza dei presenti.

13.2) - L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
13.3) - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, dirigere il regolare svolgimento dell' Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.

Art. 14. Diritto di voto e quorum assembleari.
14.1) - A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.
14.2) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.
14.3) - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che

dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo

da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la successiva convocazione avente il medesimo

ordine del giorno.

14.4) - L'assemblea in prima convocazione, in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti

soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

14.5) - L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.
Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tale da consentire l'individuazione dei soci

dissenzienti ed astenuti.

14.6) - L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma 14.4 delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei

casi previsti dai nn. 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 ce, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno
la metà del capitale sociale.

Art. 15. Verbale dell'assemblea.
15.1) - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal

notaio, se richiesto dalla legge.

15.2) - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rap-

presentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
15.3) - Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto

da un notaio.

15.4) - Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro

delle decisioni dei soci.

Art. 16. Amministrazione.
16.1) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina:
a) da un amministratore unico;
b)  da  un  consiglio  di  amministrazione  composto  da  tre  a  sei  membri,  secondo  il  numero  determinato  dai  soci  al

momento della nomina.

16.2) Gli amministratori possono essere anche non soci.

Art. 17. Durata della carica, revoca, cessazione.
17.1) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento

della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.
17.2) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo

amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18. Consiglio di amministrazione.
18.1) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i

suoi membri un presidente.

18.2) Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli ammi-

nistratori in carica.

89290

Art. 19. Adunanze del consiglio di amministrazione.
19.1) Le adunanze del consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta anche

di uno solo degli altri amministratori.

19.2) La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,

con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in
caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o in Paesi dell'Unione Europea.
19.3) Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando interviene

la maggioranza dei consiglieri in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

19.4) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese in adunanza collegiale e con il voto favorevole della

maggioranza dei suoi membri in carica, in caso di parità di voti è prevalente il voto del Presidente del Consiglio.

19.5) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza,

alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-

lizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 20. Poteri dell'organo amministrativo.
20.1) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento

degli atti che la legge riserva alla decisione dei soci.

20.2) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, nei limiti

di legge, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

20.3) Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di

atti, determinandone i poteri.

Art. 21. Rappresentanza.
21.1) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente e, nei limiti della

delega, agli amministratori delegati.

21.2) La rappresentanza della società può essere conferita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti

dei poteri stabiliti nell'atto di nomina.

Art. 22. Compensi degli amministratori.
22.1) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso pro-

porzionale agli utili netti di esercizio.

Art. 23. Organo di controllo.
23.1) - Quale organo di controllo, i soci possono nominare, in via alternativa, un Collegio Sindacale o un Revisore.
23.2) - La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito

per le società per azioni. È altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal
primo comma dell'art. 2435 bis c.c. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono
superati.

Art. 24. Composizione e competenze del collegio sindacale.
24.1) - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale

è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

24.2) - I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta

nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione
dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci

sono rieleggibili.

24.3) - Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano

nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

89291

24.4) - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza

assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
24.5) - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci

restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in
carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.
24.6) - Il compenso annuo dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del

loro ufficio.

24.7) - In tutti i casi di nomina obbligatoria del Collegio sindacale si applicano a questo ultimo le disposizioni dettate

in tema di società per azioni. In tali casi il controllo contabile è comunque esercitato dal medesimo Collegio sindacale.

24.8) - Delle riunioni del collegio sindacale deve redìgersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni

del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a mag-
gioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 12 e alle adunanze del Consiglio

di Amministrazione.

24.9) - Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della

denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 (un ventesimo)
del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte all'assemblea.

Art. 25. Recesso del socio.
25.1) - Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge.
25.2) - Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata

a.r. agli altri soci, all'Organo Amministrativo e, se nominati, ai componenti il Collegio sindacale, ovvero al Revisore. La
raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dalla data in cui:

-  è  avvenuta  l'iscrizione  nel Registro delle Imprese  della  decisione dei  soci  o  della  deliberazione assembleare  che

legittima il diritto di recesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dall'Organo Amministrativo a mezzo lettera

raccomandata a.r., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
25.3) - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/

o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

25.4) - I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore

da determinarsi ai sensi del successivo art. 26.

25.5) - In caso di esercizio del diritto di recesso relativo a quote intestate a società fiduciaria, questa ultima ha comunque

la facoltà di reintestare le quote al proprio mandante.

Art. 26. Determinazione del valore della partecipazione recedente.
26.1) - I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in pro-

porzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore
di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite rela-
zione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, che provvede anche
sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

26.2) - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro

centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

26.3) - Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro parte-

cipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo
deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora ciò non avvenga, il rimborso
è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo
ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della parteci-
pazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 27. Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili.
27.1) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
27.2) - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di

esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

27.3) - Il bilancio deve essere presentato ai soci, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo

89292

richiedano: in questo ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa
in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

27.4) - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento)

da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

27.5) - La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Art. 28. Scioglimento e liquidazione.
28.1) - Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per

la modifica del presente statuto.

28.2) - Nel caso di cui al precedente art. 28.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.

2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da
adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di

singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.
28.3) - La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa

di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente
statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter, Il comma, cod. CIV.
28.4) - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano,

in quanto compatibili, anche durante le liquidazione.

28.5) - Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Art. 29. Titoli di debito.
29.1) - La società può emettere titoli di debito.
L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del

presente statuto.

29.2) - I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali

soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde
della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

29.3) - La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve

essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 30. Clausola compromissoria.
30.1) - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori

e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell' Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la
società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero
in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente,
il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

30.2) - Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, come arbitro rituale

e secondo diritto.

30.3) - Il Collegio Arbitrale stabilirà le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
30.4) - Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge

preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

30.5) - Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la

maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successi 90
(novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 25.

Art. 31. Disposizioni Generali.
31.1) - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

89293

31.2) - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgi-

mento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all'amministrazione.

31.3) - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in

quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di
legge in tema di società unipersonale.

31.4) - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità

limitata."

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Alfonso BUONPENSIERE, prénommé, tous pouvoirs en vue d'accomplir

toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes
en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre
quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises
ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la Société.

En outre, Monsieur Alfonso BUONPENSIERE est autorisé à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter

et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Rome,
ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être
concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la Société en tant que société de droit italien et, d'autre part, la
cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la

Société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
("Registro Imprese") de Rome.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être

obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

<i>Douzième résolution

La radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sera réalisée sous la condition

suspensive de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Rome.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ trois mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: M. ALBERTUS, E. DUBLET, D. VAN AKEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2009. Relation: LAC/2009/33099. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009114725/580.
(090138214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Subtarc S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 890.710,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 104.769.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

L'administrateur de la Société, Monsieur Peter Gibbs, a changé son adresse professionnelle du 20 Southampton Street,

Londres WC2E 7QH, Royaume-Uni au 80 Pall Mall, Londres SW1Y 5ES, Royaume-Uni.

89294

Séverine Michel
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009114667/14.
(090137648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

WestLB Mellon Compass Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 67.580.

<i>Extrait des Décisions prises par le Conseil d'Administration

<i>de la Société sous forme de résolution circulaire datée du 31 juillet 2009

Le Conseil d'Administration a noté la démission de Madame Margit Timmermann de sa fonction d'administratrice et

Présidente du Conseil d'Administration de la société susmentionnée avec effet au 31 juillet 2009.

Suite à cette démission, le Conseil d'Administration a décidé de coopter avec effet au 1 

er

 août 2009, Madame Anne

de Nonancourt, née le 10 septembre 1969 à Strasbourg, France, domiciliée professionnellement à 1, rue Jean-Pierre
Brasseur, L-1258 Luxembourg, en remplacement de Madame Timmermann, en tant qu'Administratrice de la Société
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2009.

Le conseil d'Administration a décidé d'élire Monsieur Martin Tillert en qualité de Président du Conseil d'Administration

en remplacement de Madame Timmermann avec effet au 1 

er

 août 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2009.

<i>WestLB Mellon Compass Fund
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009114997/23.
(090138087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

IKB International, Société Anonyme.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 17.018.

<i>Angaben zum Verwaltungsrat der IKB International S.A.

Verwaltungsratsmitglieder:
Gesellschaftsorgan: Verwaltungsrat
Name: Dr. Glüder Vorname(n): Dieter
Geburtsdatum: 02/08/1955
Amtsausführung: Vorsitzender des Verwaltungsrates
Privat- oder Berufsadresse der Privatperson:
1, Wilhelm-Bötzkes-Strasse, D-40474 Düsseldorf

Dauer des Mandats: Begrenzt

Bestellungsdatum: 20.12.2007
Bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2012 stattfinden wird.

Laut Beschluss des Verwaltungsrats der IKB International S.A. vom 20.12.2007 in Düsseldorf wird Herr Dr. Glüder

einstimmig zum Vorsitzender des Verwaltungsrates gewählt.

Name: Schüttler Vorname(n): Hans Jörg
Geburtsdatum: 22/10/1955
Amtsausführung: Mitglied des Verwaltungsrates
Privat- oder Berufsadresse der Privatperson:
1, Wilhelm-Bötzkes-Strasse, D-40474 Düsseldorf

Dauer des Mandats: unbegrenzt

Bestellungsdatum: 27/08/2009

Laut Beschluss der Generalversammlung der IKB International S.A. vom 26.08.2009 in Luxemburg wird Herr Schüttler

einstimmig zum Mitglied des Verwaltungsrates bestellt.

Name: Momburg Vorname(n): Claus
Geburtsdatum: 28/02/1959

89295

Amtsausführung: Mitglied des Verwaltungsrates
Privat- oder Berufsadresse der Privatperson:
1, Wilhelm-Bötzkes-Strasse, D-40474 Düsseldorf

Dauer des Mandats: begrenzt

Bestellungsdatum: 10.03.2009
Bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2012 stattfinden wird.

Laut Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der IKB International S.A. vom 09.03.2009 in Luxembourg

wird Herr Momburg einstimmig zum Mitglied des Verwaltungsrates bestellt.

Name: Grzesik, Dr. Vorname(n): Reinhard
Geburtsdatum: 19/03/1959
Amtsausführung: Mitglied des Verwaltungsrates
Privat- oder Berufsadresse der Privatperson:
Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, D-40474 Düsseldorf

Dauer des Mandats: Bis 03.07.2009

Bestellungsdatum: 16/05/2008

Herr Dr. Grzesik scheidet am 03.07.2009 aus dem Verwaltungsrat der IKB International S.A. aus und legt sein Amt als

Mitglied des Verwaltungsrates der IKB International S.A. mit Wirkung zum gleichen Tag nieder.

Name: Leimbach, Dr. Vorname(n): Andreas
Geburtsdatum: 27/05/1959
Amtsausführung: Mitglied des Verwaltungsrates
Privat- oder Berufsadresse der Privatperson:
Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, D-40474 Düsseldorf

Dauer des Mandats: 31.01.2009

Bestellungsdatum: 16/05/2008

Herr Dr. Leimbach scheidet am 31.01.2009 aus dem Verwaltungsrates der IKB International S.A. aus und legt sein Amt

als Mitglied des Verwaltungsrates der IKB International S.A. mit Wirkung zum gleichen Tag nieder.

Luxemburg, 01.09.2009.

IKB International
W. Güth / U. Krusch

Référence de publication: 2009114993/55.
(090137983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Maison Seil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 112.389.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 19 août 2009 que:
- M. Bernhard Michael Veithen, gérant de succursale de IVG Belux, né à St Vith (Belgique) le 19 août 1963, ayant son

adresse professionnelle au 7, Avenue Lloyd George, 1000 Bruxelles (Belgique), a été nommé en tant qu'administrateur
de la Société, avec effet au 4 août 2009 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2015;

- M. Markus Alois Rüger, employé au département comptabilité de IVG Institutional Funds GmbH, né à Mainz (Alle-

magne) le 4 mars 1968, ayant son adresse professionnelle au Wettinerstr. 3, 65189 Wiesbaden (Allemagne), a été nommé
en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 4 août 2009 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se
tenir en 2015;

- M. Oliver Brust, employé au département comptabilité de IVG Institutional Funds GmbH, né à Wiesbaden (Allemagne)

le 3 avril 1968, ayant son adresse professionnelle à Wettinerstr. 3, 65189 Wiesbaden (Allemagne), a été nommé en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet au 4 août 2009 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en
2015; et

- M. Jens Holste, employé au département comptabilité de IVG Institutional Funds GmbH, né à Wiesbaden (Allemagne)

le 24 mai 1978, ayant son adresse professionnelle à Wettinerstr. 3, 65189 Wiesbaden (Allemagne), a été nommé en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet au 4 août 2009 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en
2015.

En conséquence, le conseil d'administration de la Société est désormais constitué des personnes suivantes:
- M. Petrus Wilhelmus Jacobus Le Loux;
- M. Georg Dieter Gottlieb Klusak;
- M. Ferdinand Enrico Bernd von Sydow;
- M. Bernhard Michael Veithen;

89296

- M. Markus Alois Rüger
- M. Oliver Brust; et
- M. Jens Holste.
Il résulte également de ces mêmes résolutions que ces nouveaux administrateurs ainsi nommés ont tous les pouvoirs

pour agir au nom de la Société, sauf en cas d'acquisition, de vente ou de création de sûretés sur des actifs immobiliers
ou sur des sociétés d'immobilier.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009114994/40.
(090138208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Frolan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 32, route de Holzem.

R.C.S. Luxembourg B 58.159.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue au siège social le 5 janvier 2009

<i>Résolutions

1. L'Assemblée approuve la modification du lieu de résidence de l'Administrateur:
Monsieur François Riggi, vers l'adresse suivante:
11, Place de la Résistance
B-7711 Dottignies
2. L'Assemblée approuve la reconduction pour une durée déterminée, allant du 1 

er

 janvier 2009 au 31 décembre

2014, du mandat de l'Administrateur:

Monsieur François Riggi
11, Place de la Résistance
B-7711 Dottignies
3. L'Assemblée approuve la reconduction pour une durée déterminée, allant du 1 

er

 janvier 2009 au 31 décembre

2014, du mandat de l'Administrateur délégué:

Monsieur François Riggi
11, Place de la Résistance
B-7711 Dottignies
4. L'Assemblée approuve la reconduction pour une durée déterminée, allant du 1 

er

 janvier 2009 au 31 décembre

2014, du mandat de l'Administrateur:

Madame Angelina Puyo
11, Place de la Résistance
B-7711 Dottignies
5. L'Assemblée approuve la résiliation, à la date de la présente assemblée générale, du mandat de l'Administrateur:
Monsieur Fabrice Riggi
176, rue de Saint-Léger
B-7700 Moucron
6. L'Assemblée approuve la modification du lieu de résidence de l'Administrateur:
Madame Puyo Carole, vers l'adresse suivante:
11, Place de la Résistance
B-7711 Dottignies
7. L'Assemblée approuve la reconduction pour une durée déterminée, allant du 1 

er

 janvier 2009 au 31 décembre

2014, du mandat de l'Administrateur:

Madame Puyo Carole
11, Place de la Résistance
B-7711 Dottignies

89297

8. L'Assemblée approuve la reconduction pour une durée déterminée, allant du 12 juin 2003 au 31 décembre 2008,

du mandat de l'Administrateur délégué:

Madame Puyo Carole
11, Place de la Résistance
B-7711 Dottignies
9. L'Assemblée approuve la reconduction pour une durée déterminée, allant du 1 

er

 janvier 2009 au 31 décembre

2014, du mandat de l'Administrateur délégué:

Madame Puyo Carole
11, Place de la Résistance
B-7711 Dottignies
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12.00 heures après signature du présent

procès-verbal par les membres du bureau.

Carole Puyo / Angelina Puyo / François Riggi
Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2009114992/55.
(090138230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Odyssey Financial Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 51.921.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration

<i>tenu au siège social en date du 24 avril 2009

Le Conseil d'Administration prend note et entérine le changement d'adresse privée de Monsieur Didier Vankeerber-

ghen - Administrateur.

Nouvelle adresse:
Avenue du Bois, 129 à 1250 Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg le 24 avril 2009.

Certifié Conforme
Guy Eggermont / Didier Vankeerberghen
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009114995/17.
(090138142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Cottonita Investments S.A., Société Anonyme,

(anc. Redevco Industrial Düsselburg S.A.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 96.935.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Cottonita Investments S.A. qui s'est tenue en date du 26

juin 2009 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur

les comptes de l'exercice 2009, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de

Bragance, Président du Conseil.

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.
- Dominic BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à D-40213 Dusseldorf, Carl-

Theodor-Strasse 6, Allemagne.

- Armand HAAS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1653 Luxembourg, 2 Avenue Charles

De Gaulle, Espace Pétrusse, "Le Dôme".

A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2009:

- Ernst &amp; Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

89298

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2009115056/26.
(090138314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Eikon Invest III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 82.133.

<i>Extract of the resolutions taken at the extraordinary general meeting of August 25 

<i>th

<i> , 2009

- The resignation of Mrs Joanne BAXTER, born on June 12 

th

 , 1970 in Guernsey, professionally residing at 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on May 29 

th

 , 2009;

- the resignation of Mrs Constance HELYAR, born on February 13 

th

 , 1948 in Guernsey, professionally residing at

13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on August 19 

th

 , 2009;

- the number of Directors be reduced from 4 to 3;
- Mrs Isabelle DONADIO, private employee, born on October 3 

rd

 , 1962 in Amnéville (France), professionally residing

at 412 F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG, be appointed as new Director. Her mandate will lapse at the Annual
General Meeting of the year 2012;

- Mr. Pierre MESTDAGH, private employee, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, and

Mr. Jean-Robert BARTOLINI, awarded in D.E.S.S., residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg will
continue their mandate of Directors which will lapse at the Annual General Meeting of the year 2012.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2009

- La démission de Madame Joanne BAXTER, née le 12 juin 1970 à Guernesey, demeurant professionnellement au 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands, est acceptée avec effet au 29 mai 2009;

- la démission de Madame Constance HELYAR, née le 13 février 1948 à Guernesey, demeurant professionnellement

au 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands est acceptée avec effet au 19 août 2009;

- le nombre d'Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, née le 3 octobre 1962 à Amnéville, demeurant professionnellement

au  412  F,  route  d'Esch,  L-2086  LUXEMBOURG,  est  nommée  comme  nouvel  Administrateur.  Son  mandat  viendra  à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086 LU-

XEMBOURG et Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412 F, route
d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG continuent leur mandat d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2012.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR EIKON INVEST III S.A.
SGG. S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009115103/38.
(090137969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

KBL European Private Bankers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 6.395.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 29 avril 2009

Composition du Conseil d Administration
En raison de son départ à la retraite, M. Herman Agneessens a présenté sa démission comme membre du Conseil

d'Administration avec effet au 29.04.2009.

Adresse professionnelle: 2, Havenlaan B - 1080 BRUXELLES

89299

Luxembourg, le 28 août 2009.

Certifié sincère et conforme
M.P. GILLEN / J.P. LOOS
<i>Secrétaire Général / Administrateur

Référence de publication: 2009115082/16.
(090138308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

LBK Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 82.138.

<i>Extract of the resolutions taken at the extraordinary general meeting of August 25 

<i>th

<i> , 2009

- The resignation of Mrs Joanne BAXTER, born on June 12 

th

 , 1970 in Guernsey, professionally residing at 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on May 29 

th

 , 2009;

- the resignation of Mrs Constance HELYAR, born on February 13 

th

 , 1948 in Guernsey, professionally residing at

13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on August 19 

th

 , 2009;

- the number of Directors be reduced from 4 to 3;
- Mrs Isabelle DONADIO, private employee, born on October 3 

rd

 , 1962 in Amnéville (France), professionally residing

at 412 F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG, be appointed as new Director. Her mandate will lapse at the Annual
General Meeting of the year 2012;

- Mr. Pierre MESTDAGH, private employee, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, and

Mr. Jean-Robert BARTOLINI, awarded in D.E.S.S., residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg will
continue their mandate of Directors which will lapse at the Annual General Meeting of the year 2012.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2009

- La démission de Madame Joanne BAXTER, née le 12 juin 1970 à Guernesey, demeurant professionnellement au 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands, est acceptée avec effet au 29 mai 2009;

- la démission de Madame Constance HELYAR, née le 13 février 1948 à Guernesey, demeurant professionnellement

au 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands est acceptée avec effet au 19 août 2009;

- Le nombre d'Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, née le 3 octobre 1962 à Amnéville, demeurant professionnellement

au  412  F,  route  d'Esch,  L-2086  LUXEMBOURG,  est  nommée  comme  nouvel  Administrateur.  Son  mandat  viendra  à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086 LU-

XEMBOURG et Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412 F, route
d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG continuent leur mandat d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2012.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR LBK FINANCE HOLDING S.A.
SGG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009115095/38.
(090137960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Maiden International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 92.865.

<i>Extrait de la résolution prise lors du procès-verbal du conseil d'administration du 3 avril 2009

Monsieur Horst SONNENTAG, directeur, demeurant professionnellement au 251, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

a été nommé Président du conseil d'administration.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre

2009 et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le re-
nouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

89300

Luxembourg, le 28 août 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009115079/16.
(090138335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Vision Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 60.002.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration en date du 27 août 2009

Le conseil d'administration nomme, avec effet au 6 juillet 2009, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences

politiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, administrateur de ca-
tégorie A et Président du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Roberto DALL'ASTE BRANDOLINI.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Reno Maurizio TONELLI viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 27 août 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009115074/16.
(090138373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Eikon Invest IV Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 89.189.

<i>Extract of the resolutions taken at the extraordinary general meeting of August 25 

<i>th

<i> , 2009

- The resignation of Mrs Joanne BAXTER, born on June 12 

th

 , 1970 in Guernsey, professionally residing at 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on May 29 

th

 , 2009;

- the resignation of Mrs Constance HELYAR, born on February 13 

th

 , 1948 in Guernsey, professionally residing at

13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on August 19 

th

 , 2009;

- the number of Directors be reduced from 4 to 3;
- Mrs Isabelle DONADIO, private employee, born on October 3 

rd,

 1962 in Amnéville (France), professionally residing

at 412 F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG, be appointed as new Director. Her mandate will lapse at the Annual
General Meeting of the year 2014;

- Mr. Pierre MESTDAGH, private employee, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, and

Mr. Jean-Robert BARTOLINI, awarded in D.E.S.S., residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg will
continue their mandate of Directors which will lapse at the Annual General Meeting of the year 2014.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2009

- La démission de Madame Joanne BAXTER, née le 12 juin 1970 à Guernesey, demeurant professionnellement au 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands, est acceptée avec effet au 29 mai 2009;

- la démission de Madame Constance HELYAR, née le 13 février 1948 à Guernesey, demeurant professionnellement

au 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands est acceptée avec effet au 19 août 2009;

- Le nombre d'Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, née le 3 octobre 1962 à Amnéville, demeurant professionnellement

au  412  F,  route  d'Esch,  L-2086  LUXEMBOURG,  est  nommée  comme  nouvel  Administrateur.  Son  mandat  viendra  à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086 LU-

XEMBOURG et Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412 F, route
d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG continuent leur mandat d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2014.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR EIKON INVEST IV HOLDING S.A.
SGG S.A.

89301

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009115097/38.
(090137961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Chordia Invest I Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 80.166.

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of August 25 

<i>th

<i> , 2009

- The resignation of Mrs Joanne BAXTER, born on June 12 

th

 , 1970 in Guernsey, professionally residing at 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on May 29 

th

 , 2009;

- the resignation of Mrs Constance HELYAR, born on February 13 

th

 , 1948 in Guernsey, professionally residing at

13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on August 19 

th

 , 2009;

- the number of Directors be reduced from 4 to 3;

- Mrs Isabelle DONADIO, private employee, born on October 3 

rd

 , 1962 in Amnéville (France), professionally residing

at 412 F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG, be appointed as new Director. Her mandate will lapse at the Annual
General Meeting of the year 2012;

- Mr. Pierre MESTDAGH, private employee, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, and

Mr. Jean-Robert BARTOLINI, awarded in D.E.S.S., residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg will
continue their mandate of Directors which will lapse at the Annual General Meeting of the year 2012.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2009

- La démission de Madame Joanne BAXTER, née le 12 juin 1970 à Guernesey, demeurant professionnellement au 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands, est acceptée avec effet au 29 mai 2009;

- la démission de Madame Constance HELYAR, née le 13 février 1948 à Guernesey, demeurant professionnellement

au 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands est acceptée avec effet au 19 août 2009;

- le nombre d'Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, née le 3 octobre 1962 à Amnéville, demeurant professionnellement

au  412  F,  route  d'Esch,  L-2086  LUXEMBOURG,  est  nommée  comme  nouvel  Administrateur.  Son  mandat  viendra  à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086 LU-

XEMBOURG et Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412 F, route
d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG continuent leur mandat d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2012.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR CHORDIA INVEST I HOLDING S.A.
SGG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009115106/38.
(090138084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

LBREM II Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.612.

EXTRAIT

Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société, a désormais son adresse professionnelle au 1271

Sixth Avenue, 38 

ème

 étage, New York, NY 10020, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89302

Luxembourg, le 31 août 2009.

<i>Pour LBREM II Europe S.à r.l.
M. Michael Denny
<i>Gérant catégorie A

Référence de publication: 2009114638/16.
(090137504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Lourmel Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.826.

<i>Extrait des résolutions prises

<i>par le conseil d'administration le 13 août 2009

- Monsieur Alain Geurts, Administrateur, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo),

demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg est nommé Président du Conseil d'Ad-
ministration. Il occupera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société.

Pour extrait conforme
<i>Pour LOURMEL HOLDING S.A.-SPF
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2009114629/16.
(090137805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Eikon Invest VI Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.738.

<i>Extract of the resolutions taken at the extraordinary general meeting of August 25 

<i>th

<i> , 2009

- The resignation of Mrs Joanne BAXTER, born on June 12 

th

 , 1970 in Guernsey, professionally residing at 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on May 29 

th

 , 2009;

- the resignation of Mrs Constance HELYAR, born on February 13 

th

 , 1948 in Guernsey, professionally residing at

13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on August 19 

th

 , 2009;

- the number of Directors be reduced from 4 to 3;
Mrs Isabelle DONADIO, private employee, born on October 3 

rd

 , 1962 in Amnéville (France), professionally residing

at 412 F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG, be appointed as new Director. Her mandate will lapse at the Annual
General Meeting of the year 2014;

Mr. Pierre MESTDAGH, private employee, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, and Mr.

Jean-Robert BARTOLINI, awarded in D.E.S.S., residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg will
continue their mandate of Directors which will lapse at the Annual General Meeting of the year 2014.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2009

- La démission de Madame Joanne BAXTER, née le 12 juin 1970 à Guernesey, demeurant professionnellement au 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands, est acceptée avec effet au 29 mai 2009;

- la démission de Madame Constance HELYAR, née le 13 février 1948 à Guernesey, demeurant professionnellement

au 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands est acceptée avec effet au 19 août 2009;

- le nombre d'Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, née le 3 octobre 1962 à Amnéville, demeurant professionnellement

au  412  F,  route  d'Esch,  L-2086  LUXEMBOURG,  est  nommée  comme  nouvel  Administrateur.  Son  mandat  viendra  à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086 LU-

XEMBOURG et Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412 F, route
d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG continuent leur mandat d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2014.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2009.

Certifié sincère et conforme

89303

<i>POUR EIKON INVEST VI HOLDING S.A.
SGG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009115099/38.
(090137963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Eikon Invest II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 79.419.

<i>Extract of the resolutions taken at the extraordinary general meeting of August 25 

<i>th

<i> , 2009

- The resignation of Mrs Joanne BAXTER, born on June 12 

th

 , 1970 in Guernsey, professionally residing at 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on May 29 

th

 , 2009;

- the resignation of Mrs Constance HELYAR, born on February 13 

th

 , 1948 in Guernsey, professionally residing at

13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on August 19 

th

 , 2009;

- the number of Directors be reduced from 4 to 3;
- Mrs Isabelle DONADIO, private employee, born on October 3 

rd

 , 1962 in Amnéville (France), professionally residing

at 412 F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG, be appointed as new Director. Her mandate will lapse at the Annual
General Meeting of the year 2012;

- Mr. Pierre MESTDAGH, private employee, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, and

Mr. Jean-Robert BARTOLINI, awarded in D.E.S.S., residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg will
continue their mandate of Directors which will lapse at the Annual General Meeting of the year 2012.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2009

- La démission de Madame Joanne BAXTER, née le 12 juin 1970 à Guernesey, demeurant professionnellement au 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands, est acceptée avec effet au 29 mai 2009;

- la démission de Madame Constance HELYAR, née le 13 février 1948 à Guernesey, demeurant professionnellement

au 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands est acceptée avec effet au 19 août 2009;

- le nombre d'Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, née le 3 octobre 1962 à Amnéville, demeurant professionnellement

au  412  F,  route  d'Esch,  L-2086  LUXEMBOURG,  est  nommée  comme  nouvel  Administrateur.  Son  mandat  viendra  à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086 LU-

XEMBOURG et Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412 F, route
d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG continuent leur mandat d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2012.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR EIKON INVEST II S.A.
SGG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009115101/38.
(090137967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and nine.
On the fourteenth day of August at 04.15 p.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

89304

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on December 3, 2007 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I - The company PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"),

having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B107564, has
been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 27 

th

 of April

2005, published in the Mémorial C number 433 of the 11 

t

 

h

 of May 2005, and whose articles of incorporation have been

amended by deeds of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of nine million eight hundred and ninety-eight thousand seven hundred and forty-

nine  Euro  (9,898,749.-  EUR),  represented  by  twenty-one  thousand  one  hundred  and  thirty-seven  point  sixty-eight
(21,137.68)  Manager  Shares  and  one  hundred  and  seventy-six  thousand  eight  hundred  and  thirty-seven  point  thirty
(176,837.30) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of twenty-five million Euro (25,000,000.- EUR) divided into:
- four hundred and fifty thousand (450.000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- fifty thousand (50,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.-EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on December 03, 2007 the General Manager has decided to increase, within the

limits of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of three hundred and ninety-five
thousand nine hundred and forty-nine Euro and ninety-five cents (395,949.95.- EUR), in order to raise it from its present
amount of nine million eight hundred and ninety-eight thousand seven hundred and forty-nine Euro (9,898,749.- EUR) to
the amount of ten million two hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-eight Euro and ninety-fifty cents
(10,294,698.95.- EUR) by issuing:

- seven thousand and seventy-three point forty-nine (7,073.49) new Ordinary Shares having a par value of fifty Euro

(50.- EUR) each, issued with a total share premium of six million seven hundred and nineteen thousand eight hundred
and seventeen Euro and thirty cents (6,719,817.30.-EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;

- eight hundred and forty-five point fifty-one (845.51) Manager Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR) each,

issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of three hundred and
ninety-five thousand nine hundred and forty-nine Euro and ninety-five cents (395,949.95 EUR) as well as the amount of
six million seven hundred and nineteen thousand eight hundred and seventeen Euro and thirty cents (6,719,817.30 EUR)
as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

89305

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital. (paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of ten million two hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-

eight Euro and ninety-fifty cents (10,294,698.95 FURY represented by twenty-one thousand nine hundred and eighty-
three point nineteen (21,983.19) Manager Shares and one hundred and eighty-three thousand nine hundred and ten point
seventy-nine (183,910.79) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately three thousand six hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den vierzehnten August um 16.15 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.ä r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 3. Dezember 2007 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP EURO-
PEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B107564, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 433 vom 11. Mai 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von neun Millionen acht hundert acht und neunzig tausend sieben hundert

neun und vierzig Euro (9.898.749,- EUR), eingeteilt in ein und zwanzig tausend ein hundert sieben und dreissig Komma
acht und sechzig (21.137,68) Manager-Aktien und ein hundert sechs und siebzig tausend acht hundert sieben und dreissig
Komma dreissig (176.837,30) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünf und zwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EUR) und

ist aufgeteilt in:

- vier hundert fünfzig tausend (450.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie;

und

- fünfzig tausend (50.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

89306

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950,- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100,- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50,- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 3. Dezember 2007 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des

genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um drei hundert fünf und neunzig tausend neun hundert neun und vierzig
Euro fünf und neunzig Cents (395.949,95 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von neun Millionen acht
hundert acht und neunzig tausend sieben hundert neun und vierzig Euro (9.898.749,- EUR) auf zehn Millionen zwei hundert
vier und neunzig tausend sechs hundert acht und neunzig Euro fünf und neunzig Cents (10.294.698,95 EUR) zu bringen
durch die Ausgabe von:

- sieben tausend drei und siebzig Komma neun und vierzig (7.073,49) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert

von je fünfzig Euro (50,-EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von sechs Millionen sieben hundert neunzehn
tausend acht hundert siebzehn Euro dreissig Cents (6.719.817,30 EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesell-
schaft zugeteilt wird;

- acht hundert fünf und vierzig Komma ein und fünfzig (845,51) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig

Euro (50,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von drei hundert fünf und
neunzig tausend neun hundert neun und vierzig Euro fünf und neunzig Cents (395.949,95 EUR) erhalten hat, so wie den
Betrag von sechs Millionen sieben hundert neunzehn tausend acht hundert siebzehn Euro dreissig Cents (6.719.817,30-
EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zehn Millionen zwei hundert vier und neunzig tausend sechs hundert

acht und neunzig Euro fünf und neunzig Cents (10.294.698,95 EUR), eingeteilt in ein und zwanzig tausend neun hundert
drei und achtzig Komma neunzehn (21.983,19) Manager-Aktien und ein hundert drei und achtzig tausend neun hundert
zehn Komma neun und siebzig (183.910,79) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr drei

tausend sechs hundert Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2009. Relation GRE / 2009/2994. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

89307

Junglinster, le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009115231/178.
(090138950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and nine.
On the fourteenth day of August at 04.00 p.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on March 20, 2006 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I - The company PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"),

having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B107564, has
been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 27 

th

 of April

2005, published in the Memorial C number 433 of the 11 

th

 of May 2005, and whose articles of incorporation have been

amended by deeds of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of five million four hundred and eighty-six thousand seven hundred and thirty-

seven Euro eighty-eight cents (5,468,737.88 EUR), represented by eleven thousand three hundred and ninety-four point
twenty-two (11,394.22) Manager Shares and ninety-seven thousand nine hundred and eighty point fifty-four (97,980.54)
Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of twenty-five million Euro (25,000,000.- EUR) divided into:
- four hundred and fifty thousand (450,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- fifty thousand (50,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.-EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on March 20, 2006. the General Manager has decided to increase, within the limits

of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of one million one hundred and ninety-
three thousand eight hundred and seventy-five Euro and eighty-two cents (1,193,875.82.- EUR), in order to raise it from
its present amount of five million four hundred and eighty-six thousand seven hundred and thirty-seven Euro eighty-eight
cents (5,468,737.88.- EUR) to the amount of six million six hundred and sixty-two thousand six hundred and thirteen
Euro seventy cents (6,662,613.70 EUR) by issuing:

89308

- twenty-one thousand forty-four point forty-six (21,044.46) new Ordinary Shares having a par value of fifty Euro (50.-

EUR) each, issued with a total share premium of nineteen million nine hundred and ninety-two thousand two hundred
and thirty-seven Euro thirty cents (19,992,237.30 EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;

- two thousand eight hundred and thirty-three point zero six (2,833.06) Manager Shares having a par value of fifty Euro

(50.- EUR) each, issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of one million one
hundred and ninety-three thousand eight hundred and seventy-five Euro and eighty-two cents (1,193,875.82 EUR) as well
as the amount of nineteen million nine hundred and ninety-two thousand two hundred and thirty-seven Euro thirty cents
(19,992,237.30 EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital, (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of six million six hundred and sixty-two thousand six hundred and thirteen

Euro seventy cents (6,662,613.70 EUR), represented by fourteen thousand two hundred and twenty-seven point twenty-
eight (14,227.28) Manager Shares and one hundred and nineteen thousand twenty-five (119,025) Ordinary Shares of a
par value of fifty Euro (50,- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand six hundred and fifty Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den vierzehnten August um 16.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.ä r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 20. März 2006 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP EUROPEAN
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B107564, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005,

89309

veröffentlicht im Memorial C Nummer 433 vom 11. Mai 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von fünf Millionen vier hundert acht und sechzig tausend sieben hundert

sieben und dreissig Euro acht und achtzig Cents (5.468.737,88 EUR), eingeteilt in elf tausend drei hundert vier und neunzig
Komma zwei und zwanzig (11.394,22) Manager-Aktien und sieben und neunzig tausend neun hundert achtzig Komma vier
und fünfzig (97.980,54) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünf und zwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EUR) und

ist aufgeteilt in:

- vier hundert fünfzig tausend (450.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie;

und

- fünfzig tausend (50.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950,- EUR); und

-jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100,- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50,- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 20. März 2006 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des geneh-

migten Kapitals, das Gesellschaftskapital um eine Million ein hundert drei und neunzig tausend acht hundert fünf und
siebzig Euro zwei und achtzig Cents (1.193.875,82 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünf Millionen
vier hundert acht und sechzig tausend sieben hundert sieben und dreissig Euro acht und achtzig Cents (5.468.737,88 EUR)
auf sechs Millionen sechs hundert zwei und sechzig tausend sechs hundert dreizehn Euro siebzig Cents (6.662.613,70
EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:

-  ein  und  zwanzig  tausend  vier  und  vierzig  Komma  sechs  und  vierzig  (21.044,46)  neuen  Vorzugsaktien  mit  einem

Nominalwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von neunzehn Millionen neun
hundert zwei und neunzig tausend zwei hundert sieben und dreissig Euro dreissig Cents (19.992.237,30 EUR) welcher
gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- zwei tausend acht hundert drei und dreissig Komma null sechs (2.833,06) Manager-Aktien mit einem Nominalwert

von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von einer Million ein hundert
drei und neunzig tausend acht hundert fünf und siebzig Euro zwei und achtzig Cents (1.193.875,82 EUR) erhalten hat, so
wie den Betrag von neunzehn Millionen neun hundert zwei und neunzig tausend zwei hundert sieben und dreissig Euro
dreissig Cents (19.992.237,30 EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von sechs Millionen sechs hundert zwei und sechzig tausend sechs hundert

dreizehn Euro siebzig Cents (6.662.613,70 EUR), eingeteilt in vierzehn tausend zwei hundert sieben und zwanzig Komma
acht und zwanzig (14.227,28) Manager-Aktien und ein hundert neunzehn tausend fünf und zwanzig (119.025) Vorzugs-
aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf

tausend sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

89310

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2009. Relation GRE/2009/2991. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009115233/178.
(090138947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Eikon Invest V Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.670.

<i>Extract of the resolutions taken at the extraordinary general meeting of August 25 

<i>th

<i> , 2009

- The resignation of Mrs Joanne BAXTER, born on June 12 

th

 , 1970 in Guernsey, professionally residing at 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on May 29 

th

 , 2009;

- the resignation of Mrs Constance HELYAR, born on February 13 

th

 , 1948 in Guernsey, professionally residing at

13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands, be accepted with effect on August 19 

th

 , 2009;

- the number of Directors be reduced from 4 to 3;
- Mrs Isabelle DONADIO, private employee, born on October 3 

rd

 , 1962 in Amnéville (France), professionally residing

at 412 F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG, be appointed as new Director. Her mandate will lapse at the Annual
General Meeting of the year 2014;

- Mr. Pierre MESTDAGH, private employee, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, and

Mr. Jean-Robert BARTOLINI, awarded in D.E.S.S., residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg will
continue their mandate of Directors which will lapse at the Annual General Meeting of the year 2014.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2009

- La démission de Madame Joanne BAXTER, née le 12 juin 1970 à Guernesey, demeurant professionnellement au 13-15,

Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands, est acceptée avec effet au 29 mai 2009;

- la démission de Madame Constance HELYAR, née le 13 février 1948 à Guernesey, demeurant professionnellement

au 13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, GY1 3ZD, Channel Islands est acceptée avec effet au 19 août 2009;

- le nombre d'Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, née le 3 octobre 1962 à Amnéville, demeurant professionnellement

au  412  F,  route  d'Esch,  L-2086  LUXEMBOURG,  est  nommée  comme  nouvel  Administrateur.  Son  mandat  viendra  à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086 LU-

XEMBOURG et Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412 F, route
d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG continuent leur mandat d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2014.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR EIKON INVEST V HOLDING S.A.
SGG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009115107/38.
(090138085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

89311

ING (L) Dynamic, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 52.519.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2009.

ING Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Par délégation

Référence de publication: 2009115214/13.
(090138706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

ING (L) Technix, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.127.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2009.

ING Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Par délégation

Référence de publication: 2009115215/13.
(090138700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

ING(L) Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.730.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 avril 2009.

ING Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Par délégation

Référence de publication: 2009115216/13.
(090138695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Netcare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 55, Gruusswiss.

R.C.S. Luxembourg B 102.059.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009115193/15.
(090138855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

89312

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and nine.
On the fourteenth of August at 04.25 p.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l.. having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally in L-1611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on March 10, 2008 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I - The company PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"),

having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B107564, has
been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 27 

th

 of April

2005, published in the Mémorial C number 433 of the 11 

th

 of May 2005, and whose articles of incorporation have been

amended by deeds of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of eleven million seventy-three thousand seven hundred and fifteen Euro and

thirty-five cents (11,073,715.35 EUR), represented by twenty-three thousand six hundred and forty-six point sixty-nine
(23,646.69)  Manager  Shares  and  one  hundred  and  eighty-three  thousand  nine  hundred  and  ten  point  seventy-nine
(197,827.61) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of twenty-five million Euro (25,000,000.- EUR) divided into:
- four hundred and fifty thousand (450,000) Ordinary Shares with a pat-value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- fifty thousand (50,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on March 10, 2008 the General Manager has decided to increase, within the limits

of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of two hundred and seventy-eight thousand
two hundred and twenty Euro and fourteen cents (278,220.14 EUR), in order to raise it from its present amount of eleven
million seventy-three thousand seven hundred and fifteen Euro thirty-five cents (11,073,715.35 EUR) to the amount of
eleven million three hundred and fifty-one thousand nine hundred and thirty-five Euro and forty-nine cents (11,351,935.49
EUR) by issuing:

- four thousand nine hundred and seventy point twenty-nine (4,970.29) new Ordinary Shares having a par value of fifty

Euro (50.- EUR) each, issued with a total share premium of four million seven hundred and twenty-one thousand seven

89313

hundred and seventy-nine Euro and eighty-six cents (4,721,779.86 EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve
of the Company;

- five hundred and ninety-four point eleven (594.11) Manager Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR) each,

issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of two hundred and
seventy-eight thousand two hundred and twenty Euro and fourteen cents (278,220.14 EUR) as well as the amount of four
million seven hundred and twenty-one thousand seven hundred and seventy-nine Euro and eighty-six cents (4,721,779.86
EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share capital, (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of eleven million three hundred and fifty-one thousand nine hundred and thirty-

five Euro and forty-nine cents (11,351,935.49 EUR), represented by twenty-four thousand two hundred and forty point
eighty (24,240.80) Manager Shares and two hundred and two thousand seven hundred and ninety-seven point ninety
(202,797.90) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately three thousand one hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den vierzehnten August um 16.25 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 10. März 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP EUROPEAN
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B107564, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005,

89314

veröffentlicht im Memorial C Nummer 433 vom 11. Mai 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von elf Millionen drei und siebzig tausend sieben hundert fünfzehn Euro fünf

und dreissig Cents (11.073.715,35 EUR), eingeteilt in drei und zwanzig tausend sechs hundert sechs und vierzig Komma
neun  und  sechzig  (23.646,69)  Manager-Aktien  und ein  hundert sieben  und  neunzig  tausend acht  hundert sieben und
zwanzig Komma ein und sechzig (197.827,61) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro
Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünf und zwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EUR) und

ist aufgeteilt in:

- vier hundert fünfzig tausend (450.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie;

und

- fünfzig tausend (50.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950,- EUR); und

-jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100,- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50,- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 10. März 2008 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des geneh-

migten Kapitals, das Gesellschaftskapital um zwei hundert acht und siebzig tausend zwei hundert zwanzig Euro vierzehn
Cents (278.220,14 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von elf Millionen drei und siebzig tausend sieben
hundert fünfzehn Euro fünf und dreissig Cents (11.073.715,35 EUR) auf elf Millionen drei hundert ein und fünfzig tausend
neun hundert fünf und dreissig Euro neun und vierzig Cents (1 1.351.935,49 EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:

- vier tausend neun hundert siebzig Komma neun und zwanzig (4.970,29) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert

von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von vier Millionen sieben hundert ein und
zwanzig tausend sieben hundert neun und siebzig Euro sechs und achtzig Cents (4.721.779,86 EUR) welcher gänzlich der
Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- fünfhundert vier und neunzig Komma elf (594,11) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (50,-

EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von zwei hundert acht und
siebzig tausend zwei hundert zwanzig Euro vierzehn Cents (278.220,14,- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von vier
Millionen  sieben  hundert  ein  und  zwanzig  tausend  sieben  hundert  neun  und  siebzig  Euro  sechs  und  achtzig  Cents
(4.721.779,86 EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von elf Millionen drei hundert ein und fünfzig tausend neun hundert fünf und

dreissig Euro neun und vierzig Cents (11.351.935,49 EUR), eingeteilt in vier und zwanzig tausend zwei hundert vierzig
Komma achtzig (24.240,80) Manager-Aktien und zwei hundert zwei tausend sieben hundert sieben und neunzig Komma
neunzig (202.797,90) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr drei

tausend ein hundert Euro abgeschätzt.

89315

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2009. Relation GRE / 2009/2996. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009115229/179.
(090138953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and nine.
On the fourteenth day of August at 04.30 p.m..
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. having its registered office in L-1611 Luxembourg,

55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B107523,

here duly represented by Mrs Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55,

avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed

to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS

GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard
d'Avranches, pursuant to a resolution taken on March 14, 2008 relatively to an increase of the corporate capital of
PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
I.- The company PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"),

having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B107564, has
been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 27 

th

 of April

2005, published in the Memorial C number 433 of the 11 

th

 of May 2005. and whose articles of incorporation have been

amended by deeds of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of eleven million three hundred and fifty-one thousand nine hundred and thirty-

five Euro and forty-nine cents (11,351,935.49 EUR), represented by twenty-four thousand two hundred and forty point
eighty (24,240.80) Manager Shares and two hundred and two thousand seven hundred and ninety-seven point ninety
(202,797.90) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of twenty-five million Euro (25,000,000.- EUR) divided into:
- four hundred and fifty thousand (450,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- fifty thousand (50.000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.
IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as

follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:
- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising

the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and

- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined

by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

89316

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are

referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of

the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend
this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on March 14, 2008 the General Manager has decided to increase, within the limits

of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of one million eighty-five thousand fifty-
eight Euro and fifty-six cents (1,085.058.56.- EUR), in order to raise it from its present amount of eleven million three
hundred and fifty- one thousand nine hundred and thirty-five Euro and forty-nine cents (11,351,935.49 EUR) to the amount
of  twelve  million  four  hundred  and  thirty-six  thousand  nine  hundred  and  ninety-four  Euro  and  zero  five  cents
(12,436,994.05 EUR) by issuing:

- nineteen thousand three hundred and eighty-four point fifteen (19,384.15) new Ordinary Shares having a par value

of fifty Euro (50.- EUR) each, issued with a total share premium of eighteen million four hundred and fourteen thousand
nine hundred and forty-one Euro and forty-four cents (18,414,941.44 EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve
of the Company;

- two thousand three hundred and seventeen point zero two (2,317.02) Manager Shares having a par value of fifty Euro

(50.- EUR) each, issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of one million eighty-
five thousand fifty-eight Euro and fifty-six cents (1,085,058.56 EUR) as well as the amount of eighteen million four hundred
and fourteen thousand nine hundred and forty-one Euro and forty-four cents (18,414,941.44 EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests

thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b)

of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital, (Paragraph b).
(b) The Corporation has a share capital of twelve million four hundred and thirty-six thousand nine hundred and ninety-

four Euro and zero five cents (12,436,994.05 EUR), represented by twenty-six thousand five hundred and fifty-seven point
eighty-two (26,557.82) Manager Shares and two hundred and twenty-two thousand one hundred and eighty-two point
zero five (222,182.05) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10,

1915 on commercial companies.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand six hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend und neun.
Den vierzehnten August um 16.30 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,

avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B107523,

89317

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.
Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Ur-

kunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP

EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines
Beschlusses vom 14. März 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP EUROPEAN
MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-

kunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit

Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B107564, wurde gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005,
veröffentlicht im Memorial C Nummer 433 vom 11. Mai 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des
unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von elf Millionen drei hundert ein und fünfzig tausend neun hundert fünf und

dreissig Euro neun und vierzig Cents (11.351.935,49 EUR), eingeteilt in vier und zwanzig tausend zwei hundert vierzig
Komma achtzig (24.240,80) Manager-Aktien und zwei hundert zwei tausend sieben hundert sieben und neunzig Komma
neunzig (202.797,90) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünf und zwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EUR) und

ist aufgeteilt in:

- vier hundert fünfzig tausend (450.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie;

und

- fünfzig tausend (50.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-

dienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt

auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.

Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950,- EUR): und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100,- EUR) wie vom Manager

festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50,- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissi-

onsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme

von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 14. März 2008 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des geneh-

migten Kapitals, das Gesellschaftskapital um eine Million fünf und achtzig tausend acht und fünfzig Euro sechs und fünfzig
Cents (1.085.058,56,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von elf Millionen drei hundert ein und fünfzig
tausend neun hundert fünf und dreissig Euro neun und vierzig Cents (11.351.935,49 EUR) auf zwölf Millionen vier hundert
sechs und dreissig tausend neun hundert vier und neunzig Euro null fünf Cents (12.436.994,05.-EUR) zu bringen durch
die Ausgabe von:

- neunzehn tausend drei hundert vier und achtzig Komma fünfzehn (19.384,15) neuen Vorzugsaktien mit einem No-

minalwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von achtzehn Millionen vier
hundert vierzehn tausend neun hundert ein und vierzig Euro vier und vierzig Cents (18.4.14.941,44,- EUR) welcher gänzlich
der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- zwei tausend drei hundert siebzehn Komma null zwei (2.317,02) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je

fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen

übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von einer Million fünf und
achtzig tausend acht und fünfzig Euro sechs und fünfzig Cents (1.085.058,56,- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von
achtzehn  Millionen  vier  hundert  vierzehn  tausend  neun  hundert  ein  und  vierzig  Euro  vier  und  vierzig  Cents
(18.414.941,44,- EUR) als Emissionsagio.

89318

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit aus-

drücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von

Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).

(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zwölf Millionen vier hundert sechs und dreissig tausend neun hundert

vier und neunzig Euro null fünf Cents (12.436.994,05 EUR), eingeteilt in sechs und zwanzig tausend fünf hundert sieben
und fünfzig Komma zwei und achtzig (26.557,82) Manager-Aktien und zwei hundert zwei und zwanzig tausend ein hundert
zwei und achtzig Komma null fünfs (222.182,05) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro
Aktie."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf

tausend sechs hundert Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen.

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2009. Relation GRE / 2009/2997. Reçu soixante quinze euros 75 EUR

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009115228/179.

(090138955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Finance et Développement, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 73.425.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 31 août 2009

1. M. Eric MAGRINI a démissionné de ses mandats d'administrateur, administrateur-délégué et de président du conseil

d'administration.

2.  M.  Vincent  TUCCI,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Moyeuvre-Grande  (France),  le  26  juillet  1968,  demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à été nommé comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

3. Monsieur Philippe TOUSSAINT, a été comme nommé président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'as-

semblée générale statutaire de 2011.

er

 SEP. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FINANCE ET DEVELOPPEMENT
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009115183/20.

(090137933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2009.

89319

Primafina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 121.092.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 janvier 2009

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée accepte les démissions de Monsieur Christophe DAVEZAC et de Madame Géraldine SCHM1T de leur

poste d'administrateur B de la Société avec effet rétroactif au 31 octobre 2008.

L'Assemblée nomme Messieurs Alain PEIGNEUX et Daniel ADAM, demeurant tous deux professionnellement au 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au poste d'administrateurs B de la société avec effet au 31 octobre 2008.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Wood, Appleton, Oliver Experts-Comptables S.à r.l. de son poste de Commis-

saire aux Comptes de la Société avec effet au 30 décembre 2008.

L'Assemblée nomme Read S.à r.l., ayant son siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au

poste de Commissaire aux Comptes de la société avec effet au 30 décembre 2008.

Son mandat commencera avec la revue des comptes annuels au 31 décembre 2007 et se terminera lors de l'assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2013.

<i>Septième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121, avenue de

la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet rétroactif au 1 

er

 décembre 2008.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009115749/27.
(090138467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Panelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.

R.C.S. Luxembourg B 6.386.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 12 juin 2009

<i>6 

<i>e

<i> Résolution

Est nommé réviseur pour la durée d'une année, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant

sur les comptes à fin 2009, la société H.R.T. Révision S.A.

<i>7 

<i>e

<i> Résolution

Sont  nommés  Administrateurs  pour  la  durée  d'une  année,  leur  mandat  prenant  fin  lors  de  l'Assemblée  Générale

Ordinaire statuant sur les comptes à fin 2009,

- Maître René FALTZ, Avocat, demeurant au 48, rue Montée de Trooskneppchen, L-6496 Echternach,
- Madame Josée FISCHER, demeurant au 247, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange,
- Monsieur Jacques LINSTER, Maitre-Boulanger, demeurant au 25, rue Auguste Neyen, L-2233 Luxembourg,
- Monsieur Patrick MULLER, Directeur, demeurant au 15, rue de la Toison d'Or, L-2265 Luxembourg.
A la suite de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration se réunit brièvement et décide à l'unanimité

de renommer pour la durée d'une année,

- Maître René Faltz, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Jacques Linster, Administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89320

Luxembourg, le 21 août 2009.

<i>Pour FIDALUX S.A.
Christophe Blondeau / Romain Thillens
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009115760/27.
(090138692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

ING(L) Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.730.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2009

<i>Conseil d'Administration

- Démission de Monsieur Philippe Gusbin en date du 14 novembre 2008.
- Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alexandre Deveen
- Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian Bellin
- Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Odilon De Groote
- Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Paul Suttor
Nomination des administrateurs suivants:
- Monsieur Michel Van Elk, Director and Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) bv, The

Hague, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Madame Maaike van Meer, Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan,

2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Jonathan Atack, Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses

Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur David Eckert, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan,

2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Jan Straatman, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan,

2595 AK The Hague, The Netherlands

-  Monsieur  Maurice  Hannon,  Head  of  Legal,  ING  Investment  Management  Luxembourg,  3  rue  Jean  Piret,  L-2350

Luxembourg

Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuvera les

comptes pour l'exercice clos en 2012.

<i>Réviseur d'Entreprises

Reconduction de mandat de la société Ernst &amp; Young, 7 parc d'activités Syrdall à L-5365 Munsbach pour une période

d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 14 avril 2009.

ING Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Par délégation

Référence de publication: 2009115761/36.
(090138698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

United Intercom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 33.355.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 avril 2008, les mandats des adminis-

trateurs MM. Hans DERMONT, Guy BAUMANN, Guy KETTMANN et Jean BODONI, ainsi que celui du commissaire
aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour une durée d'un an, prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.

Luxembourg, le 3 septembre 2009.

<i>Pour UNITED INTERCOM S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg

89321

Société anonyme
Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner
<i>Vice-President / -

Référence de publication: 2009115734/18.
(090139136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

ING (L) Dynamic, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 52.519.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 23 avril 2009 à Luxembourg

<i>Conseil d'Administration.

- Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alexandre Deveen
- Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian Bellin
- Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Odilon De Groote
- Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Paul Suttor
Nomination des administrateurs suivants:
- Monsieur Michel Van Elk, Director and Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) bv, The

Hague, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Madame Maaike van Meer, Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan,

2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Jonathan Atack, Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses

Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands -

- Monsieur David Eckert, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan,

2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Jan Straatman, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan,

2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Maurice Harmon, Head of Legal, ING Investment Management Luxembourg, 3 rue Jean Piret, L-2350

Luxembourg

Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes

clos en 2012.

<i>Réviseur d'Entreprises

Reconduction du mandat de la société Ernst &amp; Young, 7 parc d'activité Syrdall à L-5365 Munsbach pour une période

d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 23 avril 2009.

ING Investment Management Luxembourg SA
Signatures
<i>Par délégation

Référence de publication: 2009115765/35.
(090138710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

BSL Special Opportunities, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.799.056,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 146.109.

In the year two thousand and nine, on the twentieth day of August,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of BSL Special Opportunities a société à responsabilité

limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500,
registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number
B 146.109 (the "Company").

There appeared:

89322

BSL Special Opportunities Holdings Limited, a Cayman exempted company duly incorporated and validly existing under

the laws of Cayman Islands, having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87, Mary Street, PO
Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, The Cayman Island, registered with the Registrar of the Cayman Islands
under number 225593 (the "Sole Shareholder"), here represented by Isabel Dias, private employee, residing professionally
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on August 20 

th

 , 2009.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration. The chairman requests the notary to act that:

The 12,500 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can

validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the

following:

<i>Agenda

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 4,786,556.- so as to raise it from its current

amount of EUR 12,500.- to EUR 4,799,056.- by the issuance of 4,786,556 shares with a nominal value of EUR 1,- each;

2) Subscription, intervention and payment of the 4,786,556 new shares with a nominal value of EUR 1,- each, by a

contribution in kind by the sole shareholder of the Company;

3) Amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share

capital of the Company; and

4) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 4,786,556.- (four million seven hundred

eighty-six thousand five hundred fifty-six euros) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand
five hundred euro) to EUR 4,799,056.- (four million seven hundred ninety-nine thousand and fifty-six euro) by the creation
and the issuance of 4,786,556 new shares with a nominal value of EUR 1.- each, the whole being fully paid up by the Sole
Shareholder by way of a contribution in kind.

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription by the Sole Shareholder to the increase of capital by way of a contribution in

kind consisting of a receivable for an amount of USD 6,775,752.41 equivalent to EUR 4,786,556 (the "Receivable").

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder through its proxy holder, declared to subscribe to the above mentioned increase of capital of

EUR 4,786,556 by subscribing to all the 4,786,556 new shares with a nominal value of EUR 1, the whole being fully paid
up by contributing the Receivable.

<i>Evaluation

The value of the Receivable is of EUR 4,786,556 equivalent to USD 6,775,752.41 Such contribution has been valued

by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value, which has been produced to the
notary.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above, expressly declares that:
(i) the Receivable is certain, liquid and payable;
(ii) it is the sole legal owner and holder of all rights, title and interest in and to the Receivable;
(iii) the Receivable is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Receivable is not the object of a dispute or claim;
(v) the Receivable is freely transferable, with all the rights attached thereto; and
(vi) all formalities subsequent to the transfer of the Receivable required under any applicable law have or will be carried

out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third parties.

<i>Managers' intervention

Thereupon intervened:

89323

Kenneth W. Moore, Joshua R. Weiner, Pietro Longo, Hugo Froment and Cedric Carnoye, acting as managers of the

Company, each of them represented here by Isabel Dias, by virtue of a power of attorney,

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company

by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the contribution in kind,
with its valuation, with the effective transfer of the Receivable, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions and the contribution having been fully carried out, the Sole Shareholder

resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

Art. 6. The Company's share capital is set at EUR 4,799,056.- (four million seven hundred ninety-nine thousand fifty-

six euros) divided into 4,799,056 (four million seven hundred ninety-nine thousand fifty-six) shares with a nominal value
of EUR 1.- (one euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 3,500.- ( three thousand five
hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt août,
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand - Duché de Luxembourg,

soussignée.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois BSL Special Opportunities ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, avec un capital social de 12.500 EUR immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 146.109 (la "Société").

A comparu:

BSL Special Opportunities Holdings Limited, une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social c/o Walkers

SPV Limited, Walker House, 87, Mary Street, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Ile Cayman, immatriculée
auprès du Registrar of the Cayman Islands sous le numéro 225593 (l'"Associé Unique"), ici représentée par Isabel Dias,
employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand -Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé du 20 août 2009.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur restera annexée au présent acte pour être enregistrées avec ce

dernier. Le président prie le notaire d'acter que:

Les 12.500 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informée.

L'Associé Unique représenté par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 4.786.556,- EUR pour le porter de son montant actuel

de 12.500,- EUR à 4.799.056,- EUR par l'émission de 4.786.556 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR
chacune;

2) Souscription, intervention et paiement des 4.786.556 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1.- EUR

chacune, par un apport en nature de l'associé unique de la Société;

3) Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital de la

Société; et

4) Divers.

89324

Après que l'agenda ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 4.786.556 EUR (quatre millions sept cent

quatre-vingt-six mille cinq cent cinquante-six euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille
cinq cents euros ) à 4.799.056 EUR (quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-six euros) par la
création et l'émission de 4.786.556 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR chacune, la totalité devant
être entièrement libérée par l'Associé Unique au moyen d'un apport en nature.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription de l'Associé Unique à l'augmentation de capital par apport en nature d'une

créance d'un montant de 6.775.752,41 USD équivalent à 4.786.556 EUR (la "Créance").

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée d'un

montant de 4.786.556,- EUR en souscrivant à l'ensemble des 4.786.556 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de
1,- EUR chacune, le tout étant entièrement libéré par un apport en nature de la Créance.

<i>Evaluation

La valeur de la Créance a été fixée à 6.775.752,41 USD équivalent à 4.786.556,- EUR.
Un tel apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur d'apport

qui a été fournie au notaire.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Mise en oeuvre effective de l'apport

L'Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
(i) La Créance est certaine, liquide et exigible;
(ii) il est seul propriétaire de la Créance;
(iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) la Créance n'est l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
(v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés;
(vi) l'ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requises en vertu de la loi applicable seront

accomplies afin que la contribution soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

<i>Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:
Kenneth W. Moore, Joshua R. Weiner, Pietro Longo, Hugo Froment et Cédric Carnoye, agissant en leur qualité de

gérants de la Société, chacun étant représenté par Isabel Dias, en vertu d'une procuration,

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagée comme gérants de la

Société en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de l'apport
en nature, son évaluation, et le transfert effectif de la Créance, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent et l'apport ayant été pleinement effectué, l'Associé Unique a décidé de

modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 4.799.056.- (quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-six

euros), divisé en 4.799.056 (quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-six) parts sociales d'une valeur
nominale de EUR 1.- (un euro) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en

raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette augmentation de capital est évalué à environ EUR 3.500,-
(trois mille cinq cents euros).

89325

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 août 2009. Relation: LAC/2009/34517. Reçu soixante-quinze euros Eur75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009115270/181.
(090138705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

ING International (II), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 41.873.

Le bilan au 31 mars 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2009.

ING Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Par délégation

Référence de publication: 2009115206/13.
(090138721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Doka Renovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 133.628.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009115205/10.
(090138754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Sisen International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 93.232.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009115204/10.
(090138751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

ABR Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4438 Soleuvre, 218, rue de Differdange.

R.C.S. Luxembourg B 119.372.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009115202/10.
(090138746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

89326

Modaven &amp; Co SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 128.981.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009115198/11.
(090138758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Orthodontic Management Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 46, avenue Lucien Salentiny.

R.C.S. Luxembourg B 97.305.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009115200/10.
(090138743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Transfert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 100.437.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009115201/10.
(090138744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Luxumbrella, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 50.794.

Le Bilan au 30 avril 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009115197/10.
(090138790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

Rafico Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 52.136.

Les états financiers au 31 décembre 2008, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009115196/10.
(090138788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

WW+ architektur &amp; management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4152 Esch-sur-Alzette, 21, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 90.585.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89327

LUDWIG
CONSULT S.A.R.L.
<i>EXPERT COMPTABLE - FIDUCIAIRE
L-6783 GREVENMACHER - 31. OP DER HECKMILL
Signature

Référence de publication: 2009114503/14.
(090137558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Aicor S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 2, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 138.761.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009114495/10.
(090137693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Gafi Sports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 33, rue d'Audun.

R.C.S. Luxembourg B 57.805.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009114496/10.
(090137697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Brasserie Les Arcades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 5-7, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 111.961.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114488/10.
(090137744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Baustahlarmierung B.S.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5532 Remich, 19, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 69.471.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG
CONSULT S.A.R.L.
<i>EXPERT COMPTABLE - FIDUCIAIRE
L-6783 GREVENMACHER - 31. OP DER HECKMILL
Signature

Référence de publication: 2009114502/14.
(090137553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

89328


Document Outline

ABR Investissements S.A.

Aicor S.àr.l.

Baustahlarmierung B.S.V. S.A.

Brasserie Les Arcades S.à r.l.

BSL Special Opportunities

Chordia Invest I Holding S.A.

Cottonita Investments S.A.

Doka Renovation S.à r.l.

Eikon Invest III S.A.

Eikon Invest II S.A.

Eikon Invest IV Holding S.A.

Eikon Invest V Holding S.A.

Eikon Invest VI Holding S.A.

Finance et Développement

Frolan S.A.

Gafi Sports S.à r.l.

IKB International

ING International (II)

ING (L) Dynamic

ING (L) Dynamic

ING(L) Portfolio

ING(L) Portfolio

ING (L) Technix

KBL European Private Bankers S.A.

LBK Finance Holding S.A.

LBREM II Europe S.à r.l.

Lourmel Holding S.A.-SPF

Luxumbrella

Maiden International S.A.

Maison Seil S.A.

Modaven &amp; Co SCA

Netcare S.à r.l.

Odyssey Financial Technologies S.A.

Orthodontic Management Service S.à r.l.

Panelux S.A.

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR

Primafina S.A.

Rafico Holding S.A.

Redevco Industrial Düsselburg S.A.

Sisen International S.A.

Skimo S.A.

Subtarc S.A.

Thore SA

Thore S.A., SPF

Transfert S.à r.l.

United Intercom S.A.

Vision Industries S.A.

Werkstatt A.G.

Werkstatt S.à r.l.

WestLB Mellon Compass Fund

WW+ architektur &amp; management S.à r.l.