logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1830

22 septembre 2009

SOMMAIRE

ART east S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87799

Asian Capital Holdings Fund  . . . . . . . . . . . .

87835

Bone & Joint Research S.A.  . . . . . . . . . . . . .

87813

Brainsourcing S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87813

Bright Pattern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87799

CBZ Sport Construct S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

87794

DS Turkey 5 S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87813

European Office Income Venture . . . . . . . .

87825

Flowersun S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87812

Fondation Pierre Werner  . . . . . . . . . . . . . . .

87833

Fondation Pierre Werner  . . . . . . . . . . . . . . .

87832

Fondation Pierre Werner  . . . . . . . . . . . . . . .

87834

Fondation Pierre Werner  . . . . . . . . . . . . . . .

87831

Fondation Pierre Werner  . . . . . . . . . . . . . . .

87828

Fondation Pierre Werner  . . . . . . . . . . . . . . .

87830

Franklin Templeton Luxembourg Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87822

Hermes Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87834

Holding Immobilière Nouvelle S.A.  . . . . . .

87794

Immobilière des Trois Ponts S.A. . . . . . . . .

87829

Immobilière des Trois Ponts S.A. . . . . . . . .

87832

Immobilière des Trois Ponts S.A. . . . . . . . .

87831

Invista European Celsius Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87798

Jaguar Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

87823

KD Properties Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

87828

Lab Document Vault PSF S.A.  . . . . . . . . . .

87836

LSF Quintet Investments S.à r.l. . . . . . . . . .

87812

LSREF Lux Japan Investments VI S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87812

Macrovision International Solutions S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87798

Morgane Green Energy Development . . . .

87827

Mouseltrans S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87826

Nacarat Design S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87813

Nord Est Asset Management  . . . . . . . . . . . .

87813

oneOone communication S.A.  . . . . . . . . . .

87799

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87822

Power Group Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

87827

Preferred Retail S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87837

Radetzky S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87794

Ribs S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87794

RM2 International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

87814

Rovi International Solutions S.à r.l.  . . . . . .

87798

Sainte-Maxime S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87836

Sibgrave Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87798

Sodesoft S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87814

Sodesoft S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87822

Sodesoft S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87822

Sodesoft S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87799

Sogaris Logistics Estates International Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87826

Tetris SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87825

Tetris SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87826

Transports et Garage Presse S.à r.l.  . . . . .

87812

T.W. Logistics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87824

Tyson Global Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

87795

Vietnam Resource Investments S.à r.l.  . . .

87811

87793

Ribs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 117.516.

EXTRAIT

Monsieur COUSIN Patrick, gérant de la société Ribs sàrl, informe:
1. le changement d'adresse de la société
La nouvelle adresse est:
10B, Zone d'Activités Bourmicht
L-8070 Bertrange
2. le changement d'adresse du gérant
La nouvelle adresse privée du gérant est:
20, rue Maltrixhes
B-4577 Modave
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 4 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009109336/1267/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02643. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090130958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

CBZ Sport Construct S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Scheidhof.

R.C.S. Luxembourg B 58.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009112579/9.
(090135336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Radetzky S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.555.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009112581/10.
(090135326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Holding Immobilière Nouvelle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 35.507.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WILSON ASSOCIATES
11, Boulevard Royal
B.P. 742
L-2017 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009112809/14.
(090135583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

87794

Tyson Global Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 198.184.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 146.762.

In the year two thousand nine, on the second day of June.
Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Tyson Foods, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, with registered office at 2200

Don Tyson Parkway, Springdale, AR 72762-6999, United States of America, and registered with the Department of State
of Delaware under number 2082418 (hereinafter referred to as "Tyson Foods" or the "Sole Member"). Tyson Foods is
the current sole member (the "Current Sole Member") of the Company;

2) New Canada Holdings, Inc.,a company organised under the laws of the State of Delaware, United States of America,

with its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 United States of
America, registered under the United States of America's Federal Identification number 32-0216754 (hereinafter referred
to as "NCHI" or "The Subscriber").

The Current Sole Member and the Subscriber are hereby represented by Mr. Karim DELAHAIE, Lawyer, residing

professionally at 69 boulevard de la Pétrusse, L 2320 Luxembourg, by virtue of two proxies.

The said Proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed for the purpose of registration within the registration authorities.

The Current Sole Member, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the

following:

- Tyson Foods, aforementioned, is the Current Sole Member of the Company, which was incorporated pursuant to a

deed of the undersigned notary Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg city, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, on May 20, 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations .

- Tyson Foods, aforementioned, is the Current Sole Member of the Subscriber.
- The Current Sole Member has decided to deliberate on the points of the following agenda:
(i) Decision to proceed to a capital increase in the share capital of the Company of an amount of one hundred ninety

eight million one hundred seventy two thousand Euros (EUR 198,172,000.-) corresponding to three hundred and seven
million one hundred ninety-four thousand three hundred forty-one Canadian dollars (CDN$ 307,194,341) according to
an agreed rate of EUR 1.- equals CDN $ 1.55005 being the exchange rate shown on the Bloomberg currency converting
webpage (http://www.bloomberg.com/invest/calculators/currency.html) on May 27, 2009 at 6.30pm CET;

(ii) Decision to issue one million nine hundred eighty one thousand seven hundred twenty (1,981,720) new shares with

a par value of EUR 100.- each (the "New Shares") in the share capital of the Company;

(iii) Decision to waive any preferential subscription right in connection with the issuance of and subscription to the

New Shares by New Canada Holdings, Inc., a company organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, with its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 United
States of America, registered under the United States of America's Federal Identification number 32-0216754; and

(iv) Subsequent modification of Article 5, paragraph 1, of the articles of association of the Company so as to reflect

the capital increase in the share capital of the Company.

- On the basis of the agenda above, the Current Sole Member and the Subscriber have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Current Sole Member, represented as stated here above, resolves to increase the share capital of the Company

by an amount of one hundred ninety eight million one hundred seventy two thousand Euros (EUR 198,172,000.-) so as
to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred
and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, to the amount of one hundred
ninety eight million one hundred eighty four thousand five hundred Euros (EUR 198,184,500.-) by the issuance, in addition
to the existing one hundred and twenty five shares (125) of one million nine hundred eighty one thousand seven hundred
twenty (1,981,720.-) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

<i>Subscription - Payment

(i) NCHI represented as stated here above, declares to subscribe to ALL and WHOLE of the New Shares with a

nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) and to have fully paid up its nominal value of one hundred Euros (EUR
100;-)  by  contribution  in  kind  of  one  hundred  ninety  eight  million  one  hundred  seventy  two  thousand  Euros  (EUR
198,172,000.-) corresponding to three hundred and seven million one hundred ninety-four thousand three hundred forty-
one Canadian dollars (CDN$ 307,194,341) according to an agreed rate of EUR 1.- equals CDN $ 1.55005 being the

87795

exchange rate shown on the Bloomberg currency converting webpage (http://www.bloomberg.com/invest/calculators/
currency.html) on May 27, 2009 at 18.30 pm CET.

The Current Sole Member of the Company resolves to waive any preferential subscription right in connection with

the subscription to the New Shares and agrees with the subscription and payment detailed here above.

The payment in full for such shares is made by a contribution in kind of:
(i) ALL and the WHOLE of the shares held by NCHI and issued in the share capital of IBP Finance Company of Canada,

a Nova Scotia company organized under the laws of Canada, with its registered office at SU 800, 1959 Upper Water
Street, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2 and registered with Canadian authorities under the number 876820960RC001; and

(ii) two notes receivables issued by IBP Finance Company of Canada.
A valuation report dated 1 

st

 June, 2009 has been issued by the board of managers of the Company (the "Valuation

Report").

A copy of the Valuation Report is attached as Appendix 1.
The conclusion of this Valuation Report is as follows:
"Based on (i) the interim accounts, (ii) the certificate of contribution in kind, and (iii) the Notes, the net value of the

contributed assets and liabilities is evaluated at least at CND Dollars 307,194,341.-, this estimation being made according
to generally accounting principles."

<i>Second resolution

The Current Sole Member of the Company and the Subscriber resolve to amend the first paragraph of article 5 of the

Articles of Association of the Company so as to reflect the capital increase.

Consequently, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company will henceforth have

the following wording:

"The share capital is set at one hundred ninety eight million one hundred eighty four thousand five hundred Euros

(EUR 198,184,500.-), represented by one million nine hundred eighty one thousand eight hundred forty five (1,981,845)
Shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 6,500.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting

closed at seven p.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le deuxième jour de juin.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Tyson Foods, Inc., une société régie par les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 2200 Don Tyson

Parkway, Springdale, AR 72762-6999, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au registre de Commerce des Sociétés et
Associations de l'Etat du Delaware sous le numéro 2082418 (ci -après nommée "Tyson Foods" ou "l'Associé Unique").
Tyson Foods est l'associé unique actuel (l'"Associé Unique Actuel") de la Société.

2. New Canada Holdings, Inc., une société régie par les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209

Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée sous le numéro
Fédéral des Etats-Unis d'Amérique numéro 32-0216754 (ci -après nommée "NCHI" ou la "Souscriptrice")

L'Associé Unique Actuel et la Souscriptrice sont ici représentées par M. Karim DELAHAIE, avocat, demeurant pro-

fessionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Les procurations, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l'enregistrement.

L'Associé  Unique  Actuel  a  requis  le  notaire  instrumentant  d'arrêter  les  résolutions  suivantes  prises  en  sa  qualité

d'Associé Unique de la Société et en relation avec le présent agenda:

87796

I. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-dix-huit millions cent soixante-douze

mille Euros (EUR 198.172.000,-), correspondant à trois cent sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent
quarante et un dollars Canadiens (CDN $ 307.194.341,-) selon le taux de change en vigueur de EUR 1,- équivalant à CDN
$ 1,55005 comme constaté sur l'outil de conversion Bloomberg, disponible sur la page web http://www.bloomberg.com/
invest/calculators/currency.html le 27 mai 2009 à 18.30 heures CET.

II. Décision d'émettre un million neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent vingt (1.981.720,-) nouvelles parts sociales

dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune (les "Nouvelles Parts
Sociales").

III. Abandon de tout droit préférentiel de souscription relatifs à l'émission et la souscription des Nouvelles Parts Sociales

par New Canada Holdings, Inc., une société régie par les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée sous le numéro Fédéral
des Etats-Unis d'Amérique numéro 32-0216754; et

IV. Modification subséquente de l'article 5, paragraphe 1, des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de

son capital social.

Sur le fondement de l'agenda précité, l'Associé Unique Actuel et les Souscripteurs, représentés comme indiqué ci-

avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique Actuel, représenté comme indiqué ci-avant, décide d'augmenter le capital social de la Société d'un

montant de Cent quatre-vingt-dix-huit millions cent soixante-douze mille Euros (EUR 198.172.000,-) afin de le porter de
son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt cinq parts sociales (125)
ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, au montant de cent quatre-vingt-dix-huit millions cent
quatre-vingt-quatre mille cinq cents Euros (EUR 198.184.500,-) par l'émission, en sus des cent vingt cinq parts sociales
(125) existantes, de un million neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent vingt (1.981.720,-) Nouvelles Parts Sociales ayant
une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Souscription et Paiement

NCHI représenté comme indiqué ci-avant, déclare souscrire à TOUTES les Nouvelles Parts Sociales ayant pour valeur

nominale de cent Euros (EUR 100,-) par un apport en nature de Cent quatre-vingt-dix-huit millions cent soixante-douze
mille euros (EUR 198.172.000,-), correspondant à trois cent sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent
quarante et un dollars Canadiens (CDN $ 307.194.341) selon le taux de change en vigueur de EUR 1.- équivalant à CDN
$ 1.55005 comme constaté sur l'outil de conversion Bloomberg, disponible sur la page web http://www.bloomberg.com/
invest/calculators/currency.html le 27 mai 2009 à 18.30 heures CET.

L'Associé Unique Actuel abandonne tout droit préférentiel de souscription relatif à l'émission et la souscription des

Nouvelles Parts Sociales et accepte les conditions de souscription et paiement ici mentionnées.

Le paiement intégral de ces actions a été fait par un apport en nature de:
(i) TOUTES les actions détenues par NCHI dans le capital social de la société IBP Finance Company of Canada, une

société de la province du Nova Scotia, régie par les lois du Canada, ayant son siège social au SU 800, 1959 Upper Water
Street, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, et enregistrée auprès des autorités Canadiennes sous le numéro 876820960RC001;
et

ii) Deux reconnaissances des dettes émises par IBP Finance Company of Canada.

Un rapport d'évaluation daté du 1 

er

 juin 2009 a été émis par la conseil de gérance de la Société (le "Rapport d'éva-

luation").

Une copie de ce Rapport d'évaluation est annexée à la présente comme Annexe 1.
La conclusion de ce Rapport d'évaluation est la suivante:
"Basé sur (i) les comptes intérimaires, (ii) le certificat d'apport en nature, et (iii) les reconnaissances de dettes, la valeur

de l'actif net peut être évaluée à CND $ 307.194.341,-."

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique de la Société et la Souscriptrice décident de modifier l'article 5, paragraphe 1, des Statuts de la Société

afin de refléter l'augmentation de son capital social.

En conséquence, l'article 5, paragraphe 1 des Statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:

<i>Dans la version française:

"Le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit millions cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents

euros (EUR 198.184.500,-) représenté un million neuf cent quatre-vingt-un mille huit cent quarante cinq (1.981.845) Parts
Sociales ayant une valeur nominale de cent Euros chacune."

87797

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 6.500,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, il est mis fin à la séance à 19.00 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, il est spécifié qu'en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Karim Delahaie, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juin 2009. LAC/2009/21281. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009112810/179.
(090135979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Rovi International Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Macrovision International Solutions S.à r.l.).

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 6-10, rue de la Fonderie.

R.C.S. Luxembourg B 97.546.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009113006/14.
(090135774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Invista European Celsius Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.413.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Martina Schuemann / Godfrey Abel
<i>Gérants

Référence de publication: 2009113007/13.
(090135526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Sibgrave Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.557.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

87798

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009113000/10.
(090135532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

oneOone communication S.A., Société Anonyme,

(anc. ART east S.A.).

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 26.

R.C.S. Luxembourg B 107.481.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 27 août 2009.

Martine WEINANDY
<i>Notaire

Référence de publication: 2009112989/13.
(090135577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Sodesoft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 29, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 84.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009112988/10.
(090135997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Bright Pattern, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 147.840.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the sixth day of August.
Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared the following:

The public limited liability company Vonarius Holding having its registered office at L-2212 Luxembourg, 6, Place de

Nancy, (RCS Luxembourg N°B. 147.160)

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

July 14 

th

 , 2009

The above mentioned proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing

party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to draw up the following

articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme) which it declares to establish as follows:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a company in the form of a public limited liability company (société anonyme) (the "Company") which
will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the
"Articles").

The public limited liability Company exists under the name of "BRIGHT PATTERN".

Art. 2. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Director or, as the

case may be, the Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the
Company's registered office.

87799

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Director or, as the case may be, the Board of Directors.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The object of the Company is the provision of communication software, owned or licensed from others, and

entering into activities or agreements to enable, protect or benefit from the software's capabilities.

3.2 The object of the Company is further more the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg

or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets

3.4. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.5. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.6.  The  Company  may  carry  out  any  commercial  and/or  financial  transactions  with  respect  to  direct  or  indirect

investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

3.7. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved and put into liquidation, at any time, by a resolution of the general meeting of share-

holders.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.00 (thirty one thousand euro) divided into

310 (three hundred and ten) registered ordinary shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euro) each, fully paid
up.

The share capital of the Company may be divided into several classes of shares.

Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered shares.
A register of registered shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for

inspection by any shareholder. This register shall contain all of the information required by Article 39 of the Luxembourg
Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Companies Act"). Holders of shares in registered
form may request the Company to issue and deliver certificates setting out their respective holdings of registered shares.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of registered shares will be established by registration in the said register. Transfer of registered shares

shall be effected by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by
the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of regis-
tered shares shall be entered into the register of shareholders, such inscription shall be signed by the Director or, as the
case may be, two members of the Board of Directors of the Company or by one or more other persons duly authorized
thereto by the Board of Directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent such share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated
as the sole owner towards the Company.

The shares are freely transferable.

Art. 7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time

and upon conditions which the Director or, as the case may be, the Board of Directors shall from time to time determine

87800

subject to the Companies Act. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which
are not fully paid up.

Art. 8. Increase and Reduction of capital. The authorised and subscribed capital of the Company may be increased or

reduced in one or several times by a resolution of the shareholders or the sole shareholder, as the case may be, voting
with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting, voting with the quorum

and majority rules required for any amendment of the Articles, may limit or withdraw the preferential subscription right
or authorise the Board of Directors to do so.

The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

Chapter III. Directors, Board of directors, Statutory auditors

Art. 9. Board of directors. In the event the Company is composed of a single shareholder, the latter may appoint only

one  Director  (the  "Director");  however,  a  single  shareholder  may  also  appoint  a  board  of  directors  (the  "Board  of
Directors") composed of at least three members, if it so chooses (the "Directors" comprising all the Directors including
the Director, unless expressly provided otherwise). When the Company is composed of several shareholders, it shall be
managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The Director(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of share-

holders, which will determine their number, their remuneration, the duration of their mandate for a period not exceeding
six years, and they will hold office until their successors are elected. They may be re-elected, and they may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting
of shareholders.

If a corporate entity is appointed as Director, it shall designate a natural person to exercise its functions and act on

the name and behalf of the corporate entity.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, if applicable, the remaining Director(s) may meet and may elect

a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

The Director(s) shall not disclose, even after the term of their mandate, information on the Company made available

to  them,  the  disclosure  of  which  may  be  detrimental  to  the  Company's  interests,  except  when  such  a  disclosure  is
mandatory by law or in public interest.

Art. 10. Meetings of the board of directors. The Board of Directors will appoint from among its members a chairman

(the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his absence

the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other
person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date and time of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax, by electronic form or by telegram of each Director. No

separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax, by electronic form or

by telegram another Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of majority of the Directors holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In case of

equality of votes, the Chairman has a casting vote.

One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication thus enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. Such meetings shall be
considered equivalent as a meeting held at the registered office of the Company.

87801

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Art. 11. Minutes of meetings of the board of directors. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be

signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or
by any two Directors or by the Director, as the case may be.

Art. 12. General powers of the board of directors. The Director or, as the case may be, the Board of Directors is

vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's purpose. All
powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Director
or, as the case may be, the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of powers. The Director or, as the case may be, the Board of Directors may delegate its powers

to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily
management and affairs to any member or members of the Board of Directors, directors, managers or other officers
who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Director or, as the case
may be, the Board of Directors shall determine.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any

person who need not be a Director, and delegate to one or more directors, managers of the company or other agents,
who may but are not required to be shareholders, acting either alone or jointly, and appoint and dismiss all officers and
employees and fix their emoluments.

When the Company is managed by a Board of Directors, the delegation of daily management to a member of the

Board of Directors entails the obligation for the Board of Directors to report each year to the ordinary general meeting
on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

The Director, or, as the case may be, the Board of Directors may appoint one or more advisory committees. It will

determine their composition and purpose.

Art. 14. Representation of the company. In case only one Director has been appointed, the Company will be bound

toward third parties by the sole signature of that Director as well as by the joint signatures or single signature of any
person(s) to whom the Director has delegated such signatory power, within the limits of such power.

In case the Company is managed by a Board of Directors, the Company will be bound towards third parties by the

joint signature of any two Directors or by any person(s) to whom such authority has been delegated.

Art. 15. Conflict of interests - Indemnification. No contract or other transaction between the Company and any other

company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the
Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except
as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer
or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, other than transactions concluded under normal conditions and falling within the
scope of the day-to-day management of the Company, he shall make known to the Board of Directors (if any) such
personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or
officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

When the Company is composed of a single Director, minutes mentioning transactions in which the Director has a

personal interest shall be recorded.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.

Art. 16. Statutory auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more statutory

auditor(s) who need not be shareholders.

The statutory auditors will be elected by the sole shareholder or as the case may be, the shareholders' meeting, which

will determine the number of such statutory auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until
their successors are elected. At the end of their term as statutory auditors, they shall be eligible for re-election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

87802

Chapter IV. General meeting of shareholders

Art. 17. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the broadest powers to adopt and ratify any action relating to the

Company. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by the law to
the general meeting of shareholders. In such case, the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes.

Art. 18. Annual general meeting. The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or

at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on 15 April of each year, at 2 p.m. If the date
of the general meeting is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

The annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretion of the Director or, as the case may be, the

Board of Directors circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Other general meetings. The Director or, as the case may be, the Board of Directors may convene other

general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company's
capital so require in writing with an indication of the agenda of the upcoming meeting. If the general meeting is not held
within one month of the scheduled date, it may be convened by an agent designated by the judge presiding the Tribunal
d'Arrondissement dealing with commercial matters and hearing interim relief matters, upon the request of one or more
shareholders representing the 10% (ten per cent.) threshold.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the discretion of the

Director or, as the case may be, the Board of Directors circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Procedure, Vote. The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders will meet upon call by the

Director or, as the case may be, by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with
Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. Shareholders representing at least one
tenth of the Company's share capital may request in writing that additional items be included on the agenda of any general
meeting. Such request shall be addressed to the registered office of the Company by registered letter at least five days
before the date on which the general meeting shall be held.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may cast his vote by correspondence. For such purpose, the shareholder may only use the voting

forms provided by the Company.

Any executed and filled in voting forms shall be delivered to the Company at its registered office either by hand with

acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier.

Any voting form ("formulaire") which is not signed by the relevant shareholder or its authorised representative(s), as

applicable, and does not bear at least the following mentions or indications is to be considered null and void:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares and, if applicable, number of shares of each class, held by the relevant shareholder in the share

capital of the Company;

- place, date and time of the general meeting to be held;
- agenda of the general meeting to be held;
- vote by the relevant shareholder indicating, with respect to each of the proposed resolutions, whether the relevant

shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and

- name and title of the authorised representative of the relevant shareholder, if applicable.
Any voting form ("formulaire") shall be received by the Company no later than 6 p.m., Luxembourg time, on the day

which immediately precedes the day on which the general meeting shall be held and on which banks are generally open
for business in the Grand Duchy of Luxembourg. Any voting form ("formulaire") received by the Company after such
deadline shall be disregarded.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax, by electronic form or

telegram as his proxy another person who need not be a shareholder.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled

in order to take part in a general meeting of shareholders.

Except as otherwise required by law or by the present Articles, resolutions will be taken by a simple majority of votes

irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

The general meeting of shareholders shall not validly deliberate on proposed amendments of the Articles unless at

least one half of the capital is represented and resolutions related therewith, in order to be adopted, must be carried by
at least two-thirds of votes validly cast, exclusive of abstention, shares in respect of which the shareholder has not taken
part in the vote and blank and spoiled ballot papers.

87803

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication thus enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders

to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the sole Director, or in the event the Company is
managed by a Board of Directors, by any two members of the Board of Directors.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December each year.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the

requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 22. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated

to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
10% (ten per cent.) of the subscribed capital of the Company.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Director or, as the case may be, the Board of Directors may pay out an

advance payment on dividends. The Director or, as the case may be, the Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case

may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these
Articles, unless otherwise provided by law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one
or more liquidators appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders,
which will determine their powers and their compensation.

Subject to the following, after payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of

liquidation, the net assets shall be distributed equally to the shareholders of the shares pro rata to the number of the
shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 24. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable

Luxembourg laws.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party subscribed for and fully paid up in cash all

the 310 (three hundred and ten) registered shares with a par value of EUR 100,- (one hundred euro) each issued by the
Company.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in Article

26 of the Companies Act have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind, whether similar to any of those or not, which will have to be borne

by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1.300.-.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2009. The

first annual general meeting will thus be held in the year 2010.

<i>Extraordinary general meeting

The above mentioned shareholder, representing the entire subscribed capital, immediately held a first extraordinary

general meeting and passed the following resolutions:

1. Resolved to set at 3 (three) the number of Director(s) and further resolved to appoint the following as Directors

for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2010:

<i>Directors:

a.- Mr Erhan CAKMAK, businessman, born in Zongulday (Turkey), on February 24 

th

 , 1960, residing in D-59354 Hürth,

Tilsit Strasse 21h,

87804

b.- Mr Konstantin KISHINSKY, businessman, born on November 14 

th

 , 1963, residing at CA-94070 San Carlos, 10,

Withman Court (U.S.A.),

c- Mr Doter ZAFER, businessman, born in Ankara, on August 30 

th

 , 1946, residing at 34394 Esentepe Sisli, Kasap

Sokak Eser Is Merkezi 16B, Istambul Turkey

d.- Mr Romain BONTEMPS, independent auditor, residing professionally in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy
2. Resolved to appoint Mr Erhan CAKMAK, as managing director, for a period ending at the annual general meeting

of shareholders to be held in 2010

3. Resolved to set at 1 (one) the number of statutory auditor and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2010:

PKF Abax Audit, a public limited liability company, having its registered office at 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg

(RCS Luxembourg B. 142.867)

4. Resolved that the registered office shall be at 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case
of discrepancies between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendneun, am sechsten August,
Vor Uns, Paul DECKER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft Vonarius Holding mit Sitz in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, (RCS Luxembourg N°B.

147.160),

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, wohnhaft un Luxemburg, aufgrund einer am 14. Juli 2009 erteilten

Vollmacht.

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt nach Paraphierung und Unterzeichnung "ne varietur" durch den Bevollmächtigten

der erschienenen Partei und den unterzeichnenden Notar zur Eintragung an diese Urkunde angeheftet.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben ausgeführt, ersucht den unterzeichenden Notar, die folgende Satzung einer

Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie wie folgt zu gründen erklärt:

Kapitel I. Form, Firma, Eingetragener Firmensitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Firma. Es wird hiermit von dem Zeichner und all denjenigen, die Eigentümer der hiernach begebenen

Aktien werden mögen, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet (die "Gesell-
schaft"), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und der vorliegenden Satzung unterliegen (die "Satzung").

Die Aktiengesellschaft besteht unter der Firma "BRIGHT PATTERN".

Art. 2. Eingetragener Sitz. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Vorstand ist

befugt, die Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft zu ändern.

Zweigstellen und andere Geschäftsstellen können in dem Großherzogtums Luxemburg oder im Ausland durch Be-

schluss des Vorstandes eröffnet werden.

Art. 3. Gesellschaftsgegenstand.
3.1. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Kommunikations-Software, die im Eigentum der Gesellschaft

steht oder von einem Dritten lizenziert wird, sowie der Eintritt in Aktivitäten oder Vereinbarungen um die Erstellung,
den Schutz und den Nutzen von Software-Funktionen zu gewährleisten.

3.2. Zweck der Gesellschaft ist auch die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg

oder im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine.
Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere
Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagezertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemei-
neren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer börsennotierten- oder privaten Gesellschaft
gleich welcher Art ausgegeben wurden.

3.3. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann

ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder
Anteilspapiere emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissi-
onen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter

87805

Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind
(nachfolgend die "verbundenen Unternehmen"). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten
Dritter stellen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die
Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger
Weise Sicherheiten daraus schaffen.

3.4. Die Gesellschaft kann des Weiteren den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder

sonstige geistige Schutzrechte gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

3.5. Die Gesellschaft kann im Allgemeinen jegliche Finanztechniken und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke

des effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Finanztechniken und Instrumente, mit denen die Ge-
sellschaft gegen Kredit-, Währungs-, Zins-und andere Risiken abgesichert werden kann.

3.6. Die Gesellschaft kann gewerbliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten

Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Halten,
Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Umbau, Kulti-
vierung,  Bebauung,  Verkauf  oder  sonstige  Veräußerung,  hypothekarische  Beleihung,  Verpfändung  oder  Belastung  in
anderer Weise von beweglichem Eigentum oder Immobilien.

3.7. Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen

Anspruch auf Vollständigkeit.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst und liquidiert werden.

Kapitel II. Grundkapital, Aktien

Art. 5. Grundkapital. Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissig tausend Euro (31.000,-

EUR), unterteilt in dreihundertzehn (310) Namensstammaktien mit einem Nennwert von je ein hundert Euro (100,- EUR),
vollständig eingezahlt.

Das Grundkapital der Gesellschaft kann in mehrere Aktiengattungen unterteilt werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.
Ein Namensaktienregister wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zwecks Einsichtnahme jedes Aktionärs aufbe-

wahrt. Dieses Register soll alle gemäß des aktuellen Artikels 39 des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften
vom 10 August 1915 (das "Gesellschaftsgesetz") vorgeschriebenen Angaben enthalten. Inhaber von Namensaktien können
bei der Gesellschaft die Ausstellung und Aushändigung von Zertifikaten beantragen, die die genaue Anzahl der jeweils
gezeichneten Namensaktien wiedergeben.

Jeder Aktionär hat der Gesellschaft seine Adresse sowie jede Änderung derselben per Einschreiben mitzuteilen. Die

Gesellschaft ist berechtigt, sich auf die letzte derart mitgeteilte Adresse zu berufen.

Eigentum an Namensaktien entsteht durch Eintragung in das vorbenannte Namensaktienregister. Die Übertragung von

Namensaktien erfolgt durch schriftliche, ins Namensaktienregister einzutragende, vom Indossant und Indossar oder deren
dazu  berechtigten  Bevollmächtigten  datierte  und  unterschriebene  Übertragungserklärung.  Jede  Übertragung  von  Na-
mensaktien  soll  im  Namensaktienregister  eingetragen  werden,  eine  solche  Eintragung  ist  vom  Einzelvorstand  oder
gegebenenfalls von zwei Vorstandsmitgliedern oder von einem oder mehreren Personen, die vom Vorstand hierzu ord-
nungsgemäß bevollmächtigt worden sind, zu unterzeichnen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an; sollte die Inhaberschaft einer Aktie zwischen mehreren Per-

sonen aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an dieser Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmäch-
tigten ernennen, um diese Aktie gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte
bezüglich einer solchen Aktie aussetzen, solange nicht eine einzelne Person zu ihrem alleinigen Eigentümer gegenüber der
Gesellschaft benannt worden ist.

Die Aktien sind frei übertragbar.

Art. 7. Zahlungen auf Aktien. Zahlungen auf zur Zeit der Zeichnung noch nicht vollständig einbezahlte Aktien können

zu von dem Einzelvorstand oder, gegebenenfalls, dem Vorstand gemäß dem Gesellschaftsgesetz bestimmten Zeitpunkt
und Bedingungen geleistet werden. Jeder Betrag des eingeforderten Kapitals wird gleichmäßig verteilt auf alle restlichen
nicht eingezahlten Aktien.

Art. 8. Erhöhung und Reduzierung des Grundkapitals. Das genehmigte Kapital und das gezeichnete Grundkapital kön-

nen ein oder mehrere Male durch Beschluss der Aktionärsversammlung, oder gegebenenfalls, des Alleinaktionärs gemäß
der durch diese Satzung oder für den Fall der Änderung dieser Satzung gesetzlich vorgesehenen Beschlussfähigkeits- und
Mehrheitsvorschriften erhöht oder reduziert werden.

Die neuen Aktien die aufgrund der Bareinlage gezeichnet werden sollen, werden zunächst vorzugsweise den Altakti-

onären im Verhältnis zum Kapitalanteil, über den diese Aktionäre verfügen, angeboten. Der Vorstand bestimmt den
Zeitrahmen dieses Rechts auf vorzugsweise Zeichnung. Dieser Zeitraum beträgt mindestens 30 Tage.

87806

Abweichend von den vorherigen Paragraphen, kann der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der

Aktionäre gemäß den Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvorschriften notwendig für jede Abänderung der Satzung, diese
Recht auf vorzugsweise Zeichnung begrenzen oder zurücknehmen, oder den Vorstand hierzu ermächtigen.

Die Gesellschaft kann ihre Aktien im gesetzlichen Rahmen zurückkaufen.

Kapitel III. Vorstandsmitglieder, Vorstand, Satzungsmäßiger Buchprüfer

Art. 9. Vorstand. Falls die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat, so kann jener einen Einzelvorstand ernennen ("Ein-

zelvorstand"); der Alleingesellschafter kann jedoch auch einen Vorstand (der "Vorstand"), bestehend aus mindestens drei
Mitgliedern ernennen (die "Vorstandsmitglieder", umfasst sowohl die Vorstandsmitglieder als auch den Einzelvorstand,
vorbehaltlich ausdrücklich anderslautender Bestimmungen). Falls die Gesellschaft aus mehreren Aktionären besteht, wird
sie durch einen Vorstand, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, geleitet.

Das (Die) Vorstandsmitglied(er) wird (werden) von dem Alleinaktionär, oder gegebenenfalls von der Hauptversamm-

lung der Aktionäre ernannt, der (die) seine (ihre) Anzahl, Bezahlung, Amtsdauer für einen Zeitraum von maximal sechs
Jahren festsetzt, und der (die) sein (ihr) Amt bis zur Wahl seines (ihres) Nachfolgers ausübt. Er (Sie) kann wiedergewählt
und mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der
Aktionäre abgelöst werden.

Soweit eine Kapitalgesellschaft als Vorstandsmitglied bestellt ist, bestimmt sie eine natürliche Person, die ihre Aufgaben

ausübt und in ihrem Auftrag und in ihrem Namen handelt.

Im Fall einer Vakanz im Vorstand können sich gegebenenfalls die verbleibenden Vorstandsmitglieder versammeln und

einen Ersatz wählen, der die freie Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung ausübt.

Die Vorstandsmitglieder sind auch nach Ablauf ihrer Amtszeit gehalten, ihnen zugänglich gemachte Informationen über

die Gesellschaft, die den Belangen der Gesellschaft schaden könnten, nicht zu offenbaren, abgesehen den Fall, dass eine
solche Mitteilung gesetzlich vorgeschrieben ist oder im öffentlichen Interesse liegt.

Art. 10. Vorstandssitzungen. Der Vorstand bestimmt aus seinen Mitgliedern den Vorstandsvorsitzenden (der "Vor-

standsvorsitzende"). Er bestimmt des weiteren einen Schriftführer, der kein Vorstandsmitglied sein muss und dessen
Aufgabe darin besteht, das Protokoll der Vorstandssitzung und der Hauptversammlung der Aktionäre zu führen

Der Vorstand versammelt sich nach Einberufung durch den Vorstandsvorsitzenden. Eine Sitzung des Vorstandes ist

einzuberufen, sofern zwei beliebige Vorstandsmitglieder dies beantragen.

Der Vorstandsvorsitzende führt den Vorsitz bei allen Vorstandssitzungen und Hauptversammlungen der Aktionäre.

Im Falle seiner Abwesenheit kann sowohl der Vorstand ein anderes Vorstandsmitglied als zeitweiligen Vorsitzenden als
auch die Hauptversammlung der Aktionäre eine andere Person als zeitweiligen Vorsitzenden mit der Mehrheit der an-
wesenden oder vertretenen Aktionäre bestellen.

Die  Vorstandsmitglieder  sind  zu  jeder  Sitzung  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  ihrem  Beginn  durch

schriftliche Einladung, welche den Sitzungsort, das Datum und die Uhrzeit der Sitzung, eine Tagesordnung und die Art
der Angelegenheit zu enthalten hat, zu benachrichtigen, außer bei Dringlichkeit oder bei Verzicht aller Vorstandmitglieder
auf diese Einberufungsfrist.

Auf diese schriftliche Einladung kann durch Zustimmung jedes einzelnen per Brief, Fax, Telegramm oder durch anderes

gleichwertiges elektronisches Kommunikationsmittel verzichtet werden. Gesonderte Einladungen sind nicht notwendig
für Versammlungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die vorher in einem durch Beschluss des Vorstandes
genehmigten Zeitplan enthalten sind.

Jede Vorstandssitzung ist in Luxemburg oder an dem in der Einladung angegebenen Ort abzuhalten.
Jedes Vorstandsmitglied kann auf Vorstandssitzungen als Vertreter eines anderen Vorstandsmitglieds durch per Brief,

Fax, Telegramm oder anderem gleichwertigen elektronischem Kommunikationsmittel von diesem Vorstandsmitglied er-
teilter Vertretungsmacht handeln.

Der Vorstand ist nur beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der amtierenden Vorstandsmit-

glieder anwesend oder vertreten ist.

Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorstandsvorsitzenden ausschlaggebend.

Die Teilnahme eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder an Vorstandssitzungen per Konferenzschaltung, Videokon-

ferenz  oder  ähnlichem  Kommunikationsmittel,  die  eine  simultane  Verständigung  der  daran  teilnehmenden  Personen
miteinander gewährleistet, ist zulässig. Teilnehmer, welche solchermaßen der Sitzung beigewohnt haben, gelten als per-
sönlich anwesend. Diese Sitzungen stehen einer Sitzung am eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft.

Schriftliche, von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse sind zulässig und wirksam wie bei einer

ordentlich einberufenen und abgehaltenen Vorstandsitzung gefasste Beschlüsse. Diese Beschlüsse können entweder in
einem Dokument oder in mehreren gesonderten Dokumenten, die den gleichen Inhalt haben und jeweils von einem oder
mehreren Vorstandsmitgliedern unterschrieben werden, festgehalten werden.

87807

Art. 11. Protokoll der Vorstandssitzung. Die Beschlüsse des Vorstands werden in Protokollen festgehalten, die von

allen anwesenden Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden. Auszüge aus diesen Protokollen bedürfen der Unterschrift
entweder des Vorstandsvorsitzenden oder zweier (2) Vorstandsmitglieder.

Art. 12. Befugnisse des Vorstandes. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand hat die weitesten Befugnisse,

um sämtliche Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Sinne der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche Befugnisse,
welche nicht ausdrücklich vom Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind,
fallen in den Kompetenzbereich des Einzelvorstands oder gegebenenfalls des Vorstandes.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann die tägliche Ge-

schäftsführung der Gesellschaft und die Zeichnungsbefugnis im Rahmen der täglichen Geschäftsführung auf jedes Vor-
standsmitglied, jeden Direktor, Geschäftsführer, oder leitenden Angestellten, das/der nicht Aktionär der Gesellschaft sein
muss, unter den Bedingungen und mit den Befugnissen, die von dem Einzelvorstand oder gegebenenfalls dem Vorstand
bestimmt werden, übertragen.

Der  Einzelvorstand  oder  gegebenenfalls  der  Vorstand  kann  anderen  Personen,  die  nicht  Vorstandsmitglieder  sein

müssen, General- oder Spezialvollmacht erteilen und darüber hinaus einen oder mehrere Direktoren, Geschäftsführer
der Gesellschaft oder andere Angestellten, die Aktionäre sein können, aber nicht sein müssen, einzeln oder gemeinsam
bevollmächtigen, und er kann alle leitenden Angestellten und Beschäftigten ernennen und entlassen und ihre Bezüge
festsetzen.

Falls die Gesellschaft von einem Vorstand geführt wird und die tägliche Geschäftsführung auf ein Vorstandsmitglied

übertragen wurde, so ist der Vorstand verpflichtet, er Hauptversammlung der Aktionäre jährlich Bericht über das Gehalt,
die Kosten und die sonstigen Vergünstigungen des Stellvertreters zu erstatten.

Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann ein oder mehrere beratende Ausschüsse bestellen. Deren

Zusammensetzung und Zweck wird durch den Vorstand bestimmt.

Art. 14. Vertretung der Gesellschaft. Im Falle der Ernennung eines Einzelvorstands wird die Gesellschaft Dritten ge-

genüber rechtswirksam durch die alleinige Unterschrift des Einzelvorstands wie auch durch die gemeinsame oder alleinige
Unterschrift jedweder Person(en), der (denen) der Einzelvorstand eine solche Unterschriftenvollmacht erteilt hat, in den
Grenzen dieser Vollmacht.

Im Falle der Ernennung eines Vorstands wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtswirksam durch die gemeinsame

Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern oder durch jedwede Person(en) mit entsprechender Vollmacht verpflichtet.

Art. 15. Interessenkonflikt - Entschädigung. Verträge oder sonstige Transaktionen zwischen der Gesellschaft und einer

anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens werden nicht durch die Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam,
dass ein Vorstandmitglied oder mehrere Vorstandsmitglieder oder leitende Angestellte einen persönlichen Vorteil an
einem Geschäft hat (haben) oder Direktor, Teilhaber, leitender Angestellter oder Angestellter dieser anderen Gesellschaft
oder dieses anderen Unternehmens ist (sind). Vorbehaltlich anderer nachstehender Regelungen ist jedes Vorstandsmit-
glied  oder  leitender  Angestellter  der  Gesellschaft,  der  als  Direktor,  Teilhaber,  leitender  Angestellter  oder  sonstiger
Angestellter bei einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen beschäftigt ist, gegenüber der sich die
Gesellschaft vertraglich verpflichtet oder mit der sie anderweitig Geschäfte tätigt, automatisch aufgrund dieser Verbindung
zu dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen von der Beratung an und Beschlussfassung über sowie
von Handlungen hinsichtlich jedweder Angelegenheit mit Bezug zu diesen Verträge oder Geschäften ausgeschlossen.

Ungeachtet des vorherigen Absatzes muss ein Vorstandsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im

Falle eines ihn betreffenden möglichen Interessenkonflikts hinsichtlich eines jedweden Geschäfts der Gesellschaft, ausge-
nommen solcher Geschäfte, die unter normalen Umständen getätigt werden und in den Bereich der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft fallen, den Vorstand von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und darf weder an
der Beratung an einem solchen Geschäft noch an der Beschlussfassung über ein solches Geschäft teilnehmen. Ein solches
Geschäft und persönliches Interesse des Vorstandsmitglieds oder des leitenden Angestellten an ihm werden der nächsten
Hauptversammlung der Aktionäre mitgeteilt.

Falls die Gesellschaft einen Einzelvorstand hat, sind Protokolle über Geschäfte, bei denen der Einzelvorstand ein per-

sönliches Interesse / Vorteil hat, abzufassen.

Die Gesellschaft soll jedes Vorstandsmitglied oder jeden leitenden Angestellten und deren Erben, Testamentsvoll-

strecker  und  Nachlassverwalter  entschädigen  für  Aufwendungen,  die  er  vernünftigerweise  in  Verbindung  mit  einem
Verfahren, einer Klage oder einem sonstigem Rechtsstreit erlitten hat, an dem/der er Streitpartei wurde aufgrund seiner
Stellung als amtierendes oder ehemaliges Vorstandsmitglied oder als amtierender oder ehemaliger leitender Angestellter
der Gesellschaft oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft Aktionär oder
gegenüber der sie Gläubiger ist und gegenüber der er kein Recht auf Entschädigung hat, ausgenommen solcher Gegen-
stände, hinsichtlich derer er in diesem Verfahren, dieser Klage oder diesem sonstigem Rechtsstreit rechtskräftig verurteilt
wird  wegen  grober  Fahrlässigkeit  oder  schuldhaftem  Verhalten;  im  Falle  eines  Vergleichs  wird  Entschädigung  nur  im
Rahmen der Gegenstände geleistet, die vom Vergleich umfasst sind, in Bezug auf den die Gesellschaft von ihrem Rechts-
beistandes beraten wurde, dass keine Pflichtverletzung seitens des zu Entschädigenden vorliegt. Dieses Entschädigungs-
recht schließt andere dem Vorstandsmitglied oder leitenden Angestellten zustehende Rechte nicht aus.

87808

Art. 16. Gesetzlich zugelassene Abschlussprüfer. Die Überwachung der Transaktionen der Gesellschaft obliegt einem

oder mehreren gesetzlich zugelassenen Abschlussprüfer(n).

Der (Die) Abschlussprüfer (werden) wird von dem Alleinaktionär oder gegebenenfalls von der Hauptversammlung der

Aktionäre ernannt, der (die) seine (ihre) Anzahl, Bezahlung, Dauer seines (ihres) Amtes für einen Zeitraum von maximal
sechs Jahren festsetzt, darüber hinaus bestimmt, dass er (sie) sein (ihr) Amt bis zur Wahl seines (ihres) Nachfolgers
fortführt (fortführen). Nach Amtsablauf können sie wiedergewählt werden, sind allerdings mit oder ohne Grund ablösbar
durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre.

Kapitel IV. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 17. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre. Jede ordnungsgemäß einberufene Aktionärsversammlung

vertritt die Gesamtheit der Aktionäre.

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Aktionäre  hat  die  weitesten  Befugnisse,  jede  die  Gesellschaft  betreffende

Handlung zu billigen und zu ratifizieren. Falls die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, so übernimmt dieser die der
Hauptversammlung der Aktionäre zustehenden Befugnisse. In diesem Fall werden die Entscheidungen des Alleingesell-
schafters protokolliert.

Art. 18. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung findet am eingetragenen Geschäftssitz oder an einem

anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg am 15. April jeden Jahres um 14 Uhr statt. Falls an diesem
Tag in dem Großherzogtum Luxemburg die Banken nicht geöffnet sind, wird die Jahreshauptversammlung am ersten
darauffolgenden Geschäftstag abgehalten.

Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls nach dem Ermessen des Einzelvorstands oder,

gegebenenfalls, des Vorstandes außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Art. 19. Ordentliche Hauptversammlung. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann mehrere andere

ordentliche Hauptversammlungen einberufen. Diese Hauptversammlungen sind einzuberufen, sofern dies Aktionäre, die
zumindest ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, schriftlich mit Angabe der Tagesordnung der geplanten Haupt-
versammlung  beantragen. Sofern  diese  Hauptversammlung nicht  innerhalb eines  Monats ab  dem festgelegten  Termin
durchgeführt wird, kann, auf Antrag eines oder mehrerer Minderheitsaktionäre, die zusammen mindestens ein Zehntel
des Gesellschaftskapitals halten, der Vorsitzende Richters des Tribunal d'Arrondissement, das sich mit Handelssachen
und einstweiligem Rechtsschutz befasst, einen Bevollmächtigten ernennen, der die Hauptversammlung einberuft

Die ordentliche Hauptversammlung, auch die Jahreshauptversammlung, kann im Ausland abgehalten werden, falls nach

dem Ermessen des Einzelvorstands oder gegebenenfalls des Vorstandes außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Art. 20. Verfahren, Wahlrecht. Der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre wird

durch den Einzelvorstand oder gegebenenfalls den Vorstand oder durch den oder die Abschlussprüfer in Übereinstimmung
mit luxemburgischem Recht einberufen. Die an die Aktionäre gesetzesgemäß zu versendende Einladung hat den Ver-
sammlungsort,  das  Datum  und  die  Uhrzeit  der  Versammlung,  die  Tagesordnung  und  die  Art  des  vorzunehmenden
Geschäfts  anzugeben.  Aktionäre,  die  zumindest  ein  Zehntel  des  Gesellschaftskapitals  repräsentieren,  können  durch
schriftlichen Antrag verlangen, dass zusätzliche Tagesordnungspunkte der Tagesordnung hinzugefügt werden. Derartige
Anträge sind an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft per eingeschriebenem Brief mindestens fünf Tage vor dem Termin
der Hauptversammlung zu adressieren.

Falls alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie bestätigen, von der Ta-

gesordnung der Versammlung Kenntnis zu haben, kann diese ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann auch schriftlich abstimmen. Für diesen Zweck sind nur die von der Gesellschaft herausgegebenen

Wahlzettel zu benutzen.

Alle unterschriebenen und ausgefüllten Wahlzettel sollen mit Empfangsbestätigung, entweder mittels Einschreiben oder

Kurier der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zugestellt werden.

Jeder Wahlzettel ("formulaire"), der nicht von dem jeweiligen Aktionär oder gegebenenfalls seinem berechtigten Stell-

vertreter unterschrieben wurde, und nicht zumindest die folgenden Angaben enthält ist nichtig:

- Name und eingetragener Gesellschaftssitz und / oder Wohnsitz des jeweiligen Aktionärs;
- Gesamtanzahl an Aktien und, gegebenenfalls, Anzahl an Aktien jeder Aktiengattung eines Aktionärs am Aktienkapital

der Gesellschaft

- Ort, Datum und Zeit der geplanten Hauptversammlung;
- Tagesordnung der geplanten Hauptversammlung;
- Abstimmungsergebnis des jeweiligen Aktionärs in Bezug auf jeden Beschlussvorschlag, das anzeigt, ob der jeweilige

Aktionär sich enthält oder für oder gegen den Beschlussvorschlag stimmt; und

- gegebenenfalls Name und Titel des berechtigten Stellvertreters des jeweiligen Aktionärs.
Jeder Wahlzettel ("formulaire") muss der Gesellschaft nicht später als 18 Uhr, Luxemburger Zeit, an dem Tag, der der

Hauptversammlung unmittelbar vorausgeht und an dem die Banken im Großherzogtum Luxemburg geöffnet sind, zuge-
gangen sein. Jeder Wahlzettel ("formulaire"), der der Gesellschaft nach dieser Frist zugeht, wird nicht berücksichtigt.

87809

Ein Aktionär kann sich durch Bestellung eines Stellvertreters, der nicht notwendigerweise Aktionär sein muss, per

Brief, Fax, Telegramm oder durch andere gleichwertige elektronische Kommunikationsmittel vertreten lassen.

Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann alle Bedingungen festlegen, die erfüllt sein müssen, um an

der Hauptversammlung teilzunehmen.

Soweit nicht gesetzlich oder in der Satzung etwas anderes bestimmt ist, werden Beschlüsse, mit einfacher Mehrheit

gefasst, unabhängig von der Anzahl der bei der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann nicht wirksam über Änderungsvorschläge der Satzung beratschlagen, so-

fern nicht mindestens die Hälfte des Aktienkapitals anwesend oder vertreten ist. Solche Änderungsvorschläge der Satzung
können nur mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen verabschiedet werden, wobei Enthaltungen, Aktien,
die nicht an der Abstimmung teilgenommen haben und unausgefullte und nicht korrekt ausgefüllte Wahlzettel nicht gezählt
werden.

Die Teilnahme eines oder mehrerer Aktionäre an Hauptversammlungen per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder

ähnlicher kommunikationstechnischer Einrichtung, bei denen eine gegenseitige Verständigung der Teilnehmer gewähr-
leistet ist, ist zulässig. Teilnehmer, welche dergestalt der Versammlung beiwohnen, gelten als persönlich anwesend. Diese
Teilnahme steht einer Hauptversammlung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft durch die Aktionäre in Person gleich.

Abschriften oder Auszüge des Sitzungsprotokolls des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Hauptversammlung zum

Zwecke der Verwendung in Rechtsverfahren oder anderweitig wird von dem Einzel vorstand oder gegebenenfalls von
zwei beliebigen Vorstandsmitgliedern unterschrieben.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Dividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines

jeden Jahres. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand stellt den Jahresabschluss im Rahmen der luxembur-
gischen gesetzlichen Vorschriften und der allgemein anerkannten Rechnungsführungspraxis auf.

Art. 22. Verteilung des Gewinns. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft müssen fünf Prozent (5%) für die Bildung

der vom Gesetz vorgeschriebenen Rücklage vorgesehen werden. Diese Zuteilung wird nicht mehr verlangt, sobald und
solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft beträgt.

Der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt, wie der Restbetrag des jähr-

lichen Nettogewinns verteilt wird. Er (Sie) kann entscheiden, einen Teil- oder Gesamtbetrag dieses Restbetrages als
Rücklage oder Rückstellung auszuweisen oder als Gewinnvortrag, oder aber als Dividende and die Aktionäre auszuzahlen.

Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand kann unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen beschlie-

ßen, Zwischendividenden auszuschütten. Der Einzelvorstand oder gegebenenfalls der Vorstand legt den Betrag und das
Zahlungsdatum einer solchen Zwischendividende fest.

Kapitel VI. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

Art. 23. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der

Hauptversammlung der Aktionäre gemäß denselben Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvorschriften, die auch im Falle
einer Satzungsänderung gelten, unbeachtet anderslautender gesetzlicher Vorschriften, aufgelöst werden. Sollte die Ge-
sellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Konkursverwalter ausgeführt, die von dem
Alleinaktionär oder der Hauptversammlung der Aktionäre bestellt und dessen/deren Aufgaben und Vergütung festsetzt
wird/werden.

Hieraus folgt, dass nach Zahlung aller Verbindlichkeiten und Schulden der Gesellschaft und der Kosten der Liquidation

das Reinvermögen gleichmäßig zwischen den Aktionären aufgeteilt wird, und zwar anteilig der Anzahl der von ihnen
gehaltenen Aktien.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 24. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Gegenstände wird gemäß dem anwendbaren

luxemburgischen Recht entschieden.

<i>Zeichnung des Gründungskapitals

Die  Satzung  wurde  von  der  erschienen  Partei  erstellt,  und  diese  zeichnete  alle  dreihundertzehn  (310)  vollständig

einbezahlten, von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Der amtierende Notar bestätigt nach Zahlungsnachweis, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesellschaftsge-

setzes beachtet wurden.

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft zu tragenden Kosten, Gebühren und sonstigen Kosten, ob oder ob nicht gleichartig mit den

von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf Betrag 1.300,- EUR veranschlagt.

87810

<i>Übergangsvorschriften

Das erste Geschäftsjahr beginnt zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft und endet zum 31. Dezember 2009.

Die erste Jahreshauptversammlung wird daher im Jahre 2010 abgehalten.

<i>Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre

Der vorgenannte Alleingesellschafter, der das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hielt unmittelbar eine außeror-

dentliche Hauptversammlung ab und verabschiedete folgende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf 3 (drei) festgesetzt und die folgenden Vorstandsmitglieder werden bis

zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahre 2010 benannt:

<i>Vorstandsmitglieder:

a.-  Mr  Erhan  Cakmak,  Manager,  geboren  in  Zonguldak,  Türkei  am  24.  Februar  1960,  wohnaft  in  D-59354  Hürth,

Tilsitstrasse 21 h, b.- Mr Konstantin KISHINSKY, Geschäftsmann, geboren am 14. November 1963, wohnhaft in CA-94070
San Carlos, 10, Withman Court (U.S.A.),

c- Mr Zafer DÖRTER, Geschäftsmann, geboren in Ankara, am 30. August 1946, wohnhaft in 34394 Esentepe Sisli,

Kasap Sokak Eser Is Merkezi 16B, Istambul Turkey

d.- Mr Romain BONTEMPS, Wirtschaftsprüfer, berufsansässig in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy
2.- Als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied wird bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahre 2010

Mr. Erhan Cakmak, vorbenannt ernannt.

3.- Die Anzahl der Abschlussprüfer wird auf 1 (einen) festgesetzt und als Abschlussprüfer wird bis zur Jahreshaupt-

versammlung der Aktionäre im Jahre 2010 benannt.

PKF Abax Audit, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy (RCS Luxembourg N° B.

142.867)

4.- Sitz der Gesellschaft ist in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der English versteht und spricht, bestätigt hiermit, das auf Antrag der erschienenen Partei

diese notarielle Urkunde in Englisch ausgefertigt wurde, mit einer deutschen Übersetzung im Anschluss; auf Antrag der
gleichen Person ist im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text
maßgeblich.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Person, die dem Notar nach Namen, Vornamen,

Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrie-
ben.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 août 2009. Relation: LAC/2009/32880. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. August 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009112906/673.
(090135817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Vietnam Resource Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.089.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VIETNAM RESOURCE INVESTMENTS S.à r.l.
S G G S.A.
412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009112991/13.
(090135499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

87811

LSF Quintet Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 111.284.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009112992/12.
(090135608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

LSREF Lux Japan Investments VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 140.855.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009112994/12.
(090135631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Transports et Garage Presse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2411 Luxembourg, 5, rue Raiffeisen.

R.C.S. Luxembourg B 15.484.

EXTRAIT

En date du 27 juillet 2009, les constats et décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale des associés de

la Société:

1) Les associés ont constatés la démission de M. Jacques Funck prenant effet au 31 juillet 2009.
2) Le mandat de gérant des personnes suivantes a été prolongé:
- Le mandat de gérant de M. Kaspar Niklaus a été prolongé jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2010.
- Le mandat de gérant de M. Christian Schock a été prolongé jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2010.
3) Monsieur Georg Matiaska né le 16 décembre 1968, à Liestal Suisse, demeurant à Breitmattboden 34, 5073 Gipf-

Oberfrick, Suisse a été nommé en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée expirant à l'assemblée générale
annuelle devant se tenir en 2010.

Il résulte de ce qui précède que le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Kaspar Niklaus
- Monsieur Christian Schock
- Monsieur Georg Matiaska

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009112890/23.
(090134937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Flowersun S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 104.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

87812

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009112965/10.
(090135921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Nord Est Asset Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 69.705.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009112968/10.
(090135909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Bone &amp; Joint Research S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 36.928.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2009112970/10.
(090135901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

DS Turkey 5 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 138.264.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009112984/13.
(090135723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Nacarat Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 2, rue Siggy vu Letzebuerg.

R.C.S. Luxembourg B 137.363.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009112978/11.
(090135516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Brainsourcing S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d'Itzig.

R.C.S. Luxembourg B 140.861.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

87813

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2009112976/10.
(090135888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Sodesoft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 29, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 84.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009112983/10.
(090135996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

RM2 International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 132.740.

In the year two thousand nine, on the seventeenth of August.
Before Us, the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-

bourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "RM2 INTERNATIONAL S.A.", a société anonyme

(joint stock company) having its registered office at L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim (Grand Duchy of
Luxembourg), incorporated on October 23, 2007 before Maître Blanche MOUTRIER notary residing in Esch-sur-Alzette,
deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2644 of November 19 

th

 , 2007,

modified for the last time on March 5 

th

 , 2009 before Maître Carlo WERSANDT notary residing in Luxembourg, deed

published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 682 of March 30, 2009 (hereafter "the
Company").

The General Meeting was presided by Mr Jan Arie DEKKER, Chairman of the board of directors of the Company, with

address at Van Merlenlaan, 25, NL-2101 GC Heemstede, The Netherlands.

The chairman appointed as secretary Mrs Maggy KOHL-BIRGET, accountant, with professional address at 3, rue du

Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

The General Meeting elected as scrutineer Mr Charles DURO, attorney at law, with professional address at 3, rue de

la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

The chairman requested the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the one hundred thousand (100.000) shares, representing the whole capital

of the Company, are represented so that the General Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the General Meeting was the following:

<i>Agenda:

1. Change of the actual currency of the share capital of the Company, which is in Euro to US Dollar, with effect from

October 1 

st

 , 2008;

2. Decrease of the subscribed share capital of the Company by an amount of forty-two thousand nine hundred twenty-

one US Dollars (USD 42.921,-) so as to reduce it from its current amount of one hundred forty-two thousand nine
hundred twenty-one US Dollars (USD 142.921,-) to the amount of one hundred thousand US Dollars (USD 100.000,-)
by decreasing the nominal value of each share from one point forty-two thousand nine hundred and twenty-one US
Dollars (USD 1,42921 -) to the amount of one US Dollar (USD 1,-), and by creating a special reserve to compensate
losses as of September 30 

th

 , 2009;

3. Increase of the subscribed share capital by an amount of ten US Dollars (USD 10,-) so as to raise it from its current

amount of one hundred thousand US Dollars (USD 100.000) to the amount of one hundred thousand and ten US Dollars
(USD 100.010,-) by the issuance of ten (10) new shares, equivalents distributed in each Class of shares, of a nominal value
of one US Dollar (USD 1,-) with an issue premium of seven hundred fifty-four thousand five hundred thirty-two point

87814

five hundred sixty eight US Dollars (USD 754.532,568-) per share, having same rights and obligations than the existing
shares;

4. Subscription by the company FLORAVELL INVESTMENTS Ltd, a British Virgin Islands company with registered

office in Tortola, P.O. Box 3175, Road Town of the ten (10) new shares and payment by a contribution in kind consisting
in the conversion into capital of an advance made to the Company of a total amount of seven million five hundred forty-
five thousand three hundred thirty-five point sixty-eight US Dollars (USD 7.545.335,68-);

5. Amendment of the rights attached to the classes of shares;
6. Amendment of article 5 of the by-laws so as to reflect the decisions taken;
7. Restatement of articles 16 and 17 of the by-laws;
8. Decision to insert in the by-laws a new article 19;
9. Increase of the number of Directors from four (4) to five (5) members;
10. Appointment of Mr Anthony John CARSON as fifth Director;
11. Duration of directors and auditor mandates;
12. Miscellaneous.
After approval and deliberation of the foregoing, the General Meeting passed the following resolutions by unanimous

decisions:

<i>First resolution

The General Meeting resolved, as per October 1 

st

 , 2008, the conversion of the subscribed capital of the Company

of one hundred thousand euro (EUR 100.000,-) to US Dollars and to set the subscribed capital at one hundred forty-two
thousand nine hundred twenty-one US Dollars (USD 142.921,-) consisting of one hundred thousand (100.000) shares,
each share having a par value of one point forty-two thousand nine hundred twenty-one US Dollars (USD 1,42921), by
application of the exchange rate between EUR and USD on October 1 

st

 , 2008 (1,42921-).

<i>Second resolution

The General Meeting resolved to decrease the subscribed share capital of the Company by an amount of forty-two

thousand nine hundred twenty-one US Dollars (USD 42.921,-) so as to reduce it from its current amount of one hundred
forty-two thousand nine hundred twenty-one US Dollars (USD 142.921,-) to the amount of one hundred thousand US
Dollars (USD 100.000,-) by decreasing the nominal value of each share from one point forty-two thousand nine hundred
and twenty-one US Dollars (USD 1,42921 -) to the amount of one US Dollar (USD 1,-), and by constituting up to an
amount of forty-two thousand nine hundred twenty-one US Dollars (USD 42.921,-) a special reserve account to be used
solely in order to compensate with losses stated in the financial accounts as of September 30 

th

 , 2009.

<i>Third resolution

The General Meeting resolved to increase the subscribed share capital of the Company by an amount often US Dollars

(USD 10,-) so as to raise it from its current amount of one hundred thousand US Dollars (USD 100.000,-) to the amount
of one hundred thousand and ten US Dollars (USD 100.010) by the issuance of ten (10) new shares, equivalently distributed
in each Class of shares, of a nominal value of one US Dollar (USD 1,-) per share and with an issue premium of seven
hundred fifty-four thousand five hundred thirty-two point five hundred sixty-eight US Dollars (USD 754.532,568-) per
share making a total issue premium of seven million five hundred forty-five thousand three hundred twenty-five point
sixty-eight US Dollars (USD 7.545.325,68-), having same rights and obligations that the existing shares.

<i>Fourth resolution

The ten (10) new shares with a par value of one US Dollar (USD 1,-) each and the total issue premium of seven million

five hundred forty-five thousand three hundred twenty-five point sixty-eight US Dollars (USD 7.545.325,68-) have been
subscribed and entirely paid up by the company FLORAVELL INVESTMENTS Ltd, a British Virgin Islands company, having
its registered office in Tortola, P.O. Box 3175, Road Town, by a contribution in kind consisting in the conversion into
capital of an advance made to the Company of an amount of seven million five hundred forty-five thousand three hundred
thirty-five US Dollars and sixty-eight cents (USD 7.545.335,68-).

In conformity with articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended,

such value of the contribution made by means of a contribution in kind is established by a report of the company Fiduciaire
Joseph Treis Sàrl, "Réviseur d'entreprises", with registered office in Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, which
concludes as follows:

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmentée de la prime d'émission."

87815

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolved to amend the rights attached to the classes of shares and to reflect such amendments

by modifying articles 5, 16 and 17 and by inserting a new article 19 in the by-laws.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, article 5 of the by-laws has been amended and will now be read as

follows:

Art. 5. Share capital
"5.1. The issued share capital of the Company is set at one hundred thousand and ten US Dollars (USD 100.010.-)

divided into:

- ten thousand and one (10.001) Class A shares
- ten thousand and one (10.001) Class B shares
- ten thousand and one (10.001) Class C shares
- ten thousand and one (10.001) Class D shares
- ten thousand and one (10.001) Class E shares
- ten thousand and one (10.001)) Class F shares
- ten thousand and one (10.001) Class G shares
- ten thousand and one (10.001) Class H shares
- ten thousand and one (10.001) Class I shares
- ten thousand and one (10.001) Class J shares
each share with a nominal value of one US Dollar (USD 1,-), entirely paid in, and with such rights and obligations as

set out in the present articles of incorporation.

5.2. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

5.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation

of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class
(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

5.4. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the

order provided for in article 5.3.), such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the
general meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive
from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held by them
and cancelled.

5.4.1. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

5.4.2. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Directors and approved by the

General Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes
J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the
relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amend-
ment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available
Amount.

5.4.3. Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will

become due and payable by the Company."

<i>Seventh resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, articles 16 and 17 of the by laws have been amended and will now be

read as follows:

Art. 16. Distributions
16.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

16.2 The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in ac-

cordance with the provisions set forth hereafter.

16.3. The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared

by the director, or as the case may be the board of directors, showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting

87816

year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums
to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

16.4.  The  share  premium  account  may  be  distributed  to  the  shareholders  upon  decision  of  a  general  meeting  of

shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to
allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

16.5 The dividends declared may be paid in any currency selected by the director or as the case may be the board of

directors and may be paid at such places and times as may be determined by the director or as the case may be the board
of directors The director or as the case may be the board of directors may make a final determination of the rate of
exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on
a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such
share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by
the Company on behalf of holders of shares.

16.6 In the event of a dividend declaration, the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders

of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class
I shares and in such continuation until only class A shares are in existence)"

Art. 17. Dissolution, Liquidation
After  payment  of  all  debts  and  any  charges  against  the  Company  and  of  the  expenses  of  the  liquidation,  the  net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions."

<i>Eighth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, an article 19 has been inserted in the by-laws which will read as follows:

Art. 19. Definitions

Available Amount

Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward
profits) to the extend the shareholder would have been entitled to dividend
distributions according to Art. 16 of the by-laws, increased by (i) any freely
distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as
the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve
reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any
losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into
reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as
set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance
of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating
to the Class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or
of the Articles

Interim Accounts

Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

Interim Account Date

Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant class of shares,

<i>Ninth resolution

The General Meeting resolved to increase the number of Director from four (4) to five (5) members.

<i>Tenth resolution

The General Meeting resolved to appoint as director of the Company Mr Anthony John CARSON, entrepreneur, born

in Belfast on January 14 

th

 , 1956 residing at URB Marabella Club Golf Resort Casa Morisca, 7.9 Corona Borealis Benahavis

E-29679 SPAIN.

<i>Eleventh resolution

The General Meeting decided to set the duration of the mandates of the directors and of the auditor to one (1) year,

renewable.

Consequently, the mandate of the existing directors and of the auditors, together with the mandate of Mr Anthony

John CARSON will terminate at the annual general shareholders meeting which will approve the 2009 financial statements.

87817

Nothing else being on the agenda, the General Meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same persons
and in case of any divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-sept août.
Par devant Nous, la soussignée Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg).

S'est  réunit  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  "RM2  INTERNATIONAL  S.A.",

société anonyme ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim (Grand-Duché de Luxembourg),
constituée par acte du 23 octobre 2007 par devant Maître Blanche MOUTRIER notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2644 du 19 novembre 2007, modifié pour la
dernière fois par acte du 5 mars 2009 par devant Maître Carlo WERSANDT notaire de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 682 du 30 mars 2009 (ci-après "la Société").

L'Assemblée Générale était présidée par Mr Jan Arie DEKKER, Président du conseil d'administration de la Société,

demeurant à Van Merlenlaan, 25, NL-2101 GC Heemstede, Pays-Bas.

Le président a désigné comme secrétaire Mme Maggie KOHL-BIRGET, comptable, demeurant professionnellement à

3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

L'Assemblée Générale a choisit comme scrutateur M 

e

 Charles DURO, avocat, demeurant professionnellement à 3,

rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Le président a prié le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cent mille (100.000) actions, représentant l'intégralité du capital social de

la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'Assemblée Générale était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la devise du capital social de la Société, de Euro en Dollar américain, avec effet au 1 

er

 octobre 2008;

2. Réduction du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de quarante-deux mille neuf cent vingt

et un Dollars américains (USD 42.921,-) pour le réduire de son montant actuel de cent quarante-deux mille neuf cent
vingt et un Dollars américains (USD 142.921) au montant de cent mille Dollars américains (USD 100.000,-) par diminution
de la valeur nominale de chaque action du montant de un Dollar américain et quarante-deux mille neuf cent vingt et un
cents (USD 1,42921-) au montant de un Dollar américain (USD 1,-), et par constitution d'une réserve spéciale destinée
à compenser les pertes au 30 septembre 2009;

3. Augmentation du capital social souscrit à concurrence d'un montant de 10 Dollars américains (USD 10,-) pour le

porter de son montant actuel de cent mille Dollars américains (USD 100.000) au montant de cent mille dix Dollars
américains (USD 100.010,-) par l'émission de dix (10) nouvelles actions, également réparties dans chaque Classe d'actions,
d'une valeur nominale de un Dollar américain (USD 1,-) et une prime d'émission de sept cent cinquante-quatre mille cinq
cent trente-deux Dollars américains et cinq cent soixante-huit cents (USD 754.532,568-) par action, ayant les mêmes
droits et obligations que les actions existantes;

4. Souscription par la société FLORAVELL INVESTMENTS Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant

son siège social à Tortola, P.O. Box 3175 Road Town, des dix (10) nouvelles actions et libération par un apport en nature
consistant en la conversion en capital d'une avance accordée à la société d'un montant total de sept millions cinq cent
quarante-cinq mille trois cent trente-cinq Dollars américains et soixante-huit cents (USD 7.545.335,68-);

5. Modification des droits attachés aux classes d'actions;
6. Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter les décisions prises;
7. Décision de remodeler les articles 16 et 17 des statuts;
8. Décision d'insérer dans les statuts un nouvel article 19;
9. Augmentation du nombre d'administrateurs de quatre (4) à cinq (5) membres;
10. Nomination de Mr Anthony John CARSON comme cinquième administrateur;

87818

11. Durée des mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes;
12. Divers;
Après avoir approuvé et délibéré ce qui précède, l'Assemblée Générale a, à l'unanimité, décidé ce qui suit:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale a décidé de modifier la devise du capital social souscrit de la Société, de Euro en Dollar américain,

avec effet au 1 

er

 octobre 2008, et de porter le capital souscrit à cent quarante-deux mille neuf cent vingt et un Dollars

américains (USD 142.921), consistant en cent mille (100.000) actions, chaque action ayant une valeur nominale de un
Dollar américain et quarante-deux mille neuf cent vingt et un cents (USD 1,42921-), par application du taux de conversion
entre USD et EUR au 1 

er

 octobre 2008 (1,42921).

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale a décidé de réduire le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant quarante-

deux mille neuf cent vingt et un Dollars américains (USD 42.921) pour le réduire de son montant actuel de cent quarante-
deux mille neuf cent vingt et un Dollars américains (USD 142.921) au montant de cent mille Dollars américains (USD
100.000,-) par diminution de la valeur nominale de chaque action du montant de un Dollar américain et quarante-deux
mille neuf cent vingt et un cents (USD 1,42921-) au montant de un Dollar américain (USD 1,-), et par constitution à
concurrence du montant de quarante-deux mille neuf cent vingt et un Dollars américains (USD 42.921) d'une réserve
spéciale qui pourra être utilisée uniquement aux fins de compenser des pertes résultant des états financiers au 30 sep-
tembre 2009.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de dix

Dollars américains (USD 10,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille Dollars américains (USD 100.000,-) au
montant de cent mille dix Dollars américains (USD 100.010,-) par l'émission de dix (10) actions, également réparties dans
chaque Classe d'actions, d'une valeur nominale de un Dollar américain (USD 1,-) avec une prime d'émission de sept cent
cinquante-quatre mille cinq cent trente-deux Dollars américains et cinq cent soixante-huit cents (USD 754.532,568-) par
action soit une prime d'émission totale de sept millions cinq cent quarante-cinq mille trois cent vingt-cinq Dollars amé-
ricains et soixante-huit cents (USD 7.545.325,68-), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Quatrième résolution

Les dix (10) nouvelles actions d'une valeur nominale de un Dollar américain (USD 1,-) chacune et la prime d'émission

totale de sept millions cinq cent quarante-cinq mille trois cent vingt-cinq Dollars américains et soixante huit cents (USD
7.545.325,68-) sont souscrites et entièrement libérées par la société FLORAVELL INVESTMENTS Ltd, une société de
droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town, par un apport en nature
consistant en la conversion en capital d'une avance accordée à la Société à hauteur de sept millions cinq cent quarante-
cinq mille trois cent trente-cinq Dollars américains et soixante-huit cents (USD 7.545.335,68-).

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la valeur de cet

apport en nature est établi par un rapport de la société Fiduciaire Joseph Treis Sàrl, Réviseur d'entreprises, ayant son
siège social à Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, dont les conclusions sont les suivantes:

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmentée de la prime d'émission."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée Générale a décidé de modifier les droits attachés aux classes d'actions et de refléter ces changements

par la modification des articles 5, 16 et 17 des statuts, et en insérant un nouvel article 19 dans les statuts.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts a été modifié et a dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Capital social.
"5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à cent mille dix Dollars américains (USD 100.010,-) divisé en:
- dix mille et une (10.001) actions de Classe A (Les "Actions de Classe A");
- dix mille et une (10.001) actions de Classe B (Les "Actions de Classe B");
- dix mille et une (10.001)) actions de Classe C (Les "Actions de Classe C");
- dix mille et une (10.001)) actions de Classe D (Les "Actions de Classe D");
- dix mille et une (10.001) actions de Classe E (Les "Actions de Classe E");
- dix mille et une (10.001) actions de Classe F (Les "Actions de Classe F");
- dix mille et une (10.001) actions de Classe G (Les "Actions de Classe G");

87819

- dix mille et une (10.001) actions de Classe H (Les "Actions de Classe H");
- dix mille et une (10.001) actions de Classe I (Les "Actions de Classe I");
- dix mille et une (10.001) actions de Classe J (Les "Actions de Classe J");
chaque action ayant une valeur nominale de un Dollar américain (USD 1,-), et des droits et obligations tels que prévus

par les Statuts.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires de la Société

adoptée de la manière requise pour la modification de ces Statuts.

5.3 Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation d'actions de la Société y compris par l'annulation

de l'entièreté d'une ou de plusieurs classe(s) d'actions de la Société par le rachat et l'annulation de toutes les actions de
la Société émises de cette/ces classe(s). En cas de rachats et d'annulations de classe d'actions, de telles annulations et
rachats d'actions seront faits dans l'ordre alphabétique inverse (commençant avec la classe J).

5.4 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe d'actions (dans l'ordre établi

à l'article 5.3), une telle classe d'actions donne droit à ses détenteurs au pro rata de leur détention dans cette classe, au
Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'assemblée générale
des actionnaires) et les détenteurs d'actions de la classe d' actions rachetée et annulée recevront de la Société un montant
égal à la Valeur d'Annulation par Action (tel que définie ci-après) pour chaque action de la classe concernée détenue par
eux et annulée.

5.4.1 La Valeur d'Annulation par Action sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre d'actions

émises dans la classe d'actions devant être rachetée et annulé.

5.4.2 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par l'administrateur ou le cas échéant le conseil

d'administration et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires sur la base de Comptes Intérimaires afférents. Le
Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la classe
concernée au moment de l'annulation de cette classe sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires
selon la procédure prévue pour une modification des Statuts à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne
soit jamais supérieur au Montant Disponible.

5.4.3 A compter du rachat et de l'annulation des actions de la classe concernée, la Valeur d'Annulation par Action sera

due et payable par la Société."

<i>Septième résolution

Conformément aux résolutions qui précèdent, les articles 16 et 17 des statuts ont été modifiés et ont dorénavant la

teneur suivante:

Art. 16. Distributions
16.1 Sur le bénéfice net de la Société, il sera affecté cinq pour cent (5%) sur le compte de réserve légale. Cette déduction

cesse d'être obligatoire au moment où cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis par la Société.

16.2 Le solde sera distribué aux actionnaires après décision de l'assemblée générale des actionnaires conformément

aux dispositions établies ci-après.

16.3 Les actionnaires peuvent décider de déclarer et de payer des dividendes intérimaires sur la base des comptes

sociaux préparés par l'administrateur ou le cas échéant le conseil d'administration, démontrant que suffisamment de fonds
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant devant être distribué ne pourra pas excéder les profits
réalisés depuis la fin de la dernière année comptable augmentés par les profits reportés et réserves distribuables, mais
diminué des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve légale, conformément avec les dispositions
établies ci-après.

16.4 Le compte prime d'émission, peut être distribué aux actionnaires par décision prise en assemblée générale des

actionnaires conformément aux dispositions établies ci-après. L'assemblée générale des actionnaires peut décider d'al-
louer tout montant du compte de prime d'émission au compte de réserve légale.

16.5 Les dividendes déclarés peuvent être payés en toutes devises choisies par l'administrateur ou le cas échéant le

conseil d'administration et pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par l'administrateur ou
le cas échéant le conseil d'administration. L'administrateur ou le cas échéant le conseil d'administration, peut prendre
une décision finale quant au cours de change applicable pour convertir les montants des dividendes en la devise de leur
paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans, ne pourra par la suite plus être réclamé
par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la société. Aucun intérêt ne sera payé sur
les dividendes déclarés et non réclamés, qui seront détenus par la Société pour le compte des détenteurs d'actions.

16.6 En cas de déclaration de dividende, le montant total distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de

la dernière classe dans l'ordre alphabétique inversé (i.e en premier les Actions de Classe J, puis si aucune Action de Classe
J existe, les Actions de Classe I, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des Actions de Classe A existantes."

Art. 17. Dissolution, Liquidation
"17.1 Après paiement de toutes les dettes et de toutes les charges de la Société et des dépenses de liquidation, les

produits nets de la liquidation seront distribués aux actionnaires en conformité avec et en vue de parvenir sur une base

87820

globale au même résultat économique que suite à l'application des règles de distribution existantes pour les distributions
de dividendes.

<i>Huitième résolution

Conformément aux résolutions qui précèdent, un nouvel article 19 a été ajouté dans les statuts dont la teneur est la

suivante:

Art. 19. Définitions

Montant Disponible

signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés)
dans la mesure ou l'associé aura le droit à une distribution de dividendes en accord
avec l'article 16 des Statuts, augmenté par (i) toute prime d'émission librement
distribuable et autres réserves librement distribuables et (ii) le cas échéant par
le montant de la réduction de capital et la réduction de réserve légale relative
à la classe d'actions devant être annulée mais réduit par (i) toute perte (incluant
les pertes reportées) et (ii) toutes sommes qui devront être placées en réserve(s)
suivant les exigences de la loi ou des statuts déterminés sur base des Comptes
Intérimaires afférents (sans pour éviter tout doute, tout calcul en double) tel que:
MD = (PN + PE + RC) -(P + RL)
Pour lequel:
MD = Montant Disponible
PN = profits nets (incluant les profits reportés)
PE = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement
distribuables
RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve
légale en relation avec la classe d'actions devant être annulée
P = pertes (incluant les pertes reportées)
RL = sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi
ou des Statuts

Comptes Intérimaires

signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date Comptable Intérimaire
concernée.

Date Comptable Intérimaire

signifie la date ne pouvant être antérieure à huit (8) jours avant la date du rachat et
de l'annulation de la classe d'actions concernée

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le nombre d'administrateurs de quatre (4) à cinq (5) membres.

<i>Dixième résolution

L'Assemblée Générale a décidé de nommer administrateur de la Société Mr Anthony John CARSON, entrepreneur,

né à Belfast le 14 janvier 1956, demeurant à URB Marbella Club Golf Resort Casa Morisca, 7.9 Corona Borealis Benahavis
E-29679 SPAIN.

<i>Onzième résolution

L'Assemblée Générale a décidé de fixer la durée des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes à

un an (1) renouvelable.

En conséquence, les mandats des administrateurs existants et du commissaire aux comptes, ainsi que le mandat de Mr

Anthony John CARSON se termineront à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les
comptes 2009.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et qui parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes comparants
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé le présent acte.

Signé: M. Jan Arie DEKKER, Maggie KOHL-BIRGET, Charles DURO et Martine SCHAEFFER
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 août 2009 Relation: LAC/2009/34232 Reçu soixante-quinze euros Eur 75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

87821

Luxembourg, le 25 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009112915/426.
(090135616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Franklin Templeton Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.440.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009112986/12.
(090135589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Sodesoft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 29, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 84.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009112987/10.
(090135999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Sodesoft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 29, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 84.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009112985/10.
(090136000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 8 juillet 2009

L'Assemblée Générale a pris acte de la fin du mandat de la personne suivante avec effet immédiat:
- Bernard Gauthier, administrateur de société, demeurant au House 8/9, Silverstrand Garden, 11 Silverstrand Beach

Road, Clearwater Bay, Sai Kung, Hong Kong, en qualité d'administrateur.

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des personnes suivantes jusqu'à l'issue de l'Assemblée

Générale annuelle des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2009:

- Jean-François Ott, directeur de société, demeurant au 12, Rue Windsor, F-92200 Neuilly-Sur-Seine, en qualité d'ad-

ministrateur;

- Nicolas Tommasini, directeur de société, avec adresse professionnelle au 25, Rue Balzac, F-75406 Paris, en qualité

d'administrateur;

- Pierre Cornet, administrateur de société, demeurant au 6, Chemin des Ruettes, F-18110 Fussy, en qualité d'admi-

nistrateur;

- Silvano Pedretti, administrateur de société, demeurant au Nad Petruskou 8a, CZ-12000 Prague 2, en qualité d'ad-

ministrateur;

- Guy Wallier, banquier, demeurant au 192, Avenue Victor Hugo, F-75116 Paris, en qualité d'administrateur;

87822

- Ott &amp; Co. S.A., société anonyme, ayant son siège social au 38, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, inscrite

auprès du Registre du Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B 46918, représentée par son repré-
sentant légal Jean-François Ott, avec adresse professionnelle au 25, Rue Balzac, F-75406 Paris, en qualité d'administrateur;

- Central European Real Estate Management S.A., société anonyme, ayant son siège social au 40, Parc d'Activités

Capellen, L-8308 Capellen, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B
101753, représentée par son représentant légal Jean-François Ott, avec adresse professionnelle au 25, Rue Balzac, F-75406
Paris, en qualité d'administrateur.

L'Assemblée Générale a décidé de nommer les personnes suivantes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle

des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2009:

- Ales Vobruba, directeur d'Orco République Tchèque et d'Orco Slovakia, avec adresse professionnelle au Premys-

lovska 2845/43, CZ-13000 Prague, en qualité d'administrateur;

- Bernard Kleiner, expert comptable, demeurant au 36, Rue du Président Wilson, F-92300 Levallois Perret, en qualité

d'administrateur;

- Alexis Juan, banquier, demeurant au 201, Rue de Grenelle, F-75007 Paris, en qualité d'administrateur;
- Robert Coucke, promoteur immobilier, demeurant au 64, Rue de Billancourt, F-92100 Boulogne Billancourt, en

qualité d'administrateur;

- SPMB a.s., société de droit tchèque, ayant son siège social au Ripska 1142/20, CZ-62700 Brno, inscrite auprès du

tribunal de commerce de Brno sous le numéro IC 46347178, représentée par son représentant légal Mme Eva Janecková,
résidante à Havírov - Podlesí, Studentská 1558/7, 736 01 The Czech Republic en qualité d'administrateur;

- Prosperita investicni spolecnost a.s., société de droit tchèque, ayant son siège social au U Centrumu 751, CZ-73514

Orlova Lutyne, inscrite auprès du tribunal de commerce de Ostrava sous le numéro IC 26857791, représentée par son
représentant légal M. Miroslav Kurka, résidant à Praha 4, Lhotka, Mirotickâ 956/11, 140 00 The Czech Republic en qualité
d'administrateur;

- Geofin a.s., société de droit tchèque, ayant son siège social au Velka 2984/23, CZ-70200 Ostrava, inscrite auprès du

tribunal de commerce de Ostrava sous le numéro IC 25342533, représentée par son représentant légal Mr. Daniel Barc,
résidant à Velka 2984/23, Ostrava -Moravska Ostrava, 702 00, Czech Republic en qualité d'administrateur;

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des réviseurs d'entreprises suivants jusqu'à l'issue de l'As-

semblée Générale annuelle des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2009:

<i>Pour les comptes sociaux:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., société ayant siège au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite auprès du

Registre du Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B 65477;

- HRT Révision S.A., société ayant siège au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Com-

merce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B 51238.

<i>Pour les comptes consolidés:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., société ayant siège au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite auprès du

Registre du Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B 65477;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 28 août 2009.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009113528/62.
(090136245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Jaguar Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 293, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 12.727.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 mai 2009

<i>3 

<i>e

<i> Résolution

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué, à savoir:
- Monsieur Willy VAN GORP, administrateur de sociétés, demeurant à B-3060 Bertem, Bosstraat 127, administrateur

et président du conseil d'administration;

- Monsieur Jean-Louis RIGAUX, directeur général, demeurant à L-8147 Bridel, 11, rue des Prés, administrateur et

administrateur délégué;

- Monsieur Pierre HENRIET, administration &amp; finance manager, demeurant à L-1459 Luxembourg, 4, ancienne Côte

d'Eich, administrateur;

87823

- Monsieur Giovanni ROSSI, directeur commercial, demeurant à L-8211 Mamer, 87, route d'Arlon, administrateur.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.
L'assemblée décide de renouveler, à la fonction de réviseur d'entreprises et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra

en 2010:

- La société HRT Révision S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/08/2009.

<i>Pour FIDALUX S.A.
THILLENS Romain / BLONDEAU Christophe
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009113434/26.
(090136407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

T.W. Logistics S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-6917 Roodt-sur-Syre, 39, Op der Haard.

R.C.S. Luxembourg B 94.662.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 août 2009

L'an deux mil neuf, le vingt et un août à onze heures, au siège social de la société s'est tenue l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires.

<i>Bureau

L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier t'KINT. Le président a désigné comme secrétaire Madame Carine RAES.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Georges RECULE.

<i>Composition de l'assemblée

Monsieur le président déclare qu'en accord avec la liste de présence ci-annexée, la totalité des 1.000 actions est

présente ou représentée, l'assemblée peut donc valablement discuter et décider les points figurant à l'ordre du jour ci-
après reproduit, aucun quorum de présence n'étant requis par la loi. Les procurations des actionnaires représentés
resteront annexées au présent procès-verbal.

<i>Expose du président

Monsieur le président expose que:
1. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Renouvellement pour une durée de 6 ans prenant fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015

des mandats suivants:

<i>- Administrateur de Classe A:

Monsieur Didier t'Kint, ingénieur commercial, résidant professionnellement à L-6917, Roodt-Syre, 39 Op de Haard,

<i>- Administrateur de Classe B:

la société BUREAU FOR FOREIGN ECONOMIC DEVELOPMENT S.A., 39 Op der Haard, L-6917, Roodt-Syre, vala-

blement représentée par son administrateur délégué, Monsieur Didier t'Kint,

<i>- Administrateur de Classe B:

Monsieur Georges Recule, domicilié professionnellement 11, rue des Tondeurs, L-9570, Wiltz,
- à la fonction de commissaire aux comptes, M. André Lefèbvre, Expert Comptable, domicilié professionnellement 52,

rue des Charretiers, L-9514, Wiltz.

2. Divers.
II. L'intégralité du capital étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés ayant par ailleurs déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable, ainsi que du bilan, du compte de profits et pertes et du rapport du commissaire aux comptes.
Les actionnaires déclarent renoncer à toute convocation.

III. Chaque action du capital donne droit à une voix.
Après délibération, l'assemblée générale prend à l'unanimité des voix las résolutionas suivanteas:

87824

<i>Première résolution

Les mandats suivants sont renouvelés pour une durée de 6 ans prenant fin à l'assemblée générale des actionnaires qui

se tiendra en 2015:

<i>- Administrateur de Classe A:

Monsieur Didier t'Kint, ingénieur commercial, résidant professionnellement à L-6917, Roodt-Syre, 39 Op de Haard,

<i>- Administrateur de Classe B:

la société BUREAU FOR FOREIGN ECONOMIC DEVELOPMENT S.A., 39 Op der Haard, L-6917, Roodt-Syre, vala-

blement représentée par son administrateur délégué, Monsieur Didier t'Kint,

<i>- Administrateur de Classe B:

Monsieur Georges Recule, domicilié professionnellement 11, rue des Tondeurs, L-9570, Wiltz,
- à la fonction de commissaire aux comptes, M. André Lefèbvre, Expert Comptable, domicilié professionnellement 52,

rue des Charretiers, L-9514, Wiltz.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucun actionnaire n'ayant demandé la parole, le président lève la séance à onze

heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, aux heures et jour indiqués ci-dessus.

Didier t'KINT / Carine RAES / Georges RECULE
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2009113431/57.
(090136266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

European Office Income Venture, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.347.

EXTRAIT

Les actionnaires de European Office Income Venture (la «Société») ont décidé lors de l'assemblée générale ordinaire

qui s'est tenue à Luxembourg le 10 juin 2009:

1. de renouveler le mandat de membre du conseil de surveillance jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2010, de:

- Mr. Laurent Liot, domicilié professionnellement au Coeur Défense, 100, Esplanade du Général de Gaulle, F-92932

Paris, France; et de

-  Mr.  Guillaume  Spinner,  domicilié  professionnellement  au  Coeur  Défense,  100,  Esplanade  du  Général  de  Gaulle,

F-92932 Paris, France,

2. de nommer Mr. Richard Pinnock, né le 27 décembre 1959 à Enfield (Royaume-Uni), et domicilié professionnellement

au 7 Newgate Street, Londres EC1A 1NX, Royaume-Uni, en qualité de membre du conseil de surveillance de la Société
jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

3. de renouveler le mandat de Ernst &amp; Young SA, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

(Grand-Duché de Luxembourg) en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour European Office Income Venture
Signature

Référence de publication: 2009113205/25.
(090135712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Tetris SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 97.909.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Contern le 8 juillet 2008, que la personne

suivante a été nommée administrateur de la société avec effet au 8 juillet 2008 pour une durée de 6 ans:

- Monsieur Boris Peter Kröner, né le 11 juin 1968 à Trèves (Allemagne), ayant son adresse professionnelle à rue des

Chaux, L-5324 Contern (Luxembourg).

87825

Contern, le 13 juillet 2009.

<i>Pour la société TETRIS S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009113228/15.
(090135976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Mouseltrans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, Op Ahlkerrech.

R.C.S. Luxembourg B 142.836.

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und

beschließen folgendes:

Die Gesellschaftsanteile werden mit Wirkung zum 01.07.2009 wie folgt verteilt:

Frau Monika Schneeweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Anteile

Herr Ernst August Luy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 Anteile

Frau Marisa Zepfel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 Anteile

Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Anteile

Grevenmacher, den 26.06.2009.

Monika Schneeweis / Ernst August Luy / Marisa Zepfel.

Référence de publication: 2009113220/15.
(090135884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Tetris SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 97.909.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Contern le 12 mai 2009, que les mandats des

administrateurs suivants étant venus à échéance ont été reconduits pour la durée de 6 ans:

- Madame Eva Kremer, ayant son adresse professionnelle à 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg
- Monsieur Robert Dennewald, ayant son adresse professionnelle à rue des Chaux, L-5324 Contern
- Monsieur Daniel Gheza, ayant son adresse professionnelle à 24, rue Robert Krieps, L-4702 Pétange
- Monsieur Arthur Weis, ayant son adresse professionnelle à rue des Chaux, L-5324 Contern
Il résulte également de ce procès-verbal que la personne morale suivante a été nommée administrateur pour la durée

de 6 ans:

- CD-PME, ayant son siège social à 7, rue du Saint-Esprit, Luxembourg, représentée par Mme Eva Kremer, ayant son

adresse professionnelle à 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg.

La personne suivante a été nommée commissaire de la société avec effet au 12 mai 2009 et ce jusqu'à l'assemblée

générale annuelle statuant sur l'exercice social se terminant au 31 décembre 2009:

- Madame Gaby Kimmel, demeurant professionnellement à Rue des Chaux, L-5324 Contern.

Contern, le 13 juillet 2009.

<i>Pour la société TETRIS S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009113229/24.
(090135976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Sogaris Logistics Estates International Luxembourg, Société Anonyme.

Capital social: EUR 5.000.000,00.

Siège social: L-3487 Dudelange, route de Hellange.

R.C.S. Luxembourg B 146.829.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2009

L'an 2009, le huit juillet à 14.00 heures, s'est tenue à Luxembourg-Ville, une Assemblée Générale Ordinaire (ci-après

«l'Assemblée») de la société Sogaris Logistics Estates International Luxembourg S.A. (S.O.L.E.I.L.), société anonyme de
droit luxembourgeois au capital social de 5.000.000 euros dont le siège social est sis Eurohub Sud (Site WSA - Krakelshaff),
route de Hellange, L-3487 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS B 146829.

87826

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Louis FOESSEL, Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Patrick NICKELS représentant Jeannot KRECKE, Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, lui-

même représentant l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg est appelé comme scrutateur.

Madame Marie-Hélène VERDIER est désignée comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les actionnaires sont

présents ou représentés.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

<i>Deuxième résolution - Nomination du réviseur d'entreprise

L'Assemblée, après avoir examiné les propositions reçues pour la nomination d'un réviseur d'entreprise, décide de

nommer sur les recommandations du Conseil d'Administration, la société KPMG Audit S.à r.l., sis au 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme réviseur d'entreprise de S.O.L.E.I.L. pour une durée de 3
exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires.

Pour extrait certifié conforme
Jean-Louis FOESSEL / Patrick NICKELS
<i>Président / Vice-Président

Référence de publication: 2009113217/30.
(090135834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Power Group Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 40.089.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21.08.2009

Auszug  für  die  Hinterlegung  beim  Amtsgericht  Luxemburg  und  zur  Veröffentlichung  im  Mémorial,  Amtsblatt  des

Grossherzogtums Luxemburg:

1. Herr Romain Schumacher, mit Berufsanschrift in L-2561 Luxemburg, 51, rue de Strasbourg, wurde von seinem Amt

als Verwaltungsrat der Gesellschaft abberufen.

2. Frau Anne Huberland, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, wurde zum neuen Mitglied des

Verwaltungsrates ernannt.

3. Die Gesellschaft Eurocomptes S.A., mit Sitz in L-2561 Luxemburg, 51, rue de Strasbourg, wurde von ihrem Amt als

Abschlussprüfer der Gesellschaft abberufen.

4. Die Gesellschaft European Consultants (Luxembourg) S.A., mit Sitz in L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, wurde

zum neuen Abschlussprüfer ernannt

5. Die Mandate von Frau Anne Huberland und European Consultants (Luxembourg) S.A. enden anlässlich der jährlichen

Hauptversammlung des Jahres 2012.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, 21.08.2009.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

Référence de publication: 2009113182/24.
(090136022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Morgane Green Energy Development, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 141.224.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme MORGANE GREEN ENERGY

DEVELOPMENT qui s'est tenue en date du 21 août 2009 que:

L'Assemblée Générale accepte la démission de Mademoiselle Nadine HIRTZ en tant qu'administrateur de la société

avec effet à ce jour.

87827

Luxembourg, le 21 août 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2009113185/16.
(090136024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

KD Properties Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 120.156.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 6 février 2009 sous seing privé que:
Mr. Wolfgang Barg, né le 26 septembre 1950 à Mühlheim-Rhur (Allemagne), demeurant au Düppelstr. 26, D-24105

Kiel (Allemagne) a cédé l'intégralité des 30 parts sociales qu'il détenait dans le capital social de la société à Babcock &amp;
Brown European Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

Suite à ce transfert, l'actionnariat de la société est composé comme suit:

Babcock &amp; Brown Retail Portfolio 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

470 parts sociales

Babcock &amp; Brown European Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts sociales

En date du 28 août 2009, les associés ont pris par voie circulaire les résolutions suivantes:
- la démission de M. Wolfgang Barg en date du 27 août 2009 en tant que gérant unique de la société est acceptée,
- M. Mark Hatherly, né le 13 novembre 1965 à Auckland (Nouvelle-Zélande), domicilié professionnellement au 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg est nommé gérant unique de la société pour un mandat d'une durée indétermi-
née,

- le siège social de la société est transféré du 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg au 12, rue Guillaume

Schneider, L-2522 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009113184/29.
(090136003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Fondation Pierre Werner, Fondation.

Siège social: L-2728 Luxembourg, 4, rue Jules Wilhelm.

R.C.S. Luxembourg G 138.

<i>Conseil d'administration:

Mme Marie-Anne Werner, directeur honoraire, demeurant à Luxembourg;
M. Charles Werner, ingénieur e.r., demeurant à Luxembourg;
M. Romain Bausch, directeur général de la Société Européenne des Satellites, demeurant à Mamer;
M. le Ministre Luc Frieden, ministre du Trésor et du Budget, demeurant à Contern;
M. Raymond Kirsch, président du Conseil de gouvernance de l'Université du Luxembourg, demeurant à Steinsel;
M. Romain Kirt, conseiller de gouvernement, demeurant à Esch-sur-Alzette;
M. Guy de Muyser, maréchal de la Cour honoraire, demeurant à Luxembourg;
M. Charles Ruppert, administrateur de sociétés, demeurant à Niederdonven;
M. Jacques Santer, ministre d'Etat honoraire, demeurant à Luxembourg;
M. le Ministre Nicolas Schmit, ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'immigration, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg;

M. Pierre Wurth, ambassadeur honoraire, demeurant à Luxembourg

87828

<i>Siège social:

Centre d'Etudes et de Recherches Européennes Robert Schuman - 4, rue Jules Wilhelm - L-2728 Luxembourg

<i>Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2007 approuvés par le Conseil d'administration du 30 juin 2008

<i>Rapport de mission de compilation

Sur la base des informations fournies par les administrateurs, nous avons préparé les états financiers ci-joints de la

Fondation Pierre Werner pour l'exercice clos au 31 décembre 2007.

La préparation de ces états financiers a été effectuée selon la norme internationale de révision relative aux missions

de compilation d'informations financières, c'est-à-dire selon les mêmes usances que celles appliquées lors de l'établisse-
ment des comptes et des états financiers relatifs aux exercices de 1994 à 2006.

Les administrateurs restent responsables de ces états financiers qui n'ont fait l'objet ni d'une révision, ni d'un examen

limité de notre part. Nous ne donnons, par conséquent, aucune assurance sur ces derniers.

Ce rapport et les états financiers ci-joints ont été préparés pour votre usage personnel. Les informations compilées

sont destinées à être communiquées au Ministre de la Justice et publiées au Mémorial. Ce rapport et les états financiers
ci-joints ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ni diffusés à d'autres parties sans notre accord préalable.

Howald, le 30 juin 2008.

NEOGEST S.A.
Géraldine WEBER
<i>Administrateur déléguée

<i>Etat des produits et charges pour l'exercice clos le 31 décembre 2007

<i>(EXPRIME EN EUROS)

2007

2006

PRODUITS
Intérêts provenant du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14'650.59

10'054.04

CHARGES
Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(158.95)

(164.16)

Augmentation de l'actif net pour l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14'491.64

9'889.88

2007

2006

ACTIF CIRCULANT
Valeurs mobilières de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71'322.98

71'322.98

Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

322'004.37

307'812.73

ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393'327.35

379'135.71

<i>Annexe des états financiers au 31 décembre 2007

1. Constitution et objectifs
La Fondation Pierre Werner a été constituée à Luxembourg le 22 décembre 1993 sous la forme d'un établissement

d'utilité publique régi par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée.

La Fondation a pour objet de promouvoir et de pérenniser l'oeuvre de l'homme d'Etat luxembourgeois Pierre Werner.

La Fondation peut notamment soutenir tous projets de recherche, d'études, de conférences, de séminaires ayant trait à
l'unification européenne, aux problèmes monétaires, à la démocratie ou aux droits de l'homme dans tous les pays du
continent européen.

2. Principes comptables
2.1 Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées quand elles sont reçues.
2.2 Les produits d'intérêts sont comptabilisés à mesure qu'ils sont échus.
2.3 Les états financiers sont établis en euros et les livres comptables sont tenus dans cette devise.
Référence de publication: 2009112739/63.
(090135185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Immobilière des Trois Ponts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 89, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 53.334.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

87829

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009112736/10.
(090135782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Fondation Pierre Werner, Fondation.

Siège social: L-2728 Luxembourg, 4, rue Jules Wilhelm.

R.C.S. Luxembourg G 138.

<i>Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 1999 approuvés par le Conseil d'administration du 30 juin 2008

<i>Rapport de mission de compilation

Sur la base des informations fournies par les administrateurs, nous avons préparé les états financiers ci-joints de la

Fondation Pierre Werner pour l'exercice clos au 31 décembre 1999.

La préparation de ces états financiers a été effectuée selon la norme internationale de révision relative aux missions

de compilation d'informations financières, c'est-à-dire selon les mêmes usances que celles appliquées lors de l'établisse-
ment des comptes et des états financiers relatifs aux exercices de 1994 à 1998.

Les administrateurs restent responsables de ces états financiers qui n'ont fait l'objet ni d'une révision, ni d'un examen

limité de notre part. Nous ne donnons, par conséquent, aucune assurance sur ces derniers.

Ce rapport et les états financiers ci-joints ont été préparés pour votre usage personnel. Les informations compilées

sont destinées à être communiquées au Ministre de la Justice et publiées au Mémorial. Ce rapport et les états financiers
ci-joints ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ni diffusés à d'autres parties sans notre accord préalable.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

NEOGEST S.A.
Géraldine WEBER
<i>Administrateur délégué

<i>Etat des produits et charges pour l'exercice clos le 31 décembre 1999 (exprime en francs luxembourgeois)

1999

1998

PRODUITS
Intérêts provenant du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204 603.00

319 725.00

CHARGES
Frais publication Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(19 432.00)

Conférence organisée par la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 647 525.00)

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(50.00)

Augmentation de l'actif net pour l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185 171.00

(1 327 850.00)

1999

1998

ACTIF CIRCULANT
Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 225 715,00

12 040 544.00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Conférence à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(647 525.00)

ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 225 715.00

11 393 019.00

<i>Annexe des états financiers au 31 décembre 1999

1. Constitution et objectifs
La Fondation Pierre Werner a été constituée à Luxembourg le 22 décembre 1993 sous la forme d'un établissement

d'utilité publique régi par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée.

La Fondation a pour objet de promouvoir et de pérenniser l'oeuvre de l'homme d'Etat luxembourgeois Pierre Werner.

La Fondation peut notamment soutenir tous projets de recherche, d'études, de conférences, de séminaires ayant trait à
l'unification européenne, aux problèmes monétaires, à la démocratie ou aux droits de l'homme dans tous les pays du
continent européen.

2. Principes comptables
2.1 Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées quand elles sont reçues.
2.2 Les produits d'intérêts sont comptabilisés à mesure qu'ils sont échus.
2.3 Les états financiers sont établis en francs luxembourgeois et les livres comptables sont tenus dans cette devise.
Référence de publication: 2009112737/50.
(090135159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

87830

Fondation Pierre Werner, Fondation.

Siège social: L-2728 Luxembourg, 4, rue Jules Wilhelm.

R.C.S. Luxembourg G 138.

<i>Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2000 approuvés par le Conseil d'administration du 30 juin 2008

<i>Rapport de mission de compilation

Sur la base des informations fournies par les administrateurs, nous avons préparé les états financiers ci-joints de la

Fondation Pierre Werner pour l'exercice clos au 31 décembre 2000.

La préparation de ces états financiers a été effectuée selon la norme internationale de révision relative aux missions

de compilation d'informations financières, c'est-à-dire selon les mêmes usances que celles appliquées lors de l'établisse-
ment des comptes et des états financiers relatifs aux exercices de 1994 à 1999.

Les administrateurs restent responsables de ces états financiers qui n'ont fait l'objet ni d'une révision, ni d'un examen

limité de notre part. Nous ne donnons, par conséquent, aucune assurance sur ces derniers.

Ce rapport et les états financiers ci-joints ont été préparés pour votre usage personnel. Les informations compilées

sont destinées à être communiquées au Ministre de la Justice et publiées au Mémorial. Ce rapport et les états financiers
ci-joints ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ni diffusés à d'autres parties sans notre accord préalable.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

NEOGEST S.A.
Géraldine WEBER
<i>Administrateur délégué

<i>Etat des produits et charges pour l'exercice clos le 31 décembre 2000 (exprime en francs luxembourgeois)

2000

1999

PRODUITS
Intérêts provenant du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 199.00

204 603.00

CHARGES
Frais publication Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(19 432.00)

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12 852,00)

Augmentation de l'actif net pour l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 347.00

185 171.00

2000

1999

ACTIF CIRCULANT
Valeurs mobilières de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 537 758.00

Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

722 304.00

12 225 715,00

ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 260 062.00

12 225 715.00

<i>Annexe des états financiers au 31 décembre 2000

1. Constitution et objectifs
La Fondation Pierre Werner a été constituée à Luxembourg le 22 décembre 1993 sous la forme d'un établissement

d'utilité publique régi par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée.

La Fondation a pour objet de promouvoir et de pérenniser l'oeuvre de l'homme d'Etat luxembourgeois Pierre Werner.

La Fondation peut notamment soutenir tous projets de recherche, d'études, de conférences, de séminaires ayant trait à
l'unification européenne, aux problèmes monétaires, à la démocratie ou aux droits de l'homme dans tous les pays du
continent européen.

2. Principes comptables
2.1 Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées quand elles sont reçues.
2.2 Les produits d'intérêts sont comptabilisés à mesure qu'ils sont échus.
2.3 Les états financiers sont établis en francs luxembourgeois et les livres comptables sont tenus dans cette devise.
Référence de publication: 2009112735/48.
(090135162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Immobilière des Trois Ponts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 89, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 53.334.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

87831

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009112744/10.
(090135775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Immobilière des Trois Ponts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 89, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 53.334.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009112740/10.
(090135779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Fondation Pierre Werner, Fondation.

Siège social: L-2728 Luxembourg, 4, rue Jules Wilhelm.

R.C.S. Luxembourg G 138.

<i>Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 approuvés par le Conseil d'administration du 30 juin 2008

<i>Rapport de mission de compilation

Sur la base des informations fournies par les administrateurs, nous avons préparé les états financiers ci-joints de la

Fondation Pierre Werner pour l'exercice clos au 31 décembre 2006.

La préparation de ces états financiers a été effectuée selon la norme internationale de révision relative aux missions

de compilation d'informations financières, c'est-à-dire selon les mêmes usances que celles appliquées lors de l'établisse-
ment des comptes et des états financiers relatifs aux exercices de 1994 à 2005.

Les administrateurs restent responsables de ces états financiers qui n'ont fait l'objet ni d'une révision, ni d'un examen

limité de notre part. Nous ne donnons, par conséquent, aucune assurance sur ces derniers.

Ce rapport et les états financiers ci-joints ont été préparés pour votre usage personnel. Les informations compilées

sont destinées à être communiquées au Ministre de la Justice et publiées au Mémorial. Ce rapport et les états financiers
ci-joints ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ni diffusés à d'autres parties sans notre accord préalable.

Howald, le 30 juin 2008.

NEOGEST S.A.
Géraldine WEBER
<i>Administrateur délégué

<i>Etat des produits et charges pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 (exprimé en euros)

2006

2005

PRODUITS
Intérêts provenant du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10'054.04

11 685.65

CHARGES
Corrections de valeur sur titres remboursés à l'échéance . . . . . . . . . . . . . .

(912.33)

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(164.16)

(235.28)

Augmentation de l'actif net pour l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9'889.88

10 538.04

2006

2005

ACTIF CIRCULANT
Valeurs mobilières de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71'322.98

71 322.98

Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307'812.73

297 922.85

ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

379'135.71

369 245.83

<i>Annexe des états financiers au 31 décembre 2006

1. Constitution et objectifs
La Fondation Pierre Werner a été constituée à Luxembourg le 22 décembre 1993 sous la forme d'un établissement

d'utilité publique régi par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée.

La Fondation a pour objet de promouvoir et de pérenniser l'oeuvre de l'homme d'Etat luxembourgeois Pierre Werner.

La Fondation peut notamment soutenir tous projets de recherche, d'études, de conférences, de séminaires ayant trait à

87832

l'unification européenne, aux problèmes monétaires, à la démocratie ou aux droits de l'homme dans tous les pays du
continent européen.

2. Principes comptables
2.1 Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées quand elles sont reçues.
2.2 Les produits d'intérêts sont comptabilisés à mesure qu'ils sont échus.
2.3 Les états financiers sont établis en euros et les livres comptables sont tenus dans cette devise.
Référence de publication: 2009112728/48.
(090135183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Fondation Pierre Werner, Fondation.

Siège social: L-2728 Luxembourg, 4, rue Jules Wilhelm.

R.C.S. Luxembourg G 138.

<i>Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 approuvés par le Conseil d'administration du 30 juin 2008

<i>Rapport de mission de compilation

Sur la base des informations fournies par les administrateurs, nous avons préparé les états financiers ci-joints de la

Fondation Pierre Werner pour l'exercice clos au 31 décembre 2004.

La préparation de ces états financiers a été effectuée selon la norme internationale de révision relative aux missions

de compilation d'informations financières, c'est-à-dire selon les mêmes usances que celles appliquées lors de l'établisse-
ment des comptes et des états financiers relatifs aux exercices de 1994 à 2003.

Les administrateurs restent responsables de ces états financiers qui n'ont fait l'objet ni d'une révision, ni d'un examen

limité de notre part. Nous ne donnons, par conséquent, aucune assurance sur ces derniers.

Ce rapport et les états financiers ci-joints ont été préparés pour votre usage personnel. Les informations compilées

sont destinées à être communiquées au Ministre de la Justice et publiées au Mémorial. Ce rapport et les états financiers
ci-joints ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ni diffusés à d'autres parties sans notre accord préalable.

Howald, le 30 juin 2008.

NEOGEST S.A.
Géraldine WEBER
<i>Administrateur délégué

<i>Etat des produits et charges pour l'exercice clos le 31 décembre 2004

<i>(EXPRIME EN EUROS)

2004

2003

PRODUITS
Intérêts provenant du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 280,34

21 189,61

CHARGES
Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(330,40)

(331,36)

Augmentation de l'actif net pour l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 949,94

20 858,25

2004

2003

ACTIF CIRCULANT
Valeurs mobilières de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142 235,31

142 235,31

Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216 472,48

205 522,54

ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358 707,79

347 757,85

<i>Annexe des états financiers au 31 décembre 2004

1. Constitution et objectifs
La Fondation Pierre Werner a été constituée à Luxembourg le 22 décembre 1993 sous la forme d'un établissement

d'utilité publique régi par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée.

La Fondation a pour objet de promouvoir et de pérenniser l'œuvre de l'homme d'Etat luxembourgeois Pierre Werner.

La Fondation peut notamment soutenir tous projets de recherche, d'études, de conférences, de séminaires ayant trait à
l'unification européenne, aux problèmes monétaires, à la démocratie ou aux droits de l'homme dans tous les pays du
continent européen.

2. Principes comptables
2.1 Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées quand elles sont reçues.
2.2 Les produits d'intérêts sont comptabilisés à mesure qu'ils sont échus.

87833

2.3 Les états financiers sont établis en euros et les livres comptables sont tenus dans cette devise.
Référence de publication: 2009112724/48.
(090135173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Hermes Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 114.409.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009112727/10.
(090135765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2009.

Fondation Pierre Werner, Fondation.

Siège social: L-2728 Luxembourg, 4, rue Jules Wilhelm.

R.C.S. Luxembourg G 138.

<i>Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 approuvés par le Conseil d'administration du 30 juin 2008

<i>Rapport de mission de compilation

Sur la base des informations fournies par les administrateurs, nous avons préparé les états financiers ci-joints de la

Fondation Pierre Werner pour l'exercice clos au 31 décembre 2003.

La préparation de ces états financiers a été effectuée selon la norme internationale de révision relative aux missions

de compilation d'informations financières, c'est-à-dire selon les mêmes usances que celles appliquées lors de l'établisse-
ment des comptes et des états financiers relatifs aux exercices de 1994 à 2002.

Les administrateurs restent responsables de ces états financiers qui n'ont fait l'objet ni d'une révision, ni d'un examen

limité de notre part. Nous ne donnons, par conséquent, aucune assurance sur ces derniers.

Ce rapport et les états financiers ci-joints ont été préparés pour votre usage personnel. Les informations compilées

sont destinées à être communiquées au Ministre de la Justice et publiées au Mémorial. Ce rapport et les états financiers
ci-joints ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ni diffusés à d'autres parties sans notre accord préalable.

Howald, le 30 juin 2008.

NEOGEST S.A.
Géraldine WEBER
<i>Administrateur délégué

<i>Etat des produits et charges pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 (exprimé en euros)

2003

2002

PRODUITS
Intérêts provenant du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 189.61

10 549.49

CHARGES
Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(331.36)

(324.79)

Augmentation de l'actif net pour l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 858.25

10 224.70

2003

2002

ACTIF CIRCULANT
Valeurs mobilières de placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142 235.31

214 124.43

Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205 522.54

112 775.17

ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

347 757.85

326 899.60

<i>Annexe des états financiers au 31 décembre 2003

1. Constitution et objectifs
La Fondation Pierre Werner a été constituée à Luxembourg le 22 décembre 1993 sous la forme d'un établissement

d'utilité publique régi par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée.

La Fondation a pour objet de promouvoir et de pérenniser l'oeuvre de l'homme d'Etat luxembourgeois Pierre Werner.

La Fondation peut notamment soutenir tous projets de recherche, d'études, de conférences, de séminaires ayant trait à
l'unification européenne, aux problèmes monétaires, à la démocratie ou aux droits de l'homme dans tous les pays du
continent européen.

87834

2. Principes comptables
2.1 Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées quand elles sont reçues.
2.2 Les produits d'intérêts sont comptabilisés à mesure qu'ils sont échus.
2.3 Les états financiers sont établis en euros et les livres comptables sont tenus dans cette devise.
Référence de publication: 2009112729/47.
(090135170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Asian Capital Holdings Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 43.100.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 28 mai 2009

L'Assemblée Générale Ordinaire décide:
- de ratifier la cooptation de M. John Smeets en qualité d'administrateur pour une période prenant fin avec l'Assemblée

Générale Ordinaire tenue en 2009, sous condition du nihil obstat de la Commission de Surveillance du Secteur Financier
«CSSF», en remplacement de M. Pim Mol ayant démissionné le 8 août 2008.

- de renouveler, pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en

2010, du mandat des Administrateurs suivants:

* M. John Alexander
* M. Richard Katz
* M. Geoffroy Linard
* M. Dean Lush
* M. Marc Pereire
* M. Sylvain Roditi
* M. John Smeets
- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une période d'un an prenant

fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

<i>Président du Conseil d'Administration:

- Monsieur John ALEXANDER, LCF Edmond de Rothschild Asset Management LTD, Orion House, Upper St. Martin's

Lane, 5, WC2H 9EA LONDRES

<i>Administrateurs:

- Monsieur Richard KATZ, KEATS GROVE HAMPSTEAD, 1, NW3 2RT, LONDRES
- Monsieur Geoffroy LINARD, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Boulevard Emmanuel Servais, 20, L-2535

LUXEMBOURG

- Monsieur Dean LUSH, Rothschild Private Management LTD, King William Street, 1, EC4N 7AR LONDRES
- Monsieur Marc PEREIRE, Mirabaud Pereire Holdings LTD, St James Square, 21, SW1Y 4JP LONDRES
- Monsieur Sylvain RODITI, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Rue de Hesse, 18, CH-1211 GENEVE
- Monsieur John SMEETS, Prins Bernhardplein, 200, 1097 JB, AMSTERDAM

<i>Réviseur d'Entreprises:

DELOITTE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Nathalie SCHROEDER / Bénédicte LOMMEL
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Commercial

Référence de publication: 2009112764/43.
(090134931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

87835

Lab Document Vault PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 101.145.

EXTRAIT

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of Lab Document Vault PSF S.A. held on May 19 

<i>t

<i> 

<i>h

<i>2009.

The meeting reappoints the Directors for a new statutory term expiring at the date of the Annual General Meeting

to be held in 2010.

The present Directors are:
- Mr Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen
- Mr Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler
- Mrs Gillian Arcone, Director, residing in Munsbach
- Mr Mohamed Aïhi, Administrative Director, residing in Moutfort
- Mr Michel Maggi, Technical Director, residing in Moutfort
The meeting reappoints PKF ABAX Audit S.à.r.l. as "Réviseur d'entreprises", 7 rue Thomas Edison, L-1145 Luxembourg

Strassen for a new statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting to be held in 2010.

Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Lab Document Vault PSF S.A. qui s'est

<i>tenue le 19 Mai 2009.

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant à

la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Le conseil d'administration se compose de:
- Mr Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen
- Mr Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler
- Mme Gillian Arcone, Directeur, demeurant à Munsbach
- Mr Mohamed Aïhi, Directeur Administratif, demeurant à Moutfort
- Mr Michel Maggi, Directeur Technique, demeurant à Moutfort
L'assemblée décide de renommer aux fonctions de Réviseur d'entreprises PKF ABAX Audit S.à.r.l, 7 rue Thomas

Edison, L-1145 Luxembourg Strassen pour une nouvelle période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2010.

Certified true extract
Pour extrait conforme
Lab Document Vault PSF S.A.
Bernard Moreau / Patrick Lowe
<i>Administrateur délégué / Administrateur délégué

Référence de publication: 2009112766/38.
(090134944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Sainte-Maxime S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 144.014.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de Sainte-Maxime S.A.

L'actionnaire unique de la Société a accepté le 1 

er

 mai 2009 avec effet immédiat la démission de M. Georges Kohn,

demeurant professionnellement au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société.

L'actionnaire unique de la Société a nommé le 1 

er

 mai 2009 avec effet immédiat et pour une durée illimitée M. Carlo

Schneider, demeurant au 16, rue des Primevères, L-2351 Luxembourg en tant qu'administrateur de la Société.

87836

Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009112759/16.
(090135007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2009.

Preferred Retail S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.179.

In the year two thousand and nine, on the twelve of August.
Before the undersigned notary Maître Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting (the "Meeting") of the shareholders of the public limited liability company

(the "Company") PREFERRED RETAIL S.A., with registered office in L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, section B, under the number 121.179 (hereinafter
referred to as the "Company").

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Me Marc Lecuit, then notary residing in Redange-sur-

Attert, on the 17 

th

 of October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2365

of the 19 

th

 of December 2006, and whose articles of association have been amended pursuant to a deed of Me Jean

SECKLER on the 29 

th

 of June 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2017

dated on 18 

th

 September 2007, and have a last been amended pursuant to a deed of the undersigned Notary on 27 

th

March 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 900 dated on 28 April 2009.

The Meeting was opened with Mr Grégoire Chaste, lawyer, professionally residing in Luxembourg being in the chair.
The Chairman appoints as secretary Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo,

and the meeting elects as scrutineer, Mr Erwin Vande CRUYS, private employee, with same professional address.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. The Shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies signed by the appearing persons and the Notary, shall remain here annexed to be registered
with the Minutes.

II. As appears from the attendance list, the 37,953 (thirty-seven thousand nine hundred fifty-three) shares, representing

the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the Shareholders have been beforehand informed.

III. The Agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to reduce the share capital of the Company by an amount of seven hundred and fifty euro (EUR 750.-) in

order to reduce it from its current amount of forty-seven thousand four hundred forty euro and eighty cents euro (EUR
47,440.80.-) represented by thirty-seven thousand nine hundred fifty-three (37,953) shares with a nominal value of one
euro and twenty-five cents (EUR 1,25) each to an amount of forty-six thousand six hundred ninety euro and eighty cents
(EUR 46,690.80.-) represented by thirty-seven thousand three hundred fifty three (37,353) shares with a nominal value
of one euro and twenty-five cents (EUR 1,25) each.

Realisation of such a reduction by:
- The reimbursement to John Kehoe of an amount of three hundred twenty-five thousand and seven euro (EUR

325,007.-) and cancellation of one hundred ninety-five (195) existing A shares held by him;

- The reimbursement to Winfried Bottger of an amount of three hundred twenty-five thousand and seven euro (EUR

325,007.-) and cancellation of one hundred ninety-five (195) existing B shares held by him;

- The reimbursement to Iann Quinn of an amount of one hundred seventy-four thousand nine hundred ninety-three

euro (EUR 174,993.-) and cancellation of one hundred and five (105) existing C shares held by him;

- The reimbursement to Enda Quinn of an amount of one hundred seventy-four thousand nine hundred ninety-three

euro (EUR 174,993.-) and cancellation of one hundred and five (105) existing C shares held by him;

The reimbursement will be appropriated from share premium account of the Company.
The above capital reduction is subject to the provisions of article 69 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended.

Power to be granted to the board of managers to execute the conditions of reimbursement;
2. Cancellation of the shares' nominal value in the Company's Articles;

87837

3. Subsequent amendment of Article 5 of the Company's Articles of Association to reflect the capital reduction, the

cancellation of the shares' nominal value and give it the following wording:

Art. 5. The Company's capital is set at forty-six thousand six hundred ninety euro and eighty cents euro (EUR

46,690.80.-) represented by thirty-seven thousand three hundred fifty three (37,353) shares without nominal value";

4. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting

unanimously takes the following resolutions.

<i>First resolution

The meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of seven hundred and fifty euro (EUR

750.-) in order to reduce it from its current amount of forty-seven thousand four hundred forty euro and eighty cents
(EUR 47,440.80.-) represented by thirty-seven thousand nine hundred fifty-three (37,953) shares with a nominal value of
one euro and twenty-five cents (EUR 1,25) each to an amount of forty-six thousand six hundred ninety euro and eighty
cents (EUR 46,690.80.-) represented by thirty-seven thousand three hundred fifty-three (37,353) shares with a nominal
value of one euro and twenty-five cents (EUR 1,25) each.

Realisation of such a reduction by:
- The reimbursement to John KEHOE of an amount of three hundred twenty-five thousand and seven euro (EUR

325,007.-) and cancellation of one hundred ninety-five (195) existing A shares held by him;

- The reimbursement to Winfried Bottger of an amount of three hundred twenty-five thousand and seven euro (EUR

325,007.-) and cancellation of one hundred ninety-five (195) existing B shares held by him;

- The reimbursement to Iann QUINN of an amount of one hundred seventy-four thousand nine hundred ninety-three

euro (EUR 174,993.-) and cancellation of one hundred and five (105) existing C shares held by him;

- The reimbursement to Enda QUINN of an amount of one hundred seventy-four thousand nine hundred ninety-three

euro (EUR 174,993.-) and cancellation of one hundred and five (105) existing C shares held by him.

- The reimbursement will be appropriated from share premium account of the Company.
The above capital reduction is subject to the provisions of article 69 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended.

Power to be granted to the board of managers to execute the conditions of reimbursement.
The board of managers has confirmed the fair value of the shares by a resolution taken on 5 August 2009.

<i>Second resolution

The meeting resolves to cancel the nominal value of the shares in the Company Articles.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article 5, first paragraph, of the

articles of association that henceforth will be read as follows:

Art. 5. (First paragraph). The Company's capital is set at forty-six thousand six hundred ninety euro and eighty cents

(EUR 46,690.80.-) represented by thirty-seven thousand three hundred fifty-three (37,353) shares without nominal value."

<i>Costs &amp; Expenses

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its share capital reduction, have been estimated at about one thousand three hundred
euro (EUR 1,300.-).

There being no further business before the meeting, the latter was thereupon adjourned.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing persons,
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the proxy-holders of the appearing persons, who are known to the notary by their first

and last name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des obengenannten Textes

Im Jahre zweitausendundneun, am zwölften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") der Aktionäre der Aktiengesellschaft (die

"Aktiengesellschaft") PREFERRED RETAIL S.A., mit Sitz in L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, eingetragen

87838

im Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 121.179 (nachfolgend als die "Gesell-
schaft" bezeichnet) abgehalten.

Die Gesellschaft wurde durch notarielle Urkunde des Notars Maître Marc Lecuit, mit damaligem Amtssitz in Redange-

sur-Attert, am 17. Oktober 2006 gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter
der Nummer 2365 am 19. Dezember 2006 und die Satzung der Gesellschaft wurde letztmalig abgeändert durch notarielle
Urkunde des Notars Jean SECKLER am 29. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
unter der Nummer 2017 datiert auf den 18. September 2007. und wurde zuletzt abgeändert durch notarielle Urkunde
des unterzeichnenden Notars am 27. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter
der Nummer 900 datiert auf den 28. April 2009.

Die Hauptversammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Grégoire Chaste, Anwalt, beruflich ansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Frau Isabel DIAS, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-1750 Luxemburg,

74, avenue Victor Hugo,

und die Hauptversammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herr Erwin Vande CRUYS, mit gleicher beruflicher Anschrift.
Nachdem das Büro der Hauptversammlung bestimmt und durch den Vorsitzenden festgestellt ist, ersucht der Vor-

sitzende den Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die jeweilige Anzahl der von ihnen gehaltenen Namensaktien in

einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind. Diese Liste und Vollmachten unterschrieben von den anwesenden Personen und
von dem Notar, werden dieser Urkunde beigefügt und verbleiben bei dem Protokoll.

II. Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass alle 37,953 (siebenunddreißigtausendneunhundertdreiundfünfzig) Na-

mensaktien, das vollständige Gesellschaftskapital der Gesellschaft darstellend, vertreten sind, so dass die Hauptversamm-
lung über alle Punkte der Tagesordnung rechtsgültig entscheiden kann, über die die Aktionäre vor der Hauptversammlung
unterrichtet wurden.

VI. Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Entscheidung über die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von siebenhun-

dertfünfzig Euro (EUR 750.-), um es von dem bisherigen Betrag in Höhe von siebenundvierzigtausendvierhundertvierzig
Euro und achtzig Cent (EUR 47,440.80.-) eingeteilt in siebenunddreißigtausendneunhundert-dreiundfünfzig (37,953) Ak-
tien mit einem Nominalwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) je Aktie auf einen Betrag in Höhe von
sechsundvierzigtausendsechshundertneunzig Euro und achtzig Cent (EUR 46,690.80.-) eingeteilt in siebenunddreißigtau-
send-dreihundertdreiundfünfzig (37,353) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR
1,25) je Aktie.

Verwirklichung dieser Herabsetzung durch:
- Die Rückzahlung an John KEHOE eines Betrags in Höhe von dreihundertfünfundzwanzigtausendsieben Euro (EUR

325,007.-) und Streichung von einhundertfünfundneunzig (195) durch ihn gehaltene A Anteile;

- Die Rückzahlung an Winfried BOETTGER eines Betrags in Höhe von dreihundertfünfundzwanzigtausendsieben Euro

(EUR 325,007.-) and Streichung von einhundertfünfundneunzig (195) durch ihn gehaltene B Anteile;

- Die Rückzahlung an Iann QUINN eines Betrags in Höhe von einhundertvierundsiebzigtausendneunhundertdreiund-

neunzig Euro (EUR 174.993.-) und Streichung von einhundertfünf (105) durch ihn gehaltene C Anteile;

- Die Rückzahlung an Enda QUINN eines Betrags in Höhe von einhundertvierundsiebzigtausendneunhundertdreiund-

neunzig Euro (EUR 174.993.-) und Streichung von einhundertfünf (105) durch ihn gehaltene C Anteile.

- Die Rückzahlungen werden vom Konto der Aktienprämie der Gesellschaft getätigt.
- Die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft unterliegt Artikel 69 des geänderten Gesetzes vom 10.

August 1915 betreffend Gesellschaften.

Übertragung der Befugnisse zur Festlegung der Art und Weise der Rückzahlung auf den Geschäftsführerrat;
2. Streichung des Nominalwertes der Aktien in der Gesellschaftssatzung;
3. Anschließende Anpassung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung um die Kapitalherabsetzung und die Streichung

des Nominalwertes der Aktien wiederzugeben mit folgendem Wortlaut:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt sechsundvierzigtausend sechshundertneunzig Euro und achtzig Cent (EUR

46,690.80.-) eingeteilt in siebenunddreißigtausend dreihundertdreiundfünfzig (37,353) Aktien ohne Angabe eines Nomi-
nalwertes.";

4. Verschiedenes.
Nach Zustimmung der Berichte des Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Zusammensetzung, fasst die

Hauptversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Beschluss über die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von siebenhundertfünfzig

Euro (EUR 750.-) um es von dem bisherigen Betrag in Höhe von siebenundvierzigtausendvierhundertvierzig Euro und

87839

achtzig Cent (EUR 47,440.80), eingeteilt in siebenunddreißigtausend-neunhundertdreiundfünfzig (37,953) Aktien mit ei-
nem  Nominalwert  von  einem  Euro  und  fünfundzwanzig  Cent  (EUR  1,25)  je  Aktie  auf  einen  Betrag  in  Höhe  von
sechsundvierzigtausendsechshundertneunzig Euro und achtzig Cent (EUR 46,690.80.-) eingeteilt in siebenunddreißigtau-
senddreihundertdreiundfünfzig (37,353) Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR
1,25) je Aktie.

Verwirklichung dieser Herabsetzung durch:
- Die Rückzahlung an John KEHOE eines Betrags in Höhe von dreihundertfünfundzwanzigtausendsieben Euro (EUR

325,007.-) und Streichung von einhundertfünfundneunzig (195) durch ihn gehaltene A Anteile;

- Die Rückzahlung an Winfried BOETTGER eines Betrags in Höhe von dreihundertfünfundzwanzigtausendsieben Euro

(EUR 325,007.-) and Streichung von einhundertfünfundneunzig (195) durch ihn gehaltene B Anteile;

- Die Rückzahlung an Iann QUINN eines Betrags in Höhe von einhundertvierundsiebzigtausendneunhundertdreiund-

neunzig Euro (EUR 174.993.-) und Streichung von einhundertfünf (105) durch ihn gehaltener C Anteile;

- Die Rückzahlung an Enda QUINN eines Betrags in Höhe von einhundertvierundsiebzigtausendneunhundertdreiund-

neunzig Euro (EUR 174.993.-) und Streichung von einhundertfünf (105) durch ihn gehaltene C Anteile.

- Die Rückzahlungen werden vom Konto der Aktienprämie der Gesellschaft getätigt.
- Die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft unterliegt Artikel 69 des abgeänderten Gesetzes vom

10. August 1915 betreffend Gesellschaften.

Übertragung der Befugnisse auf den Geschäftsführerrat zur Festlegung der Art und Weise der Rückzahlung.
Der Geschäftsführerrat hat den Marktpreis der Aktien durch Beschluss vom 5. August 2009 bestätigt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Nominalwert der Aktien aus der Gesellschaftssatzung zu streichen.

<i>Dritter Beschluss

Als Folge der vorausgegangenen Feststellungen und Beschlüsse wird beschlossen, Absatz eins von Artikel 5 der Ge-

sellschaftssatzung anzupassen, so dass er folgenden Wortlaut haben wird:

Art. 5. (Absatz 1). Das Gesellschaftskapita! beträgt sechsundvierzigtausendsechshundertneunzig Euro und achtzig

Cent (EUR 46,690.80.-) eingeteilt in siebenunddreißigtausend-dreihundertdreiundfünfzig (37,353) Aktien ohne Angabe
eines Nominalwertes."

<i>Kosten &amp; Gebühren

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Honorare, gleich welcher Art, welche von der Gesellschaft getragen werden

und die im Zusammenhang mit der Kapitalherabsetzung stehen, werden auf eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300.-)
geschätzt.

Nachdem alle Punkte der Tagesordnung abschließend von der Hauptversammlung behandelt wurden, wurde diese für

beendet erklärt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht, stellt hiermit fest, dass auf den Wunsch der erschienenen Per-

sonen, diese Satzung in englischer Sprache, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprach abgefasst wird, auf Nachfrage
der erschienenen Personen, und im Falle von Abweichungen zwischen dem Englischen und dem Deutschen Text, soll die
englische Fassung ausschlaggebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen und Übersetzung in die Sprache der Vertreter der Erschienenen, alle dem

Notar nach Vor- und Nachnamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.

Signé: G. Chaste, I. Dias, E. Vande Cruys et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 août 2009. Relation: LAC/2009/33576. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009113342/209.
(090136292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

87840


Document Outline

ART east S.A.

Asian Capital Holdings Fund

Bone &amp; Joint Research S.A.

Brainsourcing S.àr.l.

Bright Pattern

CBZ Sport Construct S.A.

DS Turkey 5 S. à r. l.

European Office Income Venture

Flowersun S.A.

Fondation Pierre Werner

Fondation Pierre Werner

Fondation Pierre Werner

Fondation Pierre Werner

Fondation Pierre Werner

Fondation Pierre Werner

Franklin Templeton Luxembourg Holding S.A.

Hermes Portfolio

Holding Immobilière Nouvelle S.A.

Immobilière des Trois Ponts S.A.

Immobilière des Trois Ponts S.A.

Immobilière des Trois Ponts S.A.

Invista European Celsius Holdings S.à r.l.

Jaguar Luxembourg S.A.

KD Properties Holding S.à r.l.

Lab Document Vault PSF S.A.

LSF Quintet Investments S.à r.l.

LSREF Lux Japan Investments VI S.à r.l.

Macrovision International Solutions S.à r.l.

Morgane Green Energy Development

Mouseltrans S.à r.l.

Nacarat Design S.à r.l.

Nord Est Asset Management

oneOone communication S.A.

Orco Property Group

Power Group Holding S.A.

Preferred Retail S.A.

Radetzky S.A.

Ribs S.à r.l.

RM2 International S.A.

Rovi International Solutions S.à r.l.

Sainte-Maxime S.A.

Sibgrave Holding S.A.

Sodesoft S.à r.l.

Sodesoft S.à r.l.

Sodesoft S.à r.l.

Sodesoft S.à r.l.

Sogaris Logistics Estates International Luxembourg

Tetris SA

Tetris SA

Transports et Garage Presse S.à r.l.

T.W. Logistics S.A.

Tyson Global Holding Sàrl

Vietnam Resource Investments S.à r.l.