logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1663

28 août 2009

SOMMAIRE

A.J.I.L. C. & P. S.A., Consultants-Courtiers

en Assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79813

Arom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79819

Axess Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79780

Babcock & Brown Reif Investment 2 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79817

Betsy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79781

Blackstar Group Plc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79821

Borga S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79821

BRE/Europe Hotel Holding II S.à r.l.  . . . . .

79820

BRE/Europe Hotel II Lux GP S.à r.l. . . . . . .

79821

BRE/Europe Hotel II Lux Investor S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79820

BRE/Japan Hotel Holding I S.à r.l. . . . . . . . .

79819

BRE/Neuss Hotel Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

79795

BRE/Nine Hotel Holding S. à r.l.  . . . . . . . . .

79781

BRE/Student Housing Holding I S.à r.l.  . . .

79819

C2 Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79818

Car Testing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79780

Central European Budapest Investment

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79816

China Corn Oil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79814

Citex S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79778

Claudia Property Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

79822

ColTour S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79816

Cottonwood Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . .

79812

Cottonwood Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . .

79812

Crystal Partners Lux Holding Company Li-

mited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79779

DND S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79815

Encore Plus Lux Co Ile de la Jatte I S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79780

Eurazeo Real Estate Lux  . . . . . . . . . . . . . . . .

79817

FINAT S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79814

Finbourg Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79778

FV-Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79779

Gaz Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79779

GREENSTED HOLDINGS (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79815

GREENSTED HOLDINGS (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79815

Guizet Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

79812

Harsco Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

79813

Intimm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79811

Ipsyinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79814

Iron Paradox S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79780

Miroiterie Origer S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79813

Morgan Stanley Derivative Products (Lu-

xembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79812

Naropa Properties Luxembourg S.A.  . . . .

79812

OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A.  . . .

79813

Pâtes Fraîches LA ROMAGNA S.à r.l.  . . .

79779

Patron Archipel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

79823

Pink Ocean Finance SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

79815

Punto Verde Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79819

Real Pol Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

79824

Redai Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79823

Reif 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79816

Reif 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79818

Relys Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79821

Rosann S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79814

Rosann S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79814

Sky Investments S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

79822

S.L.P.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79780

Sofinas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79778

Sofinas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79778

Sofindex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79781

Sogerance Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

79821

Technossence S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79779

The 344 Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

79813

Vespa A S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79809

Wafra/Aref Opéra Investment S.à r.l.  . . . .

79778

79777

Sofinas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 20.511.

Bilan rectificatif du 14/08/2008 L080120732.04
Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009101080/11.
(090121198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Sofinas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 20.511.

Bilan rectificatif du 14/08/2008 L080120726.04
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009101079/11.
(090121195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Citex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4516 Differdange, 74, rue Henri Bessemer.

R.C.S. Luxembourg B 138.356.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009101103/10.
(090121661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Finbourg Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 56.512.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009101109/10.
(090121044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Wafra/Aref Opéra Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 112.860.

Les comptes annuels pour la période du 12 décembre 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ainsi que les

documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009101094/12.
(090121588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

79778

Technossence S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 104.580.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009101096/10.
(090121617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Gaz Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 95.071.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009101113/10.
(090121390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

FV-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 27, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 131.588.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009101116/11.
(090121574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Pâtes Fraîches LA ROMAGNA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 41, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 85.268.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18.06.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009101091/10.
(090121539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Crystal Partners Lux Holding Company Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.412.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009101125/13.
(090121225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

79779

Car Testing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 89.762.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009101122/10.
(090121221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

S.L.P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 119.783.

Le bilan de la société au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Sabrina Charny.

Référence de publication: 2009101126/10.
(090121228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Axess Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 80.040.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009101120/11.
(090121581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Iron Paradox S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 30, rue d'Orchimont.

R.C.S. Luxembourg B 69.172.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26.06.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009101086/10.
(090121533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Encore Plus Lux Co Ile de la Jatte I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.643.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 31 juillet 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009101136/13.
(090120885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

79780

Betsy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102511/10.
(090123022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Sofindex, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 43.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102512/10.
(090122721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

BRE/Nine Hotel Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 114.688.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth of July,
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

BRE/German Hotel Holding I S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 114.685, with a share capital of EUR 12,500,

here represented by Ms Patricia Sondhi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given

on 15 July 2009, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

and
Art Hotel Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 18-24, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 115.744, with a share capital of EUR 12,500,

here represented by Ms Patricia Sondhi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given

on 13 July 2009, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties are the shareholders of the Company, representing the entire share capital (the "Shareholders")

of BRE/Nine Hotel Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share
capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on 23 February 2006, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1015 of 24 May 2006,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 114.688 (the "Company") and
have required the undersigned notary to state his declarations as follows:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of the purpose of the Company and of article 2 of the Company's articles of association which shall

henceforth have the following wording:

"The purpose of the Company is the acquiring, improving, operating and disposing of the Novotel Hotels in Perlach,

Manheim, Frankfurt Airport, Mainz, Düsseldorf Sud, Bielefield, Hamburg Airport, Eschborn and of the Ibis Hotel in Os-
nabrueck (each a "Property" and all together the "Properties").

79781

The purpose of the Company is furthermore the holding of participations, in any form whatsoever, in BRE/Perlach I

Hotel S.à r.l., BRE/Mannheim I Hotel S.à r.l., BRE/Frankfurt I Hotel S.à r.l., BRE/Mainz I Hotel S.à r.l., BRE/Düsseldorf I
Hotel S.à r.l., BRE/Bielefeld I Hotel S.à r.l., BRE/Hamburg I Hotel S.à r.l., BRE/Eschborn I Hotel S.à r.l. and BRE/Osnabrück
I Hotel S.à r.l., all being Luxembourg limited liability companies, and in the German limited liability company BRE/Nine
Hotel Operations GmbH (each a "Subsidiary" and all together the "Subsidiaries"), the acquisition by purchase, subscription
or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the adminis-
tration, control and development of the above-mentioned companies.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the above-mentioned companies and their direct

and indirect subsidiaries.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment of its purpose.

In particular, the Company will provide the above-mentioned companies and their direct or indirect subsidiaries with

the services necessary to their administration, control and development. For that purpose the Company may require and
retain the assistance of other advisors.";

2. Creation of two classes of shares and replacement of the existing 500 shares of the Company by 450 shares of Class

A and 50 shares of Class B;

3. Amendment of article 9, paragraph 1 of the articles of association of the Company;
4. Amendment of article 12 of the articles of association of the Company;
5. Amendment of article 13, paragraph 1, sentence 1 of the articles of association of the Company;
6. Amendment of article 13, paragraph 7 of the articles of association of the Company;
7. Amendment of article 13, paragraph 8 of the articles of association of the Company;
8. Amendment of article 13, paragraph 9 of the articles of association of the Company;
9. Amendment of article 14 of the articles of association of the Company;
10. Insertion of a new article 15 in the articles of association of the Company;
11. Insertion of a new article 19 in the articles of association of the Company;
12. Insertion of a supplemental sentence to article 20 (new numbering) in the articles of association of the Company;
13. Insertion of a new article 21 in the articles of association of the Company in relation to reserved matters of the

shareholders;

14. Amendment of article 26 (new numbering) of the articles of association of the Company in relation to the creation

of a preference dividend;

15. Insertion of a new article 27 in the articles of association of the Company in relation to the creation of the possibility

to pay interim dividends;

16. Amendment of article 28 (new numbering) of the articles of association of the Company in relation to the creation

of a preference liquidation dividend;

17. Amendment of article 29 (new numbering) of the articles of association of the Company;
18. Resignation of the sole manager, BRE/Management S.A. and granting full discharge;
19. Fixing of the number of the managers at four;
20. Appointment of new managers and;
21. Miscellaneous;
II. - That the entire share capital being represented at the present meeting and the general meeting represented

declaring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.

Then the general meeting (the "General Meeting") takes the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolved to amend article 2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth

have the following wording:

"The purpose of the Company is the acquiring, improving, operating and disposing of the Novotel Hotels in Perlach,

Mannheim,  Frankfurt  Airport,  Mainz,  Düsseldorf  Süd,  Bielefeld,  Hamburg  Airport,  Eschborn  and  of  the  Ibis  Hotel  in
Osnabrück (each a "Property" and all together the "Properties").

The purpose of the Company is furthermore the holding of participations, in any form whatsoever, in BRE/Perlach I

Hotel S.à r.l., BRE/Mannheim I Hotel S.à r.l., BRE/Frankfurt I Hotel S.à r.l., BRE/Mainz I Hotel S.à r.l., BRE/Düsseldorf I
Hotel S.à r.l., BRE/Bielefeld I Hotel S.à r.l., BRE/Hamburg I Hotel S.à r.l., BRE/Eschborn I Hotel S.à r.l. and BRE/Osnabrück
I Hotel S.à r.l., all being Luxembourg limited liability companies, and in the German limited liability company BRE/Nine
Hotel Operations GmbH (each a "Subsidiary" and all together the "Subsidiaries"), the acquisition by purchase, subscription
or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the adminis-
tration, control and development of the above-mentioned companies.

79782

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the above-mentioned companies and their direct

and indirect subsidiaries.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment of its purpose.

In particular, the Company will provide the above-mentioned companies and their direct or indirect subsidiaries with

the services necessary to their administration, control and development. For that purpose the Company may require and
retain the assistance of other advisors.";

<i>Second resolution

The General Meeting resolved to create two classes of shares and to convert the existing five hundred (500) shares

with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, into four hundred fifty (450) shares of Class A with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each and fifty (50) shares of Class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The shares of Class A and the shares of Class B have the same rights and obligations except as stated to the contrary

in the articles of association of the Company.

The General Meeting resolved as a consequence to allocate the four hundred fifty (450) shares of Class A and the fifty

(50) shares of Class B as follows:

- four hundred fifty (450) shares of Class A are held by BRE/German Hotel Holding I S.à r.l.; and
- fifty (50) shares of Class B are held by Art Hotel Holding S.à r.l.

<i>Third resolution

The General Meeting resolved to amend article 9, paragraph 1 of the articles of association of the Company, which

shall henceforth have the following wording:

"The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, no shareholder may, directly or indi-

rectly, assign, sell, exchange, transfer, pledge or otherwise dispose of all or any part of the shares he holds in the Company
to any third party without obtaining the prior consent of the shareholders representing three quarters of the share capital
of  the  Company.  Such  transfer  may  only  be  performed  to  a  transferee  who  has  given  prior  to  the  transfer  written
acceptance and adoption of all terms and conditions of any shareholders agreement which may have been entered into
between the shareholders (the "Shareholders Agreement")."

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolved to amend article 12 of the articles of association of the Company, which article shall

henceforth have the following wording:

"The Company is managed by at least three managers.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two members of the board of managers.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument."

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolved to amend article 13, paragraph 1, sentence 1, of the articles of association of the

Company, which shall henceforth have the following wording:

"The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman."

<i>Sixth resolution

The General Meeting resolved to add the following sentence to article 13, paragraph 7, of the articles of association

of the Company:

"If any manager is prevented from participating in a meeting or a vote of the board of managers, he may request that

the matter be discussed or voted again in his presence."

<i>Seventh resolution

The General Meeting resolved to add the following sentence to article 13, paragraph 8, of the articles of association

of the Company:

"No decisions shall be taken as to matters falling into the field of responsibility of any absent manager unless such

decision would be necessary in order to avoid negative consequences for the Company."

<i>Eighth resolution

The General Meeting resolved to amend article 13, paragraph 9, of the articles of association of the Company, which

shall henceforth have the following wording:

79783

"Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. Any decisions

not being passed unanimously shall without delay be brought to the attention of the shareholders meeting which will
resolve upon the matter at a majority of shares present or represented."

<i>Ninth resolution

The General Meeting resolved to add the following sentence to article 14 of the articles of association of the Company:
"All managers shall receive copies of the minutes."

<i>Tenth resolution

The General Meeting resolved to insert a new article 15 in the articles of association of the Company, which shall have

the following wording:

"The board of managers has to report regularly to the shareholders meeting on the conduct of the business and on

any other matters requested by the shareholders meeting.

The board of managers shall on or before November 15th of each year prepare and submit to the shareholders meeting

for approval a proposed business plan for the ensuing calendar year. The business plan shall include, without limitation,
each of the following items containing the most current information with regard thereto then available: (i) a comprehensive
survey of the market in which the Properties are competing, (ii) a detailed description of the renovation, refurbishment,
maintenance, repair and management of the Properties; including without limitation, any planned or required improve-
ments to the Properties, (iii) a pro forma income and expense statement for the Properties over the entire anticipated
term  of  ownership  by  the  Company,  but  not  less  than  five  years,  (iv)  a  detailed  operating  budget,  as  defined  in  the
Shareholders Agreement, and (v) a detailed marketing report.

Not later than twenty (20) days after receipt by the shareholders meeting of the proposed business plan (or such

longer period as any shareholder may reasonably request by notice to the board of managers), the shareholders holding
the shares of Class A may deliver a notice to the board of managers stating that such shareholder objects to any infor-
mation contained in or omitted from such business plan and setting forth the nature of such objection. Upon receipt of
such notice, the board of managers shall within five (5) days modify the proposed business plan and resubmit it to the
shareholders meeting for the shareholders meeting's approval. Within ten (10) days of receipt of the resubmitted business
plan, the shareholders holding the shares of Class A may deliver a further objection notice (in which event the resubmission
and review process described above shall continue until the business plan in question is accepted and consented to by
the shareholders meeting). Notwithstanding anything to the contrary set forth herein, the shareholders meeting shall
have the right at any time subsequent to the acceptance and consent with respect to any business plan, by notice to the
board of managers, to revise such business plan or to request that the board of managers prepare for the shareholders
meeting's approval a revised business plan, taking into account such circumstances as the shareholders meeting deems
appropriate, provided, however, the revision of a business plan shall not be deemed a revocation of the board of managers
authority with respect to such actions that the board of managers may have already taken prior to such revision in
implementing such business plan, and the board of managers shall, with the prior approval of the shareholders meeting
(which approval shall not be unreasonably withheld), have the right to complete such transactions to which the board of
managers has already been committed.

If a business plan for any calendar year has not been approved by January 1st of that year, the Company shall continue

to operate under the business plan for the previous year until a new business plan is approved by the shareholders meeting,
with such adjustments to the operating budget contained therein as may be necessary to reflect approved contracts or
leases, deletion of non recurring expense items set forth on the previous operating budget and increased insurance costs,
taxes, utility costs, and debt service payments.

The Company shall operate under annual operating budgets which shall be prepared and submitted by the board of

managers to the shareholders meeting for approval. The board of managers shall implement each operating budget on
behalf of the Company and may incur the expenditures and obligations therein provided.

The board of managers shall submit to the shareholders meeting, within fifteen (15) days after the end of each month,

a monthly update of the then-applicable operating budget and the business plan, so as to inform the shareholders meeting
of:

(1) any variances from the operating budget or the business plan, including (A) cost overruns in any line item in the

operating budget to date, or any unforeseen costs or expenses which may have arisen and which, when added to all other
costs and expenses, will cause the operating budget total (or any operating budget category or line item) to be exceeded
or, otherwise cause budgeted results to differ from actual results and (B) any cost savings in any operating budget line
item or budget category realized to date;

(2) all expenditures under any contingency amounts in the operating budget showing the amount and operating budget

line item to which said expenditure was made, and all applications to date of cost offsets showing the amount and operating
budget line item to which such application was made;

(3) all cost overrun payments made to date, showing the amount and operating budget line item to which such cost

overrun payment was applied; and

(4) any variances from the operating budget or the business plan.

79784

The board of managers shall submit to the shareholders any reports and budgets received under any hotel management

agreement which may be entered into by the Company (the "Hotel Management Agreement") and any property mana-
gement agreement which may be entered into by the Company (the "Property Management Agreement") and may refer
to these reports and budgets. In case of disputes on reports and budgets to be provided under the Hotel Management
Agreement and the Property Management Agreement, the board of managers shall inform the shareholders thereof
without delay."

Thus, after the insertion of a new article 15, the former article 15 becomes the new article 16, the former article 16

becomes the new article 17 and the former article 17 becomes the new article 18.

<i>Eleventh resolution

The General Meeting resolved to insert a new article 19 (new numbering) in the articles of association of the Company,

which shall have the following wording:

"The general meeting of shareholders shall not validly deliberate unless the entire share capital of the Company is

represented. If this condition is not satisfied, the shareholder(s) present may not pass any resolutions other than ad-
journing such meeting to the same time of the day and place on a date as determined by the shareholder(s) present, which
date shall be at least five days following the date of the adjourned meeting.

Notice of such adjournment and the reconvened meeting date, time and place shall be sent to the shareholders within

five days of such adjournment.

The reconvened meeting shall not validly deliberate unless at least half of the share capital of the Company is repre-

sented."

<i>Twelfth resolution

The General Meeting resolved to add the following sentence to article 20 (new numbering) of the articles of association

of the Company:

"Resolutions  for  the  issuance  of  shares  by  the  Company  and  decisions  on  the  acquisition  of  investments  require

unanimous consent of the general meeting of shareholders provided that no consent of a shareholder who failed to make
the capital contribution required by the Company is required for the issuance of shares."

<i>Thirteenth resolution

The General Meeting resolved to insert a new article 21 (new numbering) in the articles of association of the Company

which shall have the following wording:

"No action shall be taken, sum expended, or obligation incurred by any manager regarding the matters described below

unless such specific action or expenditure is included in a business plan or operating budget approved by the shareholders
meeting or otherwise has been approved or proposed by the shareholders meeting:

(i) the acquisition, sale, transfer, exchange, mortgage, financing, hypothecation or encumbrance of all or any part of a

Property;

(ii) the determination of the terms and conditions of all Company borrowings and the identity of the lender thereof,

any determination to amend any approved loan documents, and the granting of any guaranties or indemnities by the
Company;

(iii) the approval of each business plan and operating budget, and any amendments thereto;
(iv) establishing any capital or operating reserves of the Company, other than as set forth in the then-current operating

budget;

(v) the making of any expenditure or incurrence of any obligation by or for the Company in excess of 110% of the

applicable line item in the then-current operating budget; however, if emergency repairs to a Property are necessary to
avoid imminent danger of injury to the Property or to an individual, the board of managers may make such expenditures
as may be necessary to alleviate such situation and shall promptly notify the shareholders meeting of the event giving rise
to such repairs and the actions taken with respect thereto;

(vi) the making of any distributions to shareholders or of any payments under shareholder loans;
(vii) the approval of any lease (or amendment or extension of any existing lease) demising more than 500 net rentable

square meters of space in any Property or providing for annual rental income in excess of thirty thousand Euro (EUR
30,000.-) or the termination or acceptance of cancellation or surrender of any lease other than in accordance with the
terms of the lease or the forgiveness or release of any lease covenant or requirement;

(viii) the approval of any third party agreements not included in the business plan or operating budget providing for

annual payment in excess of ten thousand Euro (EUR 10,000.-) in the aggregate;

(ix) material pricing decisions regarding the Properties;
(x) the determination of accounting policies, including selection of depreciation schedules, accounting methods and

making various decisions regarding treatment and allocation of transactions for income tax, franchise or other tax pur-
poses;

79785

(xi) the selection of banks for deposit of Company funds, and the designation of persons with signatory authority over

withdrawal of such funds;

(xii) the taking of any legal action and any determination to settle any legal action involving in excess of one hundred

thousand Euro (EUR 100,000);

(xiii) the selection of attorneys, accountants, engineers, environmental consultants, or other professionals for the

Properties or the Company;

(xiv) the disclosure of confidential information and the issuance of any press release regarding the activities of the

Company and its Subsidiaries;

(xv) moving the administration of the Company outside the Grand Duchy of Luxembourg;
(xvi) any change in the business of the Company which takes the focus of the Company's business away from the

corporate purpose specified in the articles of association of the Company;

(xvii) any agreement entered into with, any elections, consents, acknowledgments and waiver of rights given towards,

or any business passed with, (i) the shareholders holding the shares of Class B or with Dahlem Property I B.V., (ii) any
other person who controls, is controlled by or is under common control with such person, (iii) any manager, director,
officer, partner or employee of such person or any person specified in clause (i) or (ii) above or (iv) any immediate family
member of any person specified in clause (i), (ii) or (iii) above;

(xviii) the exercise of shareholder rights of the Company in subsidiaries, including shareholder approvals, insofar as

they are of the same or similar importance to a subsidiary as any of the matters referred to under items (i) through (xvi)
with respect to the Company.

As a result of the insertion of a new article 19 and a new article 21, the former article 19 becomes the new article 22,

the former article 20 becomes the new article 23, the former article 21 becomes the new article 24, the former article
22 becomes the new article 25 and the former article 23 becomes the new article 26.

<i>Fourteenth resolution

The General Meeting resolved to amend article 26 (new numbering) of the articles of association of the Company,

which shall henceforth have the following wording:

"Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders subject to the
provisions of a shareholder agreement and the following provisions:

In case of a disposal, i.e. a sale, in a single transaction or multiple transactions, to one or more third party purchasers

for cash of (i) the entirety of the Properties or any of them, (ii) a controlling interest in the Company's Subsidiaries or
any of them, (iii) following the sale of a controlling interest under (ii) hereof (but not all of the shares in the Company's
Subsidiaries or any of them) the sale of further shares in the Company's Subsidiaries or any of them, provided, that (x)
for avoidance of doubt, if the Properties or the controlling interest in the Company's Subsidiaries is sold to more than
one third party purchaser or in more than one transaction, the disposal means the collective reference to all such sales
and shall be deemed to occur on the last of such sales, and (y) a controlling interest in the Company's Subsidiaries shall
mean ownership, directly or indirectly, of more than fifty per cent (50%) of the share capital of such companies, the shares
of Class B are entitled to a preference dividend as follows:

(i) First, one hundred per cent (100%) of the proceeds, as defined in the Shareholder Agreement, to the shareholders

until the aggregate amount of the proceeds received by the shareholders is equal to the aggregate capital contributions
and shareholders loans made by the shareholders;

(ii) Second, one hundred per cent (100%) of the proceeds to the shareholders until such time as the shareholders

holding the shares of Class A have received a twenty per cent (20%) internal rate of return, as defined in the Shareholders
Agreement;

(iii) Third, eighty-five per cent (85%) of the proceeds to the shareholders and fifteen per cent (15%) to the shareholders

holding the shares of Class B until such time as the shareholders holding the shares of Class A have received a twenty-
five per cent (25%) internal rate of return;

(iv) Fourth, eighty per cent (80%) of the proceeds to the shareholders and twenty per cent (20%) to the shareholders

holding the shares of Class B until such time as the shareholders holding the shares of Class A have received a thirty per
cent (30%) internal rate of return; and

(v) Thereafter, seventy-five per cent (75%) of the proceeds to the shareholders and twenty-five per cent (25%) to the

shareholders holding the shares of Class B;

provided that, for avoidance of doubt, the foregoing provision shall only be applicable for the purposes of calculating

the preference dividend and no shareholder or other person shall have any rights as a result of the foregoing provision.

As a result of a sale of the entirety of the Properties and in the event that the preference dividend is higher than the

amount available for distribution under applicable laws, the Company will distribute to the shareholders holding the shares
of Class B that portion of the preference dividend that may be distributed under applicable laws and the balance of the
preference dividend will be distributed upon the earlier of (i) the next date of the completion of a disposal, whereupon
the balance of such preference dividend shall first be distributed to the shareholders holding the shares of Class B prior

79786

to making any distributions of any additional preference dividend due to the shareholders holding the shares of Class B
on such date and (ii) the liquidation of the Company.

The shareholders holding the shares of Class A may by written notice to the shareholders holding the shares of Class

B terminate such shareholders' entitlement to the preference dividend upon (1) the occurrence of any event set forth in
clause 10.2(c)(i), (iii) and (iv) of the Hotel Management Agreement, (2) any material breach by the shareholder holding
the shares of Class B of their obligations under Article VIII of the Shareholders Agreement, (3) a change in majority
beneficial ownership and controlling interest in the shareholders holding the shares of Class B or the manager under the
Hotel Management Agreement, and, if capable of remedy, the shareholders holding the shares of Class B or any of their
affiliates have failed, within fifteen business days of the date of a written notice served by the shareholders holding the
shares of Class A on the shareholders holding the shares of Class B confirming that the shareholders holding the shares
of Class B or their affiliates have breached materially the Shareholders Agreement or the Property Management Agree-
ment or the Hotel Management Agreement and requiring remedial action, to so remedy such breach. Upon service of
such written notice the shareholders holding the shares of Class B's entitlement to the preference dividend shall imme-
diately terminate and neither the Company nor the shareholders holding the shares of Class A shall have any further
obligations in this respect."

<i>Fifteenth resolution

The General Meeting resolved to insert a new article 27 (new numbering) in the articles of association of the Company

which shall have the following wording:

"Interim dividends may be paid subject to the following terms and conditions:
(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the general meeting

of the shareholders;

(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the management of interim

accounts showing that sufficient profits are available for such distribution;

(iii) the preference dividend to which the shares of Class B are entitled has to be respected;
(iv) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the shareholders.
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the shareholders according to the annual general

meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the shareholders.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of shareholders to distribute at any

moment to the shareholders any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts."

As a result of the insertion of a new article 27, the former article 24, becomes the new article 28 and the former

article 25 becomes the new article 29.

<i>Sixteenth resolution

The General Meeting resolved to change the second paragraph of new article 28 as follows:
"Unless the shareholders unanimously decide otherwise, the surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed

among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them subject to the provisions of the
Shareholders Agreement and the following provisions: the shares of Class B are entitled to a preference liquidation
dividend under the same terms and conditions than the preference dividend as organized in article 26."

<i>Seventeenth resolution

The General Meeting resolved to change the new article 29 as follows:
"All matters not governed by these articles of incorporation and the terms and conditions of any shareholder agreement

that may have been entered into between shareholders shall be determined in accordance with the law of 10 August
1915 regarding commercial companies, as amended.

In case of divergence between these articles of incorporation and the Shareholders Agreement, the Shareholders

Agreement shall be prevailing among the shareholders of the Company."

<i>Eighteenth resolution

The General Meeting resolved to accept the resignation of BRE/Management S.A. from its duties as sole manager of

the Company with immediate effect.

The General Meeting resolved to grant full discharge to BRE/Management S.A. for the exercise of its mandate.

<i>Nineteenth resolution

The General Meeting resolved to fix the number of managers at four.

<i>Twentieth resolution

The General Meeting resolved to appoint with immediate effect for an indefinite period as new managers:

79787

- Mr Anders Braks, jurist, born on 21 September 1959 in Landskrona (Sweden), residing at 41, Am Botanischen Garten,

50668 Köln, (Germany),

- Mr Robert Simon, director, born on 20 February 1929, in Wiesbaden (Germany) and residing at 28, rue JP Brasseur,

L-1258 Luxembourg,

- Mrs Cornelia M.W. van den Broek, director, born on 26 June 1968 in Oosterhout (the Netherlands), residing pro-

fessionally at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,

- Mr Gary Sumers, managing director, born on 12 December 1952 in New York, United States of America, residing

at 888 Park Avenue, Apt. 11#, New York, NY 10021, United States of America.

With no outstanding points on the agenda the chairman brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendneun, den sechzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

BRE/German Hotel Holding I S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach dem Recht

des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Ge-
sellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 114.685, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500,

hier vertreten durch Frau Patricia Sondhi, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, durch privatschriftliche Vollmacht, erteilt

am 15. Juli 2009, die nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben registriert zu werden,

Art Hotel Holding S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach dem Recht des Groß-

herzogtums  Luxemburg,  mit  Sitz  in  18-24,  rue  Michel  Rodange,  L-2430  Luxemburg,  eingetragen  im  Handels-  und
Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 115.744, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500,

hier vertreten durch Frau Patricia Sondhi, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, durch privatschriftliche Vollmacht, erteilt

am 13 Juli 2009, die nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben registriert zu werden.

Die erschienenen Parteien sind die Gesellschafter der Gesellschaft und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital (die

"Gesellschafter") von BRE/Nine Hotel Holding S.à r.l., einer société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, mit einem Gesell-
schaftskapital von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gegründet am 23. Februar 2006 gemäß einer Urkunde
des unterzeichneten Notars, die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1015 vom 24. Mai 2006
veröffentlicht wurde, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 114.688
(die "Gesellschaft") und ersuchen den unterzeichneten Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung

1. Änderung des Gesellschaftszweckes und des Artikels 2 der Gesellschaftssatzung, der von nun an wie folgt lauten

soll:

"Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erneuerung, der Betrieb und der Verkauf von. Novotel Hotels in

Perlach, Mannheim, Frankfurt Airport, Mainz, Düsseldorf Süd, Bielefeld, Hamburg Airport, Eschborn und des Ibis Hotel
in Osnabrück (jedes einzelne eine "Immobilie" und alle zusammen die "Immobilien").

Der Zweck der Gesellschaft ist zudem das Halten von Beteiligungen jeglicher Art, in BRE/Perlach I Hotel S.à r.l., BRE/

Mannheim I Hotel S.à r.l., BRE/Frankfurt I Hotel S.à r.l., BRE/Mainz I Hotel S.à r.l., BRE/Düsseldorf I Hotel S.à r.l., BRE/
Bielefeld I Hotel S.à r.l., BRE/Hamburg I Hotel S.à r.l., BRE/Eschborn I Hotel S.à r.l. and BRE/Osnabrück I Hotel S.à r.l.,
alle Luxemburger Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie in der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BRE/Nine Hotel Operations GmbH (jede einzelne eine "Filiale" und alle zusammen die "Filialen"), der Erwerb durch Kauf,
Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren
jeglicher Art sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung der oben genannten Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann zudem den oben genannten Gesellschaften sowie ihren direkten und indirekten Filialen Bürg-

schaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

79788

Die Gesellschaft wird insbesondere die oben genannten Gesellschaften sowie ihre direkten und indirekten Filialen mit

den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung versorgen. Zu diesem Zweck
kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen."

2. Einführung von zwei Anteilsklassen und Ersetzen der bestehenden 500 Anteile der Gesellschaft durch 450 Anteile

der Klasse A und 50 Anteile der Klasse B;

3. Abänderung des Artikel 9, Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung;
4. Abänderung von Artikel 12 der Gesellschaftssatzung;
5. Abänderung von Artikel 13 Paragraph 1, Satz 1 der Gesellschaftssatzung;
6. Abänderung von Artikel 13, Paragraph 7 der Gesellschaftssatzung;
7. Abänderung von Artikel 13, Paragraph 8 der Gesellschaftssatzung;
8. Abänderung von Artikel 13, Paragraph 9 der Gesellschaftssatzung;
9. Abänderung von Artikel 14 der Gesellschaftssatzung;
10. Einfügung eines neuen Artikels 15 in die Gesellschaftssatzung;
11. Einfügung eines neuen Artikels 19 in die Gesellschaftssatzung;
12. Einfügung eines neuen Satzes in Artikel 20 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung;
13. Einfügung eines neuen Artikels 21 in die Gesellschaftssatzung für die Festlegung der Gesellschafter vorbehaltenen

Angelegenheiten;

14. Abänderung des Artikel 26 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung für die Schaffung einer Vorzugsdivi-

dende;

15. Einfügung eines neuen Artikels 27 in die Gesellschaftssatzung für die Einführung der Möglichkeit Abschlagsdivid-

enden auszuzahlen;

16. Abänderung des Artikels 28 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung für die Schaffung einer Vorzugsdivi-

dende im Falle der Liquidation;

17. Abänderung von Artikel 29 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung;
18. Abberufung und volle Entlastung des alleinigen Geschäftsführers, BRE/Management S.A.;
19. Festlegung der Anzahl der Geschäftsführer auf vier;
20. Ernennung neuer Geschäftsführer;
21. Verschiedenes.
II. Dass das gesamte Gesellschaftskapital bei der vorliegenden Versammlung vertreten ist und die vertretenen Gesell-

schafter  erklären,  dass  sie  vor  der  Versammlung  über  die  Tagesordnung  in  Kenntnis  gesetzt  wurden,  so  dass  keine
Einberufungsschreiben notwendig waren.

Die Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") fasst im Anschluss folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Artikel 2 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun an wie folgt lauten

wird:

"Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erneuerung, der Betrieb und der Verkauf von Novotel Hotels in

Perlach, Mannheim, Frankfurt Airport, Mainz, Düsseldorf Süd, Bielefeld, Hamburg Airport, Eschborn und des Ibis Hotel
in Osnabrück (jedes einzelne eine "Immobilie" und alle zusammen die "Immobilien").

Der Zweck der Gesellschaft ist zudem das Halten von Beteiligungen jeglicher Art, in BRE/Perlach I Hotel S.à r.l., BRE/

Mannheim I Hotel S.à r.l., BRE/Frankfurt I Hotel S.à r.l., BRE/Mainz I Hotel S.à r.l., BRE/Düsseldorf I Hotel S.à r.l., BRE/
Bielefeld I Hotel S.à r.l., BRE/Hamburg I Hotel S.à r.l., BRE/Eschborn I Hotel S.à r.l. and BRE/Osnabrück I Hotel S.à r.l.,
alle Luxemburger Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie in der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BRE/Nine Hotel Operations GmbH (jede einzelne eine "Filiale" und alle zusammen die "Filialen"), der Erwerb durch Kauf,
Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren
jeglicher Art sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung der oben genannten Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann zudem den oben genannten Gesellschaften sowie ihren direkten und indirekten Filialen Bürg-

schaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die oben genannten Gesellschaften sowie ihre direkten und indirekten Filialen mit

den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung versorgen. Zu diesem Zweck
kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen."

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, zwei Anteilsklassen einzuführen und die bestehenden fünfhundert (500) Anteile

mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) in vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A mit einem

79789

Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) und in fünfzig (50) Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig Euro (EUR 25) umzuwandeln.

Die Anteile der Klasse A und die Anteile der Klasse B haben die gleichen Rechte und Pflichten, es sei denn die vor-

liegende Satzung sehe etwas anderes vor.

Die Hauptversammlung beschließt die vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A und die fünfzig (50) Anteile der

Klasse B wie folgt zu verteilen:

- vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A werden von BRE/German Hotel Holding I S.à r.l. gehalten; und
- fünfzig (50) Anteile der Klasse B werden von Art Hotel Holding S.à r.l. gehalten.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den ersten Absatz des Artikels 9 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun

an wie folgt lauten soll:

"Die Anteile der Gesellschaft können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Zuweisung, der Ver-

kauf, der Tausch, die Übertragung, die Verpfändung sowie jegliche andere Art der Veräußerung, sei es auf direkte oder
indirekte Art und Weise, aller oder eines Teils der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedürfen der vorherigen
Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Eine solche Übertragung kann lediglich
an einen Erwerber erfolgen, der vor der Übertragung sein schriftliches Einverständnis zu den Bestimmungen eines jeglichen
Gesellschaftervertrags, der möglicherweise zwischen den Gesellschaftern abgeschlossen wurde (der "Gesellschafterver-
trag"), gegeben hat."

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Artikel 12 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun an wie folgt lauten

soll:

"Die Gesellschaft wird von mindestens drei Geschäftsführern verwaltet.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, welche die Dauer ihres Mandates

bestimmt. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihrem Amt entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-

pflichtet.

Der Geschäftsführerrat kann Sondervollmachten durch notariell beglaubigte oder privatschriftliche Urkunde erteilen."

<i>Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den ersten Satz des ersten Absatzes von Artikel 13 der Gesellschaftssatzung ab-

zuändern, der von nun an wie folgt lauten soll:

"Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen

stellvertretenden Vorsitzenden."

<i>Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den folgenden Satz in dem siebten Absatz des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung

hinzuzufügen:

"Falls ein Geschäftsführer nicht an einer Versammlung oder an einer Beschlussfassung des Geschäftsführerrates teil-

nehmen  kann,  kann  dieser  verlangen,  dass  erneut  in  seiner  Anwesenheit  über  diese  Angelegenheit  diskutiert  und
abgestimmt wird."

<i>Siebter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den folgenden Satz in dem achten Absatz des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung

hinzuzufügen:

"Es können keine Beschlüsse gefasst werden bezüglich Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich eines abwe-

senden Geschäftsführers fallen, es sei denn ein solcher Beschluss wäre notwendig, um negative Auswirkungen auf die
Gesellschaft zu vermeiden."

<i>Achter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den neunten Absatz des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der nun

wie folgt lauten soll:

"Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Jegliche Beschlüsse, die nicht einstimmig gefasst wurden, werden
unverzüglich der Gesellschafterversammlung vorgelegt, die einen Beschluss bezüglich der jeweiligen Angelegenheit mit
einer Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile fasst."

<i>Neunter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den folgenden Satz in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung hinzuzufügen:

79790

"Alle Geschäftsführer erhalten Kopien der Protokolle."

<i>Zehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt einen neuen Artikel 15 in die Gesellschaftssatzung einzufügen, der wie folgt lauten

soll:

"Der Geschäftsführerrat ist verpflichtet, der Hauptversammlung der Gesellschafter regelmäßig über die Führung der

Geschäfte und jegliche andere Angelegenheiten, die von der Hauptversammlung der Gesellschafter angefragt werden,
Bericht zu erstatten.

Der Geschäftsführerrat bereitet am oder vor dem 15. November eines jeden Jahres einen Entwurf des Geschäftsplans

für das folgende Kalenderjahr vor, den er der Hauptversammlung der Gesellschafter vorlegt. Der Geschäftsplan sollte
unter anderem jeden der folgenden Punkte und in Bezug auf diese Punkte die aktuellsten Informationen, insofern verfügbar,
umfassen: (i) eine umfassende Studie des Marktes, auf dem die Immobilien tätig sind, (ii) eine ausführliche Beschreibung
der Renovierung, Modernisierung, Wartung, Reparaturen und Verwaltung der Immobilien, einschließlich aber nicht aus-
schließlich jeglicher geplanter oder erforderlicher Umänderungen der Immobilien, (iii) eine vorläufige Einnahmen- und
Ausgabenrechnung  für  die  Immobilien  für  die  voraussichtliche  Zeit  des  Besitzes  durch  die  Gesellschaft,  jedoch  nicht
weniger als fünf Jahre, (iv) ein ausführliches Betriebsbudget, wie in dem Gesellschaftervertrag definiert, und (v) einen
ausführlichen Marketingbericht.

Spätestens zwanzig (20) Tage nach Erhalt des Entwurfs des Geschäftsplans durch die Hauptversammlung der Gesell-

schafter (oder nach einem längeren Zeitraum, der von einem Gesellschafter durch Mitteilung an den Geschäftsführerrat
nach vernünftigem Ermessen beantragt wird) können die Inhaber der Anteile der Klasse A dem Geschäftsführerrat eine
Mitteilung zukommen lassen, in der der jeweilige Gesellschafter erklärt, dass er mit den in dem Geschäftsplan enthaltenen
Informationen beziehungsweise mit den Informationen, die nicht in dem Geschäftsplan enthalten sind, nicht einverstanden
ist, und in der er den Grund für seinen Einwand angibt. Nach Erhalt einer solchen Mitteilung ändert der Geschäftsführerrat
innerhalb von fünf (5) Tagen den Entwurf des Geschäftsplans ab und legt ihn erneut der Hauptversammlung der Gesell-
schafter zur Genehmigung vor. Innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt des neuen Entwurfes des Geschäftsplans haben
die Inhaber der Anteile der Klasse A die Möglichkeit eine weitere Einwandserklärung einzureichen (in diesem Fall wie-
derholen sich die Vorgänge der Unterbreitung und Überprüfung solange bis der Geschäftsplan von der Hauptversammlung
der Gesellschafter genehmigt wird). Ungeachtet jeglicher anderslautender Bestimmungen in der vorliegenden Satzung hat
die Hauptversammlung der Gesellschafter das Recht zu jedem Zeitpunkt nach der Genehmigung eines Geschäftsplanes,
durch Mitteilung an den Geschäftsführerrat, den Geschäftsplan zu überarbeiten oder den Geschäftsführerrat zu bitten,
einen überarbeiteten Geschäftsplan vorzubereiten und ihr diesen zur Genehmigung vorzulegen, unter Berücksichtigung
solcher Umstände, die die Hauptversammlung der Gesellschafter für angemessen hält, jedoch unter der Voraussetzung,
dass die Überarbeitung des Geschäftsplans nicht als eine Aufhebung der Befugnisse des Geschäftsführerrates im Hinblick
auf Maßnahmen, die der Geschäftsführerrat bereits vor einer solchen Überarbeitung zur Umsetzung des Geschäftsplans
ergriffen hat, betrachtet wird und dass der Geschäftsführerrat befugt ist, mit der vorherigen Zustimmung der Hauptver-
sammlung der Gesellschafter (die nicht ohne angemessenen Grund verweigert werden darf), die Transaktionen, für deren
Durchführung der Geschäftsführerrat sich bereits verpflichtet hat, zu vollenden.

Falls ein Geschäftsplan für ein Kalenderjahr am 1. Januar des jeweiligen Jahres noch nicht genehmigt wurde, handelt

die Gesellschaft weiterhin unter dem Geschäftsplan des vorhergehenden Jahres bis ein neuer Geschäftsplan von der
Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt wurde, mit den darin enthaltenen Anpassungen des Betriebsbudgets,
die notwendig sind, um die genehmigten Abkommen oder Mietverträge, die Streichung der nicht wiederkehrenden Aus-
gabenposten,  die  in  dem  vorherigen  Betriebsbudget  enthalten  waren,  sowie  erhöhte  Versicherungskosten,  Steuern,
Nutzungskosten und Schuldendienstkosten widerzuspiegeln.

Die Gesellschaft handelt gemäß jährlichen Betriebsbudgets, die von dem Geschäftsführerrat vorbereitet werden und

der Hauptversammlung der Gesellschafter zur Genehmigung vorgelegt werden. Der Geschäftsführerrat setzt jedes Be-
triebsbudget im Namen der Gesellschaft um und kann in diesem Zusammenhang Auslagen machen und Verpflichtungen
eingehen.

Der Geschäftsführerrat legt der Hauptversammlung der Gesellschafter innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Ende

eines jeden Monats eine monatliche Aktualisierung des jeweils zutreffenden Betriebsbudgets und Geschäftsplans vor, um
die Hauptversammlung der Gesellschafter über Folgendes zu informieren:

(1) jegliche Abweichungen von dem Betriebsbudget oder dem Geschäftsplan, einschließlich (A) der Kostenüberschrei-

tungen  in  Bezug  auf  jegliche  Einzelposten  in  dem  jeweils  aktuellen  Betriebsbudget  oder  jeglicher  unvorhergesehener
Unkosten oder Ausgaben, die entstanden sind und die, wenn sie zu allen anderen Kosten und Ausgaben hinzugefügt
werden, dazu führen, dass der Gesamtbetrag des Betriebsbudgets (oder einer Kategorie des Betriebsbudgets oder eines
Einzelpostens) überschritten wird oder dazu führen, dass die im Budget vorgesehenen Resultate nicht mit den wirklichen
Resultaten übereinstimmen und (B) jeglicher Kosteneinsparungen in jeglichem Einzelposten des Budgets oder jeglicher
Budgetkategorie, die bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt erzielt wurden,

(2) jegliche Ausgaben unvorhergesehener Beträge in dem Betriebsbudget, unter Angabe des Betrages und des Einzel-

postens des Betriebsbudgets, dem die Ausgaben zugeordnet wurden, und jeglichen Kostenausgleich unter Angabe des
Betrages und des Einzelpostens des Betriebsbudgets, dem der Ausgleich zugeordnet wurde;

79791

(3) jegliche Mehrkostenzahlungen, die bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorgenommen wurden, unter Angabe des Be-

trages und des Einzelpostens des Betriebsbudgets, auf die sich die Mehrkostenzahlung bezieht; und

(4) jegliche Abweichungen von dem Betriebsbudget oder Geschäftsplan.
Der Geschäftsführerrat legt den Gesellschaftern jegliche Berichte und Budgets vor, die er im Rahmen eines jeglichen

Hotelführungsvertrags, den die Gesellschaft abschließt (der "Hotelführungsvertrag"), und die er im Rahmen eines jeglichen
Immobilienführungsvertrags welche die Gesellschaft abschließt (der Immobilienführungsvertrag ), erhält, und kann auf
diese Berichte und Budgets verweisen. Im Falle von Streitigkeiten bezüglich der Berichte oder Budgets, die im Rahmen
des Hotelführungsvertrags und Immobilienführungsvertrags vorzulegen sind, informiert der Geschäftsführerrat die Ge-
sellschafter unverzüglich darüber."

Demnach, wird nach der Einfügung eines neuen Artikels 15, der frühere Artikel 15 zum neuen Artikel 16, der frühere

Artikel 16 zum neuen Artikel 17 und der frühere Artikel 17 zum neuen Artikel 18.

<i>Elfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, einen neuen Artikel 19 (neue Nummerierung) in die Gesellschaftssatzung einzufü-

gen, der wie folgt lauten soll:

"Die Hauptversammlung der Gesellschafter ist nur beschlussfähig, wenn das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist.

Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dürfen die anwesenden Gesellschafter keine anderen Beschlüsse fassen als den
Beschluss, die Hauptversammlung auf ein anderes Datum zu verlegen, das von den anwesenden Gesellschaftern festgelegt
wird, aber mindestens fünf (5) Tage nach dem Datum der vertagten Versammlung sein muss. Die neu einberufene Ver-
sammlung muss an dem gleichen Ort und zu der gleichen Tageszeit wie die ursprüngliche Versammlung stattfinden.

Die Mitteilungen einer solchen Vertagung sowie das Datum, der Zeitpunkt und der Ort, an dem die Versammlung

stattfinden soll, werden den Gesellschaftern innerhalb von fünf Tagen ab dem Beschluss der Vertagung zugeschickt.

Die neu einberufene Versammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten ist."

<i>Zwölfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, folgenden Satz in den Artikel 20 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung

einzufügen:

"Beschlüsse in Bezug auf die Ausgabe von Anteilen durch die Gesellschaft und Entscheidungen über den Erwerb von

Beteiligungen erfordern die einstimmige Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, vorausgesetzt, dass kei-
ne Zustimmung eines Gesellschafters, der es unterließ, die von der Gesellschaft erforderte Kapitaleinlage zu machen, für
die Ausgabe von Anteilen notwendig ist."

<i>Dreizehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, einen neuen Artikel 21 (neue Nummerierung) in die Gesellschaftssatzung einzufü-

gen, der wie folgt lauten soll:

"Die Geschäftsführer ergreifen keine Maßnahmen, machen keine Auslagen und gehen keine Verpflichtungen ein in

Bezug auf die unten stehenden Angelegenheiten, es sei denn diese spezifischen Maßnahmen oder Ausgaben sind in einem
Geschäftsplan oder Betriebsbudget enthalten, die von der Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt werden oder
anderweitig von der Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt oder vorgeschlagen wurden:

(i)  der  Erwerb,  der  Verkauf,  die  Übertragung,  der  Tausch,  die  Verpfändung,  die  Finanzierung,  die  Beleihung  oder

Belastung des gesamten oder eines Teils einer Immobilie;

(ii)  die  Festlegung  der  Bedingungen  für  alle  Gesellschaftsanleihen  und  Bestimmung  der  Identität  des  Kreditgebers,

jeglicher Beschluss genehmigte Kreditdokumente abzuändern sowie die Gewährung von Garantien oder Entschädigungen
durch die Gesellschaft;

(iii) die Genehmigung eines jeden Geschäftsplans und Betriebsbudgets sowie jegliche Änderungen dieser Dokumente;
(iv) Gründung von Kapitalreserven oder Betriebsreserven der Gesellschaft, die nicht in dem jeweils aktuellen Be-

triebsbudget vorgesehen sind;

(v) die Verursachung von Kosten oder die Übernahme von Verpflichtungen durch oder für die Gesellschaft, die 110%

des anwendbaren Einzelpostens in dem jeweils aktuellen Betriebsbudget überschreiten; wenn allerdings dringende Re-
paraturen  an  einer  Immobilie  notwendig  sind,  um  eine  drohende  Gefahr  der  Beschädigung  einer  Immobilie  oder
Verletzungsgefahren für Personen zu vermeiden, kann der Geschäftsführerrat solche Ausgaben machen, die notwendig
sind, um die Situation zu verbessern, wobei der Geschäftsführerrat unverzüglich die Hauptversammlung der Gesellschafter
über den Vorfall, der solche Reparaturarbeiten und die getroffenen Maßnahmen verursacht hat, informiert;

(vi) jegliche Auszahlungen an die Gesellschafter oder jegliche Zahlungen im Rahmen von Gesellschafterkrediten;
(vii) die Genehmigung von Mietverträgen (oder Änderungen oder Erweiterungen von bestehenden Mietverträgen)

gemäß derer mehr als 500 m2 einer Immobilie vermietet werden oder die jährliche Mieteinnahmen von über dreißigtau-
send  Euro  (EUR  30.000)  umfassen,  sowie  die  Beendigung  oder  Zustimmung  zur  Annullierung  oder  Abtretung  eines

79792

Mietvertrags, die nicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Mietvertrags erfolgen, oder der Nachlass oder
die Freigabe eines Mietabkommens oder einer Forderung;

(viii) die Genehmigung jeglicher Verträge mit Drittparteien, die nicht in dem Geschäftsplan oder Betriebsbudget ent-

halten sind und jährliche Zahlungen von insgesamt mehr als zehntausend Euro (EUR 10.000) umfassen;

(ix) Entscheidungen bezüglich wichtiger Preiskalkulationen für die Immobilien;
(x) die Festlegung der Bilanzierungsregeln einschließlich der Auswahl von Abschreibungstabellen, Buchhaltungsverfah-

ren  und  des  Treffens  von  unterschiedlichen  Entscheidungen  in  Bezug  auf  die  Handhabung  und  die  Zuteilung  von
Transaktionen für Einkommensteuer, Lizenzgebühren oder andere Steuerzwecke;

(xi) die Auswahl von Banken für die Einzahlung des Gesellschaftsvermögens und Bestimmung der Personen, die be-

vollmächtigt sind, dieses Vermögen abzuheben;

(xii) das Ergreifen gerichtlicher Maßnahmen und die Entscheidung ein Gerichtsverfahren, das Kosten in Höhe von mehr

als einhunderttausend Euro (EUR 100.000) mit sich bringt, einzuleiten;

(xiii) die Auswahl von Anwälten, Buchhaltern, Ingenieuren, Umweltberatern und anderen Fachleuten für die Immobilien

oder die Gesellschaft;

(xiv) die Bekanntmachung von vertraulichen Informationen und die Herausgabe einer Pressemitteilung in Bezug auf die

Tätigkeiten der Gesellschaft und ihrer Filialen;

(xv) die Verlegung der Verwaltung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg;
(xvi) jegliche Änderung des Geschäftsbereiches der Gesellschaft, die das Hauptaugenmerk der Tätigkeiten der Gesell-

schaft weg von dem in der Satzung der Gesellschaft genannten Gesellschaftszweck richtet;

(xvii) jeglicher Vertrag mit, jegliche Wahl, Genehmigung, Vereinbarung und jeglicher Verzicht auf Rechte zu Gunsten

von oder jegliches Geschäft mit (i) den Gesellschaftern die Anteile der Klasse B halten oder mit Dahlem Property I B.V.,
(ii) jeglichen anderen Personen, die diese Person kontrollieren, von ihr kontrolliert werden oder mit ihr unter gemein-
samer Kontrolle stehen, (iii) jeglichem Geschäftsführer, Direktor, Mitarbeiter, Angestellten oder Partner dieser Person
oder jeglicher Person, die in den oben stehenden Punkten (i) oder (ii) beschrieben ist, oder (iv) jeglichem direkten Fa-
milienmitglied einer in den oben stehenden Punkten (i), (ii) und (iii) beschriebenen Person;

(xviii) die Ausübung der Rechte der Gesellschafter in Filialen, einschließlich der Gesellschafterzustimmungen, insofern

diese für eine Filiale von gleicher oder ähnlicher Bedeutung sind wie jegliche Angelegenheit, die unter Punkt (i) bis (xvi)
in Bezug auf die Gesellschaft genannt werden.

Als Folge der Einfügung eines neuen Artikels 19, und eines neuen Artikels 21, wird der frühere Artikel 19 zum neuen

Artikel 22, der frühere Artikel 20 zum neuen Artikel 23, der frühere Artikel 21 zum neuen Artikel 24, der frühere Artikel
22 zum neuen Artikel 25 und der frühere Artikel 23 zum neuen Artikel 26.

<i>Vierzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Artikel 26 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung abzuändern, der

von nun an wie folgt lauten soll:

"Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen eines Gesellschaftervertrags und der folgenden Bestimmungen zur freien Verfügung:

Im Falle einer Veräußerung, d.h. eines Verkaufs, in einer einzelnen Transaktion oder in mehreren Transaktionen, an

einen oder mehrere Drittkäufer gegen einen Barbetrag, (i) der Immobilien oder einer einzelnen, (ii) einer Mehrheitsbe-
teiligung  in  den  Filialen  der  Gesellschaft  oder  in  einer  einzelnen  von  ihnen  (iii)  im  Anschluss  an  den  Verkauf  einer
Mehrheitsbeteiligung gemäß Punkt (ii) (jedoch nicht aller Anteile an den Filialen der Gesellschaft oder an einer ihrer
Filialen) der Verkauf von weiteren Anteilen an den Filialen der Gesellschaft oder an einer von ihnen, unter der Voraus-
setzung, dass (x), um Missverständnisse auszuschließen, wenn die Immobilien oder eine Mehrheitsbeteiligung in den Filialen
der Gesellschaft an mehr als einen Drittkäufer in mehr als einer Transaktion verkauft wird, die Veräußerung die Ge-
samtheit aller Verweise auf solche Verkäufe bedeutet und zu dem Zeitpunkt des letzten Verkaufs eintritt, und (y) eine
Mehrheitsbeteiligung an den Filialen der Gesellschaft der Besitz, direkt oder indirekt, von mehr als fünfzig Prozent (50%)
des Gesellschaftskapitals solcher Gesellschaften bedeutet, haben die Anteile der Klasse B wie folgt Anrecht auf eine
Vorzugsdividende:

(i) Zunächst, einhundert Prozent (100%) der Einnahmen, wie in dem Gesellschaftervertrag definiert, an die Gesell-

schafter bis der Gesamtbetrag der Einnahmen, der von den Gesellschaftern erhalten wurde, dem Gesamtbetrag der
Kapitaleinlagen und Gesellschafterkredite, die von den Gesellschaftern gemacht wurden, entspricht;

(ii) Zweitens, einhundert Prozent (100%) der Einnahmen an die Gesellschafter solange bis die Gesellschafter, die die

Anteile der Klasse A halten, zwanzig Prozent (20%) einer internen Ertragsrate erhalten haben, wie in dem Gesellschaf-
tervertrag definiert;

(iii) Drittens, fünfundachtzig Prozent (85%) der Einnahmen an die Gesellschafter und fünfzehn Prozent (15%) an die

Gesellschafter, die die Anteile der Klasse B halten, solange bis die Gesellschafter, die die Anteile der Klasse A halten,
fünfundzwanzig Prozent (25%) einer internen Ertragsrate erhalten haben;

79793

(iv) Viertens, achtzig Prozent (80%) der Einnahmen an die Gesellschafter und zwanzig Prozent (20%) an die Gesell-

schafter, die die Anteile der Klasse B halten, solange bis die Gesellschafter, die die Anteile der Klasse A halten, dreißig
Prozent (30%) einer internen Ertragsrate erhalten haben; und

(v) Anschließend fünfundsiebzig Prozent (75%) der Einnahmen an die Gesellschafter und fünfundzwanzig Prozent (25%)

an die Gesellschafter, die die Anteile der Klasse B halten;

vorausgesetzt, um Missverständnisse auszuschließen, dass die vorhergehende Bestimmung nur für die Berechnung der

Vorzugsdividende anwendbar ist und dass kein Gesellschafter und keine andere Person durch diese Bestimmung irgend-
welche Rechte erhält.

Als Folge eines Verkaufs der gesamten Immobilien und falls die Vorzugsdividende höher ist als der Betrag, der gesetzlich

zur Ausschüttung zur Verfügung steht, zahlt die Gesellschaft den Inhabern der Anteile der Klasse B den Anteil der Vor-
zugsdividende, der gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden darf, und der Restbetrag der
Vorzugsdividende wird am Datum des von den beiden nachstehenden Ereignissen zuerst stattfindenden Ereignisses aus-
gezahlt: (i) am Datum des nächsten Verkaufsabschlusses, wobei der Restbetrag der Vorzugsdividende zunächst an die
Inhaber der Anteile der Klasse B ausgezahlt wird, bevor jegliche zusätzliche Vorzugsdividende an die Inhaber der Anteile
der Klasse B an diesem Datum ausgezahlt wird, oder (ii) zum Zeitpunkt der Liquidierung der Gesellschaft.

Die Inhaber der Anteile der Klasse A können durch schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Anteile der Klasse B den

Anspruch dieser Gesellschafter auf die Vorzugsdividende in folgenden Fällen aufheben: (i) bei dem Auftreten eines in
Absatz 10.2 (c) (i), (iii) und (iv) des Hotelführungsvertrag beschriebenen Ereignisses, (2) bei erheblichen Verletzungen der
in Artikel VIII des Gesellschaftervertrags beschriebenen Verpflichtungen durch einen Inhaber der Anteile der Klasse B,
(3) bei einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse in Bezug auf die Nießbrauchberechtigung und die Kapitalbeteiligung
unter den Inhabern der Anteile der Klasse B oder des Geschäftsführers im Rahmen des Hotelführungsvertrags, und, falls
entschuldbar, wenn die Inhaber der Anteile B oder ihre Filialen es versäumt haben, innerhalb von fünfzehn Werktagen
ab dem Datum der schriftlichen Mitteilung, die den Inhabern der Anteile der Klasse B durch die Inhaber der Anteile der
Klasse A zugestellt wird und bestätigt, dass die Inhaber der Anteile der Klasse B oder ihre Filialen gegen den Gesellschaf-
tervertrag, den Hotelführungsvertrag oder Immobilienführungsvertrag verstoßen haben, und Abhilfemaßnahmen verlangt,
diesen Verstoß zu beheben. Nach der Zustellung einer solchen schriftlichen Mitteilung wird das Anrecht der Inhaber der
Anteile der Klasse B auf eine Vorzugsdividende unverzüglich aufgehoben und sowohl die Pflichten der Gesellschaft als
auch die Pflichten der Inhaber der Anteile der Klasse A in diesem Zusammenhang sind aufgehoben."

<i>Fünfzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt einen neuen Artikel 27 (neue Nummerierung) in die Gesellschaftssatzung einzufü-

gen, der wie folgt lauten soll:

"Abschlagsdividenden werden unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet:
(i) der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Ge-

sellschafter genehmigt;

(ii) die Abschlagsdividenden werden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Erstellung durch die Geschäftsführung

der Zwischenbilanz, aus der hervorgeht, dass ausreichend Gewinne zur Verteilung zur Verfügung stehen, ausgeschüttet;

(iii) die Vorzugsdividende, auf die die Inhaber der Anteile der Klasse B Anrecht haben, muss berücksichtigt werden;
(iv) die Entscheidung Abschlagsdividenden auszuschütten wird von der Hauptversammlung der Gesellschafter getrof-

fen.

Falls die ausgeschüttete Abschlagsdividende höher ist als der Betrag, der schließlich laut der Hauptversammlung der

Gesellschafter zur Verteilung unter den Gesellschaftern zur Verfügung steht, wird der Überschuss nicht als Abschlagsdi-
vidende betrachtet, sondern als eine unverzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.

Die oben stehenden Bestimmungen berühren nicht das Recht der Hauptversammlung der Gesellschafter, zu jedem

Zeitpunkt übertragene Gewinne aus dem vorherigen Geschäftsjahr oder Beträge aus den Konten für verteilbare Reserven
an die Gesellschafter zu verteilen."

Als Folge der Einfügung eines neuen Artikels 27, wird der frühere Artikel 24 zum neuen Artikel 28 und der frühere

Artikel 25 zum neuen Artikel 29.

<i>Sechszehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den zweiten Absatz des neuen Artikels 28 wie folgt abzuändern:
"Insofern es keine anderslautende einstimmige Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern gibt, wird der nach Beglei-

chung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem
ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt, und zwar unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesellschaftervertrags
und folgender Bestimmungen: die Anteile der Klasse B haben Anrecht auf eine Vorzugsdividende bei einer Liquidation,
unter den Bedingungen, die auch die Ausschüttung einer Vorzugsdividende regeln und in Artikel 26 beschrieben sind."

<i>Siebzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den neuen Artikel 29 wie folgt abzuändern:

79794

"Für alle Punkte, die nicht durch diese Satzung oder durch die Bestimmungen eines Gesellschaftervertrages, der mög-

licherweise zwischen den Gesellschaftern abgeschlossen wurde, geregelt werden, verweisen die Erschienenen auf die
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

Im Falle von Abweichungen zwischen der vorliegenden Satzung und dem Gesellschaftervertrag ist der Gesellschafter-

vertrag im Hinblick auf Angelegenheiten zwischen den Gesellschaftern maßgebend."

<i>Achtzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Rücktritt von BRE/Management S.A. von ihrem Mandat als alleinige Geschäfts-

führerin der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzunehmen.

Die Hauptversammlung beschließt, BRE/Management S.A. für die Erfüllung ihres Mandates voll zu entlasten.

<i>Neunzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf vier festzulegen.

<i>Zwanzigster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, folgende Personen mit sofortiger Wirkung und für einen unbestimmten Zeitraum

zu Geschäftsführern der Gesellschaft zu ernennen:

- Herrn Anders Braks, Jurist, geboren am 21. September 1959 in Landskrona (Schweden), wohnhaft in 41, Am Bota-

nischen Garten, 50668 Köln, (Deutschland),

- Herrn Robert Simon, director, geboren am 20. Februar 1929 in Wiesbaden (Deutschland), wohnhaft in 28, rue JP

Brasseur, L-1258 Luxembourg,

- Frau Cornelia M.W. van den Broek, director, geboren am 26. Juni 1968 in Oosterhout (Niederlande), mit Berufsad-

resse in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,

- Herrn Gary Summers, verwaltender Geschäftsführer, geboren am 12. Dezember in New York, Vereinigte Staaten

von Amerika, wohnhaft in 888 Park Avenue, Apt. 11#, New York, NY 10021, Vereinigte Staaten von Amerika.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, haben die Erschienenen mit dem Notar ge-

genwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. SONDHI und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29870. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 28. Juli 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009102378/795.
(090122856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

BRE/Neuss Hotel Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 127.441.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth of July,
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

BRE/German Hotel Holding III S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 127.442, with a share capital of EUR 12,500,

here represented by Ms Patricia Sondhi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given

on 15 July 2009, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

and

79795

Art European Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 18-24, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 128.211, with a share capital of EUR 12,500,

here represented by Ms Patricia Sondhi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given

on 13 July 2009, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties are the shareholders of the Company, representing the entire share capital (the "Shareholders")

of BRE/Neuss Hotel Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary on 16 April 2007, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations
number 1260 of 25 June 2007, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number
127.441 (the "Company") and have required the undersigned notary to state his declarations as follows:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of the purpose of the Company and of article 2 of the Company's articles of association which shall

henceforth have the following wording:

"The purpose of the Company is the acquiring, improving, operating and disposing of the Swisshotel Neuss (the "Pro-

perty").

The purpose of the Company is furthermore the holding of participations, in any form whatsoever, in the Luxembourg

private limited liability company BRE/Neuss I Hotel S.à r.l., and in the German limited liability company BRE/Neuss Ope-
rations GmbH (each a "Subsidiary" and all together the "Subsidiaries"), the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of the above-mentioned companies.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the above-mentioned companies and their direct

and indirect subsidiaries.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment of its purpose.

In particular, the Company will provide the above-mentioned companies and their direct and indirect subsidiaries with

the services necessary to their administration, control and development. For that purpose the Company may require and
retain the assistance of other advisors.";

2. Creation of two classes of shares and replacement of the existing 500 shares of the Company by 450 shares of Class

A and 50 shares of Class B;

3. Amendment of article 9, paragraph 1 of the articles of association of the Company;
4. Amendment of article 12 of the articles of association of the Company;
5. Amendment of article 13, paragraph 1, sentence 1 of the articles of association of the Company;
6. Amendment of article 13, paragraph 7 of the articles of association of the Company;
7. Amendment of article 13, paragraph 8 of the articles of association of the Company;
8. Amendment of article 13, paragraph 9 of the articles of association of the Company;
9. Amendment of article 14 of the articles of association of the Company;
10. Insertion of a new article 15 in the articles of association of the Company;
11. Insertion of a new article 19 in the articles of association of the Company;
12. Insertion of a supplemental sentence to article 20 (new numbering) in the articles of association of the Company;
13. Insertion of a new article 21 in the articles of association of the Company in relation to reserved matters of the

shareholders;

14. Amendment of article 26 (new numbering) of the articles of association of the Company in relation to the creation

of a preference dividend;

15. Insertion of a new article 27 (new numbering) in the articles of association of the Company in relation to the

creation of the possibility to pay interim dividends;

16. Amendment of article 28 (new numbering) of the articles of association of the Company in relation to the creation

of a preference liquidation dividend;

17. Amendment of article 29 (new numbering) of the articles of association of the Company;
18. Resignation of the sole manager, BRE/Management S.A. and granting full discharge;
19. Fixing of the number of the managers at four;
20. Appointment of new managers and;
21. Miscellaneous;

79796

II. - That the entire share capital being represented at the present meeting and the general meeting represented

declaring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.

Then the general meeting (the "General Meeting") takes the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolved to amend article 2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth

have the following wording:

"The purpose of the Company is the acquiring, improving, operating and disposing of the Swisshotel Neuss (the "Pro-

perty").

The purpose of the Company is furthermore the holding of participations, in any form whatsoever, in the Luxembourg

private limited liability company BRE/Neuss I Hotel S.à r.l. and in the German limited liability company BRE/Neuss Ope-
rations GmbH (each a "Subsidiary" and all together the "Subsidiaries"), the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of the two above-mentioned companies.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the above-mentioned companies and their direct

and indirect subsidiaries.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment of its purpose.

In particular, the Company will provide the above-mentioned companies and their direct and indirect subsidiaries with

the services necessary to their administration, control and development. For that purpose the Company may require and
retain the assistance of other advisors."

<i>Second resolution

The General Meeting resolved to create two classes of shares and to convert the existing five hundred (500) shares

with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, into four hundred fifty (450) shares of Class A with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each and fifty (50) shares of Class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The shares of Class A and the shares of Class B have the same rights and obligations except as stated to the contrary

in the articles of association of the Company.

The General Meeting notes that as a consequence, the four hundred fifty (450) shares of Class A and the fifty (50)

shares of Class B are held as follows:

- four hundred fifty (450) shares of Class A are held by BRE/German Hotel Holding III S.à r.l.; and
- fifty (50) shares of Class B are held by Art European Investments S.à r.l.

<i>Third resolution

The General Meeting resolved to amend article 9, paragraph 1 of the articles of association of the Company, which

shall henceforth have the following wording:

"The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, no shareholder may, directly or indi-

rectly, assign, sell, exchange, transfer, pledge or otherwise dispose of all or any part of the shares he holds in the Company
to any third party without obtaining the prior consent of the shareholders representing three quarters of the share capital
of  the  Company.  Such  transfer  may  only  be  performed  to  a  transferee  who  has  given  prior  to  the  transfer  written
acceptance and adoption of all terms and conditions of any shareholders agreement which may have been entered into
between the shareholders (the "Shareholders Agreement")."

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolved to amend article 12 of the articles of association of the Company, which article shall

henceforth have the following wording:

"The Company is managed by at least three managers.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two members of the board of managers.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument."

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolved to amend article 13, paragraph 1, sentence 1, of the articles of association of the

Company, which shall henceforth have the following wording:

"The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman."

79797

<i>Sixth resolution

The General Meeting resolved to add the following sentence to article 13, paragraph 7, of the articles of association

of the Company:

"If any manager is prevented from participating in a meeting or a vote of the board of managers, he may request that

the matter be discussed or voted again in his presence."

<i>Seventh resolution

The General Meeting resolved to add the following sentence to article 13, paragraph 8, of the articles of association

of the Company:

"No decisions shall be taken as to matters falling into the field of responsibility of any absent manager unless such

decision would be necessary in order to avoid negative consequences for the Company."

<i>Eighth resolution

The General Meeting resolved to amend article 13, paragraph 9, of the articles of association of the Company, which

shall henceforth have the following wording:

"Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. Any decisions

not being passed unanimously shall without delay be brought to the attention of the shareholders meeting which will
resolve upon the matter at a majority of shares present or represented."

<i>Ninth resolution

The General Meeting resolved to add the following sentence to article 14 of the articles of association of the Company:
"All managers shall receive copies of the minutes."

<i>Tenth resolution

The General Meeting resolved to insert a new article 15 in the articles of association of the Company, which shall have

the following wording:

"The board of managers has to report regularly to the shareholders meeting on the conduct of the business and on

any other matters requested by the shareholders meeting.

The board of managers shall on or before November 15th of each year prepare and submit to the shareholders meeting

for approval a proposed business plan for the ensuing calendar year. The business plan shall include, without limitation,
each of the following items containing the most current information with regard thereto then available: (i) a comprehensive
survey of the market in which the Property is competing, (ii) a detailed description of the renovation, refurbishment,
maintenance, repair and management of the Property; including without limitation, any planned or required improvements
to the Property, (iii) a pro forma income and expense statement for the Property over the entire anticipated term of
ownership by the Company, but not less than five years, (iv) a detailed operating budget, as defined in the Shareholder
Agreement and (v) a detailed marketing report.

Not later than twenty (20) days after receipt by the shareholders meeting of the proposed business plan (or such

longer period as any shareholder may reasonably request by notice to the board of managers), the shareholders holding
the shares of Class A may deliver a notice to the board of managers stating that such shareholder objects to any infor-
mation contained in or omitted from such business plan and setting forth the nature of such objection. Upon receipt of
such notice, the board of managers shall within five (5) days modify the proposed business plan and resubmit it to the
shareholders meeting for the shareholders meeting's approval. Within ten (10) days of receipt of the resubmitted business
plan, the shareholders holding the shares of Class A may deliver a further objection notice (in which event the resubmission
and review process described above shall continue until the business plan in question is accepted and consented to by
the shareholders meeting). Notwithstanding anything to the contrary set forth herein, the shareholders meeting shall
have the right at any time subsequent to the acceptance and consent with respect to any business plan, by notice to the
board of managers, to revise such business plan or to request that the board of managers prepare for the shareholders
meeting's approval a revised business plan, taking into account such circumstances as the shareholders meeting deems
appropriate, provided, however, the revision of a business plan shall not be deemed a revocation of the board of managers
authority with respect to such actions that the board of managers may have already taken prior to such revision in
implementing such business plan, and the board of managers shall, with the prior approval of the shareholders meeting
(which approval shall not be unreasonably withheld), have the right to complete such transactions to which the board of
managers has already been committed.

If a business plan for any calendar year has not been approved by January 1st of that year, the Company shall continue

to operate under the business plan for the previous year until a new business plan is approved by the shareholders meeting,
with such adjustments to the operating budget contained therein as may be necessary to reflect approved contracts or
leases, deletion of non recurring expense items set forth on the previous operating budget and increased insurance costs,
taxes, utility costs, and debt service payments.

79798

The Company shall operate under annual operating budgets which shall be prepared and submitted by the board of

managers to the shareholders meeting for approval. The board of managers shall implement each operating budget on
behalf of the Company and may incur the expenditures and obligations therein provided.

The board of managers shall submit to the shareholders meeting, within fifteen (15) days after the end of each month,

a monthly update of the then-applicable operating budget and the business plan, so as to inform the shareholders meeting
of:

(1) any variances from the operating budget or the business plan, including (A) cost overruns in any line item in the

operating budget to date, or any unforeseen costs or expenses which may have arisen and which, when added to all other
costs and expenses, will cause the operating budget total (or any operating budget category or line item) to be exceeded
or, otherwise cause budgeted results to differ from actual results and (B) any cost savings in any operating budget line
item or budget category realized to date;

(2) all expenditures under any contingency amounts in the operating budget showing the amount and operating budget

line item to which said expenditure was made, and all applications to date of cost offsets showing the amount and operating
budget line item to which such application was made;

(3) all cost overrun payments made to date, showing the amount and operating budget line item to which such cost

overrun payment was applied; and

(4) any variances from the operating budget or the business plan.
The board of managers shall submit to the shareholders any reports and budgets received under any hotel management

agreement which may be entered into by the Company (the "Hotel Management Agreement") and may refer to these
reports and budgets. In case of disputes on reports and budgets to be provided under the Hotel Management Agreement,
the board of managers shall inform the shareholders thereof without delay."

Thus, after the insertion of a new article 15, the former article 15 becomes the new article 16, the former article 16

becomes the new article 17 and the former article 17 becomes the new article 18.

<i>Eleventh resolution

The General Meeting resolved to insert a new article 19 (new numbering) in the articles of association of the Company,

which shall have the following wording:

"The general meeting of shareholders shall not validly deliberate unless the entire share capital of the Company is

represented. If this condition is not satisfied, the shareholder(s) present may not pass any resolutions other than ad-
journing such meeting to the same time of the day and place on a date as determined by the shareholder(s) present, which
date shall be at least five days following the date of the adjourned meeting.

Notice of such adjournment and the reconvened meeting date, time and place shall be sent to the shareholders within

five days of such adjournment.

The reconvened meeting shall not validly deliberate unless at least half of the share capital of the Company is repre-

sented."

<i>Twelfth resolution

The General Meeting resolved to add the following sentence to article 20 (new numbering) of the articles of association

of the Company:

"Resolutions  for  the  issuance  of  shares  by  the  Company  and  decisions  on  the  acquisition  of  investments  require

unanimous consent of the general meeting of shareholders provided that no consent of a shareholder who failed to make
the capital contribution required by the Company is required for the issuance of shares."

<i>Thirteenth resolution

The General Meeting resolved to insert a new article 21 (new numbering) in the articles of association of the Company

which shall have the following wording:

"No action shall be taken, sum expended, or obligation incurred by any manager regarding the matters described below

unless such specific action or expenditure is included in a business plan or operating budget approved by the shareholders
meeting or otherwise has been approved or proposed by the shareholders meeting:

(i) the acquisition, sale, transfer, exchange, mortgage, financing, hypothecation or encumbrance of all or any part of

the Property;

(ii) the determination of the terms and conditions of all Company borrowings and the identity of the lender thereof,

any determination to amend any approved loan documents, and the granting of any guaranties or indemnities by the
Company;

(iii) the approval of each business plan and operating budget, and any amendments thereto;
(iv) establishing any capital or operating reserves of the Company, other than as set forth in the then-current operating

budget;

(v) the making of any expenditure or incurrence of any obligation by or for the Company in excess of 110% of the

applicable line item in the then-current operating budget; however, if emergency repairs to the Property are necessary

79799

to avoid imminent danger of injury to the Property or to an individual, the board of managers may make such expenditures
as may be necessary to alleviate such situation and shall promptly notify the shareholders meeting of the event giving rise
to such repairs and the actions taken with respect thereto;

(vi) the making of any distributions to shareholders or of any payments under shareholder loans;
(vii) the approval of any lease (or amendment or extension of any existing lease) demising more than 500 net rentable

square meters of space in the Property or providing for annual rental income in excess of thirty thousand Euro (EUR
30,000.-) or the termination or acceptance of cancellation or surrender of any lease other than in accordance with the
terms of the lease or the forgiveness or release of any lease covenant or requirement;

(viii) the approval of any third party agreements not included in the business plan or operating budget providing for

annual payment in excess of ten thousand Euro (EUR 10,000.-) in the aggregate;

(ix) material pricing decisions regarding the Property;
(x) the determination of accounting policies, including selection of depreciation schedules, accounting methods and

making various decisions regarding treatment and allocation of transactions for income tax, franchise or other tax pur-
poses;

(xi) the selection of banks for deposit of Company funds, and the designation of persons with signatory authority over

withdrawal of such funds;

(xii) the taking of any legal action and any determination to settle any legal action involving in excess of one hundred

thousand Euro (EUR 100,000);

(xiii) the selection of attorneys, accountants, engineers, environmental consultants, or other professionals for the

Property or the Company;

(xiv) the disclosure of confidential information and the issuance of any press release regarding the activities of the

Company and its Subsidiaries;

(xv) moving the administration of the Company outside the Grand Duchy of Luxembourg;
(xvi) any change in the business of the Company which takes the focus of the Company's business away from the

corporate purpose specified in the articles of association of the Company;

(xvii) any agreement entered into with, any elections, consents, acknowledgments and waiver of rights given towards,

or any business passed with (i) the shareholders holding the shares of Class B or with Art Management S.à r.l., (ii) any
other person who controls, is controlled by or is under common control with such person, (iii) any manager, director,
officer, partner or employee of such person or any person specified in clause (i) or (ii) above or (iv) any immediate family
member of any person specified in clause (i), (ii) or (iii) above;

(xviii) the exercise of shareholder rights of the Company in the Subsidiaries, including shareholder approvals, insofar

as they are of the same or similar importance to the Subsidiaries as any of the matters referred to under items (i) through
(xvi) with respect to the Company.

As a result of the insertion of a new article 19 and a new article 21, the former article 19 becomes the new article 22,

the former article 20 becomes the new article 23, the former article 21 becomes the new article 24, the former article
22 becomes the new article 25 and the former article 23 becomes the new article 26.

<i>Fourteenth resolution

The General Meeting resolved to amend article 26 (new numbering) of the articles of association of the Company,

which shall henceforth have the following wording:

"Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders subject to the
provisions of a shareholder agreement and the following provisions:

In case of a disposal, i.e. a sale, in a single transaction or multiple transactions, to one or more third party purchasers

for cash of (i) the entirety of the Property, (ii) a controlling interest in the Company's Subsidiaries or any of them (iii)
following the sale of a controlling interest under (ii) hereof (but not all of the shares in the Company's Subsidiaries or
any of them) the sale of further shares in the Company's Subsidiaries or any of them, provided, that (x) for avoidance of
doubt, if the Property or the controlling interest in the Company's Subsidiaries is sold to more than one third party
purchaser or in more than one transaction, the disposal means the collective reference to all such sales and shall be
deemed to occur on the last of such sales, and (y) a controlling interest in the Company's Subsidiaries shall mean ow-
nership, directly or indirectly, of more than fifty per cent (50%) of the share capital of such companies, the shares of Class
B are entitled to a preference dividend as follows:

(i) First, one hundred per cent (100%) of the proceeds, as defined in the Shareholders Agreement, to the shareholders

until the aggregate amount of the proceeds received by the shareholders is equal to the aggregate capital contributions
and shareholders loans made by the shareholders;

(ii) Second, one hundred per cent (100%) of the proceeds to the shareholders until such time as the shareholders

holding the shares of Class A have received a twenty per cent (20%) internal rate of return, as defined in the Shareholders
Agreement;

79800

(iii) Third, eighty-five per cent (85%) of the proceeds to the shareholders and fifteen per cent (15%) to the shareholders

holding the shares of Class B until such time as the shareholders holding the shares of Class A have received a twenty-
five per cent (25%) internal rate of return;

(iv) Fourth, eighty per cent (80%) of the proceeds to the shareholders and twenty per cent (20%) to the shareholders

holding the shares of Class B until such time as the shareholders holding the shares of Class A have received a thirty per
cent (30%) internal rate of return; and

(v) Thereafter, seventy-five per cent (75%) of the proceeds to the shareholders and twenty-five per cent (25%) to the

shareholders holding the shares of Class B;

provided that, for avoidance of doubt, the foregoing provision shall only be applicable for the purposes of calculating

the preference dividend and no shareholder or other person shall have any rights as a result of the foregoing provision.

As a result of a sale of the entirety of the Property and in the event that the preference dividend is higher than the

amount available for distribution under applicable laws, the Company will distribute to the shareholders holding the shares
of Class B that portion of the preference dividend that may be distributed under applicable laws and the balance of the
preference dividend will be distributed upon the earlier of (i) the next date of the completion of a disposal, whereupon
the balance of such preference dividend shall first be distributed to the shareholders holding the shares of Class B prior
to making any distributions of any additional preference dividend due to the shareholders holding the shares of Class B
on such date and (ii) the liquidation of the Company.

The shareholders holding the shares of Class A may by written notice to the shareholders holding the shares of Class

B terminate such shareholders' entitlement to the preference dividend upon (1) any material breach by the shareholder
holding the shares of Class B of their obligations under Article VIII of the Shareholders Agreement, (2) a change in majority
beneficial ownership and controlling interest in the shareholders holding the shares of Class B or the manager under the
Hotel Management Agreement, and, if capable of remedy, the shareholders holding the shares of Class B or any of their
affiliates have failed, within fifteen (15) business days of the date of a written notice served by the shareholders holding
the shares of Class A on the shareholders holding the shares of Class B confirming that the shareholders holding the
shares of Class B or their affiliates have breached materially the Shareholders Agreement or the Hotel Management
Agreement and requiring remedial action, to so remedy such breach. Upon service of such written notice the shareholders
holding the shares of Class B's entitlement to the preference dividend shall immediately terminate and neither the Com-
pany nor the shareholders holding the shares of Class A shall have any further obligations in this respect."

<i>Fifteenth resolution

The General Meeting resolved to insert a new article 27 (new numbering) in the articles of association of the Company

which shall have the following wording:

"Interim dividends may be paid subject to the following terms and conditions:
(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the general meeting

of the shareholders;

(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the management of interim

accounts showing that sufficient profits are available for such distribution;

(iii) the preference dividend to which the shares of Class B are entitled has to be respected;
(iv) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the shareholders.
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the shareholders according to the annual general

meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the shareholders.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of shareholders to distribute at any

moment to the shareholders any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts."

As a result of the insertion of a new article 27, the former article 24, becomes the new article 28 and the former

article 25 becomes the new article 29.

<i>Sixteenth resolution

The General Meeting resolved to change the second paragraph of new article 28 as follows:
"Unless the shareholders unanimously decide otherwise, the surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed

among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them subject to the provisions of the
Shareholders Agreement and the following provisions: the shares of Class B are entitled to a preference liquidation
dividend under the same terms and conditions than the preference dividend as organized in article 26."

<i>Seventeenth resolution

The General Meeting resolved to change the new article 29 as follows:

79801

"All matters not governed by these articles of incorporation and the terms and conditions of any shareholder agreement

that may have been entered into between shareholders shall be determined in accordance with the law of 10 August
1915 regarding commercial companies, as amended.

In case of divergence between these articles of incorporation and the Shareholders Agreement, the Shareholders

Agreement shall be prevailing among the shareholders of the Company."

<i>Eighteenth resolution

The General Meeting resolved to accept the resignation of BRE/Management S.A. from its duties as sole manager of

the Company with immediate effect:

The General Meeting resolved to grant full discharge to BRE/Management S.A. for the exercise of its mandate.

<i>Nineteenth resolution

The General Meeting resolved to fix the number of managers at four.

<i>Twentieth resolution

The General Meeting resolved to appoint with immediate effect for an indefinite period as new managers:
- Mr Anders Braks, jurist, born on 21 September 1959 in Landskrona (Sweden), residing at 41, Am Botanischen Garten,

50668 Köln, (Germany),

- Mr Robert Simon, director, born on 20 February 1929, in Wiesbaden (Germany) and residing at 28, rue JP Brasseur,

L-1258 Luxembourg,

- Mrs Cornelia M.W. van den Broek, director, born on 26 June 1968 in Oosterhout (the Netherlands), residing pro-

fessionally at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,

- Mr Gary Sumers, managing director, born on 12 December 1952 in New York, United States of America, residing

at 888 Park Avenue, Apt. 11#, New York, NY 10021, United States of America.

With no outstanding points on the agenda the chairman brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendneun, den sechzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

BRE/German Hotel Holding III S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach dem Recht

des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Ge-
sellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 127.442, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500,

hier vertreten durch Patricia Sondhi, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, durch privatschriftliche Vollmacht, erteilt am

15. Juli 2009, die nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben registriert zu werden,

Art European Investments S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach dem Recht des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 18-24, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 128.211, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500,

hier vertreten durch Patricia Sondhi, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, durch privatschriftliche Vollmacht, erteilt am

13. Juli 2009, die nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben registriert zu werden.

Die erschienenen Parteien sind die Gesellschafter der Gesellschaft und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital (die

"Gesellschafter") von BRE/Neuss Hotel Holding S.à r.l., einer société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, mit einem Gesell-
schaftskapital von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gegründet am 16. April 2007 gemäß einer Urkunde des
unterzeichneten Notars, die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1260 vom 25. Juni 2007
veröffentlicht wurde, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 127.441
(die "Gesellschaft") und ersuchen den unterzeichneten Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

79802

<i>Tagesordnung

1. Änderung des Gesellschaftszweckes und des Artikels 2 der Gesellschaftssatzung, der von nun an wie folgt lauten

soll:

"Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erneuerung, der Betrieb und der Verkauf des Swisshotel Neuss (die

"Immobilie").

Der Zweck der Gesellschaft ist zudem das Halten von Beteiligungen jeglicher Art, in der luxemburgischen Gesellschaft

mit beschränkter Haftung BRE/Neuss I Hotel S.à r.l., sowie in der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung BRE/
Neuss Operations GmbH (jede einzelne eine "Filiale" und alle zusammen die "Filialen"), der Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren jeglicher Art
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung der oben genannten Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann zudem den oben genannten Gesellschaften sowie ihrer direkten und indirekten Filialen Bürg-

schaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die oben genannten Gesellschaften sowie ihre direkten und indirekten Filialen mit

den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung versorgen. Zu diesem Zweck
kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen."

2. Einführung von zwei Anteilsklassen und Ersetzen der bestehenden 500 Anteile durch 450 Anteile der Klasse A und

50 Anteile der Klasse B;

3. Abänderung von Artikel 9, Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung;
4. Abänderung von Artikel 12 der Gesellschaftssatzung;
5. Abänderung von Artikel 13 Paragraph 1, Satz 1 der Gesellschaftssatzung;
6. Abänderung von Artikel 13, Paragraph 7 der Gesellschaftssatzung;
7. Abänderung von Artikel 13, Paragraph 8 der Gesellschaftssatzung;
8. Abänderung von Artikel 13, Paragraph 9 der Gesellschaftssatzung;
9. Abänderung von Artikel 14 der Gesellschaftssatzung;
10. Einfügung eines neuen Artikels 15 in die Gesellschaftssatzung;
11. Einfügung eines neuen Artikels 19 in die Gesellschaftssatzung;
12. Einfügung eines neuen Satzes in Artikel 20 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung;
13. Einfügung eines neuen Artikels 21 in die Gesellschaftssatzung für die Festlegung der Gesellschafter vorbehaltenen

Angelegenheiten;

14. Abänderung von Artikel 26 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung für die Schaffung einer Vorzugsdivi-

dende;

15. Einfügung eines neuen Artikels 27 in die Gesellschaftssatzung für die Einführung der Möglichkeit Abschlagsdivid-

enden auszuzahlen;

16. Abänderung des Artikels 28 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung für die Schaffung einer Vorzugsdivi-

dende im Falle der Liquidation;

17. Abänderung von Artikel 29 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung;
18. Abberufung und volle Entlastung des alleinigen Geschäftsführers, BRE/Management S.A.;
19. Festlegung der Anzahl der Geschäftsführer auf vier;
20. Ernennung neuer Geschäftsführer;
21. Verschiedenes.
II. Dass das gesamte Gesellschaftskapital bei der vorliegenden Versammlung vertreten ist und die vertretenen Gesell-

schafter  erklären,  dass  sie  vor  der  Versammlung  über  die  Tagesordnung  in  Kenntnis  gesetzt  wurden,  so  dass  keine
Einberufungsschreiben notwendig waren.

Die Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") fasst im Anschluss folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Artikel 2 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun an wie folgt lauten

wird:

"Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erneuerung, der Betrieb und der Verkauf des Swisshotel Neuss (die

"Immobilie").

Der Zweck der Gesellschaft ist zudem das Halten von Beteiligungen jeglicher Art, in der luxemburgischen Gesellschaft

mit beschränkter Haftung BRE/Neuss I Hotel S.à r.l. sowie in der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung BRE/
Neuss Operations GmbH (jede einzelne eine "Filiale" und alle zusammen die "Filialen"), der Erwerb durch Kauf, Zeichnung

79803

oder auf andere Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren jeglicher Art
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung der oben genannten Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann zudem den oben genannten Gesellschaften sowie ihrer direkten und indirekten Filialen Bürg-

schaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die oben genannten Gesellschaften sowie ihre direkten und indirekten Filialen mit

den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung versorgen. Zu diesem Zweck
kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen."

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, zwei Anteilsklassen einzuführen und die bestehenden fünfhundert (500) Anteile

mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) in vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A mit einem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) und in fünfzig (50) Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig Euro (EUR 25) umzuwandeln.

Die Anteile der Klasse A und die Anteile der Klasse B haben die gleichen Rechte und Pflichten, es sei denn die vor-

liegende Satzung sehe etwas anderes vor.

Die Hauptversammlung hält fest, dass die vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A und die fünfzig (50) Anteile

der Klasse B wie folgt gehalten werden:

- vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A werden von BRE/German Hotel Holding III S.à r.l. gehalten; und
- fünfzig (50) Anteile der Klasse B werden von Art European Investments S.à r.l. gehalten.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den ersten Absatz des Artikels 9 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun

an wie folgt lauten soll:

"Die Anteile der Gesellschaft können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Zuweisung, der Ver-

kauf, der Tausch, die Übertragung, die Verpfändung sowie jegliche andere Art der Veräußerung, sei es auf direkte oder
indirekte Art und Weise, aller oder eines Teils der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedürfen der vorherigen
Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Eine solche Übertragung kann lediglich
an einen Erwerber erfolgen, der vor der Übertragung sein schriftliches Einverständnis zu den Bestimmungen eines jeglichen
Gesellschaftervertrags, der möglicherweise zwischen den Gesellschaftern abgeschlossen wurde (der "Gesellschafterver-
trag"), gegeben hat."

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Artikel 12 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun an wie folgt lauten

soll:

"Die Gesellschaft wird von mindestens drei Geschäftsführern verwaltet.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, welche die Dauer ihres Mandates

bestimmt. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihrem Amt entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-

pflichtet.

Der Geschäftsführerrat kann Sondervollmachten durch notariell beglaubigte oder privatschriftliche Urkunde erteilen."

<i>Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den ersten Satz des ersten Absatzes von Artikel 13 der Gesellschaftssatzung ab-

zuändern, der von nun an wie folgt lauten soll:

"Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen

stellvertretenden Vorsitzenden."

<i>Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den folgenden Satz in dem siebten Absatz des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung

hinzuzufügen:

"Falls ein Geschäftsführer nicht an einer Versammlung oder an einer Beschlussfassung des Geschäftsführerrates teil-

nehmen  kann,  kann  dieser  verlangen,  dass  erneut  in  seiner  Anwesenheit  über  diese  Angelegenheit  diskutiert  und
abgestimmt wird."

<i>Siebter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den folgenden Satz in dem achten Absatz des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung

hinzuzufügen:

79804

"Es können keine Beschlüsse gefasst werden bezüglich Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich eines abwe-

senden Geschäftsführers fallen, es sei denn ein solcher Beschluss wäre notwendig, um negative Auswirkungen auf die
Gesellschaft zu vermeiden."

<i>Achter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den neunten Absatz des Artikels 13 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der nun

wie folgt lauten soll:

"Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Jegliche Beschlüsse, die nicht einstimmig gefasst wurden, werden
unverzüglich der Gesellschafterversammlung vorgelegt, die einen Beschluss bezüglich der jeweiligen Angelegenheit mit
einer Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile fasst."

<i>Neunter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den folgenden Satz in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung hinzuzufügen:
"Alle Geschäftsführer erhalten Kopien der Protokolle."

<i>Zehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt einen neuen Artikel 15 in die Gesellschaftssatzung einzufügen, der wie folgt lauten

soll:

"Der Geschäftsführerrat ist verpflichtet, der Hauptversammlung der Gesellschafter regelmäßig über die Führung der

Geschäfte und jegliche andere Angelegenheiten, die von der Hauptversammlung der Gesellschafter angefragt werden,
Bericht zu erstatten.

Der Geschäftsführerrat bereitet am oder vor dem 15. November eines jeden Jahres einen Entwurf des Geschäftsplans

für das folgende Kalenderjahr vor, den er der Hauptversammlung der Gesellschafter vorlegt. Der Geschäftsplan sollte
unter anderem jeden der folgenden Punkte und in Bezug auf diese Punkte die aktuellsten Informationen, insofern verfügbar,
umfassen: (i) eine umfassende Studie des Marktes, auf dem die Immobilie tätig ist, (ii) eine ausführliche Beschreibung der
Renovierung, Modernisierung, Wartung, Reparaturen und Verwaltung der Immobilie, einschließlich aber nicht ausschließ-
lich jeglicher geplanter oder erforderlicher Umänderungen der Immobilie, (iii) eine vorläufige Einnahmen- und Ausga-
benrechnung für die Immobilie für die voraussichtliche Zeit des Besitzes durch die Gesellschaft, jedoch nicht weniger als
fünf Jahre, (iv) ein ausführliches Betriebsbudget, wie in dem Gesellschaftervertrag definiert, und (v) einen ausführlichen
Marketingbericht.

Spätestens zwanzig (20) Tage nach Erhalt des Entwurfs des Geschäftsplans durch die Hauptversammlung der Gesell-

schafter (oder nach einem längeren Zeitraum, der von einem Gesellschafter durch Mitteilung an den Geschäftsführerrat
nach vernünftigem Ermessen beantragt wird) können die Inhaber der Anteile der Klasse A dem Geschäftsführerrat eine
Mitteilung zukommen lassen, in der der jeweilige Gesellschafter erklärt, dass er mit den in dem Geschäftsplan enthaltenen
Informationen beziehungsweise mit den Informationen, die nicht in dem Geschäftsplan enthalten sind, nicht einverstanden
ist, und in der er den Grund für seinen Einwand angibt. Nach Erhalt einer solchen Mitteilung ändert der Geschäftsführerrat
innerhalb von fünf (5) Tagen den Entwurf des Geschäftsplans ab und legt ihn erneut der Hauptversammlung der Gesell-
schafter zur Genehmigung vor. Innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt des neuen Entwurfes des Geschäftsplans haben
die Inhaber der Anteile der Klasse A die Möglichkeit eine weitere Einwandserklärung einzureichen (in diesem Fall wie-
derholen sich die Vorgänge der Unterbreitung und Überprüfung solange bis der Geschäftsplan von der Hauptversammlung
der Gesellschafter genehmigt wird). Ungeachtet jeglicher anderslautender Bestimmungen in der vorliegenden Satzung hat
die Hauptversammlung der Gesellschafter das Recht zu jedem Zeitpunkt nach der Genehmigung eines Geschäftsplanes,
durch Mitteilung an den Geschäftsführerrat, den Geschäftsplan zu überarbeiten oder den Geschäftsführerrat zu bitten,
einen überarbeiteten Geschäftsplan vorzubereiten und ihr diesen zur Genehmigung vorzulegen, unter Berücksichtigung
solcher Umstände, die die Hauptversammlung der Gesellschafter für angemessen hält, jedoch unter der Voraussetzung,
dass die Überarbeitung des Geschäftsplans nicht als eine Aufhebung der Befugnisse des Geschäftsführerrates im Hinblick
auf Maßnahmen, die der Geschäftsführerrat bereits vor einer solchen Überarbeitung zur Umsetzung des Geschäftsplans
ergriffen hat, betrachtet wird und dass der Geschäftsführerrat befugt ist, mit der vorherigen Zustimmung der Hauptver-
sammlung der Gesellschafter (die nicht ohne angemessenen Grund verweigert werden darf), die Transaktionen, für deren
Durchführung der Geschäftsführerrat sich bereits verpflichtet hat, zu vollenden.

Falls ein Geschäftsplan für ein Kalenderjahr am 1. Januar des jeweiligen Jahres noch nicht genehmigt wurde, handelt

die Gesellschaft weiterhin unter dem Geschäftsplan des vorhergehenden Jahres bis ein neuer Geschäftsplan von der
Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt wurde, mit den darin enthaltenen Anpassungen des Betriebsbudgets,
die notwendig sind, um die genehmigten Abkommen oder Mietverträge, die Streichung der nicht wiederkehrenden Aus-
gabenposten,  die  in  dem  vorherigen  Betriebsbudget  enthalten  waren,  sowie  erhöhte  Versicherungskosten,  Steuern,
Nutzungskosten und Schuldendienstkosten widerzuspiegeln.

Die Gesellschaft handelt gemäß jährlichen Betriebsbudgets, die von dem Geschäftsführerrat vorbereitet werden und

der Hauptversammlung der Gesellschafter zur Genehmigung vorgelegt werden. Der Geschäftsführerrat setzt jedes Be-
triebsbudget im Namen der Gesellschaft um und kann in diesem Zusammenhang Auslagen machen und Verpflichtungen
eingehen.

79805

Der Geschäftsführerrat legt der Hauptversammlung der Gesellschafter innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Ende

eines jeden Monats eine monatliche Aktualisierung des jeweils zutreffenden Betriebsbudgets und Geschäftsplans vor, um
die Hauptversammlung der Gesellschafter über Folgendes zu informieren:

(1) jegliche Abweichungen von dem Betriebsbudget oder dem Geschäftsplan, einschließlich (A) der Kostenüberschrei-

tungen  in  Bezug  auf  jegliche  Einzelposten  in  dem  jeweils  aktuellen  Betriebsbudget  oder  jeglicher  unvorhergesehener
Unkosten oder Ausgaben, die entstanden sind und die, wenn sie zu allen anderen Kosten und Ausgaben hinzugefügt
werden, dazu führen, dass der Gesamtbetrag des Betriebsbudgets (oder einer Kategorie des Betriebsbudgets oder eines
Einzelpostens) überschritten wird oder dazu führen, dass die im Budget vorgesehenen Resultate nicht mit den wirklichen
Resultaten übereinstimmen und (B) jeglicher Kosteneinsparungen in jeglichem Einzelposten des Budgets oder jeglicher
Budgetkategorie, die bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt erzielt wurden,

(2) jegliche Ausgaben unvorhergesehener Beträge in dem Betriebsbudget, unter Angabe des Betrages und des Einzel-

postens des Betriebsbudgets, dem die Ausgaben zugeordnet wurden, und jeglichen Kostenausgleich unter Angabe des
Betrages und des Einzelpostens des Betriebsbudgets, dem der Ausgleich zugeordnet wurde;

(3) jegliche Mehrkostenzahlungen, die bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorgenommen wurden, unter Angabe des Be-

trages und des Einzelpostens des Betriebsbudgets, auf die sich die Mehrkostenzahlung bezieht; und

(4) jegliche Abweichungen von dem Betriebsbudget oder Geschäftsplan.
Der Geschäftsführerrat legt den Gesellschaftern jegliche Berichte und Budgets vor, die er im Rahmen eines jeglichen

Hotelführungsvertrags, den die Gesellschaft abschließt (der "Hotelführungsvertrag") erhält, und kann auf diese Berichte
und Budgets verweisen. Im Falle von Streitigkeiten bezüglich der Berichte oder Budgets, die im Rahmen des Hotelfüh-
rungsvertrags vorzulegen sind, informiert der Geschäftsführerrat die Gesellschafter unverzüglich darüber."

Demnach, wird nach der Einfügung eines neuen Artikels 15, der frühere Artikel 15 zum neuen Artikel 16, der frühere

Artikel 16 zum neuen Artikel 17 und der frühere Artikel 17 zum neuen Artikel 18.

<i>Elfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, einen neuen Artikel 19 (neue Nummerierung) in die Gesellschaftssatzung einzufü-

gen, der wie folgt lauten soll:

"Die Hauptversammlung der Gesellschafter ist nur beschlussfähig, wenn das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist.

Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dürfen die anwesenden Gesellschafter keine anderen Beschlüsse fassen als den
Beschluss, die Hauptversammlung auf ein anderes Datum zu verlegen, das von den anwesenden Gesellschaftern festgelegt
wird, aber mindestens fünf (5) Tage nach dem Datum der vertagten Versammlung sein muss. Die neu einberufene Ver-
sammlung muss an dem gleichen Ort und zu der gleichen Tageszeit wie die ursprüngliche Versammlung stattfinden.

Die Mitteilungen einer solchen Vertagung sowie das Datum, der Zeitpunkt und der Ort, an dem die Versammlung

stattfinden soll, werden den Gesellschaftern innerhalb von fünf Tagen ab dem Beschluss der Vertagung zugeschickt.

Die neu einberufene Versammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten ist."

<i>Zwölfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, folgenden Satz in den Artikel 20 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung

einzufügen:

"Beschlüsse in Bezug auf die Ausgabe von Anteilen durch die Gesellschaft und Entscheidungen über den Erwerb von

Beteiligungen erfordern die einstimmige Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, vorausgesetzt, dass kei-
ne Zustimmung eines Gesellschafters, der es unterließ, die von der Gesellschaft erforderte Kapitaleinlage zu machen, für
die Ausgabe von Anteilen notwendig ist."

<i>Dreizehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, einen neuen Artikel 21 (neue Nummerierung) in die Gesellschaftssatzung einzufü-

gen, der wie folgt lauten soll:

"Die Geschäftsführer ergreifen keine Maßnahmen, machen keine Auslagen und gehen keine Verpflichtungen ein in

Bezug auf die unten stehenden Angelegenheiten, es sei denn diese spezifischen Maßnahmen oder Ausgaben sind in einem
Geschäftsplan oder Betriebsbudget enthalten, die von der Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt werden oder
anderweitig von der Hauptversammlung der Gesellschafter genehmigt oder vorgeschlagen wurden:

(i)  der  Erwerb,  der  Verkauf,  die  Übertragung,  der  Tausch,  die  Verpfändung,  die  Finanzierung,  die  Beleihung  oder

Belastung des gesamten oder eines Teils der Immobilie;

(ii)  die  Festlegung  der  Bedingungen  für  alle  Gesellschaftsanleihen  und  Bestimmung  der  Identität  des  Kreditgebers,

jeglicher Beschluss genehmigte Kreditdokumente abzuändern sowie die Gewährung von Garantien oder Entschädigungen
durch die Gesellschaft;

(iii) die Genehmigung eines jeden Geschäftsplans und Betriebsbudgets sowie jegliche Änderungen dieser Dokumente;
(iv) Gründung von Kapitalreserven oder Betriebsreserven der Gesellschaft, die nicht in dem jeweils aktuellen Be-

triebsbudget vorgesehen sind;

79806

(v) die Verursachung von Kosten oder die Übernahme von Verpflichtungen durch oder für die Gesellschaft, die 110%

des anwendbaren Einzelpostens in dem jeweils aktuellen Betriebsbudget überschreiten; wenn allerdings dringende Re-
paraturen an der Immobilie notwendig sind, um eine drohende Gefahr der Beschädigung der Immobilie oder Verlet-
zungsgefahren für Personen zu vermeiden, kann der Geschäftsführerrat solche Ausgaben machen, die notwendig sind, um
die Situation zu verbessern, wobei der Geschäftsführerrat unverzüglich die Hauptversammlung der Gesellschafter über
den Vorfall, der solche Reparaturarbeiten und die getroffenen Maßnahmen verursacht hat, informiert;

(vi) jegliche Auszahlungen an die Gesellschafter oder jegliche Zahlungen im Rahmen von Gesellschafterkrediten;
(vii) die Genehmigung von Mietverträgen (oder Änderungen oder Erweiterungen von bestehenden Mietverträgen)

gemäß derer mehr als 500 m2 Mietfläche in der Immobilie vermietet werden oder die ein jährliches Mieteinnahmen von
über dreißigtausend Euro (EUR 30.000) umfassen, sowie die Beendigung oder Zustimmung zur Annullierung oder Ab-
tretung eines Mietvertrags, die nicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Mietvertrags erfolgen, oder der
Nachlass oder die Freigabe eines Mietabkommens oder einer Forderung;

(viii) die Genehmigung jeglicher Verträge mit Drittparteien, die nicht in dem Geschäftsplan oder Betriebsbudget ent-

halten sind und jährliche Zahlungen von insgesamt mehr als zehntausend Euro (EUR 10.000) umfassen;

(ix) Entscheidungen bezüglich wichtiger Preiskalkulationen für die Immobilie;
(x) die Festlegung der Bilanzierungsregeln einschließlich der Auswahl von Abschreibungstabellen, Buchhaltungsverfah-

ren  und  des  Treffens  von  unterschiedlichen  Entscheidungen  in  Bezug  auf  die  Handhabung  und  die  Zuteilung  von
Transaktionen für Einkommensteuer, Lizenzgebühren oder andere Steuerzwecke;

(xi) die Auswahl von Banken für die Einzahlung des Gesellschaftsvermögens und Bestimmung der Personen, die be-

vollmächtigt sind, dieses Vermögen abzuheben;

(xii) das Ergreifen gerichtlicher Maßnahmen und die Entscheidung ein Gerichtsverfahren, das Kosten in Höhe von mehr

als einhunderttausend Euro (EUR 100.000) mit sich bringt, einzuleiten;

(xiii) die Auswahl von Anwälten, Buchhaltern, Ingenieuren, Umweltberatern und anderen Fachleuten für die Immobilie

oder die Gesellschaft;

(xiv) die Bekanntmachung von vertraulichen Informationen und die Herausgabe einer Pressemitteilung in Bezug auf die

Tätigkeiten der Gesellschaft und ihre Filiale;

(xv) die Verlegung der Verwaltung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg;
(xvi) jegliche Änderung des Geschäftsbereiches der Gesellschaft, die das Hauptaugenmerk der Tätigkeiten der Gesell-

schaft weg von dem in der Satzung der Gesellschaft genannten Gesellschaftszweck richtet;

(xvii) jeglicher Vertrag mit, jegliche Wahl, Genehmigung, Vereinbarung und jeglicher Verzicht auf Rechte zu Gunsten

von oder jegliches Geschäft mit (i) den Gesellschaftern, die Anteile der Klasse B halten oder mit Art Management S.à r.l.,
(ii) jeglichen anderen Personen, die diese Person kontrollieren, von ihr kontrolliert werden oder mit ihr unter gemein-
samer Kontrolle stehen, (iii) jeglichem Geschäftsführer, Direktor, Mitarbeiter, Angestellten oder Partner dieser Person
oder jeglicher Person, die in den oben stehenden Punkten (i) oder (ii) beschrieben ist, oder (iv) jeglichem direkten Fa-
milienmitglied einer in den oben stehenden Punkten (i), (ii) und (iii) beschriebenen Person;

(xviii) die Ausübung der Rechte der Gesellschafter in ihren Filialen, einschließlich der Zustimmungen der Gesellschafter,

insofern diese für die Filialen von gleicher oder ähnlicher Bedeutung sind wie jegliche Angelegenheit, die unter Punkt (i)
bis (xvi) in Bezug auf die Gesellschaft genannt werden.

Als Folge der Einfügung eines neuen Artikels 19, und eines neuen Artikels 21, wird der frühere Artikel 19 zum neuen

Artikel 22, der frühere Artikel 20 zum neuen Artikel 23, der frühere Artikel 21 zum neuen Artikel 24, der frühere Artikel
22 zum neuen Artikel 25 und der frühere Artikel 23 zum neuen Artikel 26.

<i>Vierzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Artikel 26 (neue Nummerierung) der Gesellschaftssatzung abzuändern, der

von nun an wie folgt lauten soll:

"Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen eines Gesellschaftervertrags und der folgenden Bestimmungen zur freien Verfügung:

Im Falle einer Veräußerung, d.h. eines Verkaufs, in einer einzelnen Transaktion oder in mehreren Transaktionen, an

einen oder mehrere Drittkäufer gegen einen Barbetrag, (i) der gesamten Immobilie, (ii) einer Mehrheitsbeteiligung in den
Filialen der Gesellschaft oder einer einzelnen von ihnen (iii) im Anschluss an den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung gemäß
Punkt (ii) (jedoch nicht aller Anteile an den Filialen der Gesellschaft oder an einer ihrer Filialen) der Verkauf von weiteren
Anteilen an den Filialen der Gesellschaft, unter der Voraussetzung, dass, um Missverständnisse auszuschließen, (x) wenn
die Immobilie oder eine Mehrheitsbeteiligung in den Filialen der Gesellschaft an mehr als einen Drittkäufer in mehr als
einer Transaktion verkauft wird, die Veräußerung die Gesamtheit aller Verweise auf solche Verkäufe bedeutet und zu
dem Zeitpunkt des letzten Verkaufs eintritt, und (y) eine Mehrheitsbeteiligung an den Filialen der Gesellschaft der Besitz,
direkt oder indirekt, von mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals solcher Gesellschaften bedeutet, haben
die Anteile der Klasse B wie folgt Anrecht auf eine Vorzugsdividende:

79807

(i) Zunächst, einhundert Prozent (100%) der Einnahmen, wie in dem Gesellschaftervertrag definiert, an die Gesell-

schafter bis der Gesamtbetrag der Einnahmen, der von den Gesellschaftern erhalten wurde, dem Gesamtbetrag der
Kapitaleinlagen und Gesellschafterkredite, die von den Gesellschaftern gemacht wurden, entspricht;

(ii) Zweitens, einhundert Prozent (100%) der Einnahmen an die Gesellschafter solange bis die Gesellschafter, die die

Anteile der Klasse A halten, zwanzig Prozent (20%) einer internen Ertragsrate erhalten haben, wie in dem Gesellschaf-
tervertrag definiert;

(iii) Drittens, fünfundachtzig Prozent (85%) der Einnahmen an die Gesellschafter und fünfzehn Prozent (15%) an die

Gesellschafter, die die Anteile der Klasse B halten, solange bis die Gesellschafter, die die Anteile der Klasse A halten,
fünfundzwanzig Prozent (25%) einer internen Ertragsrate erhalten haben;

(iv) Viertens, achtzig Prozent (80%) der Einnahmen an die Gesellschafter und zwanzig Prozent (20%) an die Gesell-

schafter, die die Anteile der Klasse B halten, solange bis die Gesellschafter, die die Anteile der Klasse A halten, dreißig
Prozent (30%) einer internen Ertragsrate erhalten haben; und

(v) Anschließend fünfundsiebzig Prozent (75%) der Einnahmen an die Gesellschafter und fünfundzwanzig Prozent (25%)

an die Gesellschafter, die die Anteile der Klasse B halten;

vorausgesetzt, um Missverständnisse auszuschließen, dass die vorhergehende Bestimmung nur für die Berechnung der

Vorzugsdividende anwendbar ist und dass kein Gesellschafter und keine andere Person durch diese Bestimmung irgend-
welche Rechte erhält.

Als Folge eines Verkaufs der gesamten Immobilie und falls die Vorzugsdividende höher ist als der Betrag, der gesetzlich

zur Ausschüttung zur Verfügung steht, zahlt die Gesellschaft den Inhabern der Anteile der Klasse B den Anteil der Vor-
zugsdividende, der gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden darf, und der Restbetrag der
Vorzugsdividende wird am Datum des von den beiden nachstehenden Ereignissen zuerst stattfindenden Ereignisses aus-
gezahlt: (i) am Datum des nächsten Verkaufsabschlusses, wobei der Restbetrag der Vorzugsdividende zunächst an die
Inhaber der Anteile der Klasse B ausgezahlt wird, bevor jegliche zusätzliche Vorzugsdividende an die Inhaber der Anteile
der Klasse B an diesem Datum ausgezahlt wird, oder (ii) zum Zeitpunkt der Liquidierung der Gesellschaft.

Die Inhaber der Anteile der Klasse A können durch schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Anteile der Klasse B den

Anspruch dieser Gesellschafter auf die Vorzugsdividende in folgenden Fällen aufheben: (1) bei erheblichen Verletzungen
der in Artikel VIII des Gesellschaftervertrags beschriebenen Verpflichtungen durch einen Inhaber der Anteile der Klasse
B, (2) bei einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse in Bezug auf die Nießbrauchberechtigung und die Kapitalbeteiligung
unter den Inhabern der Anteile der Klasse B oder des Geschäftsführers im Rahmen des Hotelführungsvertrags, und, falls
entschuldbar, wenn die Inhaber der Anteile B oder ihre Filialen es versäumt haben, innerhalb von fünfzehn (15) Werktagen
ab dem Datum der schriftlichen Mitteilung, die den Inhabern der Anteile der Klasse B durch die Inhaber der Anteile der
Klasse A zugestellt wird und bestätigt, dass die Inhaber der Anteile der Klasse B oder ihre Filialen gegen den Gesellschaf-
tervertrag oder den Hotelführungsvertrag verstoßen haben, und Abhilfemaßnahmen verlangt, diesen Verstoß zu beheben.
Nach der Zustellung einer solchen schriftlichen Mitteilung wird das Anrecht der Inhaber der Anteile der Klasse B auf eine
Vorzugsdividende unverzüglich aufgehoben und sowohl die Pflichten der Gesellschaft als auch die Pflichten der Inhaber
der Anteile der Klasse A in diesem Zusammenhang sind aufgehoben."

<i>Fünfzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt einen neuen Artikel 27 (neue Nummerierung) in die Gesellschaftssatzung einzufü-

gen, der wie folgt lauten soll:

"Abschlagsdividenden werden unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet:
(i) der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Ge-

sellschafter genehmigt;

(ii) die Abschlagsdividenden werden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Erstellung durch die Geschäftsführung

der Zwischenbilanz, aus der hervorgeht, dass ausreichend Gewinne zur Verteilung zur Verfügung stehen, ausgeschüttet;

(iii) die Vorzugsdividende, auf die die Inhaber der Anteile der Klasse B Anrecht haben, muss berücksichtigt werden;
(iv) die Entscheidung Abschlagsdividenden auszuschütten wird von der Hauptversammlung der Gesellschafter getrof-

fen.

Falls die ausgeschüttete Abschlagsdividende höher ist als der Betrag, der schließlich laut der Hauptversammlung der

Gesellschafter zur Verteilung unter den Gesellschaftern zur Verfügung steht, wird der Überschuss nicht als Abschlagsdi-
vidende betrachtet, sondern als eine unverzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.

Die oben stehenden Bestimmungen berühren nicht das Recht der Hauptversammlung der Gesellschafter, zu jedem

Zeitpunkt übertragene Gewinne aus dem vorherigen Geschäftsjahr oder Beträge aus den Konten für verteilbare Reserven
an die Gesellschafter zu verteilen."

Als Folge der Einfügung eines neuen Artikels 27, wird der frühere Artikel 24 zum neuen Artikel 28 und der frühere

Artikel 25 zum neuen Artikel 29.

<i>Sechszehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den zweiten Absatz des neuen Artikels 28 wie folgt abzuändern:

79808

"Insofern es keine anderslautende einstimmige Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern gibt, wird der nach Beglei-

chung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem
ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt, und zwar unter Berücksichtigung der Bestimmungen eines jeglichen Gesell-
schaftervertrags und folgender Bestimmungen: die Anteile der Klasse B haben Anrecht auf eine Vorzugsdividende bei
einer Liquidation, unter den Bedingungen, die auch die Ausschüttung einer Vorzugsdividende regeln und in Artikel 26
beschrieben sind."

<i>Siebzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den neuen Artikel 29 wie folgt abzuändern:
"Für alle Punkte, die nicht durch diese Satzung oder durch die Bestimmungen eines Gesellschaftervertrages, der mög-

licherweise zwischen den Gesellschaftern abgeschlossen wurde, geregelt werden, verweisen die Erschienenen auf die
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

Im Falle von Abweichungen zwischen der vorliegenden Satzung und dem Gesellschaftervertrag ist der Gesellschafter-

vertrag im Hinblick auf Angelegenheiten zwischen den Gesellschaftern maßgebend."

<i>Achtzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Rücktritt von BRE/Management S.A. von ihrem Mandat als alleinige Geschäfts-

führerin der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzunehmen.

Die Hauptversammlung beschließt, BRE/Management S.A. für die Erfüllung ihres Mandates voll zu entlasten.

<i>Neunzehnter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf vier festzulegen.

<i>Zwanzigster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, folgende Personen mit sofortiger Wirkung und für einen unbestimmten Zeitraum

zu Geschäftsführern der Gesellschaft zu ernennen:

- Herrn Anders Braks, Jurist, geboren am 21. September 1959 in Landskrona (Schweden), wohnhaft in 41, Am Bota-

nischen Garten, 50668 Köln, Deutschland,

- Herrn Robert Simon, director, geboren am 20. Februar 1929 in Wiesbaden (Deutschland), wohnhaft in 28, rue JP

Brasseur, L-1258 Luxembourg,

- Frau Cornelia M.W. van den Broek, director, geboren am 26. Juni 1968 in Oosterhout (Niederlande), mit Berufsad-

resse in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,

- Herrn Gary Summers, verwaltender Geschäftsführer, geboren am 12. Dezember in New York, Vereinigte Staaten

von Amerika, wohnhaft in 888 Park Avenue, Apt. 11#, New York, NY 10021, Vereinigte Staaten von Amerika.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, haben die Erschienenen mit dem Notar ge-

genwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. SONDHI und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29871 Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 28. Juli 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009102377/775.
(090123524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Vespa A S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 144.458.

L'an deux mil neuf, le trois juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

79809

Monsieur Harald CHARBON, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxem-

bourg (le "Mandataire"),

agissant en sa qualité de mandataire spécial du gérant VESPA CAPITAL S.A., une société anonyme ayant son siège

social au 12F, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 144.504 (le "Gérant"), de VESPA A S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son
siège social au 12F, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 144.458, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 2008, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 402 du 24 février 2009 (la "Société"),

en vertu de pouvoirs lui conférés par décisions du Gérant, en date du 1 

er

 juillet 2009.

Un extrait des procès-verbaux des dites décisions, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel Mandataire, agissant en vertu des prédit pouvoirs, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il

suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quarante-deux mille cinq cent soixante quatorze euros

(EUR 42.574) composé de deux mille cinq cent soixante quatorze (2.574) actions d'investisseurs de classe A ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les "Actions d'Investisseurs de Classe A") et de quarante mille (40.000)
actions de commandité ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les "Actions de Commandité") chacune,
entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article 3.1 paragraphe 3 des statuts, le capital autorisé de la Société incluant le capital social

émis a été fixé à cent millions d'euros (EUR 100.000.000) composé de cent millions (100.000.000) d'actions, sous la forme
d'Actions d'Investisseurs ou d'Actions Spécifiques, ayant une valeur nominale par action d'un euro (EUR 1,00) chacune
et le Gérant a été autorisé à décider, depuis le 19 décembre 2008 et pendant une période prenant fin cinq après la date
de publication de l'acte de constitution de la Société, de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article
trois des statuts se trouvant modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le Gérant, en date du 1 

er

 juillet 2009 et conformément à l'article trois des statuts, a réalisé une augmentation

de capital social dans les limites du capital autorisé, à savoir d'un montant de sept cent quatre-vingt deux euros (EUR
782) assorti d'une prime d'émission d'un montant total de cent quatre vingt dix neuf mille huit cent vingt euros (EUR
199.820) en vue de le porter de son montant actuel de quarante deux mille cinq cent soixante quatorze euros (EUR
42.574) à quarante trois mille trois cent cinquante six euros (EUR 43.356) par la création de sept cent quatre-vingt deux
(782) actions d'investisseurs de classe A (les "Actions Nouvelles") ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1 ) chacune,
à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes

IV.- Que le Gérant a supprimé l'exercice du droit préférentiel de souscription des associés et a accepté la souscription

des actions nouvelles par:

- SULA INVESTMENTS, une société des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à Romasco Place, Wickhams

Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registrar of Corporate Affairs des Iles
Vierges Britanniques, sous le numéro 661141, de trois cent trente et une (331 ) nouvelles actions avec une prime d'émis-
sion d'un montant total de quatre vingt quatre mille six cent soixante neuf euros (EUR 84.669);

- AMS Industries, une société de droit français ayant son siège social à F-75008 Paris, 25, rue Marbeuf, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Paris, France, sous le numéro 447 948 076, de deux cent vingt et une (221)
nouvelles actions avec une prime d'émission d'un montant total de cinquante six mille quatre cent quarante-six euros
(EUR 56.446);

- PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, une société de droit français ayant son siège social à F-75016 Paris,

2, rue Mariette Martin, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris, France, sous le numéro 502 208 556,
de vingt deux (22) actions nouvelles avec une prime d'émission d'un montant total de cinq mille six cent quarante-cinq
euros (EUR 5.645);

- HOLTHI, une société de droit français ayant son siège social à F-92600 Asnieres-sur-Seine, 119B, avenue des Co-

lombes, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, France, sous le numéro 489 605 410, de vingt
deux (22) actions nouvelles avec une prime d'émission d'un montant total de cinq mille six cent quarante-cinq euros (EUR
5.645);

- Monsieur David AKNIN, demeurant au 38 Quai Louis Bleriot à 75016 Paris, France, né à Saint Ouen, France, le 20

mars 1967, demeurant à F-75016 Paris, 2, avenue Vion-Withcomb, de six (6) actions nouvelles avec une prime d'émission
d'un montant total de mille quatre cent onze euros (EUR 1.411);

- Monsieur Frédéric BRUNET, demeurant au 2 avenue Vio-WhiteComb à 75016 Paris, France, né à Neuilly-sur-seine,

le 22 janvier 1964, demeurant à F-75016 Paris, 38, Quai Louis Blériot, de six (6) actions nouvelles avec une prime d'émis-
sion d'un montant total de mille quatre cent onze euros (EUR 1.411)

- VDL &amp; Co, une société de droit français ayant son siège social au 9, rue Deves à F-92200 Neuilly-sur-Seine, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, France, sous le numéro 501 263 560, de neuf (9) actions nouvelles
avec une prime d'émission d'un montant total de deux mille deux cent cinquante huit euros (EUR 2.258);

79810

- GAREFIN Sàrl, une société de droit français ayant son siège social au 91, rue du Faubourg Saint Honoré à F-75008

Paris, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris, France, sous le numéro 498 481 860, de cent soixante
cinq (165) actions nouvelles avec une prime d'émission d'un montant total de quarante deux mille trois cent trente cinq
euros (EUR 42.335);

SULA INVESTMENTS, AMS Industries, PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, HOLTI, Messieurs David AK-

NIN et Frédéric BRUNET, GAREFIN, et VDL &amp; Co sont désignés collectivement comme étant les Souscripteurs et
individuellement comme un Souscripteur.

V.- Que les sept cent quatre vingt-deux (EUR 782) actions nouvelles assorties d'une prime d'émission d'un montant

total de cent quatre vingt dix neuf mille huit cent vingt euros (EUR 199.820) résultant de l'augmentation de capital du 1

er

 juillet 2009 ont été souscrites par les souscripteurs prédésignés et libérées intégralement en numéraire par des ver-

sements à un compte bancaire au nom de la Société, de sorte que la somme de deux cent mille six cent deux euros (EUR
200.602) a été mis à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la pré-
sentation des pièces justificatives de souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de ces augmentations dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l'article

3.1 paragraphe 2 des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante dans la version française et
dans la version anglaise:

Version française

Art. 3 Capital social - Actions.
3.1 Capital social
[...]
Le capital souscrit est fixé à quarante trois mille trois cent cinquante six euros (EUR 43.356) composé de trois mille

trois cent cinquante six (3.356) actions d'investisseurs de Classe A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les
"Actions d'Investisseur de Classe A") et de quarante mille (40.000) actions de commandité ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune (les Actions de Commandité")"

Version anglaise

3.1 Share Capital.
[...]
The subscribed capital is set at forty-three thousand three hundred fifty six euro (EUR 43.356) consisting of three

thousand three hundred fifty six (3.356) Class A Investor Shares, having a par value of one euro (EUR 1) each (the "Class
A Investors Shares") and forty thousand (40,000) management shares having a par value of one euro (EUR 1) each (the
"Management Shares").

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom, état et demeures, a signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: H. CHARBON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 juillet 2009. Relation: LAC/2009/27763. Reçu soixante-quinze euros (75

€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée par Me Carlo WERSANDT, Notaire de résidence à Luxembourg, en rempla-

cement de Me Henri HELLINCKX, Notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 août 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009102361/112.
(090122893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Intimm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.542.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

79811

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102509/10.
(090123018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Morgan Stanley Derivative Products (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 90.102.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.764.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 14 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°794 du
2 avril 2008.

Les comptes du 14 février 2008 (date de constitution de la Société) au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Morgan Stanley Derivative Products (Luxembourg) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009102466/16.
(090122971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Guizet Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 114.153.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102514/10.
(090122802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Cottonwood Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 101.507.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102515/10.
(090122723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Naropa Properties Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 123.872.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102516/10.
(090122803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Cottonwood Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 101.507.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

79812

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102513/10.
(090122722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Miroiterie Origer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9122 Schieren, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 92.678.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009102258/14.
(090121805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Harsco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3593 Dudelange, 100, rue de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 132.255.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Référence de publication: 2009102583/10.
(090122797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 113.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102582/10.
(090122794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

A.J.I.L. C. &amp; P. S.A., Consultants-Courtiers en Assurances, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 21, Stawelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 68.314.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102581/10.
(090122791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

The 344 Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 133.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

79813

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102575/10.
(090122783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

China Corn Oil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 134.716.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CHINA CORN OIL S.A.
FIDALUX S.A.
<i>Le Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009102573/14.
(090122781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Rosann S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 20.476.

Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ROSANN S.A.
Signature

Référence de publication: 2009102576/11.
(090122784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Rosann S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 20.476.

Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ROSANN S.A.
Signature

Référence de publication: 2009102577/11.
(090122786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Ipsyinvest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 52.535.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102588/10.
(090122718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

FINAT S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 67.215.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

79814

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102589/10.
(090122719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

GREENSTED HOLDINGS (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 128.307.

Les comptes au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Greensted Holdings (Luxembourg) S.à R.L.
Signature

Référence de publication: 2009102584/12.
(090122799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

GREENSTED HOLDINGS (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 128.307.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Greensted Holdings (Luxembourg) S.à R.L.
Signature

Référence de publication: 2009102585/12.
(090122801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Pink Ocean Finance SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 83.047.

Les comptes annuels au 30 septembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
C. Blondeau / Nour-Eddin NIJAR
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009102570/12.
(090122775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

DND S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 110.958.

A l'attention des membres du Conseil d'Administration de la société DND SA,
Je désire par la présente, vous faire part de mon souhait de démissionner du poste d'administrateur au sein du Conseil

d'Administration de DND SA.

Luxembourg, le 17 avril 2008.

Dr Michel GROS.

Référence de publication: 2009102048/10.
(090121898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

79815

Central European Budapest Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 108.574.

Il résulte d'une cession de parts sociales conclue en date du 1 

er

 juillet 2009 que:

Central European Participation S.à r.l. a cédé 499 parts sociales de la société Central European Budapest Investment

S.à r.l. à Central European Prague Investment S.à r.l, ayant son siège au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Suite à cette cession, les 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société sont désormais

réparties comme suit:

Central European Prague Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2009.

<i>Pour Central European Budapest Investment S.à r.l.
Dirk Ruppert
<i>Gérant

Référence de publication: 2009102033/20.
(090122198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

ColTour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 20.630,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 125.850.

En date du 21 avril 2009 l'associé unique de la Société a décidé de nommer pour une durée indéterminée Colony

Luxembourg S.à r.l., 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, aux fonctions de gérant de la Société en rempla-
cement de Mr Philippe Lenglet, 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009102037/14.
(090122168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Reif 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 480.800,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 136.779.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 26 juin 2009 sous seing privé que:
Babcock &amp; Brown European Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, a cédé l'intégralité des 9.616 parts sociales qu'elle
détenait dans le capital de la société à Solidlink Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Suite à ce transfert, l'actionnariat de la société est composé comme suit:

Solidlink Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.616 parts sociales

Par les résolutions du 26 juin 2009, l'associé unique de la société a décidé:
- d'accepter la démission de Babcock &amp; Brown European Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg de ses fonctions de gérant
de la société avec effet au 26 juin 2009;

- de nommer aux fonctions de gérant de la société avec effet au 26 juin 2009:

79816

* Mme Marjoleine Van Oort, née le 28 février 1967 à Groningen (Pays-Bas), domiciliée professionnellement au 12, rue

Alphonse Weicker, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,

* M. Giuseppe Oriani, née le 14 avril 1964 à Rome (Italie) demeurant à Via A. Boito, 10, I-20121 Milan (Italie),
* Mr. Guy Thackwray, né le 8 février 1967 à Congleton (Royaume-Uni), demeurant Aldermanbury Square 5, Level 15,

EC2V 7HR Londres (Royaume-Uni).

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009102032/31.
(090122354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Babcock &amp; Brown Reif Investment 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.100.000,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 114.025.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 26 juin 2009 sous seing privé que:
Babcock &amp; Brown European Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, a cédé l'intégralité des 124.000 parts sociales qu'elle
détenait dans le capital de la société à Solidlink Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Suite à ce transfert, l'actionnariat de la société est composé comme suit:

Solidlink Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.000 parts sociales

Par les résolutions du 26 juin 2009, l'associé unique de la société a décidé:
- d'accepter les démissions de Mme Caroline Bonald, M. Mark Dunstan, M. Yves Elsen de leurs fonctions de gérant de

la société avec effet au 26 juin 2009 et la démission de M. Nicolas Comes de ses fonctions de gérant de la société avec
effet au 24 juin 2009;

- de nommer aux fonctions de gérant de la société avec effet au 26 juin 2009:
* Mme Marjoleine Van Oort, née le 28 février 1967 à Groningen (Pays-Bas), domiciliée professionnellement au 12, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,

* M. Giuseppe Oriani, née le 14 avril 1964 à Rome (Italie) demeurant à Via A. Boito, 10, I-20121 Milan (Italie),
* Mr. Guy Thackwray, né le 8 février 1967 à Congleton (Royaume-Uni), demeurant Aldermanbury Square 5, Level 15,

EC2V 7HR Londres (Royaume-Uni).

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009102031/31.
(090122366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Eurazeo Real Estate Lux, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.809,06.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 94.709.

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société le 9 juillet 2009 que les mandats des gérants étant venus

à échéance, les associés ont décidé de réélire les gérants suivants, pour une période d'un an prenant fin à l'issue des
résolutions des associés de la Société délibérant sur les comptes annuels de la Société clos le 31 décembre 2009:

- Monsieur Bruno Keller, né le 22 décembre 1954 à Neuilly sur Seine (92), France, directeur général, domicilié pro-

fessionnellement au 32, rue de Monceau, 75008 Paris, France;

79817

- Monsieur Christophe Aubut, directeur comptable, né le 3 novembre 1965 à Noisy-le-Sec (93), France, domicilié

professionnellement au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;

- Monsieur Vincent Cormeau, directeur, né le 29 août 1960 à Verviers, Belgique, ayant son adresse professionnelle au

3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Bertrand Michaud, directeur, né le 21 novembre 1961 à Paris, France, ayant son adresse professionnelle

au 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

Il résulte de ces mêmes résolutions que le mandat de Ernst &amp; Young S.A., immatriculée auprès du RCS à Luxembourg

sous le numéro B 47.771, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant que Commissaire
de la Société, a été renouvelé pour une période d'un an prenant fin à l'issue des résolutions des associés de la Société
délibérant sur les comptes annuels de la Société clos le 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2009.

Vincent Cormeau / Bertrand Mlchaud
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009102058/27.
(090122641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Reif 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 551.600,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 136.780.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 26 juin 2009 sous seing privé que:
Babcock &amp; Brown European Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, a cédé l'intégralité des 11.032 parts sociales qu'elle
détenait dans le capital de la société à Solidlink Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Suite à ce transfert, l'actionnariat de la société est composé comme suit:

Solidlink Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.032 parts sociales

Par les résolutions du 26 juin 2009, l'associé unique de la société a décidé:
- d'accepter la démission de Babcock &amp; Brown European Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg de ses fonctions de gérant
de la société avec effet au 26 juin 2009;

- de nommer aux fonctions de gérant de la société avec effet au 26 juin 2009:
* Mme Marjoleine Van Oort, née le 28 février 1967 à Groningen (Pays-Bas), domiciliée professionnellement au 12, rue

Alphonse Weicker, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,

* M. Giuseppe Oriani, née le 14 avril 1964 à Rome (Italie) demeurant à Via A. Boito, 10, I-20121 Milan (Italie),
* Mr. Guy Thackwray, né le 8 février 1967 à Congleton (Royaume-Uni), demeurant Aldermanbury Square 5, Level 15,

EC2V 7HR Londres (Royaume-Uni).

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009102029/31.
(090122371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

C2 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8469 Eischen, Maison 5.

R.C.S. Luxembourg B 94.372.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79818

Luxembourg, le 5 août 2009.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009102030/15.
(090122534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Arom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 49.837.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009102022/13.
(090122515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

BRE/Student Housing Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BRE/Japan Hotel Holding I S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 127.147.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 26 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1199 du 19 juin 2007.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009101081/16.
(090120940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Punto Verde Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 69, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.362.

<i>Cession de parts

Entre les soussignés:
BELLOFATTO Luca, demeurant à L-4391 Pontpierre, 69, rue de Luxembourg, propriétaire de 50 parts dans la société

PUNTO VERDE SARL sàrl, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 142362, et dont le
capital social est fixé à EUR 12.500, divisé en 100 parts d'une valeur nominale de EUR 125.

PAVAN Annamaria, demeurant à L-4391 Pontpierre, 69, rue de Luxembourg, propriétaire de 25 parts dans la société

PUNTO VERDE SARL sàrl, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 142362, et dont le
capital social est fixé à EUR 12.500, divisé en 100 parts d'une valeur nominale de EUR 125.

ci-après appelé le "cédant"
et
BELLOFATTO Daniel, demeurant à L-4391 Pontpierre, 69, rue de Luxembourg, déjà propriétaire de 25 parts dans la

société PUNTO VERDE SARL sàrl, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 142362, et
dont le capital social est fixé à EUR 12.500, divisé en 100 parts d'une valeur nominale de EUR 125.

79819

BELLOFATTO Giuseppe, né le 17/09/1939 à TORELLA DEI LOMBARDI (Italie) - et demeurant à F-57240 NILVANGE,

3, rue A. CROIZAT

Ci-après dénommé "le cessionnaire"
il a été convenu ce qui suit:
Le cédant BELLOFATTO Luca cède par la présente au cessionnaire BELLOFATTO DANIEL, qui accepte, 49 parts

correspondant à 49% du capital de EUR 12.500 de la société PUNTO VERDE SARL. Le prix de la cession a été fixé à
EUR 6.125,00 correspondant à EUR 125 par part.

Le cédant BELLOFATTO Luca cède par la présente au cessionnaire BELLOFATTO Giuseppe, qui accepte, 1 part

correspondant à 1% du capital de eur 12.500 de la société PUNTO VERDE SARL. Le prix de la cession a été fixé à EUR
125,00 correspondant à EUR 125 par part.

Le cédant PAVAN Annamaria cède par la présente au cessionnaire BELLOFATTO Daniel, qui accepte, 25 parts cor-

respondant à 25% du capital de EUR 12.500 de la société PUNTO VERDE SARL. Le prix de la cession a été fixé à EUR
3.125,00 correspondant à EUR 125 par part.

Tous frais quelconques découlant de la présente cession y compris tous frais d'enregistrement éventuel ou de signifi-

cation sont à la charge du cessionnaire.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009, chaque partie reconnaissant avoir reçu un original de la présente convention.

BELLOFATTO Luca / PAVAN Annamaria / BELLOFATTO Daniel / BELLOFATTO Giuseppe
<i>LE CEDANT / LE CEDANT / LE CESSIONNAIRE / LE CESSIONNAIRE

Référence de publication: 2009102861/38.
(090122862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

BRE/Europe Hotel II Lux Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 131.504.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Mersch, en date du

er

 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2302 du 13 octobre 2007.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009101082/15.
(090120938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

BRE/Europe Hotel Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 21.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 129.624.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 26 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1789 du 23 août 2007.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009101083/15.
(090120937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

79820

BRE/Europe Hotel II Lux GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 131.509.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 1 

er

 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2301 du 13 octobre 2007.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009101084/15.
(090120936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Sogerance Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6978 Hostert, 4, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 39.091.

Les bilans au 31.12.2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009101632/9.
(090122580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Blackstar Group Plc, Société Anonyme.

Siège de direction effectif: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 114.318.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009101117/12.
(090121599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Borga S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 28.834.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2009.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009101121/12.
(090121219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Relys Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 41.173.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 juin 2009.

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Vincent THILL décidée par le conseil d'administration en sa réunion du

26 octobre 2007.

79821

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Olivier CONRARD décidée par le conseil d'administration en sa réunion

du 1 

er

 février 2008.

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Stefano DE MEO décidée par le conseil d'administration en sa réunion

du 1 

er

 septembre 2008.

Le  mandat  de  deux  des  administrateurs  venant  à  échéance,  l'assemblée  décide  d'élire  pour  la  période  expirant  à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30 juin 2011 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Vincent THILL, employé privé, né le 04/03/1971 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à L - 1724

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, administrateur;

Salvatore DESIDERIO, employé privé, né le 29/10/1976 à Pompei (Italie), demeurant professionnellement à L - 1724

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, administrateur;

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30 juin 2009 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RELYS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Un administrateur / un administrateur

Référence de publication: 2009102932/30.
(090122925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Sky Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.491.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009101128/13.
(090121229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Claudia Property Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 137.683.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009101130/13.
(090121231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

79822

Patron Archipel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 119.919.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire tenue en date du 30 juillet 2009

Première résolution
L'Assemblée accepte le transfert de siège de la Société du 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 6, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg avec effet au 30 juillet 2009;

Deuxième résolution
L'Assemblée prend note et autorise le changement d'adresse professionnelle des gérants comme suit:
- Géraldine SCHMIT du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg

avec effet immédiat;

- Michael VANDELOISE du 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet

au 30 juillet 2009.

Troisième résolution
Un des Associés, Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l., a également changé son adresse professionnelle du 121, avenue

de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009103371/25.
(090123575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2009.

Redai Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 87.878.

L'an deux mil neuf, le six juillet.
Par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée "REDAI HOLDING S.A." avec siège social à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.
Luxembourg Section B n°87878,

constituée par acte du notaire soussigné en date du 31 mai 2002, publié au Mémorial C n°31274 du 3 septembre 2002.
L'assemblée est présidée par Mme Concetta DEMARINIS, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, 5, Avenue Gaston Diderich.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg, 2, rue de la Chapelle.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mme Concetta DEMARINIS. précitée.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entièreté du capital social, sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l'ordre du jour.

II.- Que la société n'a pas émis d'obligations.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Decision to be taken to transform the company from the legal form of Holding 1929 to the legal form of a commercial

company subject to the income tax ('impôt sur le revenu des collectivités) and that starting, for the accounting and fiscal
purposes, from the date of the present act;

79823

2. Subsequent modification of the article 4 of the Articles of association to give the following phrasing: " la société a

pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles,
financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation,
d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore
l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles,
leur gestion et leur mise en valeur. Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours
ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations
ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale. Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient,
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accom-
plissement de son objet social.";

3. Miscellaneous
L'assemblée, réunissant tous les actionnaires, après s'être reconnue régulièrement convoquée, a considérée qu'elle

était valablement constituée, a approuvé l'exposé de Madame la Présidente et a abordé l'ordre du jour. Après délibération,
l'assemblée a pris, à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide d'abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 afin

d'adopter un nouvel objet social soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités, et ce avec effet comptable à la date des
présentes,

et modifie en conséquence l'article 4 des statuts comme suit:
La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre
manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens
meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur. Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter
même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale. Elle peut en outre effectuer
toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prester tous services aux so-
ciétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes
autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

<i>Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente prononce la clôture de l'assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous

connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent
acte.

Signé: C. DEMARINIS, G. SADDI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 10 juillet 2009, LAC/2009/27594: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- Pour copie conforme - Délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/08/09.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009103869/74.
(090125008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

Real Pol Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 122.179.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009101146/10.
(090121108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

79824


Document Outline

A.J.I.L. C. &amp; P. S.A., Consultants-Courtiers en Assurances

Arom S.à r.l.

Axess Europe S.A.

Babcock &amp; Brown Reif Investment 2 S.à r.l.

Betsy S.A.

Blackstar Group Plc

Borga S.A.

BRE/Europe Hotel Holding II S.à r.l.

BRE/Europe Hotel II Lux GP S.à r.l.

BRE/Europe Hotel II Lux Investor S.à r.l.

BRE/Japan Hotel Holding I S.à r.l.

BRE/Neuss Hotel Holding S.à r.l.

BRE/Nine Hotel Holding S. à r.l.

BRE/Student Housing Holding I S.à r.l.

C2 Lux S.à r.l.

Car Testing S.A.

Central European Budapest Investment S.à r.l.

China Corn Oil S.A.

Citex S.à r.l.

Claudia Property Holding S.à r.l.

ColTour S.à r.l.

Cottonwood Properties S.à r.l.

Cottonwood Properties S.à r.l.

Crystal Partners Lux Holding Company Limited

DND S.A.

Encore Plus Lux Co Ile de la Jatte I S.à r.l.

Eurazeo Real Estate Lux

FINAT S.à.r.l.

Finbourg Finance S.A.

FV-Invest S.A.

Gaz Capital S.A.

GREENSTED HOLDINGS (Luxembourg) S.à r.l.

GREENSTED HOLDINGS (Luxembourg) S.à r.l.

Guizet Immobilière S.A.

Harsco Luxembourg S.à r.l.

Intimm S.A.

Ipsyinvest S.A.

Iron Paradox S.à r.l.

Miroiterie Origer S.A.

Morgan Stanley Derivative Products (Luxembourg) S.à r.l.

Naropa Properties Luxembourg S.A.

OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A.

Pâtes Fraîches LA ROMAGNA S.à r.l.

Patron Archipel S.à r.l.

Pink Ocean Finance SA

Punto Verde Sàrl

Real Pol Investments S.A.

Redai Holding S.A.

Reif 3 S.à r.l.

Reif 4 S.à r.l.

Relys Holding S.A.

Rosann S.A.

Rosann S.A.

Sky Investments S. à r.l.

S.L.P.S. S.A.

Sofinas S.A.

Sofinas S.A.

Sofindex

Sogerance Holding S.à r.l.

Technossence S.A.

The 344 Company S.A.

Vespa A S.C.A.

Wafra/Aref Opéra Investment S.à r.l.