logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1659

28 août 2009

SOMMAIRE

4rae Renewable and Alternative Energy In-

vestments S.C.A. SICAR . . . . . . . . . . . . . . .

79625

ABN AMRO Converging Europe Invest-

ments, S.C.A., Sicar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79624

Access Management Luxembourg  . . . . . . .

79612

Agence de Publicité Signtec S.à r.l.  . . . . . .

79599

Akustik Bau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79629

Almeda S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79617

Audemars Microtec Lux Holding S.A. . . . .

79630

Black Ant Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

79628

Block Conseil S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79615

Carbeneth Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

79625

Carbeneth Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

79625

CCP II Neumarkt S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

79620

CCP II Peine S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79616

CCP II Soest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79620

CCP II Straubing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

79620

Central America Trading  . . . . . . . . . . . . . . .

79616

Cerilly Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79630

Cheyne Capital Guaranteed Credit S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79629

C. & P. International Holding S.A.  . . . . . . .

79587

Deldeg Multi-Projects S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

79615

Eikon Invest III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79606

Elistart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79625

Eterna S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79586

Financière du Stuff S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

79612

FKS Investments Holding S.A. . . . . . . . . . . .

79625

Flying Group Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79630

Forex Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79607

Fort Dumoulin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79607

GAP-W International SV  . . . . . . . . . . . . . . .

79598

Gomareal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79615

Husky Injection Molding Systems  . . . . . . . .

79621

IAFS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79629

ICEC Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79621

ING Life Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

79586

International Services Luxembourg (Inse-

lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79607

Jetlink Aviation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79621

Kinnevik S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79615

Koch KIG Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .

79615

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR  . . . . . . . .

79612

L'Occitane Groupe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

79606

LUX-INOTEC Sicherheitssysteme S.A.  . .

79629

Mastertec Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79628

Mastertec Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79628

Matsa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79587

MDM DPR Finance Company S.A.  . . . . . . .

79620

MEI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79628

Merrill Lynch Equity S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

79608

MFH S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79624

MGR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79630

MHG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79624

Montagebau Schwarz Michael S.à r.l.  . . . .

79612

Neweb Creations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

79616

Pfizer Global Investments Sàrl  . . . . . . . . . .

79606

Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl . . . . . . . .

79601

Pfizer Warner Lambert Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79606

PricewaterhouseCoopers  . . . . . . . . . . . . . . .

79631

Santex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79601

Shaf Corporation SPF, S.A.  . . . . . . . . . . . . .

79586

S.I. Umbolt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79587

Soim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79624

T-A-J-P-M- S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79586

TVM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79630

WIHSA Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79629

WJH Holdings Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79606

WOOD & Company Group S.A. . . . . . . . . .

79628

WPA Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79601

79585

Shaf Corporation SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 15.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SHAF CORPORATION SPF S.A.
Signatures
<i>Director / Director

Référence de publication: 2009100938/12.
(090120829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

T-A-J-P-M- S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 113.162.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T.-A-J-P-M S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009100939/11.
(090120820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Eterna S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 81.846.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ETERNA S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009100940/11.
(090120819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

ING Life Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 46.425.

<i>Extrait du procès-verbal du 12 décembre 2000

Il résulte d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 12 décembre

2000, enregistré à Luxembourg, que:

Conformément à la loi du 10 décembre 1998, le conseil d'administration de la prédite société a décidé de convertir

le capital social actuelle de LUF en Euro et de modifier la rubrique concernant le capital social de la société, article 5
comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à quinze millions de Euros (EUR 15.000.000), représenté par cinquante-huit mille quatre

cent trente-sept (58.437) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Boîte Postale 320
L-2013 Luxembourg
Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009101467/20.
(090121145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

79586

S.I. Umbolt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 80.550.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 avril 2009 de:
1. La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS, en sa qualité d'administrateur, est acceptée. Sera élu en son rem-

placement:

- Monsieur Olivier LIEGEOIS, bachelier en comptabilité, né le 27 octobre 1976 à Bastogne en Belgique, demeurant

professionnellement au numéro 12, rue guillaume Schneider L-2522 Luxembourg.

2. La démission de CERTIFICA Luxembourg S.à.r.l. de son poste de commissaire est acceptée. Est élu commissaire en

remplacement:

- BF CONSULTING S.à.r.l., sis 1 Val Sainte Croix L-1341 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera

sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009101478/22.
(090121567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

C. &amp; P. International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 38.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102436/10.
(090123036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Matsa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 124.490.

L'an deux mille neuf, le dix juillet.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MATSA S.A. , ayant son siège

social au 2, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 124.490.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Camille Bourke, avocat chez Arendt &amp; Medernach, avec adresse pro-

fessionnelle 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Jérémie Vuillquez, avocat chez Arendt &amp; Medernach, avec adresse profes-

sionnelle 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg

L'assemblée choisit comme scrutateur Victorien Hemery, avocat chez Arendt &amp; Medernach, avec adresse profession-

nelle 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que tous les actionnaires de la Société, tels que renseignés sur la liste complète des actionnaires au 10 juillet 2009,

qui demeurera annexée au procès-verbal, ont été convoqués par une convocation adressée par courrier recommandé à
chacun d'entre eux au minimum huit (8) jours ouvrables avant la date de la présente assemblée. Les convocations ont
été envoyées à chacun des actionnaires par la Société.

II. Que sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur

mandataire avant l'ouverture de la séance et qui demeurera annexée au présent procès-verbal.

III. Il résulte de la liste de présence que deux millions cent soixante-treize mille quatre cent soixante-seize (2.173.476)

Actions A, trois millions cinq cent quatre mille cent cinquante-neuf (3.504.159) Actions B et 1 Action C sur un total de

79587

deux millions deux cent mille sept cent soixante-trois (2.200.763) Actions A, trois millions cinq cent cinquante mille deux
cent soixante-dix (3.550.270) Actions B et une (1) Action C sont présentes ou valablement représentées.

III. Qu'il appert de cette liste de présence que plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représenté

à la présente assemblée générale extraordinaire, et ce également dans chaque classe d'actions, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

IV. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à onze millions cinq cent deux mille soixante-huit euros (€

11.502.068,-), représenté par deux millions deux cent mille sept cent soixante-trois (2.200.763) Actions A, trois millions
cinq cent cinquante mille deux cent soixante-dix (3.550.270) Actions B et une (1) Action C d'une valeur nominale de
deux euros (€ 2,-) chacune.

V. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital de la Société, réalisée avec exercice d'un droit préférentiel de souscription au profit des

actionnaires titulaires d'Actions A de la Société, pour un montant maximal de 39.614.032,- euros, soit une émission
maximale de 19.807.016 Actions A nouvelles, le montant définitif de l'augmentation de capital dépendant des souscriptions
des actionnaires titulaires d'Actions de catégorie A.

2. Exercice par les actionnaires existants d'un droit préférentiel de souscription et approbation des souscriptions aux

Actions A.

3. Souscription et libération intégrale des Actions A nouvellement émises, par conversion de compte courant ou de

créance obligataire.

4. Constatation de l'augmentation de capital.
5. Modification corrélative de l'Article 6 des Statuts.
VI. Que l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix présentes ou représentées les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital de la Société pour un montant total de trente-neuf millions cent vingt-deux

mille sept cent trente-deux euros (39.122.732,- €) par émission d'Actions de catégorie A de deux euros (2,- €) chacune
de valeur nominale, soit une émission totale de dix-neuf millions cinq cent soixante et un mille trois cent soixante-six
(19.561.366) Actions A nouvelles, avec exercice d'un droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires titulaires
d'Actions de catégorie A.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires de catégorie A décident d'exercer le droit préférentiel de souscription et en conséquence l'assemblée

décide d'approuver les souscriptions suivantes:

Nom

Prénom

Montants/

Comptes

Courants

Nombre

Actions

A émises

BAIGUE

Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.411

2.705

BEDUNEAU

Florence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.608

3.115

BESNOUX

Jérôme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

BIGAS

Jean-Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.709

1.354

BLONSKI

Jacek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

BRITZ

Sandra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

BROZ

Vaclav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.593

4.050

CANEVET

Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.204

13.365

CHASSAING

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.475

20.128

CONSEJO

Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.411

2.705

COOK

Lew  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.194

20.107

CORREIA

Eddie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

DATTEE VERNAT

Bénédicte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.382

6.191

DE LA FUENTE

Inacio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.839

3.301

DIJKEMA

Bert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.170

15.151

DIKER

Bahadir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

ENGEL

Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.508

8.723

ENGELBRECHT

Hannes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.709

1.354

ERONAT

Volkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

79588

EVERITT

Gilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.411

2.705

EYCHENNE-BARON

Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

GARDEN

Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.214

15.655

GAUTIER

Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.709

1.354

GNAGNE

Claudie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.521

7.786

HERNANDEZ

Maria-Jesus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.912

4.672

JEANNETTE

Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.411

2.705

LACHENAUD

Sophie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

LANDRY

Anne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.220

6.231

LE GUILLERME

Gildas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.434

3.504

LEBRE

Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.735

10.800

LESCURE

Fabienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.936

23.468

LIESING

Frédéric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.411

2.705

LOPEZ de AZCONA

Diego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247.816

116.805

MAESANO

Jean-Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.130

10.901

MAIA

Nuno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.043

15.574

MAITRASSE

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MARAIS

Andries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MERCIER

Gilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.940

11.970

MOISE

Costel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.623

811

NOVELLO

Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238.595

112.459

PELLERIN

Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.661

9.738

PLANCON

Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.976

13.416

RIOU

Arnaud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.220

6.231

RIQUELME

Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

SEURRE

Jérôme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.708

5.617

SEVERIN

Sylviane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

SEYMORE

Norman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.335

24.808

TAYLOR

David  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.411

2.705

TENGATTINI

Tullio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.153

9.970

TERRADE

Jean-Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.660

8.904

THEODON

Nicolas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.825

912

TINLEY

Malcom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

VAN VUUREN

Armand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

VENIER

Anthony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

BERGE

Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.453.157

684.929

BIANCHI

Jean-Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165.737

82.868

FORTIS Luxembourg Vie SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.764.632

1.774.418

LAY

Arnaud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.234

31.117

RIU

René  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

570.178

264.402

SACCHETTI

Christian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

642.394

302.785

SEGUIN

Richard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91.814

29.059

Société civile Galiléo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

642.394

302.785

SOCIETE SOLAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.956.306

2.336.102

ADO

Valentin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.232

17.906

BOUCHER

Sandrine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.546

4.330

CARAUX

Catherine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.115

19.132

CHAMPENOIS

Caroline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.386

4.193

CURIS

Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.271

46.635

DE BOURQUENEY

Bertrand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.924

20.962

de la GORCE

Marie-Christine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.223

15.187

FONTANET

Alexandra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

GAY

Denis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

LEBIDOIS

Delphine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.326

3.682

LEMENN

Catherine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.176

3.588

79589

MELEDO

Gwendal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.642

1.821

MULLER

Laurence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.223

15.187

N'GUYEN

Ngoc Tung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.798

11.216

SADOUL

Noelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.228

2.814

SAINT CRICQ

Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.576

4.985

SOUBRANNE

Alain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.188

8.101

TASSIN

Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.576

4.985

ALBERTINI

François Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.611

4.305

ALT

Charles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.562

23.361

ALVIM

Christine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

AMATHIEU

Lorris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.824

27.254

AMELOT

Bertrand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.120

11.839

ASSIS

Genine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.418

15.117

AUVRAY

Jean-Michel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.768

5.384

AVERLANT

Jacques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.933

3.739

BAILLAGOU

Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91.863

44.497

BEARDMORE

Andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

912.624

430.155

BELLEC

Frédéric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

BERTRAND

Lionel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

BIRAGHI

Marco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.220

6.231

BONNARD

Nadège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.140

18.570

BONNEVIALE

Brice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.822

36.365

BOTTOMLEY

Paul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.051

15.578

BOUSSAGE

Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

BROSS

Georges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

BRUNON

Gaelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

BUNT

Nancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.650

18.689

BUSSOLI

Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.353

25.135

CALDWELL

Robin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.474

28.033

CANTON

Laurence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.638

10.319

CARLIER

Lisiane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.915

4.673

CHALAL

Valerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.177

3.588

CHARTIER

Loic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.220

6.231

CHATEAU

Isabelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

CHEN

Sin-Fook  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.604

8.923

COLIN

Bernadette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

COOKE

Louise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

CREST

Jérôme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

CREVECOEUR

Gérard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.051

15.578

DA SILVA

Valérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

DARSY

Laurence

41.363

20.114

de la TRIBOUILLE

Valérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.478

8.938

DEFFRASNES

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.565

15.456

DELAUNAY

Christine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

DESCHRYVER

Fabien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.851

5.689

DESCOUT

Valentine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.760

4.380

DODGE

Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.650

9.733

DOUHERET

Blandine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.216

6.229

DUPREEZ

Peter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.485

27.838

ELORZA

Enrique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.543

6.854

ESPINOSA

Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.376

51.944

ESPOSITO

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.355

34.846

ESTIENNE

Frédéric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

ESTIVAL

Jacques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.591

1.795

EVANGELISTA

Paulo César . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.220

6.231

79590

FALASCHI

Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.051

15.578

FASSIER

Armelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

FAUCHADOUR

David  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

FAVIER

Séverine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

FAVOTTI

Anne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.025

2.512

FEVZI

Elmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

FIGUEIRA

Luis Carlos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.562

23.361

FITZGERALD

Mark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.562

23.361

FOULON

Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.086

13.709

FRADIN

Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

823.889

388.331

FRENKIAN

Michael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.937

7.692

FROUIN

Laurent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

793.008

373.776

FRYDA

Hervé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.955

6.757

GARONNAT

Mireille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.915

4.673

GAVURE

Jaison  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

GIMAT

Denis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.873

7.010

GLANDER

Margaret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

GREEN

Thomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

731.054

344.575

GUDOVSKIKH

Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

GUILLON

Pierre-Antoine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.597

14.731

GUINOT

Dominique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.670

42.749

HODENIUS

Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

HU

Chong  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.051

15.578

HULIN

Xavier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.815

10.281

HUMMEL

Frédéric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

HUYNH

Chinh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

IZZO

Fabien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

JARY

Jean-Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

JOLLY

Remi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.412

25.875

JUNGBLUT

Norbert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

KUHR

Matthew  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

KWASNY ECHTERHAGEN

Rudiger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

LABOURT IBARRE

Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

LAGUILLEZ

Jean-Yves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.070

46.730

LAMBERET

Séverine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

LASTENNET

Edouard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

LAUGERETTE

Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.650

18.689

LEMPEREUR

Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74.947

35.887

LENFANT

Pascal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.610

3.115

LEVET

Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

LÖF

Bengt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.819

20.962

LOVE

Mark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

MACEDO DE ALMEIDA

Reginaldo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

MANIA

Michael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830.317

391.361

MAYES

Paula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

MILBRATH

Peter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.562

23.361

MINICHIELLO

Alessandro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.294

2.603

MIRRA

Frédéric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.915

4.673

MOLITOR

Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.096

34.128

MORET

Fréderic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

MOSSER

Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89.214

42.049

MUCHA

Wociech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

NEWTON

Tony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.562

23.361

NORELIUS

Per  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.650

18.689

NORMAN

Candace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

79591

NOVENE

Jean-Marc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123.810

61.905

OXLEY

Colin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.330

28.745

PARR

Christopher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.334

15.807

PILLAUD

Olivier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.924

20.962

PLUVINAGE

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.075

16.701

PORZGEN

Dirk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.650

18.689

PRAT

Evelyne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.139

29.069

PRAUTZSCH

Volker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

QUACHE

Walter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.711

14.355

RAULIN

Marielle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.356

39.071

RAVENEAU

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.898

38.165

RAYNAUD

Lionel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

READ

Phil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.357

7.178

REGINA

Yann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.906

4.953

REID

Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.410

16.163

RICHARDSON

Martin A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

ROCHA DE FREITAS

Alexandre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

ROESKY

Reiner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.051

15.578

ROMA

Marco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.008

52.781

ROUX

Elise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.912

13.627

SAUCIER

François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.686

20.771

SAUNIER

Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

SCHROEDER

Franck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.534

10.767

SCHULZ

Marius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

SEVER

Lionel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

SIMONIN

Fabien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

TAQUET

Pascal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.992

4.419

TORGUE

Dominique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

TORRES

Laurent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113.142

55.142

TOUZO

Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

TRASSARD

Jean-Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.529

24.699

TZAMANIS

Grégory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

VALDELIEVRE

Benoît  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.007

25.867

VALMARY

Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.661

18.694

VENTER

Andries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

VEYRAT

Didier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.586

7.576

WOHRMEYER

Christoph  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.474

28.033

WOLF

Nicolas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.640

26.932

ZIEGLER

Guido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.474

28.033

ABARZUA

Mario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.494

12.959

AMESTOY

Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.916

23.056

ASSERAF

Frédéric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.279

24.116

ASTENGO

José  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.661

18.694

AUCLAIR

Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

AZEVEDO

Ricardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.042

15.574

BARBOSA

Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

BARR

Doug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.079

23.604

BERGET

Nathalie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

BERNARD

Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.067

39.533

BIRMINGHAM

Dean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

BODDAERT

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.661

18.694

BONNET

François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.120

11.839

BOUAN

François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.299.984

612.733

BOULANGER

Jean-Bernard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

BREY

Carlos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.120

11.839

79592

BUCHANAN

Carlton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.664

36.605

CAPDEVILA

Jordi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.119.750

527.783

CASET

Oscar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.308

2.154

CHAMPENOIS

Xavier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.061.723

500.431

COLLART

Jean-Luc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

COMISKEY

John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.882

24.925

CRES

Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

CUMMINS

Kenny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.882

24.925

DAUBRESSE

Anne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

de la ROCHE AYMON

Guillaume  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67.425

31.780

DE L'ESTRANGE

Stéphane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370.879

174.810

DELASSUS

Dominique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.302

19.467

DEVLIN

Liam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.330

11.939

DIEUDONNÉ

Sylvestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.798

11.216

DINAMARCA

Jorge Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.357

7.178

DRU

Didier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

FALIKOFF

Miguel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.291

3.645

FERREIRA

Sergio M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.694

25.308

FISCHER

Glenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.120

11.839

FOUCHAULT

Jacques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.627

20.563

FRATANTONIO

Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

GALLOUX

Laurent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.919

13.630

GNAGNE AGNERO

Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.408

14.332

GOARVOT

Pierric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

GONCALO

Paulo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

GONZALES

Montse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

GOURIOU

Stéphane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

HAUTSCH

Stéphane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.957

15.269

HENDERSON

Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

HERNANDEZ

Jorge Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.588

17.794

HOLFERT

Tim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

925.985

436.453

HOSTE

Darren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.086

13.709

HOUEL

Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.591

1.795

IOTTI

Denis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

JAMORNJUREEKEL

Wijit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

JAYLES

Jérôme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.000

8.956

JEANNEAU

Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

JONES

Ted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.784

11.682

JUIN

Alain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

KEITLEY

Steven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.510

8.255

KHEDIM

José  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.177

3.588

KOO

Richard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128.559

60.594

KWEK

Doris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

LACERDA

Rodrigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

949.708

447.634

LATRILLE

Julien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.228

19.166

LAVIEVILLE

Jean-Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

LE FAY

Stéphane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

LE NEDIC

Jean-François . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

LEACH

David  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

LEMAHIEU

Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.898

5.608

LEPLEY

Gérard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

LEPOUDERE

Jean-Sébastien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

LI

Christin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.256

4.128

LIM

Vincent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

LUC

Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

79593

MACIEL

Norberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MARTOS RIERA

Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.916

23.056

MAUME

Patrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

MAYET

Didier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

Mc DONALD

Tim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.357

7.178

MEDINA

Aberlado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.459

29.910

MESLET GENDRON

Ghislaine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.120

11.839

MESSINEO

Pablo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MONTIAN - ART

Panthep  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MOSES

John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.079

23.604

MUNIZ

Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.086

13.709

NGUYEN

François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417.139

196.613

NUNES

Carlos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

NUNES

Marcos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.163

29.660

NUNN

Andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.667

28.810

OWENS

Richard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.784

11.682

PAGNON

Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.798

11.216

PAPARINI

Rodolfo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

PARRA

Jordi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

Parra MEDINA

Miguel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.171

27.417

PATISON

Micheal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278.361

131.202

PHILIPPE

Jacques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.247

10.015

PICHAT

Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

RENOUARD

Nathalie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.688

3.344

RIBES HURTADU

Maria Carmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

RICHARD

Nathalie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.149

29.508

RIVIÈRE

Sylvie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.120

11.839

ROBERTSON

Tom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

ROIG

Sever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

ROSSI

Véronique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.520

7.786

RUSSELL

Glyn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.534

10.767

SAEZ

Viviana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.070

22.597

SANCHO VENTURA

Juan José  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.559

24.301

SANDERSON

Brad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.382

6.191

SHACKLE

Steve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.084

13.708

SHORROCK

Mark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.934

5.467

SIBOTTIER

Dominique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.357

7.178

SMIGIELSKI

Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.051

15.578

STEENBRUGGE

Emmanuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.177

3.588

SUWANWALAIKORN

Sombat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

TAI

Lai Kok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

TAN

Ai Huat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.970

5.171

TARASCON

Florent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.177

3.588

TARASCON

Jean-Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.047

35.116

TAVAREZ

Luciano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.130

1.947

THÉRON

Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.304

19.940

THIBIERGE

Joseph  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.177

3.588

THOMAS

François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.441

12.463

TISCOSKI

Rivaldo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.357

7.178

TORRES CABELLO

José Ramon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.914

23.055

TOURBIER

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.708

17.045

TRIVELLI

Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.492

12.958

WALLAERT

Jean-Baptiste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.177

3.588

WHITFIELD

Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

WU

Haiming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.022

16.511

79594

XU

Ying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.256

4.128

ZHANG

Yongdong  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.256

4.128

ALARCON

Beltran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.119

10.425

ALVES SILVA

Julio Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.302

16.151

ANDRE

Régis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165.210

77.870

ANTONELLO

Stefano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.016

17.447

AUBERT

Jean-Paul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.629

13.022

BARCO

Suzana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

BAYET

Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

BEETS

Adolf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.764

12.382

BEN ARRIBA SAN AUGUSTIN Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.049

15.577

BIANCHI

Massimiliano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.408

14.332

BONASSI

Claude

79.241

37.350

BONNET

Jacques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.487

12.013

BOUEDEC

Pascal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.462

8.231

BOUTONNET

Sabine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.000

8.013

BROCHARD

Grégory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.000

8.013

BURET

Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

CALDAS

Rui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357.893

168.689

CALVET

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.888

11.259

CAMACHO

Manuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

CARON

Delphine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.630

14.437

CASTALDI

Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.089

12.768

CASTRO

Victor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

CAVAGNA

Gian Pietro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.610

3.115

CHAPUIS

Caroline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.203

7.166

CIRILLO

Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.510

8.255

CLAESSENS

Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.974

10.487

CLAESSENS

Vincent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.780

8.390

CLAUSIER

Christian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.641

13.028

COELHO

Luis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

COLENTIER

Nathalie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

COMMARET

Emmanuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.199

19.599

COMPIEGNE

Jean-Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.769

12.617

COUTABLE

Yves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

d'HARCOURT

Aline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.902

16.451

DE FREITAS

Catherine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.352

9.121

de LACAM

Hubert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.017

7.078

DELAS

André  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.352

9.121

DEMAZEL

Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.022

16.511

DEMEY

Laurent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.382

6.191

DERI

Luca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.373

24.215

DERI

Stefano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

DIDOT

Florence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.177

3.588

DUBUS

Annabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

DUCASSE

Etienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

EGUIA

Iñaki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

677.160

319.172

FALCETTI

Stefano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.220

6.231

FANUCCHI

Alessandro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

FAVALI

Manuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.632

26.221

FERNANDEZ

Ricardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

FERRI

Guiliano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

FIERRO

Curado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.815

6.512

FOLGRINGER

Patricia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.604

4.997

FOUGEROUSE

Patrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519.731

244.970

79595

FOURNIER

Ghislain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

FROUIN

Pierrick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.591

1.795

FUSETTI

Anna Maria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.120

11.839

GALLARDO CUERVA

Juan Antonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.591

1.795

GARCIA

Alexandre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.591

1.795

GAUSSEN

Christian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.304

14.728

GERI

Roberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.408

14.332

GESTIN

Jean-François . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.382

6.191

GHILARDI

Francesco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.283

12.388

GIANNI

Roberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.880

11.727

GIL

Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

GIL SERRANO

Javier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.952

2.476

GIRARD

Jean-Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.140

36.359

GIRES

Valerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.220

6.231

GIUSTI

Nicola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

GORDIEN

Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.255

8.895

GORI

Marco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

GRASSINI

Gabriella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.698

7.870

GRODARD

Etienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

GUERIN

Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.380

14.319

GUYON

Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.764

12.382

HANSSENS

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

HUBO

Didier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.888

11.259

INNOCENTI

Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.052

5.209

ISABELLA

Duilio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

717.246

338.066

JULOU

Hervé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.042

15.574

L'AMINOT

Ronan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.436

13.403

LE GOT

Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.462

8.231

LE METTER

Hugues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

371.722

175.207

LE ROSE

Amedeo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

LEVY

Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.108

10.624

MALFATTI

Sylvia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.203

7.166

MANTOVANI

Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.408

14.332

MARABOTTI

Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.857

9.359

MARCHESI

Alberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MARINELLI

Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MARTINO

Hervé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.950

20.975

MARTINS

Vitor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499.946

235.644

MASSON

Marcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.585

59.193

MAYMARD

Alain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.177

3.588

MICHIELETTO

Serse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.175

16.108

MONTOIR

Hervé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.248

14.256

MORER

Oscar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MORGADO FERNANDEZ

Antonio Joaquin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.357

7.178

PADOVAN

Cristian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

PEIGNEN

Agnès  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

PERNIN

Elisabeth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.256

4.128

PODOLSKY

Jérôme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.348

20.824

POUJOL

Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.888

11.259

PRIETO

Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

346.940

163.527

REIG

Michel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

RESENTE

Rui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.390

5.840

ROUSSEL

Jo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.769

12.617

SANA SUAREZ

Orlando  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.357

7.178

SERDOZ

Mario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.908

11.739

79596

SOM

Vibona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.608

3.115

STERCKX

Sébastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.963

46.113

TADDEI

Stefano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.842

11.708

TAPIADOR

Julian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.780

11.680

TERNACLE

Charles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.824

27.254

TORRENTE

Felix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.912

4.672

TRINCHELLO

Massimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.829

9.347

TRIOLO

Bruno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.111

9.950

VALSELLS

Oriol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337.033

159.218

VIAL PRAT

José  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.302

1.651

VITALI

Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

985.056

464.295

ZAGHI

Roberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

ZILAHI

Catherine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.448

8.224

ALBERTINI

Jean-Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

548.178

251.534

BEAMONTE

Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.954

5.359

BEQUART

Jean-Luc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.952

11.868

BINNINGER

Arnaud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

BRAZEAU

Xavier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

CAMINADE

Olivier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.952

18.378

CAO

Stéphane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.954

5.359

CARON

Christophe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.428

18.506

CHASTAGNOL

Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.752

13.170

COSSON

Michel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162.102

71.752

DANCER

Jacques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.122

8.574

D'HAENE

Dominique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.152

10.566

D'ISANTO

Arnaud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

D'ISANTO

Gérard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.556

20.452

DURAND

Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

FAVAUDON

Sebastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

FERRANDIS

Guy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

GACHET

Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.122

8.574

GOSSWEILER

Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

LAIGNIEL

Henri-Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.916

17.747

LEDOYEN

Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.312

3.259

MARCHAIS

Arnaud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.954

5.359

MARTIN

Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.042

15.574

MENARD

Jean-Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.952

18.378

MICHEL

Olivier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MIGNON

Patrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

MONARD

Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291.214

132.182

NIELSEN KOLDING

Kim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.522

7.787

PAUL

Olivier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.937

11.968

PERRIN

Gilbert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

PIASECKI

Stéphane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.086

13.238

REYNAUD

Laurent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

ROUX

Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.260

3.893

Société civile DANCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

481.234

225.242

Société civile GACHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211.274

98.886

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.574.094 19.561.366

<i>Troisième résolution

Les souscripteurs sus nommés, tous ici représentés par Madame Camille Bourke, prénommée, en vertu de procura-

tions sous seing privé ci-annexées, étant tous actionnaires de la Société et titulaires d'un compte courant ou d'obligation
(s) émise(s) par la Société, déclarent individuellement souscrire au nombre d'Actions A tel qu'indiqué dans le tableau ci-

79597

dessus, et les libérer intégralement par conversion partielle ou totale (selon le cas) de leur compte courant d'actionnaire
ou de leur créance obligataire.

L'apport en nature consistant en la conversion des comptes courants d'actionnaires ou créance(s) obligataire(s) est

acceptée par la Société, la valeur de cet apport en nature étant déclarée par les administrateurs de la société être de
trente-neuf millions cent vingt-deux mille sept cent trente-deux euros (39.122.732,- €), laquelle évaluation a été acceptée
par la Société et sujette à un rapport établi par la Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l., réviseur d'entreprises indépendant,
établi au 17, rue des Jardiniers, L-1026 Luxembourg, conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et qui conclut de la manière suivante:

"Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the contributions in kind is not at least equal to the number and the nominal value of the
ordinary shares to be issued, for a total amount of 39,613,880.- € to the maximum"

Soit en français:
"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites dans la Section 4 de ce rapport, aucun fait n'a été porté à

notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports en nature ne correspond pas au moins au
nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie pour un montant maximum de 39.613.880,- euros."

Lequel rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée constate que dix neuf millions cinq cent soixante et un mille trois cent soixante-six (19.561.366) Actions

nouvelles de catégorie A de valeur nominale de deux euros (2,- €) chacune ont été souscrites et libérées et ce pour
porter le capital social de la Société de son montant actuel de onze millions cinq cent deux mille soixante-huit euros
(11.502.068,- €) à cinquante millions six cent vingt-quatre mille huit cents euros (50.624.800,- €).

Les nouvelles Actions A émises ce jour confèrent à leurs souscripteurs les mêmes droits et obligations que les Actions

A déjà existantes.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 6. Le capital souscrit de la société est de cinquante million six cent vingt quatre mille huit cents euros (50.624.800,-

€), représenté par vingt et un million sept cent soixante-deux mille cent vingt-neuf (21.762.129) Actions A, trois millions
cinq cent cinquante mille deux cent soixante-dix (3.550.270) Actions B, et une (1) Action C, chaque action ayant une
valeur nominale de deux Euros (€ 2,-)".

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

à raison du présent acte est évalué à environ EUR 6.500,-.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux comparants, président, secrétaire et scrutateur, connus du notaire par leurs

nom et prénom, état et demeure, ils ont signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: C. BOURKE, J. VUILLQUEZ, V. HEMERY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2009. Relation: LAC/2009/28154. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009102357/616.
(090123350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

GAP-W International SV, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.761.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79598

<i>Pour GAP-W International SV

Référence de publication: 2009102442/10.
(090123102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Agence de Publicité Signtec S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-6719 Grevenmacher, 3, rue du Centenaire.

R.C.S. Luxembourg B 147.458.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am fünfzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

Frau Ute Schritz, Geschäftsführerin, geb. am 04.07.1970 in D-Stuttgart wohnhaft in D-54453 Nittel, Moselstraße 18A
und
Herr Edgar Michael Schritz, Geschäftsführer, geb. am 07.02.1963 in D-Trier wohnhaft in D-54453 Nittel, Moselstraße

18A

Diese  Komparenten  ersuchten  den  amtierenden  Notar  die  Satzungen  einer  zu  gründenden  Gesellschaft  mit  bes-

chränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschließlich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Gesetz
vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft:
Zweck der Gesellschaft ist der Einzelhandel mit Computer-Schriften zum Zwecke der Werbung und für sonstige

Zwecke; das Führen einer Werbeagentur mit dem Schwerpunkt Grafik-Design, Corporate Identity, Beratung, Logos,
Drucksachen, Anzeigenerstellung, Web- und Multimediadesign sowie Werbetechnik wie Beschriftungen, Werbeanlagen,
Digitaldruck, textile Promotion, Werbeartikel, Innenausstattung.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen; sie kann weiterhin sämtliche

handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck
Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.
Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland  zu  tätigen,  welche  direkt  oder  indirekt,  ganz-  oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter, allein
oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck oder
denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert. Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kon-
trolloder  Überwachungsmaßnahmen  ergreifen  und  jede  Art  von  Tätigkeit  ausüben  die  ihr  im  Rahmen  ihres  Gesell-
schaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „Agence de Publicité Signtec S.à r. l.".

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäfts-

führung an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500.-), eingeteilt in zwölf-

tausend fünfhundert Geschäftsanteile (12.500) zu je einem Euro (EUR 1.-), welche zu sechstausend zweihundertfünfzig
(6.250) Geschäftsanteile von Frau Schritz und sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Geschäftsanteile von Herrn Schritz
übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR

12.500.-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem
ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

79599

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von den Gesellschaftern

berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch

das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Artikel 6
gekennzeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter

durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Da der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung an erfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend Euro

(EUR 1.000.-) geschätzt.

<i>Anmerkung

Der amtierende Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft

vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftsz-
weck sein muss, was der Komparent ausdrücklich anerkannt hat.

<i>Generalversammlung

Sodann fassten die Gesellschafter welche das Stammkapital vereinigen, folgende Beschlüsse:
1. Frau Ute Schritz, Geschäftsführerin, geb. am 04.07.1970 in D-Stuttgart wohnhaft in D-54453 Nittel, Moselstraße

18A, wird auf unbestimmte Dauer zum Geschäftsführer mit Einzelzeichnungsrecht ernannt.

2. Herr Edgar Michael Schritz, Geschäftsführer, geb. am 07.02.1963 in D-Trier wohnhaft in D-54453 Nittel, Moselstraße

18A, wird zum kaufmännischen Direktor mit Einzelzeichnungsrecht ernannt, auf unbestimmte Dauer.

3. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet jeweils durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers oder des

kaufmännischen Direktors.

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 3, rue du Centenaire, L-6719 Grevenmacher.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt, erstellt wird.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräu-

chlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Signé: U. Schritz, E. Schritz et M. Schaeffer.
Enregistré  à  Luxembourg  Actes  Civils,  le  17  juillet  2009.  Relation:  LAC/2009/28708.  Reçu  soixante-quinze  euros

Eur75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009102425/98.
(090122877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

79600

WPA Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 87.600.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WPA HOLDINGS SARL
Signatures

Référence de publication: 2009102444/11.
(090123106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.369.

Les comptes annuels au 30 novembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102445/10.
(090123108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Santex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 74.564.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SANTEX S.A., a société anonyme governed by the

laws of Luxembourg, with registered office at 38, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, incorporated following
a deed of Maître Frank Baden notary, on February 23 

th

 , 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number 423, on June 15 

th

 , 2000, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies

under number B 74 564 (the "Company").

The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by deed of Maître

Alphonse Lentz, notary then residing in Remich, on July 22 

nd

 , 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, number 1008, on October 9 

th

 , 2004.

The meeting is declared open with Mrs Valérie Wesquy, private employee, residing professionally in Luxembourg, in

the chair,

who appointed as secretary Mrs Corinne Petit, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Isabel Dias, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1 To increase the corporate capital by an amount of three million thirty-six thousand four hundred Swiss francs (CHF

3.036.400) so as to raise it from its present amount of two hundred fifty thousand Swiss francs (CHF 250.000) to three
million two hundred eighty-six thousand four hundred Swiss francs (CHF 3.286.400);

2 To issue three hundred three thousand six hundred forty (303.640) new shares with a nominal value of ten Swiss

francs (CHF 10) per share, having the same rights and privileges as the existing shares;

3 To accept subscription for these new shares by WILONA GLOBAL S.A. and to accept payment in full for such new

shares by a contribution in cash;

4 To introduce an authorized capital of eight million Swiss francs (CHF 8.000.000);
5 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company;
6 To acknowledge that the board of directors is composed of three members instead of the initial five and therefore

amendment of article 7, first paragraph of the articles of association;

7 To amend article 10 of the articles of incorporation.

79601

8 Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list, which, signed by the shareholders present, by the proxies of the represented
shareholders, by the board of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.

III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary. The present meeting, representing the whole corporate capital of the Company, is
thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took, each time unanimously, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of three million thirty-

six thousand four hundred Swiss francs (CHF 3.036.400) so as to raise it from its present amount of two hundred fifty
thousand Swiss francs (CHF 250.000) to three million two hundred eighty-six thousand four hundred Swiss francs (CHF
3.286.400).

<i>Second resolution

The general meeting resolved to issue three hundred three thousand six hundred forty (303.640) new shares with a

nominal value of ten Swiss francs (CHF 10) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

<i>Third resolution

Thereupon has appeared Mrs Valerie WESQUY, prenamed, acting in her capacity as duly authorised attorney-in-fact

of WILONA GLOBAL S.A., with registered office at Panama-City, Arango-Orillac Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 Street

(Panama), by virtue of a proxy given in Luxmbourg on July 17 

th

 , 2009 (the "Subscriber").

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The Subscriber declared to subscribe for three hundred three thousand six hundred forty (303.640) new shares, having

each a nominal value of ten Swiss francs (CHF 10), and to make payment for such new shares, in a total amount of three
million thirty-six thousand four hundred Swiss francs (CHF 3.036.400). The amount of three million thirty-six thousand
four hundred Swiss francs (CHF 3.036.400) is thus as from now on at the disposal of the Company, evidence thereof
having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the general meeting resolved to accept the said subscription and payment and to allot the three hundred

three thousand six hundred forty (303.640) new shares to the Subscriber.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to establish an authorized capital of eight million Swiss francs (CHF 8.000.000), divided

into eight hundred thousand (800,000) shares of a nominal value of ten Swiss francs (CHF 10), with power to the Board
of Directors, for a period of five years from the date of publication of the present, to increase by one or several times
the subscribed capital within the limits of the authorised capital.

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to amend article 5, of the articles of association,

which will from now on read as follows:

Art. 5. The corporate capital is fixed at three million two hundred eighty-six thousand four hundred Swiss francs

(CHF 3.286.400) represented by three hundred twenty-eight thousand six hundred forty (328.640) shares, with a par
value often Swiss francs (CHF 10) each.

The shares are registered shares or bearer shares.
The authorised capital is set at eight million Swiss francs (CHF 8.000.000) represented by eight hundred thousand

(800,000) shares with a value often Swiss francs (CHF 10) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the sha-

reholders adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

Articles, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased
amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to
time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving to the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

79602

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares."

<i>Sixth resolution

The general meeting acknowledges that the board of directors is composed of three members instead of the initial

five and therefore decides to amend article 7, first paragraph of the articles of association, which will henceforth read as
follows:

Art. 7. first paragraph. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members,

shareholders or not."

<i>Seventh resolution

The general meeting furthermore decides to amend article 10 of the articles of association, which will from now on

read as follows:

Art. 10. Departing from what stated in article 9, the board of directors must decide upon the following issues with

a majority of all members:

a. any investment for amounts exceeding Swiss Francs two millions (CHF 2,000,000,-);
b. any investment in real estate;
c. acquisition or sale of companies;
d. mergers of companies, except the case of mergers between controlled companies for restructuring purposes;
e. sale of business or sale of relevant assets;
f. proposals of bond issues;
g. financial leverage degree definitions;
h. loan and guarantees to third parties not strictly related to the core business;
i. proposals of changes in the by-laws of the subsidiaries;
j. designation of the chairman among its members;
k. designation of the Managing Director/Chief Executive."
Nothing else being on the agenda, and none of the shareholders present or represented asking to speak, the meeting

was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

and capital reduction are estimated at two thousand eight hundred euro (EUR 2,800).

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Follows the French translation

L'an deux mil neuf, le dix-sept juillet.
Par-devant Martine SCHAEFFER, notaire de residence a Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme SANTEX S.A., avec siège social

à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden en date
du 23 février 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 423 du 15 juin 2000 et inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous B 74.564 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par-devant Maître

Alphonse Lentz, notaire alors de résidence à Remich, en date du 22 juillet 2002, publiée au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1008 du 9 octobre 2004.

L'assemblée est présidée par Madame Valérie Wesquy, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Corinne Petit, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabel Dias, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

79603

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1.  Augmentation  du  capital  social  d'un  montant  de  trois  millions  trente-six  mille  quatre  cent  francs  suisses  (CHF

3.036.400) de manière à porter le capital social de son montant actuel de deux cent cinquante mille Francs suisse (CHF
250.000) à un montant de trois millions deux cent quatre-vingt-six mille quatre cents Francs suisses (CHF 3.286.400);

2. Emission de trois cent trois mille six cent quarante (303.640) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix

Francs suisses (CHF 10) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes;

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions par WILONA GLOBAL S.A, ayant son siège social à Panama-

City,  Arango-Orillac  Building,  2 

nd

  Floor,  East  54 

th

  Street  (Panama)  et  acceptation  de  la  libération  intégrale  de  ces

nouvelles actions par un apport en numéraire;

4. Introduction d'un capital autorisé de huit millions de Francs suisses (CHF 8.000.000);
5. Modification de l'article 5 des statuts de la Société;
6. Constatation que le conseil d'administration et composé de trois membres au lieu des cinq membres initiaux et

modification subséquente de l'article 7, alinéa premier des statuts de la Société;

7. Modification de l'article 10 des statuts de la Société;
8. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et
le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de trois millions trente-six mille quatre cent Francs

suisses (CHF 3.036.400) de manière à porter le capital social de son montant actuel de deux cent cinquante mille Francs
suisses (CHF 250.000) à un montant de trois millions deux cent quatre-vingt-six mille quatre cents Francs suisses (CHF
3.286.400).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'émettre trois cent trois mille six cent quarante (303.640) actions nouvelles ayant une valeur

nominale de dix Francs suisses (CHF 10) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

<i>Troisième résolution

Ensuite a comparu Madame Valérie Wesquy, prénommée, agissant en qualité de mandataire de la société WILONA

GLOBAL S.A., avec siège social établi à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 Street (Panama), en

vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg le 17 juillet 2009 (le "Souscripteur").

Ladite procuration, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux
formalités de l'enregistrement.

Le Souscripteur a déclaré souscrire trois cent trois mille six cent quarante (303.640) actions nouvelles ayant chacune

une valeur nominale de dix Francs suisses (CHF 10) et libérer intégralement ces actions ainsi souscrites par un apport
en espèces d'un montant total de trois millions trente-six mille quatre cent Francs suisses (CHF 3.036.400).

En conséquence le montant intégral de trois millions trente-six mille quatre cent Francs suisses (CHF 3.036.400) a dès

lors été mis à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

L'assemblée décide d'accepter ladite souscription et libération et d'attribuer les rois cent trois mille six cent quarante

(303.640) actions nouvelles au Souscripteur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'instaurer un capital autorisé de huit millions de Francs suisses (CHF 8.000.000), divisés en huit

cent mille (800.000) actions d'une valeur nominale de dix Francs suisses (CHF 10), avec pouvoir au Conseil d'Adminis-
tration, pendant une période de cinq ans, à dater du présent acte, d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
à l'intérieur des limites du capital autorisé.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions précédentes l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui sera dorénavant

rédigé comme suit:

79604

Art. 5. Le capital émis de la Société est fixé à trois millions deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent Francs suisses

(CHF 3.286.400) représenté par trois cent vingt-huit mille six cent quarante (328.640) actions ayant chacune une valeur
nominale de dix Francs suisses (CHF 10).

Les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à huit millions de Francs suisses (CHF 8.000.000) qui sera représenté par huit cent mille

(800.000) actions d'une valeur de dix Francs suisses (CHF 10) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-
après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents Statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le
conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi."

<i>Sixième résolution

Les actionnaires constatent que le conseil d'administration est composé de trois membres au lieu des cinq membres

initiaux et décide en conséquence de modifier l'article 7, alinéa premier des statuts de la Société, qui aura désormais la
teneur suivante:

Art. 7. alinéa premier. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non."

<i>Septième résolution

Les actionnaires ont décidé de modifier l'article 10 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 10. Ainsi qu'il est prévu à l'article 9, le conseil d'administration doit décider à l'unanimité sur les points suivants:
a) tout investissement pour des montants dépassant deux millions de francs suisses (2.000.000,- CHF),
b) tout investissement immobilier,
c) acquisition ou vente de société
d) fusions de sociétés à l'exception des fusions entres sociétés du groupe pour des raisons de restructurations,
e) vente du fonds de commerce ou des avoirs essentiels,
f) projet concernant l'émission d'obligations,
g) fixation du nouvel endettement,
h) prêts et garanties à des tiers non strictement en relation avec l'activité principale,
i) proposition de changements de statuts des filiales,
j) désignation du Président parmi ses membres,
k) désignation de l'Administrateur-Délégué/Chief Executive."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation et frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte, s'élèvent à environ deux mille huit cents euros (EUR 2.800).

Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: V. Wesquy, C. Petit, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré  à  Luxembourg  Actes  Civils,  le  21  juillet  2009.  Relation:  LAC/2009/29301.  Reçu  soixante-quinze  euros

Eur75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

79605

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009102374/249.
(090123248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Eikon Invest III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 82.133.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EIKON INVEST III S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009102449/12.
(090123121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.434.

Les comptes annuels au 30 novembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102447/10.
(090123116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Pfizer Global Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.370.

Les comptes annuels au 30 novembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102446/10.
(090123112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

WJH Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.074.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WJH HOLDINGS SARL

Référence de publication: 2009102443/10.
(090123104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

L'Occitane Groupe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 125.718.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79606

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009102276/12.
(090122420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Fort Dumoulin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 54, avenue du Maréchal Foch.

R.C.S. Luxembourg B 30.653.

Par jugement rendu le 5 novembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant

en matière commerciale, après avoir entendu le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:

- FORT DUMOULIN S.à r.l. (B30653), avec siège social à L-1931 Luxembourg, 54, avenue du Maréchal Foch, de fait

inconnue à cette adresse,

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Bertrand Christmann
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009102309/16.
(090122430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

International Services Luxembourg (Inselux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 26.291.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 15. Juli 2009.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Prüfungsgesellschaft KPMG Audit, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 9,

Allée Scheffer, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg.

<i>Für INTERNATIONAL SERVICES LUXEMBOURG (INSELUX) S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2009102330/15.
(090122432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Forex Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 22.578.

Par jugement rendu le 5 novembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant

en matière commerciale, après avoir entendu le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:

- FOREX HOLDING S.A. (B22578), dont le siège social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, a été dénoncé en

date du 9 avril 1990,

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Bertrand Christmann
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009102295/15.
(090122435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

79607

Merrill Lynch Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 600.001,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.670.

In the year two thousand nine, on the first day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Merrill Lynch Equity S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg with registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.670 and having a share capital of EUR
600,000.- (the Company). The Company has been incorporated on February 5, 2007 pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 753 on
May 2, 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last
time pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, on February 26, 2009, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 680 on March 30, 2009.

There appeared:

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incor-

porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 96.380 and having a share capital of EUR 7,220,000.- (the Sole Shareholder),

hereby represented by Gilles Ralet, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1.-) in order to bring the share capital

of the Company from its present amount of six hundred thousand euro (EUR 600,000.-) represented by five hundred
forty thousand (540,000) class A shares and sixty thousand (60,000) class B shares, with a par value of one euro (EUR
1.-) each, to six hundred thousand and one euro (EUR 600,001.-) by way of the issuance of one (1) new class A share of
the Company, having a par value of one euro (EUR 1.-).

2. Subscription for and payment of the newly issued share as specified under item 1. above by a contribution in kind.
3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase of the share capital specified under item 1. above.

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued share in the register of shareholders of the Company and to see to any formalities in
connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with the relevant
Luxembourg authorities).

5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1.-) in

order to bring the share capital of the Company from its present amount of six hundred thousand euro (EUR 600,000.-)
represented by five hundred forty thousand (540,000) class A shares and sixty thousand (60,000) class B shares, with a
par value of one euro (EUR 1.-) each, to six hundred thousand and one euro (EUR 600,001.-) by way of the issuance of
one (1) new class A share of the Company, having a par value of one euro (EUR 1.-).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

79608

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to the new

share of the Company, having a par value of one euro (EUR 1.-), and fully pays it up by way of a contribution in kind
consisting in a receivable in an aggregate amount of three hundred fifteen thousand seven hundred euro (EUR 315,700.-)
that the Sole Shareholder has against the Company (the Receivable).

The contribution in kind of the Receivable to the Company, in an aggregate net value of three hundred fifteen thousand

seven hundred euro (EUR 315,700.-) is to be allocated as follows:

(i) an amount of one euro (EUR 1.-) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and
(ii) an amount of three hundred fifteen thousand six hundred ninety nine euro (EUR 315,699.-) is to be allocated to

the share premium reserve account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced by inter alia, (i) the pro forma accounts of the

Company dated June 29, 2009 and signed for approval by the management of the Company (the Pro Forma Accounts)
and (ii) a contribution certificate issued on the date hereof by the management of the Sole Shareholder and acknowledged
and approved by the management of the Company.

The contribution certificate dated July 1, 2009 issued by the management of the Sole Shareholder and the Company

in respect of the Receivable states in essence that:

"- the Receivable contributed by the Sole Shareholder to the Company is shown on the attached pro forma accounts

as per June 29, 2009 (the Pro Forma Accounts);

- the Sole Shareholder is the sole owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power

to dispose of the Receivable;

- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable contributed to the Company per the

attached Pro Forma Accounts is valuated at at least three hundred fifteen thousand seven hundred euro (EUR 315,700.-)
and since the Pro Forma Accounts, no material changes have occurred which would have depreciated the value of the
contribution made to the Company;

- the Receivable contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is

not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be

accomplished  by  the  Sole  Shareholder  and  upon  the  contribution  of  the  Receivable  by  the  Sole  Shareholder  to  the
Company, the Company will become the full owner of the Receivable. which will be extinguished by way of confusion in
accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code."

Such certificate and a copy of the Pro Forma Accounts of Company, after signature "ne varietur" by the proxyholder

of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles, so

that it shall henceforth read as follows:

Art. 6. The Company's share capital is set at six hundred thousand and one euro (EUR 600,001.-) represented by

six hundred thousand and one (600,001) shares divided into five hundred forty thousand and one (540,001) class A shares
(the "Class A Shares") and sixty thousand (60,000) class B shares (the "Class B Shares"), with a par value of one euro
(EUR 1.-) each. Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings''

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company
with the registration of the newly issued share in the register of shareholders of the Company and to see to any formalities
in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with the relevant
Luxembourg authorities).

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,300.- (one thousand three hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

79609

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le premier jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Merrill Lynch Equity S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.670 ayant un capital social de EUR 600.000,- (la Société). La Société a été
constituée le 5 février 2007 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 753 du 2 mai 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à
Luxembourg, daté du 26 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°680 du 30 mars 2009.

A comparu :

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, avec siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.380 ayant un capital social
de EUR 7.220.000,- (l'Associé Unique),

ici représenté par Gilles Ralet, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregis-
trement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société ;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit :
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un euro (EUR 1,-) afin de porter le capital social de la

Société de son montant actuel de six cent mille euros (EUR 600.000,-) représenté par cinq cent quarante mille (540.000)
parts sociales de classe A et soixante mille (60.000) parts sociales de classe B, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR
1,-) chacune, à six cent mille un euros (EUR 600.001,-) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale de classe A de la
Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

2. Souscription à et libération de la part sociale nouvellement émise comme mentionné au point 1. ci-dessus par un

apport en nature.

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du capital

social mentionnée au point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'inscription de la part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société et de veiller à toutes les
formalités qui s'y rapportent (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des
autorités luxembourgeoises concernées).

5. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un euro (EUR 1,-) afin de porter

le capital social de la Société de son montant actuel de six cent mille euros (EUR 600.000,-) représenté par cinq cent
quarante mille (540.000) parts sociales de classe A et soixante mille (60.000) parts sociales de classe B, ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à six cent mille un euros (EUR 600.001,-) par l'émission d'une (1) nouvelle part
sociale de classe A de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation

du capital social comme suit:

<i>Souscription - Libération

Sur ce, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à la nouvelle part sociale

de la Société ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), et la libère intégralement par un apport en nature composé

79610

d'une créance d'un montant total de trois cent quinze mille sept cents euros (EUR 315.700,-) que l'Associé Unique détient
envers la Société (la Créance).

L'apport en nature de la Créance à la Société, d'une valeur nette totale de trois cent quinze mille sept cents euros

(EUR 315.700,-) sera affecté de la manière suivante:

(i) un montant d'un euro (EUR 1,-) sera affecté au compte capital social nominal de la Société, et
(ii) un montant de trois cent quinze mille six cent quatre-vingt dix-neuf euros (EUR 315.699,-) sera affecté au compte

de réserve de prime d'émission de la Société.

L'évaluation de l'apport en nature de la Créance est documentée, entre autres, par (i) les comptes pro forma de la

Société datés du 29 juin 2009 et signés pour accord par la gérance de la Société (les Comptes Pro Forma) et (ii) un
certificat d'apport émis à la date des présentes, par la gérance de l'Associé Unique et constaté et approuvé par la gérance
de la Société.

Le certificat d'apport daté du 1 

er

 juillet 2009 émis par la gérance de l'Associé Unique et la Société en ce qui concerne

la Créance expose essentiellement que :

"- la Créance apportée par l'Associé Unique à la Société est indiquée sur les comptes pro forma annexés au 29 juin

2009 (les Comptes Pro Forma);

- l'Associé Unique est l'unique propriétaire de la Créance, et il est le seul à avoir droit à la Créance et a le pouvoir de

céder la Créance ;

- la Créance est certaine, liquide et exigible ;
- sur base de principes comptables généralement acceptés au Luxembourg, la valeur de la Créance apportée à la Société

d'après les Comptes Pro Forma annexés est estimée à au moins trois cent quinze mille sept cent euros (EUR 315.700,-)
et depuis les Comptes Pro Forma, aucun changement matériel ne s'est produit qui aurait déprécié la valeur de l'apport
fait à la Société ;

- la Créance apportée à la Société est librement cessible par l'Associé Unique à la Société et n'est soumise à aucune

restriction ou grevée d'un gage ou privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur ; et

- toutes les formalités afin de transférer la propriété juridique de la Créance apportée à la Société ont été ou seront

accomplies par l'Associé Unique et dès l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Société deviendra le
plein propriétaire de la Créance qui s'éteindra par confusion conformément à l'article 1300 du Code Civil luxembour-
geois."

Ce certificat et une copie des Comptes Pro Forma de la Société, après signature "ne varietur" par le mandataire de la

partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis aux formalités de
l'enregistrement.

L'apport en nature de la Créance de l'Associé Unique à la Société sera affecté au compte de capital social nominal de

la Société.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de sorte qu'il

aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à six cent mille un euros (EUR 600.001,-) représenté par six cent mille

un (600.001) parts sociales divisées en cinq cent quarante mille un (540.001) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales
de Classe A") et soixante mille (60.000) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B") d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires"

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de
la Société à l'inscription de la part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société et de veiller à
toutes les formalités qui s'y rapportent (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents
auprès des autorités luxembourgeoises concernées).

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ EUR 1.300,- (mille trois cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

79611

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble

avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé : G. RALET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juillet 2009. Relation: LAC/2009/26696. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009102351/224.
(090123385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Financière du Stuff S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 105.803.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FINANCIERE DU STUFF S.A.
N. THIRION / F. DUMONT
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009102452/12.
(090123127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 127.959.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 août 2009.

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR
Signatures

Référence de publication: 2009102453/13.
(090123140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Access Management Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 94.564.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009102454/11.
(090123144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Montagebau Schwarz Michael S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5362 Schrassig, 4, rue de l'Orée.

R.C.S. Luxembourg B 147.470.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend neun.
Den zweiundzwanzigsten Juli.

79612

Vor dem unterzeichneten Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster, in Vertretung seines verhinderten Kollegen

Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg), welch letztgenannter Depositar der
gegenwärtigen Urkunde bleibt.

ist erschienen:

Herr Michael SCHWARZ, Schreiner, wohnhaft in D-54294 Trier, Daunerstrasse 10,
hier vertreten durch Herrn Helge STOFFELS, Steuerfachangestellter, wohnhaft in D-54343 Föhren, Müllenburg 33,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 22. Juli 2009,

welche Vollmacht nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Komparenten und dem amtierenden Notar

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher  Komparent,  vertreten  wie  vorerwähnt,  den  instrumentierenden  Notar  ersuchte,  folgende  Gesellschafts-

gründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "MONTAGEBAU SCHWARZ MICHAEL S.à r.l."

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schrassig.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Montagebau von Fenstern, Türen und Rollläden.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder

denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN

HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche integral durch Herrn
Michael SCHWARZ, Schreiner, wohnhaft in D-54294 Trier, Daunerstrasse 10, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€

12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690

des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter Ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

79613

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-

gen  bezüglich  der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  ein.  Sie  sind  jedoch  für  die  ordnungsgemässe  Ausführung  ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.

Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2009.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

<i>Erklärung

Der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon,

dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Michael SCHWARZ, Schreiner, geboren in Trier (Deutschland), am 28. Juli 1969, wohnhaft in D-54294 Trier,

Daunerstrasse 10.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und

verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5362 Schrassig, 4, rue de l'Orée.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.

Gezeichnet: H. STOFFELS, Jean SECKLER
Enregistré à Echternach, le 23 juillet 2009. Relation: ECH/2009/1043. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

<i>Le Receveur (signé): J.- M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

79614

Echternach, den 30. Juli 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009102416/113.
(090123065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Koch KIG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 143.585.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 05 mai 2009, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 26 mai 2009.

Francis KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009102282/13.
(090122506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Gomareal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 56.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GOMAREAL S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009102451/12.
(090123125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Deldeg Multi-Projects S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 128.324.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009102455/11.
(090123147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Block Conseil S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3503 Dudelange, 31, Um Kraeizbierg.

R.C.S. Luxembourg B 137.252.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102456/10.
(090123150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Kinnevik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 64.958.

<i>Résolution du Conseil d'Administration de la société, qui a eu lieu au Luxembourg le 30 juin 2009.

Résolution

79615

Le Conseil d'Administration décide d'approuver le transfert du siège social de la société du 2-4, avenue Marie-Thérèse

L-2132 Luxembourg au 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Il a été également résolu que le procès-verbal a été signé par deux administrateurs de la société.
Aucun autre point n'étant porté à l'agenda, l'assemblée a été clôturée.

Mikael Holmberg / Anja Schröder.

<i>Resolution by the Board of Directors of the Company, taken at a meeting in Luxembourg on June 30, 2009

Resolution
The Board of Directors resolved to move the registered office of the Company from 2-4, avenue Marie-Thérèse

L-2132 Luxembourg to 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, with effect as at 1 July, 2009.

It was further resolved that these minutes be signed by two directors of the Board.
There being no further items on the agenda the meeting was closed.

Mikael Holmberg / Anja Schröder.

Référence de publication: 2009102336/21.
(090121968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Neweb Creations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R.C.S. Luxembourg B 141.142.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 31 juillet 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Jean SECKLER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009102284/14.
(090122514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Central America Trading, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 89.540.

<i>Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Central America Trading tenu au siège de la société

<i>en date du 15 juin 2009.

Les associés sont présents.
Les gérants ont pris la décision suivante:
Les associés décident:
- de transférer le siège social de la société du 62, Route de Luxembourg L-4760 Pétange au 165 A, Route de Longwy

L-4751 Pétange.

La décision a été admise à l'unanimité.
Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Signé en nom de CENTRAL AMERICA TRADING

Mr D'ARGEMBEAU Marc
<i>Gérant administratif

Référence de publication: 2009102288/19.
(090121978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

CCP II Peine S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 129.782.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2008 - Annule et remplace le dépôt numéro L090107375.04 du 16 juillet 2009 a été

déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

79616

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102460/11.
(090123167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Almeda S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 147.472.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend neun.
Den vierzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1) Die Aktiengesellschaft DAIRO HOLDING S.A., mit Sitz in L-2419 Luxemburg, 7, rue du Fort Rheinsheim, eingetragen

beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 48.933.

2) Die Gesellschaft INLAND NAVIGATION LUXEMBOURG S.A., abgekürzt „INL S.A", mit Sitz in L-5401 Ahn, 7,

route du Vin, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 78.719.

Beide Gesellschaften sind hier vertreten durch Frau Evelien MACLEANEN, Privatbeamtin, wohnhaft in L-5401 Ahn,

5, route du Vin, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 08. Juli 2009.

welche Vollmachten, von der Komparentin und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie vorerwähnt, den handelnden Notar ersuchten die Satzungen einer zu grün-

denden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Almeda S.A." gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können. Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung der Binnenschifffahrt jeder Art.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Ausserdem kann die Gesellschaft alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer Art

ausüben, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen
lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften
teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben, verwalten und verwerten.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt ZWEIUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 32.000.-), eingeteilt in drei

hundert zwanzig (320) Aktien mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT EURO (€ 100.-), welche in voller Höhe
eingezahlt sind.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

79617

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so kann, falls das Gesetz es erlaubt, das frei gewordene Amt

vorläufig besetzt werden, unter Beachtung der dann geltenden Gesetze.

Art. 7. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden erwählen. Im Falle der Verhinderung

des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Zum ersten Mal kann die der Gesellschaftsgründung folgende ausserordentliche Generalversammlung einen Vorsi-

tzenden und/oder einen Delegierten des Verwaltungsrats ernennen.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat alle Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft

im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und
durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung und alle Handlungen bleiben weisungsgebunden an die Gene-
ralversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern, wovon eine Unterschrift die des Delegierten des Verwaltungsrates sein muss oder durch die Einzelunters-
chrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 13. Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor oder Handlungsbevollmächtigten, seine

Erben und Rechtsnachfolger, schadlos halten für jeden Ausfall, Verlust oder Schaden (inbegriffen die Gerichtskosten eines
jeden Prozesses), welcher ihm oder ihnen entstanden wäre durch Handlungen, Klagen, Rechtsstreitigkeiten oder Prozesse,
an welchen er oder sie beteiligt wären in seiner oder ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder, Bevollmächtigte
oder Direktoren dieser Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft von welcher diese Gesellschaft Hauptaktionärin
oder Gläubigerin wäre, es sei denn, die betreffenden Personen wären schlussendlich wegen schwerer Nachlässigkeit oder
schlechter Verwaltung verurteilt worden. Bei einem aussergerichtlichen Vergleich erfolgt eine solche Entschädigung nur
dann, wenn der Rechtsbeistand dieser Gesellschaft ihr bestätigt hat, dass die betreffende Person nicht verantwortlich ist
wegen schwerer Nachlässigkeit oder schlechter Verwaltung. Dieser Schadenersatzanspruch schliesst andere Rechtsans-
prüche der betreffenden Person nicht aus.

Art. 14. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 15. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-

chreiben genannten Ort zusammen, und zwar am ersten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres um 14:00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschafts-
kapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

79618

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren vor.

Art. 20. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft

dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verp-
flichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-

tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 22. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2010 statt.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Urkunde erwachsen, auf ungefähr ein tausend drei hundert Euro (€ 1.300.-).

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden gezeichnet wie folgt:

1) Die Gesellschaft DAIRO HOLDING S.A., vorgenannt, zwei hundert vierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
2) Die Gesellschaft INLAND NAVIGATION LUXEMBOURG S.A., vorgenannt, achtzig Aktien . . . . . . . . . . . .

80

Total: drei hundert zwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Das  gezeichnete  Kapital  wurde  in  voller  Höhe  eingezahlt.  Demzufolge  steht  der  Gesellschaft  der  Betrag  von

ZWEIUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 32.000.-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und
von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der

Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse
gefasst:

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2014 stattfindet, werden ernannt:
- Frau Sandy PIUS, Schiffsführerin, geboren in Antwerpen (Belgien), am 06. Januar 1977, wohnhaft in B-2170 Antwerpen-

Merksem, Pauwstraat 36.

- Frau Evelien MACLEANEN, Privatbeamtin, geboren in Eindhoven (Niederlande), am 19. Januar 1973, wohnhaft in

L-5401 Ahn, 5, route du Vin.

- Frau Silke KOSTER, Privatbeamtin, geboren in Trier (Deutschland), am 29. März 1981, wohnhaft in D-54308 Langsur,

Römerstrasse 1.

3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:

79619

Die Gesellschaft EWA Revision S.A., mit Sitz in L-9053 Ettelbrück, 45, avenue J.F. Kennedy, eingetragen beim Handels-

und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 38.937.

4) Die Generalversammlung beschliesst Frau Sandy PIUS, vorbenannt, zum delegierten Verwaltungsratsmitglied zu

ernennen, ihr Mandat endet bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2014, mit der Befugnis die
Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung zu verpflichten und die Gesellschaft gegenüber Dritten im
Rahmen dieser tagtäglichen Geschäftsführung durch ihre Einzelunterschrift rechtsgültig zu vertreten

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Echternach, in der Amtsstube, des amtierenden Notars, Am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrie-
ben.

Gezeichnet: E. MACLEANEN, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 14 juillet 2009. Relation: ECH/2009/982. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

<i>Le Receveur

 (signé): J.- M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 30. Juli 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009102418/172.
(090123085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

CCP II Neumarkt S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 129.843.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2008 - Annule et remplace le dépôt numéro L090107379.04 du 16 juillet 2009 a été

déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102461/11.
(090123172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

CCP II Soest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 129.783.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2008 - Annule et remplace le dépôt numéro L090107371.04 du 16 juillet 2009 a été

déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102462/11.
(090123175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

CCP II Straubing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 129.784.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2008 - annule et remplace le dépôt numéro L090107369.04 du 16 juillet 2009 a été

déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102463/11.
(090123180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

MDM DPR Finance Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 121.170.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

79620

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009102464/10.
(090122964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Jetlink Aviation, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 140.950.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Karine REUTER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009102277/11.
(090122448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Husky Injection Molding Systems, Société Anonyme.

Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 21.683.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102467/10.
(090122974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

ICEC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 117.630,45.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 144.514.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of July.
Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Stichting Administratiekantoor ICEC, a foundation organised under the laws of The Netherlands, with its official seat

in Vrouwenmantel 3A, 2871 NJ Schoonhoven, The Netherlands, registered at the Trade Register of the Chamber of
Commerce of The Netherlands under the number 24441743 (hereafter the "Shareholder), here duly represented by Mr
Jan Arie DEKKER, board member of the Shareholder, with address in NL-2101 GC Heemstede, Van Merlenlaan, 25 (the
Netherlands).

The Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I.- The Shareholder is the sole shareholder of ICEC Holding S. à r.l., a société à responsabilité limitée (joint stock

limited liability company) having its registered office at L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim (Grand Duchy of
Luxembourg), incorporated under the name "ICEC HOLDING A.V.V." and which registered office and central adminis-
trative seat was transferred from Oranjestad to Luxembourg on January 15th, 2009 by notarial deed before Maître Martine
Schaeffer prenamed, deed published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 443 of February
28th, 2009 (hereafter the "Company").

II.- The issued share capital of the Company is currently fixed at one hundred thirteen thousand one hundred fifty-

three point forty Dollars of the United States (113.153.40 USD) divided into two hundred fifty-one thousand four hundred
fifty-two (251.452) shares with a nominal value of zero point forty-five Dollars of the United States (0,45 USD) each, all
of which are fully paid up.

III.- The Shareholder has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

<i>Agenda

1. Increase of the subscribed share capital by an amount of four thousand four hundred seventy-seven point five Dollars

of the United States (4.477,05 USD) so as to raise it from its current amount of one hundred thirteen thousand one
hundred fifty-three point forty Dollars of the United States (113.153,40 USD) to the amount of one hundred seventeen

79621

thousand six hundred thirty point forty-five Dollars of the United States (117.630,45 USD) by the issuance of nine thousand
nine hundred forty-nine (9.949) new shares of a nominal value of zero point forty-five Dollars of the United States (0,45
USD) each with a share premium of two hundred seventy-six point forty-six Dollars of the United States (276,46 USD)
per share, having same rights and obligations than the existing shares, for a total amount of two million seven hundred
fifty-four thousand nine hundred seventy-seven point fifty-nine Dollars of the United States (2.754.977,59 USD);

2. Subscription and payment of the nine thousand nine hundred forty-nine (9.949) new shares by the sole Shareholder,

the Stichting Administratiekantoor ICEC, a foundation organised under the laws of The Netherlands, with its official seat
in Vrouwenmantel 3A, 2871 NJ Schoonhoven (The Netherlands), registered at the Trade Register of the Chamber of
Commerce of the Netherlands under the number 24441743, by a contribution in cash;

3. Amendment of article 5§1 of the by-laws so as to reflect the decisions taken;
4. Miscellaneous.
IV.- The Shareholder requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to increase the subscribed share capital by an amount of four thousand four hundred seventy-

seven point five Dollars of the United States (4.477,05 USD) so as to raise it from its current amount of one hundred
thirteen thousand one hundred fifty-three point forty Dollars of the United States (113.153,40 USD) to the amount of
one hundred seventeen thousand six hundred thirty point forty-five Dollars of the United States (117.630,45 USD) by
the issuance of nine thousand nine hundred forty-nine (9.949) new shares of a nominal value of zero point forty-five
Dollars of the United States (0,45 USD) each with a share premium of two hundred seventy-six point forty-six Dollars
of the United States (276,46 USD) per share, having same rights and obligations than the existing shares.

<i>Second resolution

The nine thousand nine hundred forty-nine (9.949) new shares of a nominal value of zero point forty-five Dollars of

the United States (0,45 USD) each with a share premium of two hundred seventy-six point ninety-one Dollars of the
United States (276,46 USD) per share have been subscribed and entirely paid up by the Shareholder, Stichting Adminis-
tratiekantoor ICEC, prenamed, by a contribution in cash.

Evidence of such contribution has been given to the undersigned notary by a bank certificate, so that the amount of

two million seven hundred fifty-four thousand nine hundred seventy-seven point fifty-nine Dollars of the United States
(2.754.977,59 USD) is as of now available to the Company.

Said bank certificate will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, article 5 §1 of the bylaws has been amended and will now be read as

follows:

Art. 5. §1. Share capital. The issued capital of the Company is set at one hundred seventeen thousand six hundred

thirty point forty-five Dollars of the United States (117.630,45 USD) divided into two hundred sixty-one thousand four
hundred and one (261.401) shares with a nominal value of zero point forty-five Dollars of the United States (0,45 USD)
each, all of which are fully paid up."

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at two thousand six hundred euro (EUR 2,600).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same person
and in case of any divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le dix-sept juillet.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Stichting Administratiekantoor ICEC, une fondation existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Vrou-

wenmantel 3A, 2871 NJ Schoonhoven, Pays-Bas, immatriculée au Registre du Commerce de la Chambre de Commerce
des Pays-Bas sous le numéro 24441743 (ci-après l'«Associé»), dûment représentée par Monsieur Jan Arie Dekker, mem-
bre du conseil de gestion de l'Associé, demeurant à NL-2101 GC Heemstede, Van Merlenlaan, 25 (Pays-Bas).

L'Associé, représenté comme mentionné ci-dessus, a demandé au notaire instrumentaire d'enregistrer que:

79622

I.- L'Associé est le seul associé de ICEC Holding S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2419

Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim (Grand-Duché de Luxembourg), constituée sous la dénomination «ICEC HOLD-
ING A.V.V.» et dont le siège social et l'administration centrale ont été transférés de Oranjestas, Aruba à Luxembourg
par acte notarié du 15 janvier 2009 par devant le notaire instrumentaire publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 443 du 28 février 2009 (ci-après la "Société")

II.- Le capital émis de la Société est actuellement fixé à cent treize mille cent cinquante-trois virgule quarante cents

dollars des Etats-Unis (113.153,40 USD) divisé en deux cent cinquante et un mille quatre cent cinquante-deux (251.452)
parts sociales ayant une valeur nominale de zéro virgule quarante-cinq dollars des Etats-Unis (0,45 USD) chacune, celles-
ci étant entièrement libérées.

III.- L'Associé a reconnu être totalement informé des résolutions devant être prises sur la base de l'agenda suivant:

<i>Ordre du jour

1) Augmentation du capital social souscrit à concurrence d'un montant de quatre mille quatre cent soixante-dix-sept

virgule cinq dollars des Etats-Unis (4.477,05 USD) pour le porter de son montant actuel de cent treize mille cent cinquante-
trois virgule quarante dollars des Etats-Unis (113.153,40 USD) au montant de cent dix-sept mille six cent trente virgule
quarante-cinq dollars des Etats-Unis (117.630,45 USD) par l'émission de neuf mille neuf cent quarante-neuf (9.949) nou-
velles  parts  sociales  d'une  valeur  nominale  de  zéro  virgule  quarante-cinq  dollars  des  Etats-Unis  (0,45  USD)  chacune
augmentée d'une prime d'émission de deux cent soixante-seize virgule quarante-six dollars des Etats-Unis (276,46 USD)
par part sociale, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, pour un montant total de deux
millions  sept  cent  cinquante-quatre  mille  neuf  cent  soixante-dix-sept  virgule  cinquante-neuf  dollars  des  Etats-Unis
(2.754.977,59 USD);Souscription et libération des neuf mille neuf cent quarante-neuf (9.949) nouvelles parts sociales par
l'associé unique, Stichting Administratiekantoor ICEC, une fondation existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège
social à Vrouwenmantel 3A, 2871 NJ Schoonhoven, Pays-Bas, immatriculée au Registre du Commerce de la Chambre de
Commerce des Pays-Bas sous le numéro 24441743, par un apport en numéraire;

3) Modification de l'article 5 alinéa 1 des statuts afin de refléter les décisions prises;
4) Divers.
IV.- L'Associé a demandé au notaire instrumentaire d'enregistrer les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence d'un montant de quatre mille quatre cent

soixante-dix-sept virgule cinq dollars des Etats-Unis (4.477,05 USD) pour le porter de son montant actuel de cent treize
mille cent cinquante-trois virgule quarante dollars des Etats-Unis (113.153,40 USD) au montant de cent dix-sept mille six
cent trente virgule quarante-cinq dollars des Etats-Unis (117.630,45 USD) par l'émission de neuf mille neuf cent quarante-
neuf (9.949) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de zéro virgule quarante-cinq dollars des Etats-Unis (0,45
USD) chacune augmentée d'une prime d'émission de deux cent soixante-seize virgule quarante-six dollars des Etats-Unis
(276,46 USD) par part sociale, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Deuxième résolution

Les neuf mille neuf cent quarante-neuf (9.949) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de zéro virgule quarante-

cinq dollars des Etats-Unis (0,45 USD) chacune augmentée d'une prime d'émission de deux cent soixante-seize virgule
quarante-six dollars des Etats-Unis (276,46 USD) par part sociale ont été souscrites et entièrement libérées par l'Associé,
Stichting Administratiekantoor ICEC, prénommée, par un apport en numéraire.

La preuve de la contribution a été donnée au notaire par un certificat de blocage des fonds, de sorte que le montant

de deux millions sept cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix-sept virgule cinquante-neuf dollars des Etats-
Unis (2.754.977,59 USD) est à présent à la disposition de la Société.

Ledit certificat restera attaché au présent acte pour être enregistré avec lui.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié et a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1. Capital Emis. Le capital émis de la Société est fixé à cent dix-sept mille six cent trente virgule quarante-

cinq dollars des Etats-Unis (117.630,45 USD) divisé en deux cent soixante et un mille quatre cent une (261.401) parts
sociales ayant une valeur nominale de zéro virgule quarante-cinq dollars des Etats-Unis (0,45 USD) chacune, celles-ci étant
entièrement libérées.»

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont

estimées à deux miles six cents euros (2.600 EUR).

Le notaire instrumentant, qui comprend et qui parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête du comparant,

le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française et qu'à la requête du même com-
parant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

79623

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a avec Nous notaire signé le présent acte.

Signé: J. A. Dekker et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29292. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009102365/152.
(090123134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

ABN AMRO Converging Europe Investments, S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 112.130.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102489/12.
(090122832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

MHG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.341.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102486/10.
(090122830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

MFH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.815.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102483/10.
(090122826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Soim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adelaïde.

R.C.S. Luxembourg B 54.049.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102480/10.
(090122993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

79624

Elistart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 78.380.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009102474/12.
(090122815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Carbeneth Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 49.562.

Les comptes annuels au 30 novembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102495/10.
(090122846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Carbeneth Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 49.562.

Les comptes annuels au 30 novembre 2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102497/10.
(090122847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

FKS Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.695.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102498/10.
(090123012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

4rae Renewable and Alternative Energy Investments S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions

sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 140.056.

RECTIFICATIF

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

4rae Renewable and Alternative Energy S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 140.057, with a share capital of EUR 12,500,-, acting in its capacity
as manager (the Manager) of 4rae Renewable and Alternative Energy Investments S.C.A. SICAR (the Company), repre-

79625

sented by Maître Grégory Beltrame, avocat, with professional address in Luxembourg, which declared and requested the
notary to state that:

I. The Company, a Luxembourg société en commandite par actions organised as a société d'investissement en capital

à risque, having its registered office at L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 140.056, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated 4 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 1883 of 31 

st

 July 2008, whose articles of association have been amended several times and for the last

time by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated 3 July 2009, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Deed)

II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Acknowledgement of a material error relating to the name of two of the three subscribers of the thirty-five thousand

four hundred and eighty-seven (35,487) newly issued Class A Shares in the share capital of the Company as described in
paragraph V of the Deed;

2. Rectification of the Deed by replacing the name of Cum Grano Salis S.a r.l. by Agate B.V. and Wodwal Holdings

Limited by Kenket Holdings Ltd. in relation to the issuance of eleven thousand eight hundred and twenty-nine (11,829)
Class A Shares to each of the above-mentioned entities;

3. Miscellaneous.
III. The following corrective resolutions have to be taken:

<i>First resolution

It is acknowledged that a material error occurred in paragraph V of the Deed relating to the name of two of the three

subscribers of the thirty-five thousand four hundred and eighty-seven (35,487) newly issued Class A Shares in the share
capital of the Company.

<i>Second resolution

It is resolved to rectify the Deed by replacing the name of Cum Grano Salis S.a r.l. by Agate B.V., a private company

with limited liability, organised under the laws of the Netherlands, and having its corporate seat in Amsterdam, the
Netherlands, and address at: 1118 CX Luchthaven Schiphol, the Netherlands, Evert van de Beekstraat 310, Trade Register
number: 20137456 (Agate) and Wodwal Holdings Limited by Kenket Holdings Ltd., a company organised under the laws
of Liberia, with address at: 80 Broad Street, Monrovia, Liberia, registered under number C-110349 (Kenket).

Consequently, the thirty-five thousand four hundred and eighty-seven (35,487) newly issued Class A Shares have been

fully subscribed as follows:

- eleven thousand eight hundred and twenty-nine (11,829) additional Class A Shares by Agate;
- eleven thousand eight hundred and twenty-nine (11,829) additional Class A Shares by Kenket; and
- eleven thousand eight hundred and twenty-nine (11,829) additional Class A Shares by Rompetrol Holding S.A., a

company organised under the laws of Switzerland, having its address at: Route de Chantemerle 58, 1763 Granges Paccot,
Fribourg, Switzerland, registered with the Trade Register of Fribourg under file number: CH 217-0138827-9 (Rompetrol).

The thirty five thousand four hundred and eighty-seven (35,487) newly issued Class A Shares have been entirely paid

up by contributions in kind made by Agate, Kenket and Rompetrol to the Company, as approved by the Resolutions (as
defined in the Deed), evidence of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it expressly. The
remaining amount of the contributions in kind has to be splitted as follows: an amount of thirty five million four hundred
fifty one thousand five hundred and thirteen euro (EUR 35,451,513.-) has to be booked to the share premium account
of the Company and an amount of one thousand four hundred and thirty-four Euro (EUR 1,434.-) has to be repaid to
Agate, Kenket and Rompetrol.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of this

corrective deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le dix-sept juillet.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

79626

A comparu:

4rae Renewable and Alternative Energy S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 7 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 140.057, avec un capital social de 12.500 EUR, agissant en sa qualité de gérant (le Gérant)
de  4rae  Renewable  and  Alternative  Energy  Investments  S.C.A  SICAR  (la  Société),  dûment  représentée  par  Grégory
Beltrame, Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

La partie comparante, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La Société, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois organisée en société d'investissement

en capital à risque, ayant son siège social au 7 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.056, a été constituée suivant l'acte de Maître Gérard
Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, en date du 4 Juillet 2008, publié au Mémorial, recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1883 du 31 Juillet 2008, dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par un acte de
Maître Martine. Schaeffer, notaire résidant au Luxembourg, en date du 3 juillet 2009, qui n'a pas encore été publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (l'Acte).

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Reconnaissance d'une erreur matérielle relative au nom de deux des trois souscripteurs des trente-cinq mille quatre

cent quatre-vingt-sept (35.487) nouvelles Actions de Classe A émises dans le capital social de la Société comme décrit
au paragraphe V de l'Acte;

2. Rectification de l'Acte en remplaçant le nom de Cum Grano Salis S.à.r.l par Agate B.V et Wodwal Holdings Limited

by Kenket Holdings Ltd. en relation avec l'émission de onze mille huit, cent vingt-neuf (11.829) Actions de Classe A pour
chacune des sociétés susmentionnées;

3. Divers.
III. Les résolutions correctrices suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est reconnu qu'une erreur matérielle est intervenue au paragraphe V de l'Acte concernant le nom de deux des trois

souscripteurs des trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept (35.487) nouvelles Actions de Classe A émises dans le
capital social de la Société.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de rectifier l'Acte en replaçant le nom de Cum Grano Salis S.à r.l par Agate B.V, une société à responsabilité

limitée, de droit néerlandais, dont le siège social se situe à Amsterdam au: 1118 CX Luchthaven Schipol, Evert van de
Beekstraat 310, Pays-Pas, inscrite au registre du commerce sous le numéro: 20137456 (Agate) et Wodwal Holdings
Limited by Kenket Holdings Ltd., une société de droit du Libéria, dont l'adresse est: 80 Broad Street, Monrovia, Liberia,
enregistrée sous le numéro: C-110349 (Kenket).

Par conséquent, les trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept (35.487) nouvelles Actions de Classe A émises ont

été entièrement souscrites comme suit:

- onze mille huit cent vingt-neuf (11.829) Actions de Classe A supplémentaires par Agate
- onze mille huit cent vingt-neuf (11.829) Actions de Classe A supplémentaires par Kenket; et
- onze mille huit cent vingt-neuf (11.829) Actions de Classe A supplémentaires par Rompetrol Holding S.A, une société

de droit suisse, dont l'adresse est: 58 Route de Chantemerle, 1763 Granges Paccot, Fribourg, Suisse, inscrite au registre
du commerce de Fribourg sous le numéro: CH 217-0138827-9 (Rompetrol).

Les trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept (35.487) Actions de Classe A nouvellement émises ont été entiè-

rement libérées par des apports en nature faits par Agate, Kenket et Rompetrol à la Société, comme approuvé par les
Résolutions (comme défini dans l'Acte), la preuve a été donnée au notaire désigné qui l'a reconnue expressément. Le
montant restant des apports en nature doit être divisé comme suit: un montant de trente-cinq millions quatre cent
cinquante et un mille cinq cent treize euros (EUR 35.451.513,-) doit être enregistré dans le compte de prime d'émission
de la Société et un montant de mille quatre cent trente-quatre euros (EUR 1.434,-) doit être remboursé à Agate, Kenket
et Rompetrol.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte rectificatif sont estimés à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la personne comparante ci-dessus, le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

79627

Signé: G. Beltrame et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 juillet 2009. Relation: LAC/2009/29296. Reçu douze euros Eur 12.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009102375/132.
(090123258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

MEI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.465.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102477/10.
(090122824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Mastertec Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.261.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009102493/10.
(090122842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Mastertec Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.261.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009102494/10.
(090122843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

WOOD &amp; Company Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 83.396.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102499/10.
(090122850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Black Ant Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 110.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Black Ant Luxembourg S.à r.l.

79628

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009102448/14.
(090123119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Cheyne Capital Guaranteed Credit S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 133.421.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009102465/10.
(090122968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Akustik Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 19.652.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102458/10.
(090123156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

LUX-INOTEC Sicherheitssysteme S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 92.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102457/10.
(090123154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

WIHSA Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.572.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WIHSA HOLDINGS S.A.

Référence de publication: 2009102441/10.
(090123099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

IAFS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 99.475.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79629

Junglinster, le 31 juillet 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009102279/14.
(090122475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

MGR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.814.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102475/10.
(090122821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Cerilly Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102501/10.
(090123014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

TVM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 134.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102503/10.
(090122857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Audemars Microtec Lux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 69.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102504/10.
(090123016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Flying Group Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Luxembourg, route de Trèves, Findel Airport.

R.C.S. Luxembourg B 141.715.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79630

Junglinster, le 31 juillet 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009102280/14.
(090122488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Les associés M. Thierry Blondeau, M. Etienne Boulard, M. Valéry Civilio, M. Laurent de La Mettrie, M. Sami Douénias,

M. Bernard Dubois, M. Philippe Duren, M. Amaury Evrard, M. Michel Guilluy, M. Luc Henzig, M. Pierre Krier, Mme
Véronique Lefebvre, M. Jean-Robert Lentz, M. Steven Libby, M. Gian Marco Magrini, M. Mervyn Martins, M. Laurent Marx,
M. Roland Mertens, M. Marc Minet, M. Olivier Mortelmans, M. Didier Mouget, M. Paul Neyens, M. John Parkhouse, Mme
Valérie Piastrelli, M. Wim Piot, M. Christophe Pittie, M. Didier Prime, M. Pascal Rakovsky, Mme Odile Renner, M. Michiel
Roumieux, M. Marc Saluzzi, M. Serge Saussoy, M. Thomas Schiffler, M. Philippe Sergiel, M. Günter Simon et Luxfide S.à
r.l., représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ont
pris les décisions suivantes:

- La collectivité des associés entérine avec effet au 1 

er

 juillet 2009 les cessions de parts entre Luxfide S.à r.l. et les

autres associés telles que approuvées par le Conseil de Gérance en accord avec l'article 7 des statuts lors de sa réunion
du 15 mai 2009.

- Comme conséquence des résolutions précédentes, le registre des associés sera modifié de la façon suivante au 1

er

 juillet 2009:

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

2. Monsieur Etienne Boulard, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg,

deux cent quarante-trois parts sociales (243);

3. Monsieur Valéry Civilio, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg,

deux cent quarante-trois parts sociales (243);

4. Monsieur Laurent de La Mettrie, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxem-

bourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

5. Monsieur Sami Douénias, expert-comptable, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxem-

bourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

6. Monsieur Bernard Dubois, consultant en gestion d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch

à L-1471 Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

7. Monsieur Philippe Duren, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

8. Monsieur Amaury Evrard, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

9. Monsieur Michel Guilluy, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg,

deux cent quarante-trois parts sociales (243);

10. Monsieur Luc Henzig, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxem-

bourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

11. Monsieur Pierre Krier, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxem-

bourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

12. Madame Véronique Lefebvre, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

13. Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

14. Monsieur Steven Libby, certified public accountant, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

15. Monsieur Gian Marco Magrini, consultant en gestion d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route

d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

79631

16.  Monsieur  Mervyn  Martins,  réviseur  d'entreprises,  demeurant  professionnellement  400,  route  d'Esch  à  L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

17. Monsieur Laurent Marx, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

18. Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg,

deux cent quarante-trois parts sociales (243);

19. Monsieur Marc Minet, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxem-

bourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

20. Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

21. Monsieur Didier Mouget, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

22. Monsieur Paul Neyens, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

23.  Monsieur  John  Parkhouse,  réviseur  d'entreprises,  demeurant  professionnellement  400,  route  d'Esch  à  L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

24. Madame Valérie Piastrelli, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

25. Monsieur Wim Piot, expert-comptable, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg,

deux cent quarante-trois parts sociales (243);

26. Monsieur Christophe Pittie, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

27. Monsieur Didier Prime, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

28. Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

29. Madame Odile Renner, consultante, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg, deux

cent quarante-trois parts sociales (243);

30. Monsieur Michiel Roumieux, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg,

deux cent quarante-trois parts sociales (243);

31. Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

32. Monsieur Serge Saussoy, conseil fiscal, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg,

deux cent quarante-trois parts sociales (243);

33. Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471

Luxembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

34. Monsieur Philippe Sergiel, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

35. Monsieur Günter Simon, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement 400, route d'Esch à L-1471 Lu-

xembourg, deux cent quarante-trois parts sociales (243);

36. Luxfide S.à.r.l., réviseur d'entreprises, dont le siège social est situé 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg B 60.245, douze mille cent soixante-treize parts sociales (12.173);

Total: vingt mille six cent soixante-dix-huit parts sociales (20.678).

Luxembourg, le 15 mai 2009.

<i>Pour PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Pascal Rakovsky

Référence de publication: 2009103605/97.

(090123596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

79632


Document Outline

4rae Renewable and Alternative Energy Investments S.C.A. SICAR

ABN AMRO Converging Europe Investments, S.C.A., Sicar

Access Management Luxembourg

Agence de Publicité Signtec S.à r.l.

Akustik Bau S.à r.l.

Almeda S.A.

Audemars Microtec Lux Holding S.A.

Black Ant Luxembourg

Block Conseil S.àr.l.

Carbeneth Luxembourg S.A.

Carbeneth Luxembourg S.A.

CCP II Neumarkt S.à.r.l.

CCP II Peine S.à.r.l.

CCP II Soest S.à r.l.

CCP II Straubing S.à r.l.

Central America Trading

Cerilly Finance S.A.

Cheyne Capital Guaranteed Credit S.A.

C. &amp; P. International Holding S.A.

Deldeg Multi-Projects S.A.

Eikon Invest III S.A.

Elistart S.A.

Eterna S.A.

Financière du Stuff S.A.

FKS Investments Holding S.A.

Flying Group Lux S.A.

Forex Holding S.A.

Fort Dumoulin S.à r.l.

GAP-W International SV

Gomareal S.A.

Husky Injection Molding Systems

IAFS S.A.

ICEC Holding S.à r.l.

ING Life Luxembourg S.A.

International Services Luxembourg (Inselux) S.à r.l.

Jetlink Aviation

Kinnevik S.A.

Koch KIG Luxembourg S.à r.l.

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR

L'Occitane Groupe S.A.

LUX-INOTEC Sicherheitssysteme S.A.

Mastertec Invest S.A.

Mastertec Invest S.A.

Matsa S.A.

MDM DPR Finance Company S.A.

MEI S.à r.l.

Merrill Lynch Equity S.à r.l.

MFH S.à r.l.

MGR S.à r.l.

MHG S.à r.l.

Montagebau Schwarz Michael S.à r.l.

Neweb Creations S.à r.l.

Pfizer Global Investments Sàrl

Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl

Pfizer Warner Lambert Luxembourg S.à r.l.

PricewaterhouseCoopers

Santex S.A.

Shaf Corporation SPF, S.A.

S.I. Umbolt S.A.

Soim S.A.

T-A-J-P-M- S.A.

TVM S.A.

WIHSA Holdings S.A.

WJH Holdings Sàrl

WOOD &amp; Company Group S.A.

WPA Holdings Sàrl