logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1421

23 juillet 2009

SOMMAIRE

ACCOFIN, Société Fiduciaire  . . . . . . . . . . .

68170

Agardh Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68163

AGD Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68169

Allegra Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

68168

Aral Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68167

Arcelor Commercial Rebar S.A.  . . . . . . . . .

68171

ArcelorMittal Belval & Differdange  . . . . . .

68170

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.  . .

68171

ArcelorMittal International  . . . . . . . . . . . . .

68171

Capinvest International Holding S.A.  . . . .

68166

Caralto Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68171

Casatex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68164

CC-Center SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68166

CitCor Residential Holdings S.à r.l.  . . . . . .

68174

Condo Hotel Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

68208

Condo Hotel Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

68208

Dayson S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68166

Dinvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68163

Duforêt Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68162

Erste Luxemburger Forderungsankaufge-

sellschaft AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68162

Euro Investment 2000 S.A. . . . . . . . . . . . . . .

68163

Europ Infos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68169

Faïence S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68206

F.B.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68170

Fondations Capital Management S.A.  . . . .

68197

Galileo Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

68168

Gamma 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68208

Garage du Riesenhoff S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

68204

Gestion Comptable et Fiscale S.A. . . . . . . .

68194

HFC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68162

HNM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68166

Immotep S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68205

Integral Solutions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68167

Kabuki S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68162

Kaelum Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68167

Kateco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68168

LAIF Luxembourg Holding S.à r.l.  . . . . . . .

68165

Lala Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

68164

LaSalle German Income and Growth Lu-

xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68164

Lys Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68170

Madidi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68169

Malderen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68164

Mercator Finance Luxembourg AG  . . . . . .

68165

Miras S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68163

Niwron S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68172

Noir I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68171

Ojaco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68169

Opportunity Fund III Hochheim Property

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68172

Opportunity Three  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68162

Otto Finance Luxembourg A.G.  . . . . . . . . .

68165

Paninvest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68166

Pearson Luxembourg Holdings  . . . . . . . . . .

68165

Polarsun Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68167

Resitalia Equity S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68169

R.N.O. Group S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68170

Silverimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68165

Siren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68167

Société Financière EDITH  . . . . . . . . . . . . . .

68168

Stodiek Ariane III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68172

Stodiek Ariane II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68172

Stodiek Ariane I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68172

Topvel Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

68207

Trimline Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68168

Troimats S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68173

Vandus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68163

Verdandi Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

68164

Zhermack International S.à r.l.  . . . . . . . . . .

68208

68161

Kabuki S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 80.896.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 22 juin 2009 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de fixer le siège social au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 juillet 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2009083686/14.
(090099326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Opportunity Three, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 139.683.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009084286/10.
(090100254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Erste Luxemburger Forderungsankaufgesellschaft AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 136.548.

Les comptes annuels au 28 février 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084287/10.
(090100235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

HFC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 140.377.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084288/10.
(090100236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Duforêt Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 75.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084289/10.
(090100237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68162

Agardh Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 91.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084292/10.
(090100238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Vandus, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 131.119.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084293/10.
(090100239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Euro Investment 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084295/10.
(090100240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Miras S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 140.429.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084297/10.
(090100243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Dinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 24.540.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
18, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Nathalie Wolff / Isabelle ASSERAY
<i>Member of Management / Membre de la Direction

Référence de publication: 2009084337/14.
(090101216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68163

LaSalle German Income and Growth Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 118.529.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084276/10.
(090100281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Lala Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 135.534.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084299/10.
(090100244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Casatex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 143.165.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084300/10.
(090100246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Malderen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 61.058.

Mention rectificative du bilan déposé le 29/06/2009, accepté au registre sous le N 

o

 L090093499.04.

Le bilan modifié au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084309/11.
(090100231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Verdandi Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 130.373.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Verdandi Holding S.à r.l.
SGG S.A.
<i>Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009084280/13.
(090100252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68164

Silverimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 142.789.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084302/10.
(090100248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Otto Finance Luxembourg A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2510 Luxembourg, 31, rue Schafstrachen.

R.C.S. Luxembourg B 83.846.

Les comptes annuels au 28 février 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084310/10.
(090100232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Mercator Finance Luxembourg AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2510 Luxembourg, 31, rue Schafstrachen.

R.C.S. Luxembourg B 136.816.

Les comptes annuels au 28 février 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084311/10.
(090100233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Pearson Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.716.

Les comptes annuels au 30 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Pearson Luxembourg Holdings
Benoît NASR

Référence de publication: 2009084342/11.
(090101248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

LAIF Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.584.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LAIF Luxembourg Holding S.à r.l.
SGG S.A.
<i>Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009084278/13.
(090100251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68165

Paninvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 74.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084312/10.
(090100229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

HNM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 140.541.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084313/10.
(090101314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Capinvest International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 10.018.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CAPINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A.
SGG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009084283/12.
(090100253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Dayson S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.306.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084314/10.
(090100211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

CC-Center SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8821 Koetschette, 3, rue Napoléon.

R.C.S. Luxembourg B 86.466.

Le Bilan au (Die Bilanz von) 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (wurde im

Luxemburger Handelsregister eingereicht).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.)

Koetschette, den 14.05.09.

Signature (Unterschrift).

Référence de publication: 2009084393/12.
(090101190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68166

Siren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 18.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084315/10.
(090100214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Polarsun Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084316/10.
(090100215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Kaelum Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 87.281.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084317/10.
(090100217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Integral Solutions, Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 117.977.

<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> juillet 2009

L'assemblée générale extraordinaire:
- décide d'accepter le transfert du siège social à l'adresse suivante: L-9227 DIEKIRCH, 50, Esplanade.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009084388/11.
(090100868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Aral Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 5.722.

AUSZUG

Das Mandat von Gerbert Baumgartner als Geschäftsführer der Gesellschaft endete am I. Oktober 2002.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations.
Zwecks Veröffentlichung des Vorstehenden im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

Référence de publication: 2009084699/13.
(090100406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68167

Société Financière EDITH, Société Anonyme.

Siège social: L-6488 Echternach, 8, rue des Vergers.

R.C.S. Luxembourg B 94.665.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Société Financière EDITH
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009084710/12.
(090100291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Galileo Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 124.975.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084731/10.
(090100266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Allegra Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 106.377.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084732/10.
(090100268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Kateco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 44.829.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KATECO S.A.
Mariagrazia RINALDI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009084736/12.
(090101179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Trimline Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 29.944.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084734/10.
(090100271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68168

Madidi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.

R.C.S. Luxembourg B 81.330.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MADIDI S.A.
Mohammed KARA / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009084739/12.
(090101186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Europ Infos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 81.202.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2009084748/11.
(090101048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

AGD Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 114.858.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2009084751/11.
(090100492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Resitalia Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 95.323.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084746/10.
(090101312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Ojaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 111.694.

Les comptes annuels au 30/09/2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009084771/10.
(090100328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68169

ACCOFIN, Société Fiduciaire, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.592,01.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 62.492.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084749/11.
(090100651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

F.B.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 55.580.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2009084754/11.
(090100499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

R.N.O. Group S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 137.558.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084774/10.
(090100648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

ArcelorMittal Belval &amp; Differdange, Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 41.983.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084775/10.
(090100837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Lys Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.365.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LYS FINANCE S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009084773/12.
(090100830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68170

ArcelorMittal International, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 3.983.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084776/10.
(090100844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 2.050.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084778/10.
(090100847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Arcelor Commercial Rebar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 2, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 47.058.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084779/10.
(090100853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Noir I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.927.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2009.

Michael Verhulst.

Référence de publication: 2009084780/10.
(090100677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Caralto Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 17.938.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/03/2009 à Luxembourg

Suite au décès de Monsieur Guy GLESENER, liquidateur, l'Assemblée décide de nommer en remplacement Monsieur

Etienne Gillet, expert comptable, né à Bastogne le 19/09/1968, avec adresse professionnelle 3A, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que nouveau liquidateur de la société.

Pour copie conforme
Etienne Gillet
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2009084727/14.
(090101092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68171

Stodiek Ariane I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 66.603.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084781/10.
(090100856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Stodiek Ariane II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 66.604.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084782/10.
(090100858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Niwron S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 28.683.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour NIWRON S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009084772/12.
(090100827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Stodiek Ariane III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 66.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009084783/10.
(090100860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Opportunity Fund III Hochheim Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 116.885.

Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Opportunity Fund III Property S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009084793/12.
(090100804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68172

Troimats S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 106.601.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le dix-huit juin.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Benoît CAILLAUD, avocat, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la

Pétrusse,

Agissant  en  sa  qualité de mandataire  spécial  de  Monsieur  Fred-Gérard  STADLER,  né le  30  mars 1942  à  Ruegsau

(Belgique), administrateur de sociétés, demeurant à CH-1228 Plan Les Ouates (Suisse),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 11 juin 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société anonyme TROIMATS S.A., R.C.S. Luxembourg B 106.601, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg,

128, boulevard de la Pétrusse, a été constituée suivant acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niede-
ranven en date du 14 février 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 675 en date du 8
juillet 2005;

- que le capital social de la société anonyme TROIMATS S.A. s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS

(31.000,- EUR) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100 EUR)
libérées à hauteur de CENT POUR CENT (100%);

- que Monsieur Fred-Gérard STADLER est devenu seul propriétaire de toutes les actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution

anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 31 mai 2009,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du

passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 31 mai 2009 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de

leurs mandats respectifs;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2330 Luxembourg,

boulevard de la Pétrusse, 128.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. CAILLAUD, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 juin 2009. Relation: LAC/ 2009/ 24313. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009084424/220/54.
(090100508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68173

CitCor Residential Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 130.183.

In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of June.
Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg-Eich, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in

replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed.

There appeared

"CPI CPEH 2 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 118.036,

"Corpus Sireo Investment Residential No. 2 GmbH" (formerly known as "Corpus Sireo Wohnen Beteiligung No. 2

GmbH"), a limited liability company existing under the laws of Germany, having its registered office at Düsseldorf, Ger-
many, registered with the Düsseldorf Trade Register under number HRB 57351,

both here represented by Mrs Nadia WEYRICH, employee, professionally residing at Belvaux, by virtue of proxies,

given on 19 June 2009 and on 23 June 2009.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the sole partners of "CitCor RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l.", (hereinafter the "Com-

pany"), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 130.183, incorporated pursuant to a notarial deed dated 9 July 2007, whose
articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 11 September
2007 (number 1951, page 93609) (the "Mémorial C"), and whose by laws have never been amended yet.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to change the par value of the existing shares from one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-)

each to one Euro (EUR 1.-) each, so that the share capital is represented by twelve thousand and five hundred (12,500)
shares of one Euro (EUR 1.-) each.

<i>Second resolution

The partners resolve to create two (2) classes of shares referred to as the class A shares (the "Class A Shares") and

the class B shares (the "Class B Shares") each such shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) and with such rights
and obligations as set out in the Company's articles of incorporation, as further adopted.

<i>Third resolution

The partners decide to transform the twelve thousand five hundred (12,500) existing shares with a nominal of one

Euro (EUR 1.-) each into eleven thousand two hundred and fifty (11,250) class A shares and one thousand two hundred
and fifty (1,250) class B shares.

Following the creation of the different classes of shares, the share capital shall be allocated as follows:
- "CPI CPEH 2 S.à r.l.", prenamed: eleven thousand two hundred and fifty (11,250) class A shares;
- "Corpus Sireo Investment Residential No. 2 GmbH", prenamed: one thousand two hundred and fifty (1,250) class B

shares.

<i>Fourth resolution

The partners decide to increase the Company's share capital by an amount of six hundred twenty-three thousand two

hundred thirty-seven Euro (EUR 623,237.-), so as to raise it from its present amount of twelve thousand and five hundred
euro (EUR 12,500.-) up to six hundred thirty-five thousand seven hundred thirty-seven Euro (EUR 635,737) by the issue
of five hundred sixty thousand nine hundred and thirteen (560,913) Class A Shares (the "New Class A Shares") and sixty-
two thousand three hundred twenty-four (62,324) Class B Shares (the "New Class B Shares" and together with the New
Class A Shares the "New Shares"), having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and having the same rights and obligations
as the existing shares.

The New Shares have been subscribed as follows:
a. all five hundred sixty thousand nine hundred and thirteen (560,913) New Class A Shares by "CPI CPEH 2 S.à r.l.",

prenamed, paid up by a contribution in kind consisting of unquestioned claims due for immediate payment held by "CPI
CPEH 2 S.à r.l." against the Company for (aa) an amount of four hundred forty-six thousand one hundred thirty-three

68174

Euro and sixteen Cent (EUR 446,133.16), and (bb) an amount of one hundred fourteen thousand seven hundred seventy-
nine Euro and eighty-four Cent (EUR 114,779.84) out of an unquestioned claim in the total amount of two hundred ninety-
two thousand five hundred Euro (EUR 292,500.-);

the total contribution of five hundred sixty thousand nine hundred and thirteen Euro (EUR 560,913.-) will be entirely

allocated to the share capital;

the proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary;
b. all sixty-two thousand three hundred twenty-four (62,324) New Class B Shares by "Corpus Sireo Investment Re-

sidential No. 2 GmbH", prenamed, paid up by a contribution in kind consisting of unquestioned claims due for immediate
payment held by "Corpus Sireo Investment Residential No. 2 GmbH" against the Company for (aa) an amount of forty-
nine thousand five hundred seventy Euro and thirty-five Cent (EUR 49,570.35) and (bb) an amount of twelve thousand
seven hundred fifty-three Euro and sixty-five Cent (EUR 12,753.65) out of an unquestioned claim in the total amount of
thirty-two thousand five hundred Euro (EUR 32,500);

the total contribution of sixty-two thousand three hundred twenty-four Euro (EUR 62,324.-) will be entirely allocated

to the share capital;

the proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The partners decide to determine the period of the first accounting year of the Company which shall begin on the

date of the incorporation of the Company, i.e on 9 July 2007 and shall terminate on 31 December 2007.

<i>Sixth resolution

The partners acknowledge the resignation of Michael Astarita, born in New York (New York - USA) on 19 August

1961, residing at 399 Park Avenue, 7 

th

 Floor, New York, NY 10022, USA, as from the date of today and resolve to accept

such resignation and to grant discharge to Michael Astarita for the performance of his duties as manager until then.

The partners acknowledge the resignation of Steven Skaar, born in Salt Lake City, Utah, USA on 21 July 1972, residing

at Ground Floor, Stirling Square, 5-7 Carlton Gardens, London SW1Y5AD, United Kingdom, as from the date of today
and resolve to accept such resignation and to grant discharge to Steven Skaar for the performance of his duties as manager
until then.

The partners resolve to appoint Dr. Christian Kolb, born in Mannheim, Germany, on 15 June 1975, residing profes-

sionally at 4a, rue Albert Borschette, L - 1246 Luxembourg, as manager of the Company for an undetermined duration
starting on the date of today.

The partners resolve to appoint John Cassin, born in New York, USA, on 4 December 1940, residing professionally

at 14-16 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, as manager of the Company for an undetermined duration starting on the
date of today.

<i>Seventh resolution

The partners decide to fully restate the Articles without changing the Company's purpose, in order to give them the

following wording:

CONSOLIDATED ARTICLES OF ASSOCIATION OF CitCor Residential Holdings S.à r.l.

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is formed a company with limited liability (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (the "Company") and in particular by the Luxembourg Companies Act as well as
by the present Articles.

Art. 2.
2.1 The Company's object is to acquire or sell or otherwise dispose and to hold, directly or indirectly, interests in

foreign real estate, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through
participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt
instruments in any form whatsoever, and to administer, develop and manage such interests.

2.2 The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its

subsidiaries or to its affiliated companies (the "Connected Companies"). It may also give guarantees and grant securities
in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries or its affiliated companies. The
Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3 The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

68175

2.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form, except by way of public offer, or to obtain any form of credit facility and raise funds

through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or
equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by

any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of the Luxembourg Companies Act.

2.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 3. The Company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company assumes the name "CitCor Residential Holdings S.à r.l.".

Art. 5.
5.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It

may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be trans-
ferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of Shareholders,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

B. Share capital

Art. 6.
6.1 The Company's share capital is set at six hundred thirty-five thousand seven hundred thirty-seven Euro (EUR

635,737.-) divided into five hundred seventy-two thousand one hundred sixty-three (572,163) Class A Shares in registered
form with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each and sixty-three thousand five hundred seventy-four (63,574) Class
B Shares in registered form with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

6.2 In addition to the issued share capital, there may be set a share premium account into which any share premium

paid on any Share in addition to its nominal value is transferred.

Art. 7.
7.1 The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the general meeting of

Shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

7.2 Unless otherwise provided for in these Articles or otherwise agreed by unanimous resolution at a general meeting

of Shareholders, any Capital Contribution to the Company shall be made with Shares and Shareholder Loans issued at
the then existing Net Asset Value ("NAV") per share. The Capital Contribution allocated to such Shares shall be booked
at the then existing nominal value with the balance of the contribution booked as share premium into the Company's
capital reserve.

7.3 If one of the Shareholder fails to make a Capital Contribution required to be made in accordance with an Agreed

Investment Budget or an Annual Budget (in case of the latter, however, only if the Annual Budget was approved by an
unanimous resolution at a general meeting of Shareholders) (such Shareholder is hereinafter referred to as a "Non-
Contributing Shareholder"), and such default is not cured within ten (10) Business Days of the date such payment was
due (a "Shortfall"), then any other Shareholder who himself is non a Non-Contributing Shareholder (a "Contributing
Shareholder") may pay the Shortfall directly to the Company in his own name and for his own account or for a third
shareholder nominated and represented under power of attorney by the Contributing Shareholder.

7.4 In case of and with respect to a Shortfall by the Non-Contributing Shareholder according to article 7.3, (i) the

Shares issued to the Contributing Shareholder funding such Shortfall shall be issued at fifty (50) percent of the NAV, (ii)
the Non-Contributing Shareholder shall transfer to the Contributing Shareholder from the Shareholder Loans granted
by the Non-Contributing Shareholder and/or its Affiliated Lenders (and the Non-Contributing Shareholder shall ensure

68176

such transfer by Affiliated Lenders if applicable) a portion equal to twenty-five (25) percent of the nominal value of
Shareholder Loans granted by the Contributing Party when funding such Shortfall ("Penal Dilution").

7.5 If any Shareholder fails to make a share Capital Contribution required to be made in accordance with an Annual

Budget to which it did not consent when the respective Annual Budget was approved at a general meeting of Shareholders,
article 7.3 shall apply mutatis mutandis with the exception that there shall not be Penal Dilution but a straight dilution
(i.e. Shares issued at NAV).

C. Transfer of shares

Art. 8.
8.1 Without prejudice of the provisions of the Luxembourg Companies Act, no Shareholder may transfer any Shares

or Shareholder Loans other than in accordance with the provisions of the Shareholders' Agreement and these Articles.
In the event of any purported transfer by a Shareholder of any Share or Shareholder Loan in violation of the Shareholders'
Agreement and these Articles, such purported transfer will be void and of no effect, and the Company will not give effect
to any such transfer.

8.2 Without prejudice to article 9.1, no transfers of Shares or Shareholder Loans shall be permitted hereunder, within

the first three years after the Commencement Date (the "Initial Holding Period"), without the prior written consent of
all the Shareholders and then only in accordance with this article 8.

8.3 Notwithstanding article 8.2 and subject to the provisions of the Luxembourg Companies Act, the following transfers

shall be permitted:

8.3.1 the transfer by a Shareholder of all or part of its Shares or Shareholder Loans to an Affiliate pursuant to article

8.5 below;

8.3.2 the transfer by a Shareholder of all or part of its Shares or Shareholder Loans to entities established by such

Shareholder for co-investment purposes alongside such Shareholder or alongside the direct shareholder of a Shareholder,
or a fund and/or third party investors whose investments are managed by a Shareholder and/or an Affiliate of a Shareholder
pursuant to article 8.5 below; and

8.3.3 the sale of all Shares of the Company or a sale of Shares of the Company via a listing on a stock exchange (the

"IPO") initiated by the Class A Shareholder pursuant to article 9.

8.4 It is acknowledged that the Company will have to be converted into a form of a company which allows the offering

of shares to the public and their listing on a stock exchange ("Public Company") before an IPO and that any provision of
these Articles that relate to an IPO will apply after the conversion of the Company into a Public Company.

8.5 Notwithstanding articles 8.3.1 and 8.3.2 above, each Shareholder may transfer all or part of its Shares to an Affiliate

or to entities established by such Shareholder for co-investment purposes alongside such Shareholder or alongside the
direct shareholder of a Shareholder, or a fund and/or third party investors whose investments are managed by a Share-
holder and/or an Affiliate provided that any Affiliates or entities holding Shares shall immediately retransfer its Shares to
the relevant Shareholder or one of its Affiliates if it ceases to be an Affiliate of the relevant Shareholder or managed by
relevant Shareholder.

8.6 Any transfer of Shares or Shareholder Loans shall in addition always be subject to and will be effective and reco-

gnized by the Company only if the transferee in each case, becomes a party to the Shareholders' Agreement or in case
of an assignment of Shareholder Loans, accepts the terms and conditions of the Shareholder Loans.

Art. 9.
9.1 The Class A Shareholder shall be entitled to decide at its sole discretion (i) upon the sale of all Shares in the

Company or a sale of part of the Shares in the Company which comprise more than forty (40) percent of the share capital
or (ii) on the sale of any number of Shares and the corresponding voting rights in the Company in connection with an
IPO (the "Class A Shareholder Exit Privilege") subject to article 9.3. For the avoidance of any doubt, this right is granted
to the Class A Shareholder also within the Initial Hold Period.

9.2 In case the Class A Shareholder exercises the Class A Shareholder Exit Privilege and subject to article 9.3, the

Class A Shareholder shall have a drag along right (the "Drag Along Right") with respect to all Class B Shares and Share-
holder Loans of the Class B Shareholder, provided, however, that:

9.2.1. any such sale is made at terms and conditions not less favorable than those at which the Class A Shareholder

sells its Shares;

9.2.2. the Class B Shares, including any Shareholder Loans, are not being sold for a purchase price below the amount

of the Total Investment Value of Class B Shareholder increased at a rate of five (5) percent since the date of the respective
Capital Contributions or Distributions were made;

9.2.3. the Class A Shareholder sells a portion of its shares comprising more than 40% of the share capital and voting

rights in the Company;

9.2.4. any Shares sold by the Class A Shareholder and the Class B Shareholder are sold to a third party and not to one

or more persons being Affiliates of the Class A Shareholder; and

68177

9.2.5. in case of a sale of Shares of the Class A Shareholder other than according to article 9.1 (ii) above, the Class A

Shareholder may only exercise its Drag Along Right with respect to all and every Share that the Class B Shareholder
holds at the relevant point of time in the Company.

9.3 Before the Class A Shareholder is entitled to exercise the Class A Shareholder Exit Privilege, the Class A Share-

holder shall promptly notify to the Class B Shareholder its intention to exercise the Class A Shareholder Exit Privilege
by written notice (the "Sale Notice") and the Class B Shareholder shall within forty-five (45) days after receipt of the Sale
Notice (the "Offer Period") be entitled to offer to the Class A Shareholder to purchase the Class A Shares at the relevant
point of time for a price to be stated in the offer (the "Class B Shareholder Offer") stating the terms and conditions on
which it is prepared to acquire the Class A Shares and any other interest in the Company (including without limitation,
the Shareholder Loans) and the Class B Shareholder shall be bound to the Class B Shareholder Offer for a period of
forty-five (45) days. If the Class A Shareholder does not accept the Class B Shareholder Offer, the Class A Shareholder
is free to sell its Shares in the Company to a third party at a price no less than and under terms and conditions no less
favourable than under the Class B Shareholder Offer. If the Class A Shareholder achieves a higher purchase price than
the purchase price offered pro rata under the Class B Shareholder Offer, the Class A Shareholder has the Drag Along
Right with respect to the Class B Shares. If the Class B Shareholder does not issue a Class B Shareholder Offer within
the Offer Period, the Class A Shareholder is entitled to sell the Class B Shares in accordance with article 9.2.

9.4 In case the Class A Shareholder exercises the Class A Shareholder Exit Privilege and wishes to sell Shares in the

Company, the Class B Shareholder has a tag-along right with respect to a pro rate portion of its Class B Shares, however
the tag along right shall apply to all of the Class B Shares if due to the execution of the Class A Shareholder Exit Privilege,
the Class A Shareholder and Class B Shareholder jointly would or do not hold more than fifty (50) percent of the Shares
and corresponding voting rights in the Company any longer, in each case at the same terms and conditions according to
which the Class A Shareholder sells.

Art. 10. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

D. Management

Art. 11.
11.1 The Company is managed by a Board composed of three (3) board members appointed as a collegiate body by

the general meeting of Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The members of the Board
(each a "Board Member") need not be Shareholders.

11.2 The Board shall always be composed so that:
11.2.1 one (1) Board Member shall be appointed or removed, as the case may be, by the general meeting of Shareholders

upon designation for appointment or removal, as the case may be, of a respective candidate by the Class A Shareholder
(such Board Members referred to as "Class A Board Member");

11.2.2 one (1) Board Member shall be appointed or removed, as the case may be, by the general meeting of Shareholders

upon designation for appointment or removal, as the case may be, of a respective candidate by the Class B Shareholder
(such Board Member referred to as "Class B Board Member");

11.2.3 one (1) Board Member who shall be a Luxembourg resident manager shall be appointed by the general meeting

of Shareholders (such Board Member referred to as "Class A and Class B Board Member").

11.2.4 The respective Class A Board Member may be removed from office only with the consent of the respective

Class A Shareholder in a general meeting of Shareholders pursuant to article 17. The respective Class B Board Member
may be removed from office only with the consent of the respective Class B Shareholder in a general meeting of Share-
holders pursuant to article 17. At any time the Class B Shareholder is entitled to require that another person designated
for appointment by it shall be appointed by the general meeting of Shareholders in replacement of a Board Member having
been appointed in accordance with article 11.2.2. This applies accordingly to a Board Member nominated by the Class A
Shareholder in accordance with article 11.2.1.

The Class A and Class B Board Member may be removed by the general meeting of Shareholders with simple majority

pursuant to article 17.

If no term is indicated, the Board Members are appointed for an undetermined period. The Board Members may be

re-elected.

Art. 12. The Board Members assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 13.
13.1 The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the Board is present or

represented at a meeting of the Board.

13.2 Meetings of the Board shall be called by any two Board Members with at least eight (8) days prior notice, unless

corporate affairs require a shorter notice period or for urgency (but not less than four (4) days). The convening notice

68178

may be waived by the unanimous consent given in writing or by fax, cable, telegram, email or telex of all Board Members.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the Board.

13.3. Meetings of the Board may be held physically at the registered office of the Company or any other place in

Luxembourg unanimously determined by the Board or, in all circumstances, by way of conference call (or similar means
of communication which permit the participants to communicate with each other). Meetings of the Board shall be held
as often as the business of the Company so requires.

13.4 The Board may further in all circumstances take decisions by way of unanimous written resolutions. Resolutions

in writing approved and signed by all Board Members shall have the same effect as resolutions passed at a Board meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by mail, courier, electronic mail or telefax.

13.5. Any Board Member may participate in any meeting of the Board by vidéoconférence or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any Board Member may act at any meeting of
the Board by appointing in writing, by telefax or electronic mail another Board Member as his proxy. A Board Member
may represent more than one of his colleagues.

13.6 If a Board meeting is not quorate, a new Board meeting with the same agenda is to be called observing the same

convocation period and notification as set out in article 13.2. In such new Board meeting a quorum shall be deemed
constituted as long as at least two Board Members are present or represented, provided however that all Board Members
were notified of such fact in the invitation.

13.7 Resolutions shall be taken by a majority of votes of the Board Members present or represented at such meeting,

provided that at least the Class B Board Member approves the resolution. Each Board Member has one vote.

13.8. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by any two Board Members.

Art. 14.
14.1 Any contractual relationships and/or any measure that is not within the scope of the ordinary business of the

Company such as the actions and resolutions listed hereunder, shall not be undertaken by the Board unless decided with
the prior unanimous consent of all the Shareholders acting in ordinary or extraordinary general meetings (the "Approval
Actions"):

14.1.1 any acquisitions of Investment Targets or other investment save as the ones which qualify as Additional Invest-

ments for which Shareholders resolutions shall be passed by simple majority;

14.1.2 the adoption of the strategic Business Plan of the Company and the Subsidiaries and the Agreed Investment

Budget(s);

14.1.3 amendment of the Staffing Step Plan (including staff selection process);
14.1.4 all transactions between the Company or any of its Subsidiaries on the one hand and the Shareholders or any

of their respective Affiliates or related persons in the sense of article 8.5 on the other hand;

14.1.5 any change to a Subsidiary's - articles of association/partnership agreement with the exception of changes which

are a consequence of the fact that a Shareholder has exercised a right under the Shareholders' Agreement or failed to
comply with an obligation under the Shareholders' Agreement;

14.1.6  any  changes  in  the  Business  Plan  and  an  Agreed  Investment  Budget  which  result  in  cost  increases  for  the

Company or an investment increase for the Shareholders exceeding three (3) percent of the budgeted costs/investments
or disposal of Investment Targets;

14.1.7 entering into and varying the terms of major contracts with a contractual value above one million Euro (EUR

1,000,000) and all construction and project management contracts and steps with regard to significant cost over-runs
pertaining to such contracts; and

14.1.8 all actions where the Board cannot unanimously resolve how to proceed (for the avoidance of doubt, in case

not all members of the Board present or represented at a meeting of the Board (including those who have notified the
other members of their intention to attend, but who did not attend) approve an action, measure, resolution, such action,
measure, resolution shall not be implemented by the Company and its Board until the general meeting of Shareholders
resolves otherwise).

14.2 Each Board Member shall be entitled to present an Approval Action to the general meeting of Shareholders for

final approval/resolution.

Art. 15.
15.1 The Board is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or

perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly
reserved by the law or by these Articles to the general meeting of Shareholders shall be within the competence of the
Board. Vis-à-vis third parties, the Board has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circums-
tances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or these
Articles to the general meeting of Shareholders or as may be provided herein.

68179

15.2 Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
15.3 The Company shall be bound by the joint signature of any of two Board Members or by the joint or single signatures

of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 15.2. of these Articles.

Art. 16. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or entity shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the Board Members or officers of the Company is interested in or is
a manager, director, officer or employee of such other corporation or entity. Any Board Member or officer of the
Company who serves as manager, director, officer or employee of any corporation or entity with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not solely by reason of such affiliation with such other corporation
or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other
business.

E. Collective decisions of the shareholders

Art. 17.
17.1 All Shareholders' decisions are taken by the general meeting of Shareholders to be held at the registered office

of the Company and at least once a year. Each Shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
numbers of Shares which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Each Share-
holder may appoint a proxy to represent him at meetings.

17.2 A general meeting of Shareholders shall be convened by the Board by registered letter accompanied by the agenda

with a prior notice of eight (8) days to their address appearing in the register of Shareholders held by the Company. Any
Shareholder shall also be entitled to convene meetings pursuant to the same formalities. Any Shareholder or any Board
Member may require the addition of one (1) or more items to the agenda by at least three (3) days' prior notice. If all
the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of
the meeting, the general meeting of Shareholders may be held without prior notice.

17.3 The quorum for a Shareholders' meeting shall be one hundred per cent (100 %) of the total number of Shares in

issue.

17.3.1 If a quorum is not present within one hour of the time fixed for such meeting, then the Shareholders present

may not pass any resolutions other than adjourning such meeting to a date as determined by the shareholders present
or, failing that, as set by the Board, which date shall be at least seven (7), but no more than thirty (30) days following the
date of the adjourned meeting. Notice of such adjournment and the reconvened meeting date, time and place shall be
sent to the Shareholders within two (2) days of such adjournment.

17.3.2 The quorum at such reconvened meeting with respect to the items that were to be considered at the adjourned

meeting shall be fifty (50) per cent of the total number of Shares in issue, provided that if a Shareholder informs the other
Shareholder that he/she or its representatives will be unable to attend the meeting owing to reasons outside of his/her
or the representative's control, the Shareholders' meeting shall take place seven (7) days later at the same time and place
and with the same agenda unless otherwise agreed between all Shareholders.

17.4 Save as provided under 17.5, collective decisions of the general meeting of Shareholders shall be validly adopted

if approved by Shareholders representing more than half of the total number of Shares then in issue.

17.5 The following decisions must be taken by Shareholders representing one hundred (100) per cent of the total

number of Shares in issue:

17.5.1 the Approval Actions listed under article 14.1, save as the investments which qualify as Additional Investments

for which Shareholders resolutions shall be passed by simple majority;

17.5.2 the creation of any obligation of the Shareholders to make additional Capital Contributions to the Company;
17.5.3 the adoption of the statutory accounts;
17.5.4 the amendment of the Articles;
17.5.5 the reorganization and /or liquidation of the Company;
17.5.6 any changes to the Shareholders 'Agreement.
17.6 With respect to a decision relating to the acquisition of the Management Platform:
(i) if the Shareholder's meeting does not come to an unanimous decision because of a veto the Class A Shareholder,

the Company shall refrain from such acquisition.

(ii) if the Shareholders' meeting does not come to an unanimous decision because of a dissenting vote by the Class B

Shareholder and the Shareholders agree on the NAV of the Company within 30 (thirty) days of the respective Share-
holders' meeting, the following shall apply cumulatively.

(a) the Class A Shareholder shall be entitled to furnish solely the equity to fund the acquisition of the Management

Platform by the Company;

(b) the Class A Shareholder shall be responsible to secure bank financing for the acquisition of the Management Platform

by the Company without recourse to the Shareholders;

68180

(c) upon completion of the acquisition of the Management Platform by the Company, the Class B Shareholder shall be

diluted at the equity level based on the NAV at such time in relation to the Capital Contribution of the Class A Share-
holders for the acquisition of the Management Platform.

OR
(iii) if the Shareholders cannot agree on NAV within 30 (thirty) days of the respective Shareholders' meeting, the Class

A Shareholder shall be entitled to procure that the Company may nonetheless pursue and complete the acquisition of
the Management Platform and at the same time, (ii) shall apply mutatis mutandis with the provision that at the election
of the Class A Shareholder either

(a) NAV shall be deemed to be the Total Investment Value of each Shareholder increased at a rate of fifteen (15)

percent per annum since the respective Capital Contributions or Distributions were made, or

(b) the Class A shareholder may opt to sell its Class A Shares to the Management Platform and the Class B Shareholder

shall remain a minority shareholder in the Company (i.e the Class B Shareholder shall not entitled to a tag-along right as
provided for in 9.5).

F. Financial year - Annual accounts - Profits distribution

Art. 18.
18.1 The financial year of the Company shall begin on 1 January of each year and shall terminate on 31 December of

the same year.

18.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the Board must prepare the balance sheet and the

profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the
statutory auditor(s) (if any) and Shareholders towards the Company.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 19.
19.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the

Luxembourg Companies Act. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 6.1 hereof.

19.2 Profits and losses shall be allocated among the Shareholders in proportion to their respective shareholding in the

Company. Changes in the percentage of the shareholding during a fiscal year shall be taken into account pro rata temporis.

19.3 The general meeting of Shareholders by majority resolution, upon recommendation of the Board, shall determine

how the annual net profits (after deduction of debt service and amortization) will be distributed to the Shareholders,
unless restricted by loan or other financing agreements.

19.4 The share premium account may be distributed to the Shareholders, in proportion to their shareholding in the

Company, upon decision by the general meeting of Shareholders, unless restricted by loan or other financing agreements.

19.5 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and distributable
reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of Shareholders within two (2) months from

the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Shareholders

must refund the excess to the Company.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 20.
20.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who  do  not  need  to  be  Shareholders,  appointed  by  a  resolution  of  the  general  meeting  of  Shareholders  which  will
determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the Shareholders or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

20.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the Shareholders in proportion to the shares held by each Shareholder in the Company.

68181

H. Other - Definition

Art. 21. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the

Luxembourg Companies Act and those in the Shareholder Agreements.

Art. 22. Definitions.
"Additional Investments" means an investment of the Company in Investment Targets, only being subject to a majority

resolution of the Shareholders if the Shareholders voting in favour of the resolution secure financing to the Company
without recourse to the Shareholders and commit to solely furnish the equity necessary for such investment in Investment
Targets.

"Affiliate(s)": mean(s) legally independent entities which, in relation to each other, are controlled or controlling or

group companies.

"Affiliated Lenders" means, with respect to any Shareholder, any of its Affiliates granting a loan to the Company.
"Agreed Investment Budget": means in connection with the acquisition of a Target Property by the Company, the

proposal of the Board, as approved by the Shareholders' meeting of the amount of Capital Contributions by the Share-
holders which shall become part of the financing of the acquisition and the financial requirements for any future capex
for the Target Property.

"Annual Budget" means the annual budget proposed by the Board Members, specifying the amount of the working

capital for the Company to fund operations of the Company and the respective amount of Capital Contributions, if any,
no later than three months before the commencement of each financial year, and resolved on by the Shareholders at the
general meeting of the Shareholders by majority resolution.

"Approval Actions" shall have the meaning set out in article 14.1 of the Articles.
"Articles" means the articles of association of the Company, as amended from time to time.
"Board": means the board of managers of the Company appointed from time to time in accordance with article 11 of

the Articles.

"Board Member": shall have the meaning set out in article 11 of the Articles.
"Business Day" means a day other than a Saturday, Sunday or day on which banks are authorized or required by law

to be closed in the Grand-Duchy of Luxembourg, the United Kingdom and Germany.

"Business Plan": means the initial strategic business plan of the Company and the Subsidiaries.
"Capital Contribution": means, with respect to each Shareholder, the nominal value of its portion of the issued share

capital of the Company plus any cash payment which was made (i) by such Shareholder to the Company as a premium
booked to the capital reserves of the Company in connection with the subscription of its shares, and (ii) paid by such
Shareholder and its Affiliated Lenders as Shareholder Loans granted to the Company or its Subsidiaries.

"Class A Shareholder" means the holder(s) of the Class A Shares in the Company from time to time.
"Class A Shareholder Exit Privilege" shall have the meaning set out in article 9.1 of the Articles.
"Class A Shares" means, from time to time, all issued and outstanding shares in registered form in the share capital of

the Company of class A, having a nominal value of ONE EURO (1.- EUR) each.

"Class B Shareholder" means the holder(s) of the Class B Shares in the Company from time to time.
"Class B Shareholder Offer" shall have the meaning set out in article 9.3 of the Articles.
"Class B Shares" means, from time to time, all issued and outstanding shares in registered form in the share capital of

the Company of class B, having a nominal value of ONE EURO (1.- EUR) each.

"Commencement Date": means the effective date of the Shareholders Agreement.
"Connected Companies" shall have the meaning set out in article 2.2 of the Articles.
"Contributing Shareholder" shall have the meaning set out in article 7.3 of the Articles.
"Drag Along Right" shall have the meaning set out in article 9.2 of the Articles.
"Distribution" means any cash outflow as to the Shareholders in the form of dividends, returns of capital, share re-

demption as well as interest payments and principal repayments on Shareholder Loans.

"Initial Hold Period" shall have the meaning set out in article 8.2 of the Articles.
"Investment": means each acquisition of Investments Targets by way of any single transaction.
"Investment Target": means residential assets in Germany which are not suited for a sale by the Company or the

Subsidiaries through a privatisation process, such suitability for privatisation to be considered given if the majority of the
units of a portfolio are to be acquired for a multiplier of sixteen (16) or more of the Net Rental Income and that have
been under-managed, offer near-term prospects for reducing management costs, improving revenues or otherwise offer
repositioning opportunities, however in each case the Investment Targets must be consistently lettable on a high level.

"IPO" shall have the meaning set out in article 8.3.3 of the Articles.
"Luxembourg Companies Act" means the Luxembourg law dated August 10 

th

 , 1915 on commercial company, as

amended from time to time.

68182

"Management Platform": means the acquisition of a third party residential platform sufficiently staffed with real estate

professionals with or without assets.

"NAV": means (i) the amount agreed from time to time by unanimous decision of the Shareholders to be value of of

all Shares, premiums and the Shareholder Loans, or, in the absence of such an agreement, (ii) the sum of the Total
Investment Values of each Shareholder increased at a rate of fifteen (15) percent p.a since the date of the respective
Capital Contributions or Distributions were made, i.e. in case of Capital Contributions of EUR 10,000,000.- in aggregate
having been made and no repayment of Capital Contributions or interest payments having occurred, the NAViafter one
year amounts to EUR 11,500,000.-, which, in case of 100,000 shares having been issued in total, results in NAV Per Share
of EUR 115.-.

"Net Rental Income": means all rental payments resulting from Investments payable to the Company or the Subsidiaries

excluding service charges (Betriebskosten im Sinne der deutschen Betriebskostenverordnung) and excluding any VAT
received or receivable by the Company or the Subsidiaries.

"Non-Contributing Shareholder" shall have the meaning set out in article 7.3 of the Articles.
"Offer Period" shall have the meaning set out in article 9.3 of the Articles.
"Penal Dilution" shall have the meaning set out in article 7.4 of the Articles.
"Public Company" shall have the meaning set out in article 8.4 of the Articles.
"Sale Notice" shall have the meaning set out in article 9.3 of the Articles.
"Shareholder Loans" means any loan granted or to be granted by the Shareholders in favour of the Company from

time to time.

"Shareholders" means the Class Shareholder(s) A and the Class B Shareholder(s), collectively, and any person to whom

Shares are transferred or issued from time to time (excluding the Company) in accordance with the terms of the Sha-
reholders' Agreement and/or the Articles, and "Shareholder" means any of them.

"Shareholders'Aqreement": means any agreement that may be entered into from time to time between the Sharehol-

ders.

"Shares" means, from time to time, collectively, the Class A Shares and the Class B Shares (or any of them if the context

so requires).

"Shortfall" shall have the meaning set out in article 7.3 of the Articles.
"Staffing Step Plan": means the step plan for internal management of the Company.
"Subsidiaries": means any limited companies set up under the laws of Germany or Luxembourg and partnerships set

up under the laws of Germany that the Company will own directly or indirectly.

"Total Investment Value": means in respect of a Shareholder the balance of
(i) all Capital Contributions of such Shareholder;
(ii) minus: all amounts paid by the Company to such Shareholder as Distributions (i) of profits or (ii) out of reserves;
(iii) minus: all amounts paid by the Company to such Shareholder and its Affiliated Lenders in payment of interest and

repayment of principal on Shareholder Loans.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to two thousand five hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a German version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre Zweitausendneun, am sechsundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Herrn Carlo WERSANDT, mit Amtwohnsitz in Luxemburg-Eich, Großherzogtum

Luxemburg, welcher als Vertretung für Herrn Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtwohnsitz in Sassenheim, Großher-
zogtum Luxemburg handelt, wobei Herr Notar Jean-Joseph WAGNER Verwahrer der vorliegenden Originalurkunde
bleibt.

Sind erschienen:

"CPI CPEH 2 S.à r.l.", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), gegründet unter

dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit registriertem Sitz in 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg, registriert
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 118.036, und

68183

"Corpus Sireo Investment Residential No. 2 GmbH" (ehemals "Corpus Sireo Wohnen Beteiligung No. 2 GmbH"), eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit registriertem
Sitz in Düsseldorf, registriert im Handelsregister von Düsseldorf unter der Nummer HRB 57351,

beide hier vertreten durch Frau Nadia WEYRICH, Angestellte, mit beruflicher Adresse in Belvaux, auf Grund von

Vollmachten, welche am 19. Juni 2009 und am 23. Juni 2009 ausgestellt wurden.

Diese Vollmachten, die vom Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und vom Notar ne varietur abgezeichnet

wurden, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt um gleichzeitig bei der Registrierungsbehörde einge-
reicht zu werden.

Diese erschienene Parteien sind die alleinigen Gesellschafter von "CITCOR RESIDENTIAL HOLDINGS S.à r.l." (im

Folgenden die "Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), gegründet
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit registriertem Sitz in 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg,
registriert  im  Luxemburger  Handels-  und  Gesellschaftsregister  unter  der  Nummer  B  130.183,  gegründet  durch  eine
notarieller  Urkunde  mit  Datum  vom  9.  Juli  2007  und  deren  Gesellschaftssatzung,  die  bis  zum  heutigen  Datum  nicht
geändert wurde, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 11. September 2007 (Nummer 1951, Seite
93609) (das "Mémorial C") veröffentlicht worden ist.

Die erschienenen Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, ersuchen den Notar die folgenden Be-

schlüsse aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, den Nominalwert der bestehenden Anteile von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR

125,-) pro Anteil in einen Euro (EUR 1.-) pro Anteil umzuändern, so dass das gezeichnete Aktienkapital in zwölftausend
fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1.-) pro Anteil, eingeteilt wird.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, zwei verschiedene Kategorien von Stammaktien zu schaffen, Stammaktien der Kate-

gorie A und Stammaktien der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1.-), wobei jede Stammaktie
die in der geänderten Satzung dargelegten Rechte und Pflichten hat.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammaktien mit einem Nennwert

von jeweils einem Euro (EUR 1,-) in elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Stammaktien der Kategorie A und eintau-
sendzweihundertfünfzig (1.250) Stammaktien der Kategorie B umzuwandeln.

Nach der Schaffung der zwei Kategorien von Stammaktien wird das Stammkapital wie folgt zugewiesen:
- "CPI CPEH 2 S.à r.l.", vorbenannt: elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Stammaktien der Kategorie A.
- "Corpus Sireo Investment Residential No. 2 GmbH", vorbenannt: tausendzweihundertfünfzig (1.250) Stammaktien

der Kategorie B.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von sechshundertd-

reiundzwanzigtausend  zweihundertsiebenunddreißig  Euro  (EUR  623.237,-)  um  es  durch  Schaffung  und  Ausgabe  von
fünfhundertsechzigtausend  neunhundertdreizehn  (560,913)  Stammaktien  der  Kategorie  A  (die  "Neuen  Kategorie  A
Stammaktien") und von zweiundsechzigtausend dreihundêrtvierundzwanzig (62,324) Stammaktien der Kategorie B (die
"Neuen Kategorie B Stammaktien" und zusammen mit den Neuen Kategorie A Stammaktien die "Neuen Stammaktien"),
mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1.-) und mit den selben Rechten und Pflichten wie die bestehenden
Stammaktien, vom aktuellen Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf sechshundertfün-
funddreißigtausend siebenhundertsiebenunddreißig Euro (EUR 635.737,-) anzuheben.

Die Neuen Stammaktien wurden vollständig wie folgt gezeichnet:
- alle fünfhundertsechzigtausend neunhundertdreizehn (560.913) Neue Kategorie A Stammaktien von "CPI CPEH 2

S.à r.l.", oben benannt, bezahlt vollständig durch die Einbringung einer Sacheinlage, bestehend aus fälligen und durchsetz-
baren Forderungen, welche der "CPI CPEH 2 S.à r.l." gegen die Gesellschaft (aa) in Höhe von vierhundertsechsundvier-
zigtausend einhundert dreiunddreißig Euro und sechzehn Cent (EUR 446.133,16) und (bb) in Höhe von einhundertvier-
zehntausend siebenhundertneunundsiebzig Euro und vierundachtzig Cent (EUR 114.779.84) aus einer Gesamtforderung
in Höhe von zweihundertzweiundneunzigtausend fünfhundert Euro (EUR 292.500,-) zustehen;

die Einlage in Höhe eines Gesamtbetrages von fünfhundertsechzigtausend neunhundertdreizehn Euro (EUR 560.913,-)

wird im Ganzen dem Aktienkapital zugeordnet;

der Nachweis über das Bestehen und über den Wert der Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar gegenüber

erbracht;

- alle zweiundsechzigtausend dreihundêrtvierundzwanzig (62,324) Neue Stammaktien der Kategorie B von "Corpus

Sireo Investment Residential No. 2 GmbH", oben benannt, bezahlt vollständig durch die Einbringung einer Sacheinlage,
bestehend aus fälligen und durchsetzbaren Forderungen, welche der "Corpus Sireo Investment Residential No. 2 GmbH"

68184

gegenüber der Gesellschaft (aa) in Höhe von neunundvierzigtausend fünfhundertsiebzig Euro und fünfunddreißig Cent
(EUR  49.570,35)  und  (bb)  in  Höhe  von  zwölftausend  siebenhundert  dreiundfünfzig  Euro  fünfundsechzig  Cent  (EUR
12.753,65) aus einer Gesamtforderung in Höhe von zweiunddreißigtausend fünfhundert Euro (EUR 32.500,-) zustehen;

die Einlage in Höhe eines Gesamtbetrages von zweiundsechzigtausend dreihundertvierundzwanzig Euro (EUR 62.324,-)

wird im Ganzen dem Aktienkapital zugeordnet;

der Nachweis über das Bestehen und über den Wert der Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar gegenüber

erbracht.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft am Datum des Handelsregistereintrags

der Gesellschaft, d. h. am 9. Juli 2007 beginnt und am 31. Dezember 2007 endet.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen, dass Michael Astarita, geboren in New York (New York - USA) am 19. August 1961,

wohnhaft 399 Park Avenue, 7th Floor, New York, NY 10022, USA, sein Amt zum heutigen Datum der Gesellschafter-
versammlung niederlegt und beschließen, diese Amtsniederlegung zu akzeptieren und Michael Astarita für die Erfüllung
seiner Verpflichtungen als Geschäftsführer entstandenen Verbindlichkeiten bis dahin zu entlassen.

Die Gesellschafter bestätigen, dass Steven Skaar, geboren in Salt Lake City, Utah, USA am 21 Juli 1972, wohnhaft in

Ground Floor, Stirling Square, 5-7 Carlton Gardens, London SW1Y5AD, Grossbritannien, sein Amt zum heutigen Datum
der Gesellschafterversammlung niederlegt und beschließen, diese Amtsniederlegung zu akzeptieren und Steven Skaar für
die Erfüllung seiner Verpflichtungen als Geschäftsführer entstandenen Verbindlichkeiten bis dahin zu entlassen.

Die Gesellschafter beschließen, Dr. Christian Kolb, geboren am 15. Juni 1975 in Mannheim, Deutschland, geschäfts-

ansässig in 4a rue Albert Borschette, L- 1246 Luxemburg, als Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte
Zeitperiode, beginnend am heutigen Tag der Gesellschafterversammlung, zu benennen.

Die Gesellschafter beschließen, John Cassin, geboren am 4. Dezember 1940 in New York, USA, geschäftsansässig in

14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg, als Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Zeitperiode, begin-
nend am heutigen Tag der Gesellschafterversammlung, zu benennen.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Satzung vollständig neu zu formulieren, ohne den Zweck der Gesellschaft zu ändern

und ihr den folgenden Wortlaut zu geben:

KONSOLIDIERTER GESELLSCHAFTSVERTRAG DER CitCor Residential Holdings S.à r.l.

A. ZWECK - DAUER - NAME - SITZ

Art. 1.  Es  wird  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  gegründet,  die  den  für  ein  solches  Unternehmen  (die

„Gesellschaft") geltenden Gesetzen, insbesondere dem Luxemburger Gesellschaftsgesetz sowie den vorliegenden Be-
stimmungen unterliegt.

Art. 2.
2.1 Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb oder Verkauf oder die sonstige Verfügung über, sowie der direkte

oder indirekte Besitz von Beteiligungen an ausländischen Immobilien, u. a. im Wege der Zeichnung oder des Erwerbs von
Wertpapieren und Rechten durch Beteiligung, Einbringung, Garantie der Übernahme (Underwriting), Firmenkauf oder
Option, Übertragung durch Indossament o. ä. von Schuldverschreibungen oder in sonstiger Form, sowie die Verwaltung
und Erweiterung dieser Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft darf Geldmittel, insbesondere die Erlöse aus Krediten und/oder der Emission von Schuldtiteln an

ihre Tochtergesellschaften oder ihre Konzerngesellschaften (die „verbundenen Unternehmen") verleihen. Zur Sicherung
ihrer Verbindlichkeiten oder der Verbindlichkeiten ihrer Tochter- oder Konzerngesellschaften darf die Gesellschaft Ga-
rantien oder Sicherheiten zu Gunsten Dritter gewähren. Die Gesellschaft darf darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder
teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder auf sonstige Weise Sicherheiten daran bestellen.

2.3 Die Gesellschaft darf darüber hinaus in den Erwerb und die Verwaltung von Patentportfolios und/oder andere

gewerbliche Schutzrechte gleich welcher Art und welchen Ursprungs investieren.

2.4 Die Gesellschaft darf zum Zwecke der effizienten Verwaltung ihrere Investitionen generell alle Techniken und

Instrumente anwenden, insbesondere Techniken und Instrumente, die dafür bestimmt sind, die Gesellschaft vor Kredit-,
Wechselkurs-, Zins- und anderen Risiken zu schützen.

2.5 Die Gesellschaft darf insbesondere die folgenden Geschäfte vornehmen, wobei Einvernehmen darüber besteht,

dass die Gesellschaft keine Geschäfte vornehmen darf, die als zulassungspflichtige Geschäfte im Finanzsektor gelten wür-
den:

- Kapitalaufnahme in beliebiger Form, nicht aber im Wege des Börsengangs; Inanspruchnahme von Kreditfazilitäten

sowie Beschaffung von Geldern insbesondere durch Privatplatzierung von Anleihen, Schuldtiteln, Schuldverschreibungen

68185

oder  sonstigen  Instrumenten  zur  Aufbringung  von  Eigen-  oder  Fremdkapital,  Verwendung  von  Finanzderivaten  oder
sonstigem;

- Gewährung von Vorschüssen oder Darlehen oder Hinterlegung von Geldmitteln oder Einräumung von Krediten an

oder Zeichnung oder Erwerb von Schuldverschreibungen, die von einem luxemburgischen oder ausländischen Unter-
nehmen ausgegeben wurden, zu angemessenen Bedingungen, mit oder ohne Sicherheiten;

- Stellung von Bürgschaften, Pfandrechten oder anderen Sicherheiten, gleich ob im Wege eines persönlichen Verspre-

chens, eines Grundpfandrechts oder einer Belastung des gesamten oder Teilen der Gesellschaft, (gegenwärtiger oder
zukünftiger) Vermögenswerte oder eine oder alle dieser Methoden, für die Durchführung von Verträgen oder Verpflich-
tungen der Gesellschaft und verbundener Unternehmen oder eines Direktors oder leitenden Angestellten der Gesell-
schaft oder eines verbundenen Unternehmens im Rahmen des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes.

2.6 Die Gesellschaft darf alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfte tätigen

und generell alle Transaktionen durchführen, die dem Gesellschaftszweck in allen oben bezeichneten Bereichen unmit-
telbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Die Gesellschaft erhält die Firmenname „CitCor Residential Holdings S.à r.l.".

Art. 5.
5.1 Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt im Großherzogtum Luxemburg. Übertragungen innerhalb der Stadt-

grenzen können auf Beschluss des Verwaltungsrats vorgenommen werden. Der eingetragene Sitz kann durch einen den
vorgeschriebenen  Bedingungen  für  Satzungsänderungen  entsprechenden  Beschluss  der  Gesellschafterversammlung  an
jeden beliebigen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlagert werden.

5.2  Zweigniederlassungen,  Tochtergesellschaften  oder  sonstige  Filialen  können  per  Verwaltungsratsbeschluss  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland eingerichtet werden. Wenn der Verwaltungsrat feststellt, dass außeror-
dentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bevorstehen oder bereits eingetreten sind, welche
die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen
dem Hauptsitz und einer Person im Ausland beeinträchtigen, kann der eingetragene Sitz bis zum vollständigen Wegfall
dieser Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche vorübergehende Maßnahme berührt nicht die
Nationalität der Gesellschaft; diese verbleibt trotz vorübergehender Verlegung ihres eingetragenen Sitzes eine in Lu-
xemburg eingetragene Gesellschaft.

B. Stammkapital

Art. 6.
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft wird auf sechshundertfünfunddreißigtausend siebenhundertsiebenunddreißig

Euro  (EUR  635.737)  festgelegt,  eingeteilt  in  fünfhundertzweiundsiebzigtausend  einhundertdreiundsechzig  (572.163)
Stammaktien der Kategorie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-) und dreiundsechzigtausend fünfhun-
dertvierundsiebzig (63.574) Stammaktien der Kategorie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-), alle
gezeichnet und in voller Höhe einbezahlt.

6.2 Zusätzlich zum ausgegebenen Stammkapital kann ein Aktienaufgeldkonto eröffnet werden, auf das Aktienaufgelder

überwiesen werden, die zusätzlich zum Nennwert von Geschäftsanteilen auf diese eingezahlt wurden.

Art. 7.
7.1 Das Stammkapital kann durch einen den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen entsprechenden

Beschluss der Gesellschafterversammlung in einer oder mehreren Stufen erhöht oder gesenkt werden.

7.2 Sofern in dieser Satzung nicht anderweitig vorgesehen oder nicht anderweitig durch einstimmigen Beschluss der

Gesellschafterversammlung vereinbart, hat eine Kapitaleinlage des Stammkapitals durch Emission von Anteilen und Ge-
sellschafterdarlehen  zu  dem  zum  betreffenden  Zeitpunkt  bestehenden  Nettoinventarwert  („NAV")  zu  erfolgen.  Die
solchen Anteilen zugeordnete Kapitaleinlage wird mit dem zum betreffenden Zeitpunkt bestehenden Nennwert gebucht,
wobei der Saldo der Einbringung als Aufschlag unter Rücklagen der Gesellschaft gebucht wird.

7.3 Falls ein Gesellschafter eine laut vereinbartem Investitionsbudget oder einem Jahresbudget erforderliche Kapital-

einlage verabsäumt (im Fall des Jahresbudgets jedoch nur dann, wenn es durch die Gesellschafterversammlung einstimmig
beschlossen wurde) (wobei dieser Gesellschafter hiernach als „nicht einbringender Gesellschafter" bezeichnet wird), und
dieses Säumnis nicht spätestens zehn (10) Geschäftstage nach dem Fälligkeitstermin für diese Einlage geheilt wird („Un-
terschuss"),  kann  ein  beliebiger  anderer  Gesellschafter,  der  nicht  selber  ein  „nicht  einbringender  Gesellschafter"  ist
(„einbringender Gesellschafter") den Unterschuss auf eigenen Namen und eigene Rechnung oder für einen von ihm be-
nannten durch Vollmacht vertretenen dritten Gesellschafter direkt an die Gesellschaft einzahlen.

7.4 Im Fall eines Unterschusses des nicht einbringenden Gesellschafters nach Ziffer 7.3 (i) werden die an den Unter-

schuss  finanzierenden  einbringenden  Gesellschafter  emittierten  Anteilen  zu  fünfzig  (50)  %  des  Nettoinventarwerts
ausgestellt; (ii) die nicht einbringenden Gesellschafter werden einen Teil der von den nicht einbringenden Gesellschaftern
und/oder ihren verbundenen Kreditgebern gewährten Gesellschafterdarlehen an die einbringenden Gesellschafter über-
tragen  (und  die  nicht  einbringenden  Gesellschafter  werden  gegebenenfalls  solche  Übertragungen  durch  verbundene

68186

Kreditgeber sichern), der fünfundzwanzig (25) % des Nettoinventarwerts der von der einbringenden Partei gewährten
Gesellschafterdarlehen bei der Finanzierung eines solchen Unterschusses beträgt („Verwässerungsstrafe").

7.5 Falls ein Gesellschafter eine laut einem Jahresbudget erforderliche Kapitaleinbringung verabsäumt, wenn er dem

Beschluss des betreffenden Jahresbudgets durch die Gesellschafterversammlung nicht zugestimmt hat, gilt Ziffer 7.3 sinn-
gemäß, wobei in diesem Fall jedoch keine Verwässerungsstrafe sondern eine einfache Verwässerung zur Anwendung
kommt (d.h. Anteile werden zum Nettoinventarwert emittiert).

C. Übertragung von anteilen

Art. 8.
8.1 Unbeschadet der Bestimmungen des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes dürfen die Gesellschafter Geschäftsanteile

oder Gesellschafterdarlehen nur gemäß den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags und der vorliegenden Bestim-
mungen  übertragen.  Im  Falle  einer  beabsichtigten  Übertragung  eines  Geschäftsanteils  durch  einen  Inhaber  eines  Ge-
schäftsanteils oder eines Gesellschafterdarlehens unter Verstoß gegen diesen Gesellschaftsvertrag ist diese ungültig und
unwirksam, und die Gesellschaft wird eine solche Übertragung nicht als wirksam behandeln.

8.2 Unbeschadet der Bestimmungen von Ziffer 9.1 bedürfen Übertragungen von Geschäftsanteilen oder Gesellschaf-

terdarlehen im Rahmen des Gesellschaftsvertrags innerhalb der ersten drei Jahre nach der Aufnahme der Geschäftstä-
tigkeit (die „anfängliche Halteperiode") der vorherigen schriftlichen Zustimmung aller Gesellschafter und der Einhaltung
dieser Ziffer 8.

8.3 Unbeschadet der Bestimmungen von Ziffer 8.2 und vorbehaltlich der Bestimmungen des Luxemburger Gesell-

schaftsgesetzes sind folgende Übertragungen zulässig:

8.3.1 die teilweise oder vollständige Übertragung von Geschäftsanteilen oder Gesellschafterdarlehen eines Gesell-

schafters an eine Konzerngesellschaft gemäß Ziffer 8.5 unten;

8.3.2 die teilweise oder vollständige Übertragung der Geschäftsanteile oder Gesellschafterdarlehen eines Gesellschaf-

ters an vom jeweiligen Gesellschafter für die Zwecke der Mitbeteiligung neben diesem Gesellschafter oder dem direkten
Anteilsinhaber eines Gesellschafters gegründete Unternehmen, oder einen Fonds und/oder

Drittinvestor, dessen Anlagen von einem Gesellschafter und/oder einer Konzerngesellschaft eines Gesellschafters ge-

mäß Ziffer 8.5 unten verwaltet werden; und

8.3.3 der Verkauf aller Geschäftsanteile der Gesellschaft oder die Veräußerung von Geschäftsanteilen der Gesellschaft

über eine durch den Gesellschafter der Klasse A gemäß Ziffer 9 herbeigeführte Notierung an einer Börse („IPO").

8.4 Vor einem IPO muss die Gesellschaft in eine Gesellschaftsform umgewandelt werden, die das öffentliche Anbieten

von Aktien und deren Zulassung an einer Börse erlaubt („Aktiengesellschaft"); Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags,
die sich auf einen IPO beziehen, gelten nach der Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft.

8.5 Unbeschadet der Bestimmungen von Ziffern 8.3.1 und 8.3.2 oben kann jeder Gesellschafter seine Geschäftsanteile

ganz oder teilweise an eine Konzerngesellschaft oder an Unternehmen übertragen, das von dem jeweiligen Gesellschafter
für die Zwecke der Mitbeteiligung neben diesem Gesellschafter oder dem direkten Anteilsinhaber eines Gesellschafters
gegründet wurde, oder einen Fonds und/oder Drittinvestor, dessen Anlagen von einem Gesellschafter und/oder einer
Konzerngesellschaft eines Gesellschafters verwaltet werden, sofern die Konzerngesellschaften oder Unternehmen, die
Geschäftsanteile halten, ihre Geschäftsanteile sofort an den jeweiligen Gesellschafter oder eine seiner Konzerngesell-
schaften zurück übertragen, wenn sie nicht mehr Konzerngesellschaften des jeweiligen Gesellschafters sind oder nicht
mehr von dem jeweiligen Gesellschafter verwaltet werden.

8.6 Dass der Übertragungsempfänger in jedem Fall Partei der Gesellschaftervereinbarung wird oder im Falle einer

Übertragung von Gesellschafterdarlehen die Bestimmungen der Gesellschafterdarlehen anerkennt, ist stets Voraussetzung
für eine Übertragung von Geschäftsanteilen oder Gesellschafterdarlehen, die Wirksamkeit der Übertragung und deren
Anerkennung durch die Gesellschaft.

Art. 9.
9.1 Der Gesellschafter der Klasse A kann nach alleinigem Ermessen (i) über den kompletten oder teilweisen Verkauf

der Geschäftsanteile an der Gesellschaft entscheiden, die mehr als vierzig Prozent (40) des Stammkapitals umfassen, oder
(ii) über den Verkauf einer beliebigen Anzahl von Geschäftsanteilen und der entsprechenden Stimmrechte an der Ge-
sellschaft in Verbindung mit einem IPO (das „Veräußerungsvorrecht des Gesellschafters der Klasse A") gemäß Ziffer 9.3.
Zur Klarstellung wird an dieser Stelle festgehalten, dass dieses Recht dem Gesellschafter der Klasse A auch während der
Anfänglichen Halteperiode gewährt wird.

9.2 Soweit der Gesellschafter der Klasse A das ihm zustehende Veräußerungsvorrecht ausübt, steht dem Gesellschafter

der Klasse A ein Mitverkaufsrecht („Drag Along Right") bezüglich aller Geschäftsanteile und Gesellschafterdarlehen der
Klasse B zu, soweit:

9.2.1. ein solcher Verkauf unter Bedingungen erfolgt, die nicht weniger günstig sind als jene, zu denen der Gesellschafter

der Klasse A seine Anteile verkauft;

9.2.2. die Geschäftsanteile der Klasse B, einschließlich von Gesellschafterdarlehen, nicht zu einem Preis unter dem

Betrag des Gesamtanlagewertes des Gesellschafters der Klasse B veräußert werden, zuzüglich fünf (5) % seit dem Datum,
an dem die jeweilige Kapitaleinlagen oder Dividenden erfolgte;

68187

9.2.3. der Gesellschafter der Klasse A verkauft einen Teil seiner Geschäftsanteile, welcher mehr als vierzig (40 ) % des

Gesellschaftskapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft umfasst;

9.2.4.  jedwede  vom  Gesellschafter  der  Klasse  A  und  vom  Gesellschafter  der  Klasse  B  verkauften  Anteile  an  eine

Drittpartei verkauft werden und nicht an eine oder mehrere Tochtergesellschaften des Gesellschafters der Klasse A; und

9.2.5. Im Falle des Verkaufs von Anteilen des Gesellschafters der Klasse A, die nicht gemäß Ziffer 9.1 (ii) erfolgen, kann

der Gesellschafter der Klasse A nur sein Mitverkaufsrecht (Drag Along Right) ausüben im Hinblick auf alle Anteile, die
der Gesellschafter der Klasse B zum jeweiligen Zeitpunkt an der Gesellschaft hält.

9.3 Bevor der Gesellschafter der Klasse A vom Veräußerungsvorrecht des Gesellschafters der Klasse A Gebrauch

machen kann, ist er verpflichtet, seine Absicht, das Veräußerungsvorrecht des Gesellschafters der Klasse A auszuüben,
dem Gesellschafter der Klasse B durch schriftliche Mitteilung (die „Verkaufsmitteilung") unverzüglich anzuzeigen, und der
Gesellschafter der Klasse B ist innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach Erhalt der Verkaufsmitteilung („Angebots-
zeit") berechtigt, dem Gesellschafter der Klasse A den Kauf der Geschäftsanteile der Klasse A zu einem bestimmten
Zeitpunkt zu einem in dem jeweiligen Angebot angegebenen Preis anzubieten (das „Angebot des Gesellschafters der
Klasse B"). Dieses Angebot muss die Bedingungen enthalten, unter denen er bereit ist, die Anteile der Klasse A und
sonstige Beteiligungen an der Gesellschaft (einschließlich der, jedoch nicht beschränkt auf die Gesellschafterdarlehen) zu
erwerben, und der Gesellschafter der Klasse B ist gegenüber dem Gesellschafter der Klasse B für einen Zeitraum von
fünfundvierzig (45) Tagen verpflichtet. Wenn der Gesellschafter der Klasse A das Angebot des Gesellschafters der Klasse
B nicht akzeptiert, steht es dem Gesellschafter der Klasse A frei, seine Anteile an der Gesellschaft an eine dritte Partei
zu einem nicht geringeren Preis und zu für den Erwerber nicht weniger günstigen Bedingungen als im Angebot des Ge-
sellschafters der Klasse B zu veräußern. Erzielt der Gesellschafter der Klasse A einen höheren Kaufpreis als den anteiligen,
im Rahmen des Angebots des Gesellschafters der Klasse B angebotenen Käufpreis, steht dem Gesellschafter der Klasse
A ein Mitverkaufsrecht (Drag Along Right) mit Bezug auf die Geschäftsanteile der Klasse B zu. Soweit der Gesellschafter
der Klasse B innerhalb der Angebotsfrist kein Angebot des Gesellschafters der Klasse B abgibt, ist der Gesellschafter der
Klasse A berechtigt, die Geschäftsanteile der Klasse B gemäß Ziffer 9.2 zu verkaufen.

9.4 Soweit der Gesellschafter der Klasse A von seinem Vorrecht Gebrauch macht und die Geschäftsanteile an der

Gesellschaft verkaufen möchte, steht dem Gesellschafter der Klasse B ein anteiliges Mitverkaufsrecht (Tag Along Right)
hinsichtlich der Geschäftsanteile der Klasse B zu. Jedoch gilt das Mitverkaufsrecht für alle Anteile der Klasse B, wenn
infolge der Ausübung des Veräußerungsvorrechts des Gesellschafters der Klasse A der Gesellschafter der Klasse B nicht
mehr als fünfzig (50) Prozent der Anteile und der entsprechenden Stimmrechte an der Gesellschaft besitzt, jeweils unter
den gleichen Bedingungen, zu denen der Gesellschafter der Klasse A seine Anteile verkauft.

Art. 10. Die Gesellschaft endet nicht durch den Tod, die Aufhebung von Bürgerrechten, die Insolvenz, den Konkurs

oder ein ähnliches Ereignis, das einen oder mehrere Gesellschafter betrifft.

D. Management

Art. 11.
11.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat") geleitet, der aus 3 (drei) Mitgliedern

besteht und der von der Gesellschafterversammlung als Organ gemäß den nachfolgend aufgeführten Bestimmungen be-
stellt  wird.  Die  Mitglieder  des  Verwaltungsrats  (einzeln  „Verwaltungsratsmitglied"  genannt)  müssen  nicht  gleichzeitig
Gesellschafter sein.

11.2 Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
11.2.1 Die Ernennung oder Abberufung eines (1) Verwaltungsratsmitglieds aus der Gesellschafterversammlung erfolgt

durch einen entsprechenden Vorschlag eines Kandidaten durch den Gesellschafter der Klasse A (dieses Verwaltungs-
ratsmitglied wird nachfolgend "Verwaltungsratsmitglied der Klasse A" genannt");

11.2.2 Die Ernennung oder Abberufung eines (1) Verwaltungsratsmitglieds aus der Gesellschafterversammlung erfolgt

durch einen entsprechenden Vorschlag eines Kandidaten durch den Gesellschafter der Klasse B (dieses Verwaltungs-
ratsmitglied wird nachfolgend „Verwaltungsratsmitglied der Klasse B" genannt);

11.2.3 Ein (1) Verwaltungsratsmitglied, ein in Luxemburg ansässiger Geschäftsführer, wird von der Gesellschafterver-

sammlung  bestellt  (dieses  Verwaltungsratsmitglied  wird  nachfolgend  „Verwaltungsratsmitglied  der  Klasse  A  und  B"
genannt).

11.2.4 Der entsprechende Gesellschafter der Klasse A kann nur mit der Zustimmung des jeweiligen Gesellschafters

der Klasse A in einer Gesellschafterversammlung gemäß Ziffer 17 seiner Funktionen entbunden werden. Die Entlassung
eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse B aus dem Amt bedarf stets der Zustimmung des entsprechenden Gesellschaf-
ters der Klasse B in einer Gesellschafterversammlung gemäß Ziffer 17. Der Gesellschafter der Klasse B kann jederzeit
verlangen, dass eine andere von ihm zur Ernennung vorgeschlagene Person von der Gesellschafterversammlung als Er-
setzung eines Verwaltungsratsmitglieds, die gemäß Ziffer 11.2.2. ernannt wurde, eingesetzt wird. Dies gilt entsprechend
für ein Verwaltungsratsmitglied, das vom Gesellschafter der Klasse A gemäß Ziffer 11.2.1 ernannt wurde.

Verwaltungsratsmitglieder der Klassen A und B können von der Gesellschafterversammlung durch einfachen Mehr-

heitsbeschluss gemäß Ziffer 17 abberufen werden 17.

68188

Soweit keine Dauer angegeben ist, werden die Verwaltungsratsmitglieder auf unbestimmte Zeit bestellt. Die Verwal-

tungsratsmitglieder können wiedergewählt werden.

Art. 12. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen aufgrund ihrer Stellung keine persönliche Haftung bezüglich der

von ihnen im Namen der Gesellschaft regelmäßig eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind einfache bevollmächtigte Ver-
treter und haften nur für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Art. 13.
13.1. Der Verwaltungsrat kann nur wirksam beraten oder handeln, wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungs-

ratsmitglieder bei einer Versammlung des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten ist.

13.2 Sitzungen des Verwaltungsrats werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unter Einhaltung einer Frist von

mindestens acht (8) Tagen einberufen, soweit gesellschaftliche Angelegenheiten nicht eine kürzere Einberufungsfrist ver-
langen (jedoch nicht weniger als vier (4) Tage). Die Verwaltungsratsmitglieder können durch einstimmigen entweder
schriftlich oder per Telefax, Telegramm, Email oder Telex gefassten Beschluss aller Verwaltungsratsmitglieder auf eine
Einladung verzichten. Für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die in einem zuvor per Verwal-
tungsratsbeschluss gefassten Plan bestimmt wurden, ist keine gesonderte Mitteilung notwendig.

13.3. Verwaltungsratssitzungen werden unter persönlicher Anwesenheit am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen

Platz in Luxemburg abgehalten, der von dem Verwaltungsrat einstimmig bestimmt wird, oder in jedem Fall per Telefon-
konferenz (oder ähnliche Kommunikationsmittel, die eine Kommunikation miteinander ermöglichen). Verwaltungsrats-
sitzungen werden so oft abgehalten, wie es die Geschäfte der Gesellschaft verlangen.

13.4 Der Verwaltungsrat kann ferner in allen Fällen Entscheidungen durch einstimmigen schriftlichen Beschluss her-

beiführen. Schriftliche und von allen Geschäftsführern genehmigte und unterzeichnete Beschlüsse haben dieselbe Wirkung
wie bei Verwaltungsratssitzungen gefasst Beschlüsse. In diesen Fällen sind Beschlüsse oder Entscheidungen ausdrücklich
zu fassen bzw. zu treffen, d.h. entweder schriftlich im Umlaufverfahren auf dem Postweg, per Kurier, Email oder Telefax.

13.5. Die Verwaltungsratsmitglieder können an den Verwaltungsratssitzungen im Wege einer Telefonkonferenz oder

über ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die den Teilnehmern der jeweiligen Sitzung ermöglichen, sich gegenseitig
zu hören. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht einer Teilnahme an dieser Sitzung durch persönliche
Anwesenheit. Die Verwaltungsratsmitglieder können sich bei Sitzungen des Verwaltungsrats durch ein anderes Verwal-
tungsratsmitglied vertreten lassen, das sie schriftlich, per Telefax oder Email bestimmen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann
mehr als ein Verwaltungsratsmitglied vertreten.

13.6. Ist eine Verwaltungsratssitzung nicht beschlussfähig, ist eine neue Verwaltungsratssitzung mit derselben Tages-

ordnung unter Einhaltung der in Ziffer 13.2 festgelegten Einberufungsfrist und Benachrichtigungsbestimmungen einzube-
rufen. Bei einer solchen neuen Verwaltungsratssitzung besteht Beschlussfähigkeit, wenn mindestens zwei Verwaltungs-
ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind, vorausgesetzt dass alle Verwaltungsratsmitglieder in der Einladung über
diesen Umstand informiert wurden.

13.7. Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der bei einer Verwaltungsratssitzung anwesenden oder vertretenen Stimmen

der Verwaltungsratmitglieder, sofern wenigstens das Verwaltungsratsmitglied der Klasse B den Beschluss annimmt. Jedes
Verwaltungsratmitglied hat eine Stimme.

13.8. Das Protokoll jeder Verwaltungsratssitzung ist von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

Art. 14.
14.1  Die  Genehmigung  von  Vertragsbeziehungen  und/oder  Maßnahmen,  die  nicht  im  Rahmen  des  normalen  Ge-

schäftsbetriebs  der  Gesellschaft  liegen,  sind  nicht  vom  Verwaltungsrat  zu  genehmigen,  sofern  sie  nicht  im  Voraus
einstimmig  von  allen  Gesellschaftern  auf  einer  ordentlichen  oder  außerordentlichen  Gesellschafterversammlung  (die
„Genehmigungshandlung") beschlossen wurden:

14.1.1 der Erwerb von Anlagezielen oder sonstigen Anlagen, ausgenommen zusätzliche Anlagen, im Hinblick auf welche

Gesellschafterbeschlüsse einer einfachen Mehrheit der Stimmen bedürfen;

14.1.2  die  Annahme  des  strategischen  Geschäftsplans  der  Gesellschaft  und  ihrer  Tochtergesellschaften  sowie  des

vereinbarten Investitionsplans/der vereinbarten Investitionspläne;

14.1.3 die Änderung des Stellenbesetzungsplans (einschließlich Bewerberauswahlverfahren);
14.1.4 alle Geschäfte zwischen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften einerseits und den Gesell-

schaftern oder einer ihrer jeweiligen Konzerngesellschaften im Sinne von Ziffer 8.5 andererseits;

14.1.5 eine Änderung des Gesellschaftsvertrags/der Satzung einer Tochtergesellschaft; ausgenommen hiervon sind

Änderungen aufgrund des Umstands, dass ein Gesellschafter ein Recht im Rahmen der Gesellschaftervereinbarung aus-
geübt hat oder eine Verpflichtung im Rahmen der Gesellschaftervereinbarung nicht erfüllt hat;

14.1.6 eine Änderung des Geschäftsplans und eines vereinbarten Anlageplans, die für die Gesellschaft erhöhte Kosten

oder für die Gesellschafter eine Erhöhung der Anlagebeträge oder eine Veräußerung der Zielimmobilien zur Folge haben,
sofern diese Kostensteigerungen mehr als drei Prozent (3 %) der veranschlagten Kosten/Anlagen betragen;

14.1.7 der Abschluss und die Änderung von größeren Verträgen mit einem Vertragswert von mehr als einer Million

Euro (EUR 1.000.000,00), und von allen Bau- und Projektverwaltungsverträgen sowie Maßnahmen in Bezug auf erhebliche
Mehrkosten im Zusammenhang mit diesen Verträgen; und

68189

14.1.8 alle Handlungen, bei denen der Verwaltungsrat nicht einstimmig beschließt, wie verfahren werden soll (zur

Klarstellung: Falls nicht alle persönlich oder in Vertretung auf einer Gesellschafterversammlung anwesenden Verwal-
tungsratsmitglieder (einschließlich jener, die die anderen Mitglieder über ihre Absicht, der Versammlung beizuwohnen,
benachrichtigt haben), Handlungen, Maßnahmen und Beschlüsse genehmigen, werden solche Handlungen, Maßnahmen
und Beschlüsse von der Gesellschaft und ihrem Verwaltungsrat nicht durchgeführt, bis die Gesellschafterversammlung
gegenteiliges beschließt).

14.2 Jedes Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, der Gesellschafterversammlung eine Genehmigungsmaßnahme zur

endgültigen Genehmigung/ Beschließung vorzulegen.

Art. 15.
15.1 Der Verwaltungsrat ist mit allen zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft notwendigen Befugnissen ausgestattet

und ist berechtigt, alle im Rahmen durch den Gesellschaftszweck gedeckten Veräußerungs- und Verwaltungsmaßnahmen
zu  genehmigen  und/oder  durchzuführen.  Dem  Verwaltungsrat  stehen  alle  Befugnisse  zu,  die  laut  Gesetz  und  diesem
Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat ist Dritten
gegenüber  in  jeder  Hinsicht  und  im  weitest  möglichen  Umfang  für  die  Gesellschaft  vertretungsberechtigt,  sowie  zur
Vornahme und Genehmigung sämtlicher Rechtshandlungen und Tätigkeiten mit Bezug auf die Gesellschaft befugt, die laut
Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag nicht der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind oder die hierin bestimmt
sind.

15.2 Ein oder zwei Vertreter des Verwaltungsrats können mit besonderen und spezifischen Befugnissen ausgestattet

werden.

15.3 Die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die einzelnen oder gemeinsamen

Unterschriften von Personen, die diese Unterschriftsbefugnis gemäß Ziffer 15.2 ordnungsgemäß erhalten haben, sind für
die Gesellschaft bindend.

Art. 16. Ein Vertrag oder sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder einem

anderen Unternehmen bleibt unberührt, bzw. wird nicht ungültig dadurch, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmit-
glieder oder leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen
beteiligt oder Geschäftsführer, Direktor, leitender Angestellter oder Angestellter dieser anderen Gesellschaft oder dieses
anderen Unternehmens sind. Verwaltungsratsmitgliedern oder leitenden Angestellten der Gesellschaft, die als Geschäfts-
führer, Direktor, leitender Angestellter oder Angestellter einer Gesellschaft oder eines Unternehmens beschäftigt sind,
mit denen die Gesellschaft einen Vertrag abschließt oder anderweitig geschäftliche Beziehungen unterhält, ist es aufgrund
dieser Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen nicht untersagt, bei Angelegen-
heiten mit Bezug auf diesen Vertrag oder die anderweitige geschäftliche Beziehung mitzuwirken und abzustimmen.

E. Gemeinsame Beschlüsse der Gesellschafter

Art. 17.
17.1 Alle Gesellschafterbeschlüsse werden in der Gesellschafterversammlung gefasst, die am Sitz der Gesellschaft und

mindestens einmal jährlich stattfinden. Jeder Gesellschafter kann sich gemeinsamen Beschlüssen beteiligen, unabhängig
von der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile. Die Stimmrechte der Gesellschafter entsprechen ihrem An-
teilsbesitz. Die Gesellschafter können sich bei Versammlungen vertreten lassen.

17.2 Eine Gesellschafterversammlung wird vom Verwaltungsrat per Einschreiben an die im Gesellschafterregister der

Gesellschaft hinterlegten Adressen der Gesellschafter unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist
von mindestens acht (8) Tagen einberufen. Auch die Gesellschafter dürfen Versammlungen gemäß diesen Formvorschrif-
ten einberufen. Ein Gesellschafter oder ein Verwaltungsratsmitglied kann mit einer Frist von mindestens drei (3) Tagen
die  zusätzliche Aufnahme  von  einem  (1)  oder  mehreren  Tagesordnungspunkten  verlangen. Wenn alle Gesellschafter
persönlich oder in Vertretung anwesend sind, die Versammlung als ordnungsgemäß einberufen betrachten und ihrem
Ermessen nach hinreichend über die Tagesordnung informiert sind, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige
Benachrichtigung abgehalten werden.

17.3 Eine Gesellschafterversammlung ist bei Anwesenheit von einhundert Prozent (100 %) aller ausgegebenen Ge-

schäftsanteile beschlussfähig.

17.3.1 Ist eine Versammlung nicht innerhalb einer Stunde nach dem für die Versammlung festgesetzten Zeitpunkt

beschlussfähig, dürfen die anwesenden Gesellschafter keine Beschlüsse fassen, ausgenommen der Beschluss zur Vertagung
der Versammlung auf ein von den anwesenden Gesellschaftern bestimmtes Datum, oder in Ermangelung desselben, auf
ein von dem Verwaltungsrat bestimmtes Datum, das frühestens sieben (7) Tage, jedoch spätestens dreißig (30) Tage nach
dem Datum der vertagten Versammlung liegen darf. Die Benachrichtigung über die Vertagung und das Datum, die Uhrzeit
sowie den Ort der neuen Versammlung geht den Gesellschaftern innerhalb von zwei (2) Tagen nach einer solchen Ver-
tagung zu.

17.3.2 Eine neu einberufene Versammlung ist hinsichtlich der bei der vertagten Versammlung anstehenden Tagesord-

nungspunkte beschlussfähig, wenn fünfzig (50) Prozent aller ausgegebenen Geschäftsanteile anwesend ist. Voraussetzung
hierfür ist jedoch, dass, wenn ein Gesellschafter die anderen Gesellschafter darüber in Kenntnis setzt, dass er/sie oder
seine Vertreter aus Gründen, die außerhalb seiner/ihrer Kontrolle liegen, nicht in der Lage ist, der Versammlung beizu-

68190

wohnen,  die  Versammlung  sieben  (7)  Tage  später  zur  gleichen  Uhrzeit,  am  gleichen  Datum  und  mit  der  gleichen
Tagesordnung stattfindet, sofern die Gesellschafter nichts anderes vereinbart haben.

17.4 Vorbehaltlich Ziffer 17.5 sind gemeinsame Beschlüsse der Gesellschafterversammlung rechtswirksam, wenn sie

von mehr als der Hälfte der die Gesamtheit der jeweils ausgegebenen Geschäftsanteile besitzenden Gesellschaftern ge-
nehmigt wurden.

17.5 Beschlüsse in den nachfolgend bezeichneten Angelegenheiten bedürfen einer Mehrheit von hundert (100) Prozent

der Stimmen der die gesamten ausgegebenen Geschäftsanteile vertretenden Gesellschafter:

17.5.1 die in Ziffer 14.1 aufgeführten Genehmigungsmaßnahmen, ausgenommen zusätzliche Anlagen, im Hinblick auf

welche Gesellschafterbeschlüsse einer einfachen Mehrheit der Stimmen bedürfen;

17.5.2 die Begründung einer Verpflichtung der Gesellschafter, zusätzliche Kapitaleinlage in die Gesellschaft einzubrin-

gen;

17.5.3 die Feststellung des gesetzlichen Abschlusses;
17.5.4 die Änderung des Gesellschaftsvertrags;
17.5.5 die Restrukturierung und/oder Liquidation der Gesellschaft;
17.5.6 die Änderung der Gesellschaftervereinbarung.
17.6 Im Hinblick auf einen Beschluss bezüglich des Erwerbs der Managementplattform:
(i) muss die Gesellschaft auf einen solchen Erwerb verzichten, wenn die Gesellschafterversammlung aufgrund des Vetos

des Gesellschafters der Klasse A keinen einstimmig gefassten Beschluss herbeiführen kann.

(ii)  gilt  folgendes  kumulativ,  wenn  die  Gesellschafterversammlung aufgrund der  abweichenden Stimme des Gesell-

schafters der Klasse B keinen einstimmig gefassten Beschluss herbeiführen kann und die Gesellschafter sich innerhalb von
dreißig (30) Tagen nach der jeweiligen Gesellschafterversammlung auf den Inventarwert der Gesellschaft („Nettoinven-
tarwert") einigen: .

(a) der Gesellschafter der Klasse A hat das Recht, das Kapital zur Finanzierung der Managementplattform durch die

Gesellschaft allein zu stellen;

(b) der Gesellschafter der Klasse A ist für die Sicherung der Bankfinanzierung im Rahmen des Erwerbs der Manage-

mentplattform durch die Gesellschaft zuständig, ohne Inanspruchnahme der Gesellschafter.;

(c) nach der Durchführung des Erwerbs der Managementplattform durch die Gesellschaft kommt es wegen der Be-

rücksichtigung der für den Erwerb der Managementplattform aufgewandten Kapitaleinlage der Gesellschafter der Klasse
A zu einer Werteinbuße des Kapitals des Gesellschafters der Klasse B im Verhältnis zu dem Nettoinventarwert der
Gesellschaft.

ODER
(iii) Können die Gesellschafter sich innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der jeweiligen Gesellschafterversammlung

nicht auf einen Nettoinventarwert einigen, kann der Gesellschafter der Klasse A erreichen, dass die Gesellschaft den
Erwerb der Managementplattform dessen ungeachtet weiterverfolgt und zum Abschluss bringt und gleichzeitig Ziffer (ii)
mit der Maßgabe entsprechend gilt, dass nach Wahl des Gesellschafters der Klasse A

(a) als Nettoinventarwert der Gesamtanlagewert jedes Gesellschafters gilt, erhöht um fünfzehn (15) Prozent p. a. ab

Leistung der jeweiligen Kapitaleinlage, oder

(b) der Gesellschafter der Klasse A sich für den Verkauf seiner Geschäftsanteile der Klasse A an die Management-

plattform entscheiden kann und der Gesellschafter der Klasse B Minderheitsgesellschafter an der Gesellschaft bleibt, (d.h.
Gesellschafter der Klasse B sind nicht zu einem Mitverkaufsrecht (Tag Along Right) gemäß 9.5 berechtigt).

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnausschüttung

Art. 18.
18.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.
18.2 Jedes Jahr muss der Verwaltungsrat im Hinblick auf das Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss, die Gewinn-

und Verlustrechnung der Gesellschaft sowie einen Inventar vorbereiten, einschließlich einer Bezugnahme auf den Wert
der Aktiva und Passiva der Gesellschaft mit einem Anhang, der alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft sowie die Ver-
bindlichkeiten  der  Manager,  der  Rechnungsprüfer  (falls  zutreffen)  und  der  Gesellschafter  gegenüber  der  Gesellschaft
zusammenfasst.

Jeder Gesellschafter kann den oben genannten Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 19.
19.1 Von dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) den gemäß dem Luxemburger

Gesellschaftsgesetz erforderlichen Rücklagen zugeführt. Diese Verpflichtung endet, sobald und soweit die Rücklagebe-
träge zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 6.1 betragen.

19.2 Gewinne und Verluste sind auf die Gesellschafter entsprechend der jeweiligen Beteiligung der Gesellschafter an

der Gesellschaft aufzuteilen. Änderungen hinsichtlich des Prozentsatzes der Beteiligung in einem Geschäftsjahr werden
anteilig berücksichtigt.

68191

19.3 Die Gesellschafterversammlung bestimmt durch Mehrheitsbeschluss auf Empfehlung des Verwaltungsrats über

die Art der Ausschüttung des jährlichen Nettogewinns (nach Abzug von Schuldendienst und Abschreibung) an die Ge-
sellschafter, soweit diesbezüglich keine Beschränkungen durch Darlehens- oder andere Finanzierungsverträge bestehen.

19.4 Das Aktienaufgeldkonto kann auf Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter gemäß ihres

Anteils an der Gesellschaft ausgeschüttet werden, soweit diesbezüglich keine Beschränkungen durch Darlehens- oder
andere Finanzierungsverträge bestehen.

19.5 Zwischendividenden können zu jeder Zeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) Zwischenbilanzen werden vom Verwaltungsrat erstellt;
(ii) Diese Zwischenbilanzen zeigen, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (einschließlich Aktienaufgeld)zur

Verteilung bereitstehen, wobei Einvernehmen darüber besteht, dass die zu verteilenden Beträge nicht die seit Ende des
letzten Finanzjahres, für das die Jahresabschlüsse genehmigt wurden, erwirtschaftete Gewinne übersteigen dürfen, zu-
züglich der vorgetragenen Gewinne und abzüglich der zu verteilenden Reserven und der gesetzlichen Rücklage .

(iii) Die Entscheidung bezüglich der Ausschüttung von Zwischendividenden wird von der Hauptversammlung der Ge-

sellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab Datum der Zwischenbilanzen gefällt;

(iv) Die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind nicht gefährdet unter Berücksichtigung des Kapitals der Gesellschaft;

und

(v) wenn die ausgezahlten Zwischendividenden die am Ende des Finanzjahres zuteilbaren Gewinne übersteigen, müssen

die Gesellschafter den Überschuss an die Gesellschaft zurückbezahlen.

G. Auflösung - Liquidation

Art. 20.
20.1. Bei einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Konkursverwaltern durch-

geführt (die nicht Aktionäre sein müssen), die von der eine solche Auflösung genehmigende Gesellschafterversammlung
bestellt werden. In dieser Gesellschafterversammlung werden ferner die Befugnisse und die Vergütung des Konkursver-
walters festgelegt.

20.2. Der von der Liquidierung der Vermögenswerte und der Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft stamm-

ende Überschuss wird den Gesellschaftern entsprechend ihrem jeweiligen Anteil am Gesellschaftskapital gezahlt.

H. Weitere Definitionen

Art. 21. Für alle nicht in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten Angelegenheiten gelten die Bestimmungen des lu-

xemburgischen Gesellschaftsgesetzes und der Aktionärsvereinbarung.

Art. 22. Definitionen.
„Zusätzliche Investitionen" bedeutet eine Investition in Anlageziele auf der Grundlage eines Mehrheitsbeschlusses der

Gesellschafter, falls die für den Entschluss stimmenden Gesellschafter die Finanzierung ohne jeglichen Ersatzanspruch an
die Gesellschafter sichern und sich verpflichten, ausschließlich das notwendige Kapital für eine solche Investition in dieses
Anlageziel zur Verfügung stellen.

„Konzerngesellschaft(en)" sind rechtlich unabhängige Unternehmen, die sich gegenseitig kontrollieren oder kontrolliert

werden, oder Konzerngesellschaften.

„Verbundene Kreditgeber" bedeutet im Hinblick auf den jeweiligen Gesellschafter jegliche angeschlossene Gesellschaft,

die dem Konzern einen Kredit gewährt.

„Vereinbarter Investitionsplan" bedeutet im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Zielimmobilie durch die Gesell-

schaft, die Zustimmung des Verwaltungsrates, wie von der Gesellschafterversammlung genehmigt, zur Beschlussvorlage
des Verwaltungsrats hinsichtlich der Höhe der Kapitaleinlagen der Gesellschafter, die Bestandteil der Finanzierung des
Kaufs und der Finanzbedingungen für den gesamten zukünftigen Investitionsaufwand für die Zielimmobilie wird.

„Jahresbudget" bedeutet das Jahresbudget, das von den Verwaltungsratmitgliedern vorgeschlagen wird, das die Summe

des Betriebskapitals der Gesellschaft zur Finanzierung von Operationen der Gesellschaft und, gegebenenfalls, die ent-
sprechenden Summe der Kapitaleinlagen, nicht später als drei Monate vor dem Beginn eines jeden Finanzjahres, und das
auf der Hauptversammlung der Gesellschafter per Mehrheitsbeschluss beschlossen wurde.

„Zustimmungshandlungen" haben die Bedeutung, die ihnen in Artikel 14.1 des Gesellschaftsvertrags zugeteilt wurde.
„Gesellschaftsvertrag" bezeichnet die Satzung der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen Version.
„Verwaltungsrat" bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft, der von Zeit zu Zeit gemä Artikel 11
„Verwaltungsratmitglied" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 11 des Gesellschaftsvertrags zugeteilt wurde.
„Arbeitstag" bezeichnet jeden Tag außer Samstag, Sonntag und alle Tage, an denen Banken im Großherzogtum Lu-

xemburg, im Vereinigten Königreich und in der Bundesrepublik Deutschland geschlossen bleiben dürfen oder gesetzlich
dazu verpflichtet sind.

„Geschäftsplan" ist der anfängliche strategische Geschäftsplan der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften.
„Kapitaleinlage"  ist  im  Hinblick  auf  den  jeweiligen  Gesellschafter  der  Nennwert  seines  Anteils  am  ausgegebenen

Stammkapital der Gesellschaft zuzüglich etwaiger Barbeträge, die (i) der jeweilige Gesellschafter als unter Kapitalrücklagen

68192

der Gesellschaft zu verbuchendes Aufgeld im Zusammenhang mit der Zeichnung seiner Anteile an der Gesellschaft an die
Gesellschaft zu leisten hatte und (ii) die vom jeweiligen Gesellschafter und seinen Kreditgebern als Gesellschafterdarlehen
an die Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften gezahlt wurden.

„Gesellschafter der Klasse A" bezeichnet den/die zeitweiligen Besitzer der Geschäftsanteile der Klasse A an der Ge-

sellschaft.

„Veräußerungsvorrecht  des  Gesellschafters  der  Klasse  A"  hat  die  Bedeutung,  die  diesem  Begriff  in  Artikel  9.1  im

Gesellschaftervertrag zugeteilt wurde.

„Geschäftsanteile der Klasse A" bezeichnet alle zeitweiligen ausgegebenen und gezeichneten Anteile in registrierter

Form am Geschäftskapital der Klasse A, mit einem Nennwert von EINEM EURO (1,00 EUR) pro Stück.

„Gesellschafter der Klasse B" bezeichnet den/die zeitweiligen Besitzer der Geschäftsanteile der Klasse B an der Ge-

sellschaft.

„Angebot des Gesellschafters der Klasse B" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9.3 im Gesellschaftervertrag

zugeteilt wurde.

„Geschäftsanteile der Klasse B" bezeichnet alle zeitweiligen ausgegebenen und gezeichneten Anteile in registrierter

Form am Geschäftskapital der Klasse B, mit einem Nennwert von EINEM EURO (1,00 EUR) pro Stück.

„Aufnahme der Geschäftstätigkeit" ist das Datum des Inkrafttretens der Gesellschaftervereinbarung.
„Verbundene Unternehmen" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 2.2 im Gesellschaftervertrag zugeteilt

wurde.

„Einbringender Gesellschafter" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 7.3 im Gesellschaftervertrag zugeteilt

wurde.

„Mitkaufsrecht (Drag Alone Right)" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9.2 im Gesellschaftervertrag zu-

geteilt wurde.

„Zuteilung" bezeichnet jeglichen Cash Outflow an die Gesellschafter in Form von Dividenden, Kapitalerträgen, An-

teilsauszahlung als auch Zinszahlungen und Rückzahlungen von Gesellschafterdarlehen.

„Anfängliche  Halteperiode"  hat  die  Bedeutung,  die  diesem  Begriff  in  Artikel  8.2  im  Gesellschaftervertrag  zugeteilt

wurde.

„Anlage" bezeichnet jeden Erwerb von Anlagezielen im Zuge einer einzelnen Transaktion.
„Anlageziel" ist der in Deutschland gelegene Bestand an Wohnimmobilien (residential assets), der nicht zum Verkauf

durch die Gesellschaft oder die Tochtergesellschaften im Wege einer Privatisierung geeignet ist, wobei die Eignung zur
Privatisierung vorliegt, wenn die Mehrheit der im Portfolio enthaltenen Einheiten für das sechzehnfache (16) oder mehr
als sechzehnfache (16) der Nettomieteinnahmen zu erwerben sind, bei deren Verwaltung noch Verbesserungspotenzial
besteht (under-managed), Aussichten auf kurzfristige Reduzierung der Verwaltungskosten gegeben sind, oder die Ein-
nahmesituation oder die Positionierung verbessert werden kann, jedoch müssen die Anlageziele in jedem Fall stets auf
hohem Niveau vermietbar sein.

„IPO" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 8.3.3 im Gesellschaftervertrag zugeteilt wurde.
„Luxemburgisches Gesellschaftsgesetz" bezeichnet das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Ge-

sellschaften, in seiner jeweils gültigen Version.

„Managementplattform" bezeichnet den Erwerb einer Wohnungsplattform eines Dritten, die ausreichend mit Immo-

bilienfachkräften und ggf. Vermögenswerten ausgestattet ist.

„NAV" (Nettoinventarwert) bedeutet (i) den von Zeit zu Zeit durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter fest-

gelegten Betrag des Wertes aller Anteile, Aufgelder oder der Gesellschafterdarlehen, oder bei Fehlen einer solchen
Vereinbarung (ii)die Summe der Gesamtinvestitionen jedes Gesellschafters plus fünfzehn (15) Prozent p.a. ab dem Datum
der  jeweiligen  Kapitaleinlage  oder  der  Zuteilungen,  die  z.B.  durch  Kapitaleinlagen  in  einer  Gesamthöhe  von  EUR
10.000.000gemacht wurden und keine Rückzahlung von Kapitaleinlagen oder Zinszahlungen gemacht wurden. NAV be-
trägt nach einem Jahr EUR 11.500.000 , die im Falle von 100.000 Anteilen, die insgesamt ausgegeben wurden, einen NAV
pro Aktie von EUR 115 ergeben.

"Nettomieteinnahmen" sind alle Mietzahlungen aus an die Gesellschaft oder die Tochtergesellschaften zu leistenden

Anlagen, ausgenommen hiervon sind Betriebskosten im Sinne der deutschen Betriebskostenverordnung sowie von der
Gesellschaft oder die Tochtergesellschaften vereinnahmte oder zu vereinnahmende MwSt.

„Nicht einbringender Gesellschafter" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 7.3 im Gesellschaftervertrag

zugeteilt wurde.

„Angebotszeit" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9.3 im Gesellschaftervertrag zugeteilt wurde.
„Verwässerungsstrafe" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 7.4 im Gesellschaftervertrag zugeteilt wurde.
„Aktiengesellschaft" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 8.4 im Gesellschaftervertrag zugeteilt wurde.
„Verkaufsmitteilung" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 9.3 im Gesellschaftervertrag zugeteilt wurde.
„Gesellschafterdarlehen" bezeichnet jegliche Darlehen, die der Gesellschaft von Zeit zu Zeit von den Gesellschaftern

gewährt wurden oder werden.

68193

"Gesellschafter" bezeichnet die Gesellschafter der Klasse A und der Klasse B zusammen, sowie jede Person, an die

Anteile übertragen oder ausgegeben wurden (außer die Gesellschaft selbst) in Übereinstimmung mit der Gesellschafter-
vereinbarung und/oder des Gesellschaftervertrags, wobei Gesellschafter einen jeden davon bezeichnet.

„Gesellschaftervereinbarung" ist eine Vereinbarung, die jeweils zwischen den Gesellschaftern getroffen wird.
„Anteile" bezeichnet die jeweiligen Anteile der Klasse A und B zusammen (oder falls der Zusammenhang dies erfordert

je eine der beiden Klassen).

„Unterschuss" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Artikel 7.3 im Gesellschaftervertrag zugeteilt wurde.
„Stellenbesetzungsplan" bezeichnet den Plan für die interne Verwaltung der Gesellschaft.
„Tochtergesellschaften" sind alle beschränkt haftenden, nach deutschem oder luxemburgischen Recht organisierten

Gesellschaften, und deutschem Recht gegründeten Personengesellschaften und nach deutschem Recht organisierte Part-
nerschaften, die direkt oder indirekt im Eigentum der Gesellschaft stehen.

„Gesamtanlagewert" bedeutet mit Bezug auf einen Gesellschafter den Saldo
(i) aller Kapitaleinlagen des jeweiligen Gesellschafters
(ii) abzüglich aller durch die Gesellschaft dem jeweiligen Gesellschafter gezahlten Beträge, als Zuteilung von (i) Ge-

winnen oder (ii) aus Reserven

(iii) abzüglich aller von der Gesellschaft an den jeweiligen Gesellschafter und seine verbundenen Kreditgeber im Wege

der Zinszahlung oder Rückzahlung der für die Gesellschafterdarlehen gezahlten Kapitalbeträge.

<i>Kosten und Auslagen

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten

fallen oder sonst aufgrund dieser Urkunde von ihr getragen werden, wird auf zweitausendfünfhundert euro geschätzt.

Worüber Urkunde erstellt wurde in Luxemburg zum Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Erschienenen, diese

Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Und nach Verlesung alles Vorhergehenden an die Bevollmächtigte, welche dem Notar mit Vor- und Nachnamen und

Anschrift bekannt ist, hat die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und der Notar die vorliegende Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: N. WEYRICH, C. WERSANDT.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 30. Juni 2009. Relation: EAC/2009/7552. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-

EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Ge-

sellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 01 JUIL 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009085276/239/1158.
(090101614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2009.

G.C.F. S.A., Gestion Comptable et Fiscale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8469 Gaichel, Maison 4.

R.C.S. Luxembourg B 30.430.

L'an deux mille neuf, le cinq juin.
Par-devant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme GESTION COMPTABLE ET FISCALE S.A.,

en abrégé, G.C.F. S.A., ayant son siège social à L-8469 Gaichel, Maison 4, inscrite au registre commerce de et à Luxembourg
sous le numéro B 30.430, constituée, sous forme de société à responsabilité limitée, aux termes d'un acte reçu par le
notaire soussigné, alors de résidence à Redange/Attert, en date du 10 avril 1989, publié au Mémorial C numéro 235 du
26 août 1989 et modifiée en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 1 

er

 octobre 1999,

publié au Mémorial C numéro 962 du 15 décembre 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent ALLARD, comptable, demeurant à B-Villers-devant-Orval, qui désigne

comme secrétaire Madame Christine NOËL, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Bernard SCHOLTUS, comptable, demeurant à B-Saint-Léger.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

68194

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les DEUX CENT CINQUANTE (250) actions représentant l'intégralité

du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Adaptation de divers articles des statuts, suite à la loi du 25 août 2006.
2.- Modification de l'objet social et en conséquence de l'article deux des statuts.
3.- a) Suppression de la valeur nominale des actions,
b) confirmation de la transformation du capital en euros et augmentation à concurrence de TREIZE EUROS TRENTE

ET UN CENTS (13,31 €), pour le porter à TRENTE ET UN MILLE (31.000,-) EURO,

c) changement de la nature des actions,
d) instauration d'un droit de préemption ainsi que d'un droit d'agrément,
e) modification subséquente de l'article trois des statuts.
4.- Suppression du mandat spécial accordé à un des administrateurs et démission de cet administrateur. Nomination

d'un nouvel administrateur.

5.- Démission du commissaire aux comptes. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En conformité de la loi du 25 août 2006, l'assemblée décide d'adapter les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .

- il est inséré un second paragraphe comme suit:
"La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires".
- à la fin du dernier paragraphe sont ajoutés les mots suivants:
"ou de l'associé unique".

Art. 4. Il est supprimé et remplacé par le suivant:
"Tant que la société ne compte qu'un associé unique, elle peut être administrée par un administrateur unique, qui n'a

pas besoin d'être l'associé unique de la société.

Si la société compte plus qu'un actionnaire, elle sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois

membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera considérée automatiquement comme une référence

à l'administrateur unique tant que la société ne compte qu'un seul associé.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent qui la repré-

sentera, conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée."

Art. 5.
- au cinquième paragraphe, les mots "est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des action-

naires" sont supprimés.

- à la fin du dernier paragraphe sont ajoutés les mots "ou encore de l'associé unique".

Art. 10.
- il est ajouté deux paragraphes comme suit:
"Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par

visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Pour le cas où il n'existe qu'un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues,

tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social. En conséquence l'article deux est supprimé et remplacé par le suivant:
"La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte

de tiers:

- les activités de comptable (-fiscaliste): à savoir:
* l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;
* l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;

68195

* la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales

en la matière;

* les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables;
- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés,
- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale,
- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que

ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (-fiscaliste).

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/

ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales, ou sociétés civiles, dotées d'un objet social
similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.
Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie et exclusivement pour son compte propre,

les opérations financières, mobilières ou Immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de
nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions, de confirmer la transformation du capital social en

euros et de l'augmenter à concurrence de TREIZE EUROS TRENTE ET UN CENTS (13,31 €), pour le porter à TRENTE
ET UN MILLE (31.000,-) EUROS, représenté par DEUX CENT CINQUANTE (250) actions sans désignation de valeur
nominale.

La prédite augmentation de capital a été faite par incorporation de réserves de la société.
L'assemblée décide que les actions seront désormais uniquement nominatives et qu'elles le resteront.
L'assemblée décide d'instaurer un droit de préemption, ainsi qu'un droit d'agrément.
En conséquence de tout ce qui précède, l'article trois des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:
"Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE (31.000,-) EUROS, représenté par DEUX CENT CINQUANTE

(250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.
Dans le cas où la société compte plusieurs actionnaires, chacun bénéficiera d'un droit de préemption sur les actions

de la société, au prix tel que fixé par le cédant et le cessionnaire. Avant toute vente d'actions à des tiers non actionnaires,
l'actionnaire cédant tout ou partie de ses actions devra les proposer par lettre recommandée avec accusé de réception
aux autres actionnaires.

En cas d'acceptation de l'offre par plus d'un actionnaire endéans la quinzaine, les actions leur seront attribuées au

prorata de leur participation antérieure.

A défaut d'acceptation de l'offre dans les quinze jours de sa réception, l'actionnaire cédant pourra céder ses actions

à des tiers.

Outre le droit de préemption, les actions ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou à cause de mort à

des non-actionnaires qu'avec l'agrément donné comme suit:

- s'il existe plus que deux associés, la décision sera prise en assemblée générale des actionnaires représentant au moins

les trois quarts du capital social et à la majorité des votants;

- s'il n'existe que deux associés, la décision sera prise par l'autre associé dans un délai de quinze jours.
En cas de refus d'agrément, le ou les autres associé(s) est/sont tenu(s) de racheter les actions aux conditions propo-

sées."

<i>Quatrième résolution

L'assemblée  décide de  supprimer  le mandat  spécial  accordé  à Madame  Marie-Pierre  SCHADECK,  aux termes de

l'assemblée générale du 29 juillet 2005.

L'assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Marie-Pierre SCHADECK et lui donne dé-

charge pour sa mission jusqu'à ce jour.

Elle nomme administrateur Monsieur Jean-Paul HAYON, comptable, demeurant à B-6700 Arlon, 7, rue des Roses, en

remplacement de Madame SCHADECK. Il continuera son mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale qui statuera
sur l'élection définitive.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de Monsieur Thomas LENOIR et lui donne

décharge pour sa mission jusqu'à ce jour.

Elle nomme pour une durée de six années, comme commissaire aux comptes, Monsieur Joffroy BAYET, comptable,

demeurant à B-6840 Neufchâteau, 7, route de la Maladrerie.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

68196

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ MILLE TROIS CENT CIN-

QUANTE (1.350,-) EUROS.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: ALLARD - NOËL - SCHOLTUS - THOLL.
Enregistré à Mersch, le 10 juin 2009. Relation: MER/2009/1029. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Mersch, le 15 juin 2009.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2009084351/232/138.
(090100681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Fondations Capital Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 129.318.

In the year two thousand and nine, on the fifteenth of the month of May.
Before Us, Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Fondations Capital Management S.A., a joint-stock

company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 121,
Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 129.318 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of June 13, 2007, pu-
blished in the Mémorial C n°1680 of August 9, 2007, and whose bylaws have last been amended pursuant to a deed of
the undersigned notary of February 25, 2008, published in the Mémorial C, n°1233 of May 21, 2008.

The meeting is chaired by Mr. Xavier Marin, residing at 102, rue de Grenelle, 75007 Paris, France.
The chairman appointed as secretary Mr. Philippe Renauld, residing at 42, rue Cardinet, 75017 Paris, France.
The meeting elected as scrutineer Mr. Olivier Ferres, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders are present and the number of their shares is shown on an attendance list, signed by the

chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be registered with the present
minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Company, presently fixed at thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) are present or represented at the present general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered seat from its current location to 1A Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Municipality of

Niederanven.

2. Conversion of the twenty one thousand three hundred thirty-three (21,333) existing class A shares and of the ten

thousand six hundred sixty-seven (10,667) existing class B shares, all having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each,
into thirty-two thousand (32,000) ordinary shares of one Euro (EUR 1.-) each.

3. Subsequent restatement of the articles of association of the Company.
4. Granting of power.
IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to transfer the registered seat of the Company from its current address to 1A Heienhaff, L-1736

Senningerberg, municipality of Niederanven.

<i>Second resolution

The meeting resolved to convert the twenty one thousand three hundred thirty-three (21,333) existing class A shares

and the ten thousand six hundred sixty-seven (10,667) existing class B shares, all having a nominal value of one Euro (EUR
1.-) each, into thirty-two thousand (32,000) ordinary shares of one Euro (EUR 1.-) each.

68197

<i>Third resolution

Pursuant to the above resolution, the meeting resolved to restate the articles of association of the Company as follows:

Preliminary title: Definitions

"AGM", means the annual general meeting of the shareholders of the Company.
"Articles", means the present articles of association of the Company.
"Board", means the board of directors in office of the Company.
"Company" means Fondations Capital Management S.A.
"EGM", means the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company.
"Law", means the Luxembourg law of August 10, 1915 governing commercial companies as amended.

Title I. Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a joint stock company under the name of Fondations Capital Management S.A.,

which will be governed by the Law as well as by the Articles.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Senningerberg, municipality of Niederanven.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an EGM

deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

It may be transferred to any other address in the same municipality by a resolution of the Board.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. The purpose of the Company is to serve on an exclusive basis as the general partner (associé commandité) of

Fondations Capital I S.C.A. SICAR, a société d'investissement en capital à risque organized as a partnership limited by
shares (société en commandite par actions) existing under the Luxembourg law of 15 June 2004 relating to the investment
company in risk capital (the "SICAR"), as further described in a management agreement entered into between the Com-
pany and the SICAR and as further detailed in the placement memorandum of the SICAR, as same may be amended from
time to time.

The Company may carry out any commercial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment

of its purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) represented by thirty-two thousand

(32,000) ordinary shares of one Euro (EUR 1.-) each, fully paid up.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

The shares will be created as and will remain registered shares.
The corporate capital may be increased or reduced by means of a resolution of an EGM at the cumulative conditions

of (i) the quorum and majority conditions required for amendments to the Articles and (ii) the majority of the sharehol-
ders. A preferential subscription right may be waived only with the written unanimous approval of all shareholders.

The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with the requirements of the Law.

Title III. Management

Art. 6. The Company is managed by a Board composed of four (4) members, either shareholders or not, divided into

two categories, namely the category A directors (each a "Category A Director") and the category B directors (each a
"Category B Director"), who are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them. The shareholder holding the highest number of shares will designate the chairman
of the Board (the "Chairman").

The total number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders

of the Company.

Art. 7. The Board convenes upon call by the Chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must

be convened each time two (2) directors so request.

All decisions of the Board shall be taken during meetings where all members are physically present in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, in cases where an immediate decision is required and where one or several members of

68198

the Board are not in Luxembourg, the members of the Board may take decisions during a conference held by way of any
appropriate mean. Minutes of the Board ratifying the decisions so taken shall then be executed by all the Board's members
during a meeting physically held in Luxembourg as soon as practicable thereafter.

Art. 8. The Board is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in com-

pliance with the Company's object and the present Articles. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board. The Board may decide to pay advance
dividends, in compliance with the requirements of the Law.

Art. 9. Subject to Article 13, resolutions are taken by the Board at the unanimity of the board members for all reso-

lutions:

- to propose to the extraordinary general meeting of shareholders a change of the Company's name;
- to propose to the extraordinary general meeting of shareholders a change of the Company's nationality;
- to opening of a new Investment vehicle, entry into a new line of business, investments or disinvestments of the

Company out of the annual budget;

- in connection with the allocation of a carried interest to a third party or employment of a manager that will benefit

from a carried interest;

- in connection with the investment decisions at the level of Fondations Capital I S.C.A. SICAR;
- in connection with the definition of the annual budget of the Company;
- in connection with disinvestment decisions at the level of Fondations Capital I S.C.A. SICAR.

Art. 10. All other management decisions of the Company are taken by the joint signature of one Category A Director

and one Category B Director, or by the individual signature of the Company's managing director provided that special
resolutions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board pursuant to article 11 of the Articles.

Art. 11. The Board may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or several

directors, who will be called managing directors. Such delegation may provide for a joint signature of the Company's
managing director and one director belonging to the other category for payments exceeding an amount defined by the
Board. Any decision to implement or terminate such delegation can only be adopted at the unanimity of the board
members.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or several managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholder, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

Art. 12. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

Company by the Board, represented by its Chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Investment committee

Art. 13. The Board shall, by an unanimous vote of its members, establish an investment committee and appoint its four

(4) members, two members of which shall be members of the Board and two other members of which shall be residents
of Luxembourg having an experience in the corporate finance field (the "Investment Committee").

Any investment and disinvestment decision of the Board shall be taken after consultation and prior approval of the

Investment Committee. Decisions at the Investment Committee are taken at a majority of three (3) out of four (4).

The Investment Committee shall meet as frequently as the business requires. The Investment Committee will deter-

mine, after its implementation, its internal rules including the methods by which a meeting of the Investment Committee's
members shall be convened. All decisions taken by the Investment Committee shall be recorded in minutes of the In-
vestment Committee which shall be kept in a record.

All decisions of the Investment Committee shall be taken during meetings where all the members are physically present

in Luxembourg. Notwithstanding the foregoing, in cases where an immediate decision is required and where one or
several members of the Investment Committee are not in Luxembourg, the members of the Investment Committee may
take decisions during a conference held by way of any appropriate mean. Minutes of the Investment Committee ratifying
the decisions so taken shall then be executed by all the Investment Committee's members during a meeting physically
held in Luxembourg as soon as practicable thereafter.

Title V. Supervision

Art. 14. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders which will fix their number, their remuneration and the term of their office, which must not exceed six (6) years.

Title VI. Annual general meeting

Art. 15. The AGM will be held at the Company's registered office or at any other location in Luxembourg specified in

the convening notices on June 30 at 2.00 pm. If such day is a legal holiday, the AGM will be held on the next following
business day.

68199

Title VII. Accounting year, Allocation of profits

Art. 16. The accounting year of the Company shall begin on the first of January (safe for the first year which shall begin

on the date hereof) and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 17. After deduction of any and all expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents

the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company, but
it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been
touched.

The balance less the difference, if null or positive, of (i) the forecasted cost and expenses for the first six months of

the accounting year and (ii) net cash available shall be distributed among shareholders prorata to their shares.

Title VIII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. The Company may be dissolved by a resolution of the EGM. The liquidation will be carried out by one or

more liquidators, physical or legal persons, appointed by the EGM, which will specify their powers and fix their remune-
ration.

Title IX. General provision

Art. 19. All matters not governed by the Articles are to be construed in accordance with the Law.

<i>Third resolution

The meeting resolved to empower any employee of Fideos Financial Services, with address at 1A, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg to update the shareholders' register of the Company accordingly.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille neuf, le quinze du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Fondations Capital Management S.A., une société

anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 129.318 (la "Société"), constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 juin 2007, publié au Mémorial C n°1680 du 9 août 2007, et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 février 2008, publié
au Mémorial C n°1233 du 21 mai 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Xavier Marin, résidant au 102, rue de Grenelle, 75007 Paris, France.
Le président désigne comme secrétaire M. Philippe Renauld, avec résidant au 42, rue Cardinet, 75017 Paris, France.
L'assemblée choisit comme scrutateur M. Olivier Ferres, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.
I. Que les actionnaires sont présents et que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuel-

lement fixé à trente-deux mille Euro (EUR 32.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

68200

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, commune

de Niederanven.

2. Conversion des vingt et un mille trois cent trente-trois (21.333) actions existantes de catégorie A et des dix mille

six cent  soixante-sept  (10.667) actions  existantes  de catégorie  B, toutes  d'une  valeur  nominale d'un  Euro  (EUR 1,-)
chacune, en trente-deux mille (32.000) actions ordinaires d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

3. Refonte subséquente des statuts de la Société.
4. Délégation de pouvoirs.
IV. L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 1A, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, commune de Niederanven.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident de convertir les vingt-et-un mille trois cent trente-trois (21.333) actions existantes de ca-

tégorie A et les dix mille six cent soixante-sept (10.667) actions existantes de catégorie B, toutes d'une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,-) chacune, en trente-deux mille actions ordinaires d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, les actionnaires décident de refondre les statuts de la Société comme suit:

Titre préliminaire: Définitions

"AGA", désigné l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.
"Statuts", désigne les présents statuts de la Société.
"Conseil", désigne le conseil d'administration en fonction de la Société.
"Société", désigne Fondations Capital Management S.A.
"AGE", désigne l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.
"Loi", désigne la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est par les présentes formé une société anonyme sous la dénomination de Fondations Capital Management

S.A. régie par la Loi ainsi que par les Statuts.

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Senningerberg, commune de Niederanven.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'AGE statuant comme

en matière de modification des Statuts.

Il peut être transféré à toute autre adresse de la même municipalité par simple résolution du Conseil.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet de la Société est de gérer de manière exclusive, en qualité d'associé commandité, Fondations Capital I

S.C.A. SICAR, une société d'investissement en capital à risque organisée sous la forme d'une société en commandite par
actions, soumise à la Loi du Grand-Duché de Luxembourg du 15 juin 2004 organisant la société d'investissement en capital
à risque (la "SICAR"), tel que cela est défini par un contrat de gestion signé par la Société et par la SICAR et tel que plus
avant détaillé par le prospectus de la SICAR, ainsi que modifiés de temps à autre.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec toutes les matières décrites ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euro (EUR 32.000,-) représenté par trente-deux mille (32.000)

actions ordinaires d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, libérées intégralement.

68201

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont créées et resteront nominatives.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par résolution de l'AGE aux conditions cumulatives de (i) quorum

et majorité requis pour une modification des Statuts et (ii) à la majorité des actionnaires. Il ne peut être renoncé à un
droit préférentiel de souscription qu'avec l'accord unanime de tous les actionnaires.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la Loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de quatre (4) membres au moins, actionnaires ou non,

divisé en deux catégories, à savoir les administrateurs de catégorie A (chacun un "Administrateur de Catégorie A"), et
les administrateurs de catégorie B (chacun un "Administrateur de Catégorie B") qui seront nommés par l'assemblée
générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans et toujours révocables par elle.

L'actionnaire détenant le plus grand nombre d'actions désignera le président du Conseil (le "Président").

Art. 7. Le Conseil se réunit sur la convocation du Président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit

être convoqué chaque fois que deux (2) administrateurs le demandent.

Toutes les décisions du conseil doivent être prises lors de réunions tenues à Luxembourg et où tous les membres du

Conseil sont présents. Nonobstant ce qui précède, dans les cas ou une décision immédiate est requise et au cas où un
ou plusieurs membres ne pourraient être présents à Luxembourg, les membres du Conseil pourront prendre leur décision
par conférence (téléphonique ou visioconférence) tenue par tout moyen approprié. Les minutes de la réunion du Conseil
ratifiant les décisions ainsi prises seront prises lors d'une réunion physiquement tenue à Luxembourg dès que possible.

Art. 8. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui

rentrent dans l'objet et les Statuts de la Société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale. Le Conseil est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la Loi.

Art. 9. Sous réserves des stipulations de l'article 13, l'unanimité des membres du Conseil est requise pour les résolu-

tions suivantes:

- proposant a l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de modifier le nom de la Société;
- proposant a l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de modifier la nationalité de la Société;
- relatives à la création d'un nouveau véhicule d'investissement, à l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité, à des

investissements ou des désinvestissements non prévus au budget annuel;

- relatives à l'allocation a un droit au carried à des tiers ou l'emploi d'un nouveau gérant ayant droit au carried;
- relatives aux décisions d'investissement dans le chef de Fondations Capital I S.C.A. SICAR;
- relatives à la détermination du budget annuel de la Société;
- relatives aux décisions de réalisation d'investissement dans le chef de Fondations Capital I S.C.A. SICAR.

Art. 10. Toutes autres décisions de gestion de la Société sont prises par la signature conjointe d'un Administrateur de

Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B, ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué de la
Société, sous réserve que des résolutions spécifiques aient été prises autorisant cette délégation en cas de délégation de
pouvoirs et mandats conférés par le Conseil en vertu de l'article 11 des Statuts.

Art. 11. Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront

la dénomination d'administrateurs-délégués. Une telle délégation pourra notamment prévoir que société soit valablement
engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un administrateur de l'autre catégorie pour le paiement
de montants excédant l'autorisation accordée par le Conseil.

Toute décision de terminer cette délégation ne sera prise qu'à l'unanimité des administrateurs.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, administrateurs ou on, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil,

poursuites et diligences de son Président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Comité d'investissement

Art. 13. Le Conseil pourra par une décision unanime de ses membres, établir un comité d'investissement et nommer

ses quatre (4) membres, dont deux seront des membres du Conseil et deux autres des professionnels Luxembourgeois
justifiant d'une expérience significative en finance d'entreprises (le "Comité d'Investissement").

68202

Toute décision du Conseil relative à un investissement ou à la réalisation d'un investissement après consultation et

accord préalable du Comité d'Investissement qui devra être donné à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du
Comité d'Investissement.

Le Comité d'Investissement se réunira aussi souvent que les affaires de la Société le requièrent. Le Comité d'Inves-

tissement déterminera après sa mise en place ses règles de fonctionnement et de convocation. Toutes les décisions du
Comité d'Investissement seront retranscrites dans des minutes conservées au siège de la Société.

Toutes les décisions du Comité d'Investissement seront prises lors de réunions tenues à Luxembourg et où tous les

membres du Comité d'Investissement sont présents à Luxembourg. Nonobstant ce qui précède, dans les cas ou une
décision immédiate est requise et au cas où un ou plusieurs membres ne pourraient être présents à Luxembourg, les
membres du Comité d'Investissement pourront prendre leur décision par conférence (téléphonique ou visioconférence)
tenue par tout moyen approprié. Les minutes de la réunion du Comité d'Investissement ratifiant les décisions ainsi prises
seront prises lors d'une réunion physiquement tenue à Luxembourg dès que matériellement possible.

Titre IV. Surveillance

Art. 14. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale, qui

fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans.

Titre V. Assemblée générale annuelle

Art. 15. L'AGA se réunit au siège de la Société ou en tout autre endroit au Luxembourg, tel qu'indiqué dans les

convocations, le trente juin à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'AGA a lieu le premier jour ouvrable
suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve avait été entamé.

Le solde diminué de la différence, si nul ou positif, (i) des coûts et dépense prévisionnels pour les six premiers de

l'exercice comptable et (ii) des liquidités nettes disponibles devra être distribuées entre les actionnaires au prorata de
leur participation.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. La Société peut être dissoute par décision de l'AGE.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'AGE qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Disposition générale

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la Loi.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident de donner pouvoir à tout employé de Fideos Financial Services, avec adresse au 1A, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, de mettre à jour le registre d'actionnaires de la Société confor-
mément aux résolutions précédentes.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état

et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Xavier MARIN, Philippe RENAULD, Olivier FERRES, Joseph ELVINGER.

68203

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 20 mai 2009. Relation: LAC/2009/19547. Reçu soixante-quinze euros (€

75,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009084417/211/362.
(090101009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Garage du Riesenhoff S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8818 Grevels, 32, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 101.855.

L'an deux mil neuf, le quinze juin.
Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GARAGE DU RIESENHOFF

S.A.", ayant son siège social à L-8805 Rambrouch, 3, route de Martelange, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés Luxembourg sous le numéro B 101.855,

Constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre

1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 181, du 20 avril 1995.

L'assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Willy NOISET, administrateur de société,

demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique), 7A, Malmaison.

Qui désigne comme secrétaire, Monsieur Stany NOISET, administrateur de société, demeurant à B-6637 Fauvillers,

10, Sainlez.

L'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Miguel  NOISET,  administrateur  de  société,  demeurant  à  B-6637

Fauvillers, 7D, Malmaison.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège de la société de L-8805 Rambrouch, 3, route de Martelange à L-8818 Grevels, 32, rue Principale,

et modification afférente de l'article 2 premier alinéa des statuts comme suit:

Art. 2. (Alinéa 1). Le siège social est établi à Grevels."
2) Modification de l'article 5 alinéa premier des statuts par suite du basculement de la devise du capital social en euros

par adaptation de la monnaie d'expression du capital social de 1.250.000,00 LUF en 30.986,69 EUR, qui aura désormais
la teneur suivante:

Art. 5. (Alinéa 1). Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69

EUR) divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent neuf euros quatre-vingt-sept cents (309,87 EUR)
chacune."

3) Renouvellement des mandats des administrateurs.
4) Autorisation conférée au Conseil d'administration de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de

la société à un ou plusieurs administrateurs.

5) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur"
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des

voix, les résolutions suivantes:

68204

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de L-8805 Rambrouch, 3, route de Martelange à L-8818 Grevels,

32, rue Principale, et de modifier subséquemment l'article 2 alinéa 1 des statuts comme suit:

Art. 2. (Alinéa 1). Le siège social est établi à Grevels."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 alinéa premier des statuts par suite du basculement de la devise du capital

social en euros par adaptation de la monnaie d'expression du capital social de 1.250.000,00 LUF en 30.986,69 EUR, qui
aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (Alinéa premier). Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR) divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent neuf euros quatre-vingt-sept cents
(309,87 EUR) chacune."

<i>Troisième résolution

L'assemblée renouvelle, pour une durée allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2014, les mandats des

administrateurs:

- Willy NOISET, administrateur de société, demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique), 7A, Malmaison, né à Hollange

(Belgique), le 29 novembre 1938.

- Monsieur Stany NOISET, administrateur de société, demeurant à B-6637 Fauvillers, 10, Sainlez, né à Bastogne (Bel-

gique), le 23 août 1969.

- Monsieur Miguel NOISET, administrateur de société, demeurant à B-6637 Fauvillers, 7D, Malmaison, né à Bastogne

(Belgique), le 1 

er

 avril 1973.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée autorise le Conseil d'administration de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la

société à un ou plusieurs administrateurs.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée renouvelle, pour une durée allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2014, le mandat du com-

missaire aux comptes: Monsieur Jacques FOSTIER, expert-comptable (I.E.C), licencié en sciences économiques appliquées,
né à Charleroi (Belgique), le 29 janvier 1949, demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique), 23, rue du Centre.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 17.15 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.150,- €.

Fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants  tous  connus  du  notaire  instrumentant  par  noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Noiset, Noiset, Noiset, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 juin 2009. Relation: LAC/2009/23564. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

Hesperange, le 25 juin 2009.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2009084354/241/87.
(090100552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Immotep S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5670 Altwies, 7A, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 97.385.

L'an deux mil neuf, le cinq juin.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOTEP S.A., avec siège

social à L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

68205

constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven en date du 2 décembre

2003,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 42 du 13 janvier 2004 (la "Société").
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Francesca Cottoni, demeurant à Altwies,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Fabio Mauro EMILI, indépendant, demeurant à L-4383 Ehlerange, 25, Cité op

Gewaennchen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Francesca Cottoni, préqualifiée.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège vers L-1638 Senningerberg, 74, rue du Golf.
2. Adaptation de l'article 2 premier alinéa: Le siège est établi dans la commune de Mondorf/Bains.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.-  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  cent  pour  cent  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social du 74, rue du Golf, L-1638 Senningerberg au 7A, route de Mondorf,

L-5670 Altwies.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2 alinéa 1 

er

 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Mondorf/Bains."
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de sept cent cinquante cents euros (EUR 750,-).

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.

Signé: Cottoni, Ramos, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, le 12 juin 2009. Relation: RED/2009/762. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de la publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 7 juillet 2009.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2009084353/7851/53.
(090100715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Faïence S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 31.105.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 19 juin 2009

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31.12.2009, les personnes

suivantes composent le conseil d'administration:

68206

- M. Eric Bernard, expert-comptable, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

- M. Bob Faber, expert-comptable, né le 15 mai 1964 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Lu-

xembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

- M. Bob Bernard, expert-comptable, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 123. avenue de la Faïencerie.

- M. Christian Bernard, conseil, né le 20 mai 1972 à EttelbUck, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg,

123, avenue de la Faïencerie.

- M. Alain Heinz, expert-comptable, né le 17 mai 1968 à Forbach, en France, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

- M. Charles MEYER, expert-comptable, né le 19 avril 1969 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

- M. Alain Peigneux, expert-comptable, né le 27 février 1968 à Huy en Belgique, ayant son domicile professionnel à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Interaudit S. à r.l. est reconduite dans sa fonction de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale appelée à

se prononcer sur les comptes annuels au 31.12.2009.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions

<i>prises par le conseil d'administration en date du 19 juin 2009

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31.12.2009, le conseil d'ad-

ministration décide à l'unanimité:

- de reconduire M. Eric Bernard comme président du conseil d'administration,
- de reconduire M. Eric Bernard et M. Bob Faber dans leur mandats d'administrateurs-délégués.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Faïence S.A.
BERNARD &amp; ASSOCIES, société civile
Signature

Référence de publication: 2009084501/38.
(090100699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Topvel Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 44.992.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 5 juin 2009 que:
- Les mandats des administrateurs suivants sont reconduits et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se

tiendra en l'an 2014:

Monsieur DE FEIJTER Adriaan, né le 12.04.1939 à Axel (Pays-Bas), demeurant au 3, rue de Bridel, L-7344 Steinsel;
Maître ELVINGER Victor, né le 26.09.1954 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich, L-1461

Luxembourg;

Madame SNYDER Carol Lee, née le 25.06.1948 au New Jersey (USA), demeurant au 323, Lindeley Avenue à USA,

91316 Encino L.A.

- Le mandat d'administrateur-délégué détenu par Madame Carol Lee SNYDER, née le 25.06.1948 au New Jersey (USA),

demeurant au 323, Lindeley Avenue à USA, 91316 Encino L.A. est reconduit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
qui se tiendra en l'an 2014.

- Le mandat de commissaire aux comptes détenu par la société Fidu-Concept Sàrl, immatriculée au Registre de Com-

merce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 38.136, ayant son siège social au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg est reconduit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2014.

- Le siège de la société est transféré de 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg au 39, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2009084376/26.
(090100517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

68207

Condo Hotel Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 73.224.

La société Fiduciaire de Trèves S.C. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société CONDO HOTEL

GROUP S.A., 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, R.C.S. B 73.224.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

FIDUCIAIRE DE TREVES S.C.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009084381/13.
(090100916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Condo Hotel Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 73.224.

La  société  Fiduciaire  de  Trèves  S.C.  a  dénoncé,  avec  effet  immédiat,  le  siège  social  de  la  société  BLUMENTHAL

INVESTMENTS S.A., 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, R.C.S. B 88.727.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2009.

FIDUCIAIRE DE TREVES S.C.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009084382/13.
(090100916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Zhermack International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.540.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 130.434.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 30.06.2009 il a été décidé:
- de transférer, avec effet au 1 

er

 juillet 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Edoardo TUBIA / Salvatore Desiderio

Référence de publication: 2009084603/16.
(090101329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Gamma 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 121.033.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GAMMA 2 SA
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009084708/12.
(090100300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

68208


Document Outline

ACCOFIN, Société Fiduciaire

Agardh Invest S.A.

AGD Consulting S.A.

Allegra Investments S.A.

Aral Luxembourg S.A.

Arcelor Commercial Rebar S.A.

ArcelorMittal Belval &amp; Differdange

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.

ArcelorMittal International

Capinvest International Holding S.A.

Caralto Holding S.A.

Casatex S.A.

CC-Center SA

CitCor Residential Holdings S.à r.l.

Condo Hotel Group S.A.

Condo Hotel Group S.A.

Dayson S.A.

Dinvest

Duforêt Holding S.A.

Erste Luxemburger Forderungsankaufgesellschaft AG

Euro Investment 2000 S.A.

Europ Infos S.à r.l.

Faïence S.A.

F.B.I. S.A.

Fondations Capital Management S.A.

Galileo Investments S.A.

Gamma 2 S.A.

Garage du Riesenhoff S.A.

Gestion Comptable et Fiscale S.A.

HFC S.A.

HNM S.A.

Immotep S.A.

Integral Solutions

Kabuki S.A.

Kaelum Consult S.A.

Kateco S.A.

LAIF Luxembourg Holding S.à r.l.

Lala Private Equity S.A.

LaSalle German Income and Growth Luxembourg S.à r.l.

Lys Finance S.A.

Madidi S.A.

Malderen S.A.

Mercator Finance Luxembourg AG

Miras S.A.

Niwron S.A.

Noir I S.à r.l.

Ojaco S.à r.l.

Opportunity Fund III Hochheim Property S.à r.l.

Opportunity Three

Otto Finance Luxembourg A.G.

Paninvest Holding S.A.

Pearson Luxembourg Holdings

Polarsun Holding S.A.

Resitalia Equity S.à r.l.

R.N.O. Group S.C.A.

Silverimmo S.A.

Siren S.A.

Société Financière EDITH

Stodiek Ariane III S.A.

Stodiek Ariane II S.A.

Stodiek Ariane I S.A.

Topvel Investments S.A.

Trimline Holding S.A.

Troimats S.A.

Vandus

Verdandi Holding S.à r.l.

Zhermack International S.à r.l.