This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1092
2 juin 2009
SOMMAIRE
Barendina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52375
Baus-Agri S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52381
Buurschter Jangeli S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52410
Cetus Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52377
Conical SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52386
DHL Express (Luxembourg) S.A. . . . . . . . .
52373
D.M. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52374
EECF Moravia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52380
EECF Moravia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52376
EPI Orange Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52410
EPI Orange Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52373
Etablissements Locanord S.A. . . . . . . . . . . .
52371
Financière d'Ancône . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52373
Finarch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52371
FLOBONA Co Limited . . . . . . . . . . . . . . . . .
52370
FLOBONA Co Limited . . . . . . . . . . . . . . . . .
52370
Forum Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52405
Gate Gourmet Holding I S.à r.l. . . . . . . . . .
52383
Gestair International Council S.à r.l. . . . . .
52378
Grus Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52375
Homilux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52372
Initiatives Céramiques S.à r.l. . . . . . . . . . . .
52376
Langerheights S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52378
Meteor Investment Fund S.A., SICAV-SIF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52379
Moto Pazzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52395
Net Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52371
New Quasar S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52370
Novalux G.m.b.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52379
OI-Clothing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52373
Panfret S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52371
Paul MN Holdings, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52398
Pendragon Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
52380
Petrusse Capital Markets S.A. . . . . . . . . . . .
52413
PGM LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52400
PPG Luxembourg Finance S.àr.l. . . . . . . . .
52375
Protect S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52372
Rainforest Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52379
Real Properties (Luxembourg) Two S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52415
Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. . . . . . . . .
52388
Sanderlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52377
Shon Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52377
Shon Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52378
Sludge Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
52380
Sonafi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52374
SPGF Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52374
Sublime Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52376
Sublime Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52376
Taillerie Luxembourgeoise de Pierres Pré-
cieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52370
TBU-1 International S.A . . . . . . . . . . . . . . . .
52406
TH Construction S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52416
The Turquoise II Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52375
Tomkins Investments Company S.à r.l. . .
52396
Tomkins Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
52403
Tous Travaux Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52371
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à.r.l. . . . .
52392
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. &
Partners, S.C.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52390
UBAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52372
Vameca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52374
Vega Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52379
Vega Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52378
Vega Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52377
Vireos Investment Funds S.A., SICAV-SIF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52380
VisuConcept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52372
Wellness Center Luxembourg S.à r.l. . . . .
52370
52369
FLOBONA Co Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 99.886.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009062214/10.
(090072792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
FLOBONA Co Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 99.886.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009062216/10.
(090072787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
New Quasar S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 91.832.
Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 19 mai 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009062234/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03352. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090072648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
Taillerie Luxembourgeoise de Pierres Précieuses, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 52, Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 11.533.
Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 19 mai 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009062237/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03355. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090072651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
Wellness Center Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 52, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 89.234.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009062159/10.
(090072231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
52370
Net Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3830 Schifflange, 41, rue des Fleurs.
R.C.S. Luxembourg B 84.246.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009062150/10.
(090072207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
Tous Travaux Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.
R.C.S. Luxembourg B 118.807.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009062155/10.
(090072219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
Etablissements Locanord S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9510 Wiltz, 3, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 129.798.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ARBO SA
Wiltz
Signature
Référence de publication: 2009062180/12.
(090072694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
Finarch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.384.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009062158/10.
(090072226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
Panfret S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 2-4, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 118.368.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2007.
PANFRET S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2009062167/12.
(090072854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
52371
Protect S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 16, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 100.776.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009062157/10.
(090072225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
VisuConcept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 7-9, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 134.236.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009062156/10.
(090072222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
UBAM, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.412.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2009.
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire
p.o. Le Conseil d'Administration
i>Signatures
Référence de publication: 2009062139/1670/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2009, réf. LSO-DD07169. - Reçu 238,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090072464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2009.
Homilux Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 21.362.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/03/2009 à Luxembourgi>
Suite au décès de Monsieur Guy GLESENER, l'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'adminis-
trateur:
Monsieur Laurent Jacquemart, expert comptable, né à Daverdisse le 19/06/1968, avec adresse professionnelle 3A,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2013.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009061570/3842/18.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08327. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090071993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
52372
Financière d'Ancône, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 33.608.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/03/2009 à Luxembourgi>
Suite au décès de Monsieur Guy GLESENER, l'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'adminis-
trateur:
Monsieur Laurent Jacquemart, expert comptable, né à Daverdisse le 19/06/1968, avec adresse professionnelle 3A,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2013.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009061568/3842/18.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08350. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090071990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
OI-Clothing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.717.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55192 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009061565/211/12.
(090071647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
EPI Orange Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 103.548.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55140bis ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009061567/211/12.
(090071782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
DHL Express (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 11A, rue Edmond Reuter - Z.I. Weiergewan.
R.C.S. Luxembourg B 5.679.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2009.
Blanche MOUTRIER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009061558/272/12.
(090071613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
52373
Vameca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 16.602.
Le bilan de la société au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009061631/12.
(090071601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
SPGF Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 75.350.
Le bilan de la société au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009061632/12.
(090071602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Sonafi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 29.901.
Le bilan de la société au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009061633/12.
(090071603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
D.M. Investments S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 37.550.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27/03/2009 à Luxembourgi>
Suite au décès de Monsieur Guy GLESENER en date du 26/03/2009, l'Assemblée décide de nommer au poste d'ad-
ministrateur:
Monsieur Laurent Jacquemart, expert comptable, né à Daverdisse le 19/06/1968, avec adresse professionnelle 3A,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2013.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009061572/3842/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD07820. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090071995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
52374
Barendina S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 129.382.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2009.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signatures
Référence de publication: 2009061641/12.
(090071442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
PPG Luxembourg Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 97.149.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2009.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un Géranti>
Référence de publication: 2009061644/13.
(090071458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
The Turquoise II Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 135.452.
EXTRACT
Les Administrateurs ont décidé à l'unanimité par résolution circulaire datée du 17 mars 2009 de changer le siège social
de la société du 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg à compter
du 30 avril 2009.
<i>For THE TURQUOISE II FUND
i>HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009061650/14.
(090071879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Grus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.240.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2009.
Grus Investments S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Manageri>
Référence de publication: 2009061724/15.
(090071319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
52375
Initiatives Céramiques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 102.268.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2009.
Signatures
<i>LE GERANTi>
Référence de publication: 2009061722/12.
(090071314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
EECF Moravia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.403.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2009.
<i>Pour EECF Moravia S.A.
i>Matthijs Bogers
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009061713/13.
(090071553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Sublime Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 98.195.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2009.
Sublime Investments S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manageri>
Référence de publication: 2009061725/14.
(090071323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Sublime Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 98.195.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2009.
Sublime Investments S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Manageri>
Référence de publication: 2009061726/15.
(090071330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
52376
Vega Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 95.340.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2009.
Vega Investments S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Manageri>
Référence de publication: 2009061731/15.
(090071346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Cetus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 103.377.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2009.
Cetus Investments S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manageri>
Référence de publication: 2009061729/14.
(090071341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Sanderlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R.C.S. Luxembourg B 61.718.
Les comptes au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
SANDERLUX S.A.
Jean-Marc HEITZ / Angelo DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009061708/13.
(090071515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Shon Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 132.467.
Le bilan et l'annexe au 31décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SHON INVEST
i>Signatures
Référence de publication: 2009061701/12.
(090071482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
52377
Shon Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 132.467.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SHON INVEST
i>Signatures
Référence de publication: 2009061702/12.
(090071488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Langerheights S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 118.194.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LANGERHEIGHTS S.A.
i>C. BLONDEAU / N-E NIJAR
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009061700/13.
(090071480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Vega Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 95.340.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2009.
Vega Investments S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manageri>
Référence de publication: 2009061728/14.
(090071339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Gestair International Council S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1257 Luxembourg, 2, rue Nicolas Braunshausen.
R.C.S. Luxembourg B 100.562.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2009.
<i>Pour Gestair International Council S. à R.L.
i>Monsieur Guillaume de Cugnac Dampierre
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2009061697/15.
(090071474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
52378
Novalux G.m.b.h., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 51, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 128.388.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2009i>
L'associé unique décide de transférer le siège social actuellement situé 14, rue Pasteur à L-4276 ESCH SUR ALZETTE.
A compter du 1
er
mai 2009, le siège social sera situé au 51, rue du Brill à L-4042 ESCH SUR ALZETTE.
Monsieur WIRTZ Heinz Peter.
Référence de publication: 2009061691/12.
(090071171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Rainforest Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.
R.C.S. Luxembourg B 140.627.
FIDUCIAIRE EUROLUX, société anonyme, a dénoncé le siège social au 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, de
la société RAINFOREST CAPITAL S.A. avec effet au 31 mars 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE EUROLUX, S.A.
Signature
Référence de publication: 2009061689/607/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2009, réf. LSO-DD06093. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090071322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Vega Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 95.340.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2009.
Vega Investments S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manageri>
Référence de publication: 2009061727/14.
(090071336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Meteor Investment Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.352.
Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2009.
<i>Pour Meteor Investment Fund S.A. SICAV-SIF
i>Pictet Funds (Europe) S.A.
Christian Jeanrond / Christopher Misson
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2009061758/15.
(090071204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
52379
Sludge Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 64.121.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2009.
<i>Pour le conseil d'administration
i>Signature
Référence de publication: 2009061746/12.
(090071312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
EECF Moravia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.403.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2009.
<i>Pour EECF Moravia S.A.
i>Matthijs Bogers
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009061712/13.
(090071552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Pendragon Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.562.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2009.
<i>Pour PENDRAGON HOLDING S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2009061743/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07686. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090071294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Vireos Investment Funds S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.353.
Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2009.
<i>Pour Vireos Investment Fund S.A. SICAV-SIF
i>Pictet Funds (Europe) S.A.
Christian Jeanrond / Christopher Misson
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2009061760/15.
(090071207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
52380
Baus-Agri S.C., Société Civile.
Siège social: L-8291 Meispelt, 4, rue de Keispelt.
R.C.S. Luxembourg E 4.083.
STATUTEN
Zwischen den Unterzeichnenden:
1. Herr Guy Baus, Landwirt, geb. am 18. April 1961 in Luxemburg, verheiratet, wohnhaft in 4, rue de Keispelt, L-8291
Meispelt,
2. Frau Patricia Küntsch, Landwirtin, geb. am 10. März 1966 in Wiltz, verheiratet,
wohnhaft in 4, rue de Keispelt, L-8291 Meispelt,
wird eine zivilrechtliche Gesellschaft gegründet.
I. Gründung und Gesellschaftszweck
Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung beschließen die vorbenannten Personen ein Lohnunternehmen im landwirt-
schaftlichen Bereich zu gründen. Das Ziel ist die Ausführung von Maschinenarbeiten im Lohn. Zu diesem Zweck bilden
sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in
den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen
oder die Durchführung derselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres
Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes
förderlich und nützlich erscheinen.
II. Benennung und Gesellschaftsitz
Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen „Baus-Agri s.c.", zivilrechtliche Gesellschaft.
Ihr Sitz befindet sich in L-8291 Meispelt, 4, rue de Keispelt und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter
an einen anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.
III. Gesellschaftsdauer
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf unbegrenzte Zeit vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige
Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.
IV. Gesellschaftskapital
Art. 4. Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von 1.000,00 EUR (i.W. eintausend Euro) umfasst folgende
Einlagen:
A) Von Seiten des Herrn Guy Baus, vorbenannt
a. Bareinlage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990,00 EUR
B) Von Seiten der Frau Patricia Küntsch, vorbenannt:
a. Bareinlage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,00 EUR
Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge 1.000,00 EUR, das in 100 Anteile von je zehn Euro (10,00
€) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:
1) An Herrn Guy Baus, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neunundneunzig Anteile (99)
2) An Frau Patricia Küntsch, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ein Anteil (1)
Zusammen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
einhundert Anteile (100)
V. Übereignung von Anteilen
Art. 6. Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter
Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt
werden.
Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder
Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.
Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief
mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers,
sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutre-
tenden Anteile. Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief
mitteilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufrecht ganz oder teilweise
Gebrauch macht.
52381
Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile,
welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.
Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht
oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder durch
Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung
eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst
eine Weise geschieht.
VI. Tod eines Gesellschafters
Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich.
VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr
beginnt mit der Gründung und endigt am einunddreißigsten Dezember 2009.
Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche
Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.
Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom Einkommen der Gesellschaft zur Bildung von Reservefonds
vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals er-
reicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Gesellschaftern wird eine
Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.
Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit
unter den Gesellschaftern aufgeteilt. Die Modalitäten dieser Gewinnaufteilung werden in einer internen Geschäftsordnung
festgehalten und in ein Spezialregister eingetragen. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemein-
samen Beschluss festgelegt werden, zuerkannt.
Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen
zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.
Art. 13. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,
deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden
Artikel.
VIII. Haftung der Gesellschafter
Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-,
Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.
Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft Im Ve-
rhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863
des Zivilgesetzbuches.
IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in der Gesellschaft mitzuarbeiten.
X. Verwaltung und Beschlüsse
Art. 17. Die Gesellschaftsführung besteht aus 1 Verwalter, der von der Generalversammlung ernannt wird. Zum
Verwalter der Gesellschaft wird ernannt:
1. Herr Guy Baus, vorbenannt.
Der Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechts-
kräftig zu verpflichten. Dem Verwalter steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den
Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.
Art. 18. Der Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein.
Dazugehörende Dokumente werden beigebogen. Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bin-
dend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle
Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.
XI. Generalversammlung
Art. 19. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung
werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.
Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er
es für nötig hält.
52382
Art. 20. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.
Art. 21. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen
Familienangehörigen vertreten lassen.
Art. 22. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen
Gesellschaftern unterzeichnet und in ein Spezialregister eingetragen.
XII. Auflösung - Liquidation
Art. 23. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von
Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.
Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief
seine Partner zwei Jahre im Voraus davon in Kenntnis setzen.
Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,
falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.
Art. 24. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen
Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.
XIII. Schlussbestimmungen
Art. 25. Für alle Fälle, die In der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivil-
gesetzbuches anwendbar.
Art. 26. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-
tigkeit dieses Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass er mit der ungültigen
Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des
Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.
Art. 27. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaften entstehen, in betreff der
Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder Geschäfte, werden obligatorisch einem Schiedsrichter
zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von Unstim-
migkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.
Art. 28. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Doppelt ausgefertigt in Meispelt am 5. Mai 2009.
Unterschriften.
Référence de publication: 2009061517/134.
(090071859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Gate Gourmet Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 86.445.
In the year two thousand and nine, on the twenty-second of April,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
appeared:
Gate Gourmet Group Holding LLC, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the State
of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., with company
registration number 3499693,
here represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 22 April 2009,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole member of Gate Gourmet Holding I S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having
its registered office at 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Compa-
nies' Register section B number 86.445, incorporated under the name of "Griffin Endeavour I S.à r.l." pursuant to a notarial
deed dated 8 March 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 14 June 2002, number
908.
The articles have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 23 July 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 2 September 2003, number 899 (hereafter the "Company").
The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of
the meeting is as follows:
52383
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of two hundred thirty-five thousand nine
hundred euro (EUR 235,900), represented by two thousand three hundred fifty-nine (2,359) shares, having a par value
of one hundred euro (EUR 100) each, up to three million seven hundred thirty-three thousand five hundred Euro (EUR
3,733,500), through the issue of thirty-four thousand nine hundred seventy-six (34,976) new shares, having a par value
of one hundred euro (EUR 100) each, by a contribution in kind;
2. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of incorporation of the Company;
3. Deletion of Article 11 of the articles of incorporation of the Company;
4. Subsequent renumbering of the articles following Article 10 of the articles of incorporation of the Company.
The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, takes the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The sole member resolves to increase the share capital by an amount of three million four hundred ninety-seven
thousand six hundred Euro (EUR 3,497,600) so as to raise it from its current amount of two hundred thirty-five thousand
nine hundred euro (EUR 235,900), represented by two thousand three hundred fifty-nine (2,359) shares, having a nominal
value of one hundred euro (EUR 100) each, up to three million seven hundred thirty-three thousand five hundred euro
(EUR 3,733,500), through the issue of thirty-four thousand nine hundred seventy-six (34,976) new shares, having a nominal
value of one hundred euro (EUR 100) each.
The thirty-four thousand nine hundred seventy-six (34,976) new shares are entirely subscribed by the sole member,
aforementioned, at a total price of seventeen million four hundred eighty-seven thousand eight hundred forty-three euro
and thirty-two cents (EUR 17,487,843.32) out of which:
- three million four hundred ninety-seven thousand six hundred Euro (EUR 3,497,600) are allocated to the share capital;
- thirteen million six hundred forty thousand four hundred eighty-three Euro and thirty-two cents (EUR 13,640,483.32)
are allocated to the share premium; and,
- three hundred forty-nine thousand seven hundred sixty Euro (EUR 349,760) are allocated to the legal reserve.
Said thirty-four thousand nine hundred seventy-six (34,976) new shares are fully paid up by the sole member, afore-
mentioned, through a contribution in kind of a loan receivable of a total amount of twenty-two million nine hundred
thirty-one thousand eight hundred and eight US dollars and ninety-four cent (USD 22,931,808.94), equivalent to seventeen
million four hundred eighty-seven thousand eight hundred forty-three euro and thirty-two cent (EUR 17,487,843.32),
including interest accrued.
The proof of the existence and of the total value of the contribution of seventeen million four hundred eighty-seven
thousand eight hundred forty-three euro and thirty-two cent (EUR 17,487,843.32) has been given to the undersigned
notary, by a statement of contribution value made by the Company which will remain attached to the present deed.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and
shall now read as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at three million seven hundred thirty-three thousand five hundred euro
(EUR 3,733,500), represented by thirty-seven thousand three hundred thirty-five (37,335) shares with a nominal value of
one hundred euro (EUR 100) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."
<i>Third resolutioni>
The sole member resolves to delete article 11 of the articles of incorporation of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the articles following article 10 of the articles of incorporation of the
Company are renumbered.
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at
the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the proxyholder
of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; and upon request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder appearing signed
together with the notary the present deed.
52384
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le vingt-deuxième jour du mois d'avril,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire, de résidence à Luxembourg,
a comparu:
Gate Gourmet Group Holding LLC, une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois de l'Etat
du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19807, Etats-Unis d'Amérique, inscrite
sous le numéro 3499693;
ici représentée par Madame Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 avril 2009.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est la seule associée de Gate Gourmet Holding I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg section B numéro 86.445, constituée sous le nom de "Griffin Endeavour I S.à r.l." suivant acte notarié en date
du 8 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 14 juin 2002, numéro 908.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 23 juillet 2003, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations le 2 septembre 2003, numéro 899 (ci après la "Société").
La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre
du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de deux cent trente-cinq mille neuf cent euros
(EUR 235.900), représenté par deux mille trois cent cinquante-neuf (2.359) parts sociales ayant une valeur nominale de
cent euros (EUR 100) chacune, à trois millions sept cent trente-trois mille cinq cent Euros (EUR 3.733.500), par l'émission
de trente-quatre mille neuf cent soixante-seize (34.976) parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune, par un apport en nature;
2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société;
3. Suppression de l'article 11 des statuts de la Société;
4. Renumérotation subséquente des articles suivants l'article 10 des statuts de la Société.
La comparante, représentée comme indiquée ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social par un montant de trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-
sept mille six cents euros (EUR 3.497.600) pour le porter de son montant actuel de deux cent trente-cinq mille neuf
cents euros (EUR 235.900), représenté par deux mille trois cent cinquante-neuf (2.359) parts sociales ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à trois millions sept cent trente-trois mille cinq cents euros (EUR 3.733.500),
par l'émission de trente-quatre mille neuf cent soixante-seize (34.976) parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune.
Les trente-quatre mille neuf cent soixante-seize (34.976) nouvelles parts sociales sont entièrement souscrites par
l'associé unique, susmentionné, pour un montant global de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille huit cent
quarante-trois euros et trente-deux cents (EUR 17.487.843,32) dont
- trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents euros (EUR 3.497.600) sont alloués au capital social;
- treize millions six cent quarante mille quatre cent quatre-vingt-trois euros trente-deux cents (EUR 13.640.483,32)
sont alloués à la prime d'émission; et,
- trois cent quarante-neuf mille sept cent soixante euros (EUR 349.760) sont alloués à la réserve légale.
Lesdites nouvelles parts sociales sont entièrement libérées par l'associée unique, prénommée, par un apport en nature
d'une créance d'un montant global de vingt-deux millions neuf cent trente et un mille huit cent huit dollars US et quatre-
vingt-quatorze cents (USD 22.931.808,94), équivalent à dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille huit cent
quarante-trois euros et trente-deux cents (EUR 17.487.843,32), y compris les intérêts échus.
La preuve de l'existence et de la valeur totale de l'apport de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille huit
cent quarante-trois euros et trente-deux cents (EUR 17.487.843,32), a été apportée au notaire soussigné, par un statement
of contribution value de la Société et qui restera annexé au présent acte.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
52385
" Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions sept cent trente-trois mille cinq cents euros (EUR 3.733.500), repré-
senté par trente-sept mille trois cent trente-cinq (37.335) parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires."
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de supprimer l'article 11 des statuts de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite de la résolution qui précède, les articles suivant l'article 10 des statuts de la Société sont renumérotés.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ce dernier a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: A. BADOT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 avril 2009. LAC/2009/ 16307. Reçu soixante quinze euros €75,-
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 14 mai 2009.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2009061263/7241/152.
(090071751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Conical SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.581.
L'an deux mille neuf, le vingt-sept mars.
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONICAL SPF S.A. (la "Société"), une
société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, constituée sous la
dénomination CONICAL HOLDING S.A. suivant acte notarié en date du 15 décembre 2003, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 254 du 3 mars 2004, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.581.
Les statuts de la Société ont été modifiés une fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1
er
octobre
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2622 du 27 octobre 2008.
L'assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Isabelle SCHUL, employée privée, demeurant
professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita MAGGIPINTO, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank STOLZ-PAGE, employé privé, demeurant professionnellement
à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Limitation de la durée de vie de la société au 31/03/2019 et modification afférente de l'article 1 des statuts pour lui
donner la teneur suivante: "La durée de la société est fixée jusqu'au 31/03/2019."
2. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 9.966.000 (neuf millions neuf cent soixante six
mille) pour le porter de son montant actuel de EUR 34.000 (trente quatre mille) à EUR 10.000.000 (dix millions) par
l'émission de 9.966 (neuf mille neuf cent soixante six) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille)
chacune.
52386
3. Souscription et libération des 9.966 (neuf mille neuf cent soixante six) actions nouvelles par l'actionnaire unique de
la société par incorporation d'une créance certaine, liquide et exigible.
4. Modification afférente de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: "Le capital social est fixé à EUR
10.000.000 (dix millions) représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,-(mille) chacune.";
et adaptation du capital autorisé de la manière suivante: "Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital
social initial à concurrence de soixante dix-neuf millions neuf cent soixante-six mille euros (EUR 79.966.000) pour le
porter de son montant actuel de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) à quatre-vingt neuf millions neuf cent soixante-
six mille euros (89.966.000), le cas échéant par l'émission de soixante dix-neuf mille neuf cent soixante-six (79.966) actions
de mille euros (EUR 1.000,00) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes."
5. Modification de l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante: "L'année sociale commencera le 1
er
janvier
et finit le trente et un décembre de chaque année." De manière transitoire l'exercice social commence le 1
er
avril 2009
et se terminera le 31 décembre 2009.
6. Modification de la date de tenue de l'assemblée générale statutaire pour la fixer au 2
ème
mardi du mois de février
à 11.00 heures et modification subséquente de l'article 11 des statuts.
7. Divers
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions
qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de limiter la durée de vie de la Société au 31 mars 2019 et de modifier en conséquence
le dernier alinéa de l'article 1 des statuts de la Société comme suit:
"La durée de la Société est fixée jusqu'au 31 mars 2019."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de neuf millions
neuf cent soixante-six mille euros (EUR 9.966.000) pour le porter de son montant actuel de trente-quatre mille euros
(EUR 34.000) à dix millions d'euros (EUR 10.000.000) par l'émission de neuf mille neuf cent soixante-six (9.966) actions
nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.
<i>Souscription et Libérationi>
L'actionnaire unique IMT Trust Services Establishment et SGG ANSTALT agissant conjointement en tant que trustees
du trust 16.81 dénommé NIF, avec siège social au 56, Austrasse, 9490 Vaduz, Liechtenstein, enregistré auprès du registre
de commerce de la Principauté du Liechtenstein sous le numéro H.1112/99.
ici représentée par Madame Isabelle Schul, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 23 mars 2009,
déclare souscrire les neuf mille neuf cent soixante-six (9.966) actions nouvelles et les libérer intégralement pour un
montant total de neuf millions neuf cent soixante-six mille euros (EUR 9.966.000) en contrepartie d'un apport en nature
constitué par la conversion d'une partie de la créance que IMT Trust Services Establishment et SGG ANSTALT agissant
conjointement en tant que trustees du trust 16.81 dénommé NIF, prénommée, a sur la Société.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, l'apport en nature ci-dessus
décrit a fait l'objet d'un rapport établi en date du 25 mars 2009 par TEAMAUDIT S.A., réviseur d'entreprises, établie à
L-2730 Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
La valeur de ladite créance est constatée par ledit rapport, dont il ressort par ailleurs qu'elle est certaine, liquide et
exigible, et qui conclu comme suit:
"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale de
l'apport ne correspond pas au moins au nombre des actions nouvelles à émettre en contrepartie."
52387
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les 1
er
et 3
ème
alinéas de
l'article 3 des statuts de la Société comme suit:
"Le capital social est fixé à dix millions d'euros (EUR 10.000.000) représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur
nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de soixante dix-neuf millions
neuf cent soixante-six mille euros (EUR 79.966.000) pour le porter de son montant actuel de dix millions d'euros (EUR
10.000.000) à quatre-vingt neuf millions neuf cent soixante-six mille euros (89.966.000), le cas échéant par l'émission de
soixante dix-neuf mille neuf cent soixante-six (79.966) actions de mille euros (EUR 1.000) chacune, jouissant des mêmes
droits que les actions existantes."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la fin de l'année sociale de la Société du trente et un mars au trente et un
décembre.
En conséquence, l'article 13 des statuts de la Société est modifié pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 13. L'année sociale commencera le 1
er
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année."
Exceptionnellement, le prochain exercice social sera écourté et commencera le 1
er
avril 2009 pour terminer le 31
décembre 2009.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au deuxième
mardi du mois de février à 11.00 heures.
En conséquence, l'article 11 des statuts de la Société est modifié pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de février à 11.00 heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: I. SCHUL, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mars 2009. LAC / 2009 / 12251. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 23 avril 2009.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2009061274/7241/119.
(090071666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 127.492.
Im Jahre zweitausendundneun, am fünfzehnten April,
vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung ihrer Kollegin
Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, zur Zeit abwesend, welch Letztere Depositar der gegenwärtigen Urkunde
bleibt,
sind die Aktionäre der Kommanditgesellschaft auf Aktien Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. (die "Gesellschaft"), mit Sitz
in L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet, eingetragen im luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer
B 127.492, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Benannte Gesellschaft wurde gemäß einer am 30. März 2007 durch den Notar Joëlle Baden aufgenommene Urkunde
unter der Firma Rosert S.A. gegründet, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 991 vom
29. Mai 2007 veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal durch eine am 18. Dezember 2008 durch den Notar Joëlle Baden
aufgenommene Urkunde abgeändert, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 524 vom 11.
März 2009 veröffentlicht wurde.
52388
Die Generalversammlung wurde um 15.30 Uhr unter dem Vorsitz von Friedrich Carl Janssen, Mitglied des Aktionärs-
Pools der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., geboren am 5. Mai 1944 in Hirschberg/Schlesien, Deutschland,
geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eröffnet,
welcher Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, geschäftsansässig in 17, rue des Bains, L-1212 Luxemburg zum
Schriftführer berufen hat.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Max Kremer, Anwalt, geschäftsansässig in 14 rue Erasme,
L-2082 Luxembourg.
Sodann die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist, ersucht der Vorsitzende den unterzeich-
nenden Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:
I. Dass die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Änderung von § 8 der Satzung der Gesellschaft.
2. Änderung von § 13, Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft.
3. Änderung von § 18, Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft.
4. Änderung von § 33, Absatz 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft.
5. Verschiedenes.
II. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste ein-
getragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigeführt und ordnungsgemäß von den anwesenden
Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.
III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Generalversammlung anwesend oder vertreten ist, dass alle
anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis vom Termin der Generalversammlung und von der Tage-
sordnung gehabt zu haben und dass somit keine Einladungen erforderlich waren.
IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß zusammen getreten und sodann zu vorstehender
Tagesordnung beschlussfähig ist.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den § 8 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
"Die Aufnahme eines neuen persönlich haftenden Gesellschafters kann nur durch Beschluss der Generalversammlung
der Aktionäre mit der zur Satzungsänderung bestimmten Mehrheit und unter Zustimmung von zwei Drittel (2/3) der
persönlich haftenden Gesellschafter erfolgen."
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den § 13, Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
"(2) Die Wahl der Mitglieder des Aktionärsausschusses erfolgt auf Vorschlag aller persönlich haftenden Gesellschafter
durch die Generalversammlung der Aktionäre. Mitglieder des Aktionärsausschusses können auch ohne Vorschlag der
persönlich haftenden Gesellschafter gewählt werden, wenn die Wahl mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel
(2/3) der anwesenden bzw. vertretenen Aktionärsstimmen stattfindet. Als Mitglieder können nur Kommanditaktionäre,
Gesellschafter von Kommanditaktionären oder frühere oder zukünftige Kommanditaktionäre oder Gesellschafter von
Kommanditaktionären gewählt werden."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den § 18, Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
"(4) Für Beschlüsse, deren Gegenstand die Kündigung gegenüber einem persönlich haftenden Gesellschafter ist, ist eine
Mehrheit von zwei Drittel (2/3) der abgegebenen Stimmen erforderlich. Ein solcher Beschluss kann nur in einer Sitzung
gefasst werden, zu der schriftlich mit einer Frist von mindestens drei (3) Wochen eingeladen worden ist, wobei in der
Einladung darauf hingewiesen werden muss, dass über die Kündigung gegenüber einem persönlich haftenden Gesellschaf-
ter Beschluss gefasst werden soll. Der Aktionärsausschuss ist in diesem Fall nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei
Drittel (2/3) der Mitglieder anwesend oder vertreten sind."
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den § 33, Absatz 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
"(1) Beschlüsse der Generalversammlung der Aktionäre über Satzungsänderungen bedürfen der Vertretung von min-
destens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und werden mit einer Zweidrittel- (2/3) Mehrheit der abgegebenen Stimmen
und des bei der Beschlussfassung vertretenen Gesellschaftskapitals gefasst, soweit nicht gesetzlich eine höhere Mehrheit
zwingend erforderlich ist.
(2) Jede von der Generalversammlung der Aktionäre beschlossene Abänderung der Satzung bedarf zu ihrer Gültigkeit
außerdem der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Drittel (2/3) der persönlich haftenden Gesellschafter."
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo, am Datum wie eingangs erwähnt.
52389
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. C. JANSSEN, F. STOLZ-PAGE, M. KREMER und M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A. C., le 22 avril 2009. LAC/2008/ 15528. Reçu soixante-quinze euros €75,-
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 12. Mai 2009.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2009061261/7241/81.
(090071730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. & Partners, S.C.S, Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 972.243,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.954.
In the year two thousand and nine, on the second of April.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
- TST Netherlands V GP, LLC, a limited liability company organized under the laws of Delaware with its registered
office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of
Delaware 19904, United States of America, with its principal place of business at 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY
10111, United States of America, registered under number 3412615.
- TST International Fund V CV-II, GP, LLC, a limited liability company organized under the laws of Delaware, with its
registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent,
State of Delaware 19904, United States of America, with its principal place of business at 45 Rockerfeller Plaza, New
York, NY 10111, United States of America, registered under number 3447230.
- TST International Fund V CV-A, GP, LLC, a limited liability company organized under the laws of Delaware having
its registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent,
State of Delaware 19904, United States of America, with its principal place of business at 45 Rockerfeller Plaza, New
York, NY 10111, United States of America, registered under number 3801167.
- TSCAI International Extension Real Estate Venture V, LP, a limited partnership organized under the laws of Delaware,
with registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent,
State of Delaware 19904, United States of America, with its principal place of business at 45 Rockerfeller Plaza, New
York, NY 10111, United States of America, registered under number 3816514.
- TS Koenigsallee Holdings II S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Trade and Company
Register of Luxembourg, section B under number 110.400.
- Tishman Speyer European Real Estate Venture VI Holdings S.à r.l., a private limited liability company, incorporated
and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered
with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number 110.407.
- Stichting TST Netherlands-Europe Investments V, a company having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083
HK, Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34164080.
- Stichting TST Dutch IA Foundation, a company having its registered office Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,
the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34207066.
- Stichting TST Dutch Foundation II, a company having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,
the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34176985.
- TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Trade and Com-
pany Register of Luxembourg, section B, under number 110.295,
all represented by Ms. Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue
of ten (10) proxies established on May 30
th
, 2008.
The said proxies, signed "ne varietur" by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the limited partnership (société en commandite simple) existing
in Luxembourg under the name of TS Koenigsallee Holdings (GP), S.à r.l. & Partners S.C.S. (the "Partnership"), having its
52390
registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and registered with the Luxembourg Trade and Company Re-
gister, section B, under number 110.954, incorporated by a deed of the undersigned notary of September 7
th
, 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 201 dated January 28
th
, 2006, whose bylaws
have been lastly by a deed of the undersigned notary of May 15
th
, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2069 dated November 6
th
, 2007.
II. The shareholders resolve to transfer the registered office of the Partnership from 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg to 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
III. Pursuant to the above transfer of registered office, the first paragraph of article 5 of the Partnership's articles is
amended and shall henceforth read as follows:
" Art. 5. (1
st
paragraph). The registered office of the Partnership is established in Luxembourg. Branches or other
offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the Manager."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six hundred Euro (€ 600.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary who
understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is
worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille neuf, le deux avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
- TST Netherlands V GP, LLC, une limited liability company régie par les lois de l'état du Delaware, ayant son siège
social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of
Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, mais ayant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111,
Etats-Unis d'Amérique, enregistrée sous le numéro 3412615,
- TST International Fund V CV-II, GP, LLC, une limited liability company régie par les lois de l'état du Delaware ayant
son siège social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent,
State of Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, mais ayant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York,
NY 10111, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée sous le numéro 3447230,
- TST International Fund V CV-A, GP, LLC, une limited liability company régie par les lois de l'état du Delaware ayant
son siège social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent,
State of Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, mais ayant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York,
NY 10111, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée sous le numéro 3801167,
- TSCAI International Extension Real Estate Venture V, LP, un limited partnership organisé selon les lois du Delaware,
ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of
Kent, State of Delaware 19904, United States of America, mais exerçant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza,
New York, NY 10111, Etats-Unis d'Amérique, enregistré sous le numéro 3816514,
- TS Koenigsallee Holdings II S.à r.L, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social
à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.400,
- Tishman Speyer European Real Estate Venture VI Holdings S.à r.L, une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.407,
- Stichting TST Netherlands-Europe Investments V, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,
Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34164080.
- Stichting TST Dutch IA Foundation, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam, Pays-Bas,
enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34207066,
- Stichting TST Dutch Foundation II, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam, Pays-Bas,
enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34176985,
52391
- TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.L, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.295.
ici représentés par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxem-
bourg, en vertu de dix (10) procurations données le 30 mai 2008. Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne
varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être
enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société en commandite simple établie à Luxembourg sous la dénomination
de "TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.L & Partners S.C.S" (la "Société"), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro
110.954, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 7 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 201 en date du 28 janvier 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 15 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2069 en date du 6 novembre 2006.
II. Les associés décident de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
III. Suite au transfert du siège social ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié
pour avoir désormais la teneur suivante:
" Art. 5. (1
er
paragraphe). Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. La Société peut ouvrir des agences
ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché ou dans tous autres pays, en vertu d'une décision du Gérant."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents Euros (€ 600,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 8 avril 2009. Relation: LAC/2009/13795. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 20 avril 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009061294/211/142.
(090071429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 22.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.295.
In the year two thousand and nine, on the second of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appear:
- Tishman Speyer European Real Estate Venture VI Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 34-38 avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Company
Register, section B, under number 110.407,
- TSCAI International Extension Real Estate Venture V, L.P., a limited partnership organized in Delaware, USA with
registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent,
52392
State of Delaware 19904, United States of America, and with principal place of business at 45 Rockefeller Plaza, New
York, NY 10111, United States of America, registered under number 3816514,
- TST International Fund V CV-A, GP, L.L.C., a limited liability company having its registered office at National Regis-
tered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, United
States of America, and with principal place of business at 45 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111, United States of
America, registered under number 3801167,
- Stichting TST Dutch IA Foundation, a company having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amster-
dam, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 342 07 066,
- TST International Fund V CV-II, GP, L.L.C., a limited liability company having its registered office at National Registered
Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, United States of
America, and with principal place of business at 45 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111, United States of America,
registered under number 3447230,
- Stichting TST Dutch Foundation II, a company having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,
The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34176985,
- TST Netherlands V GP, L.L.C., a limited liability company having its registered office at National Registered Agents,
Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, United States of America,
and with principal place of business at 45 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111, United States of America, registered
under number 3412615,
- Stichting TST Netherlands-Europe Investments V, a company having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083
HK, Amsterdam, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34164081,
all represented by Ms. Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of
eight (8) proxies established on May 30
th
, 2008. The said proxies, signed "ne varietur" by the persons appearing and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities. Such appearing
parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité
limitée) existing in Luxembourg under the name of "TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l." (the "Company") incorporated
and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B,
number 110.295, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incor-
porated by a deed of the undersigned notary enacted on August 16th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1416 dated December 20
th
, 2005, lastly amended by an extraordinary general meeting
of shareholder held on September 6
th
, 2005 and published in the Memorial C, Recueil des sociétés et associations
number 171 dated of January 25
th
, 2006.
II. The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
to 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
III. Pursuant to the above transfer of registered office, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of
association is amended and shall henceforth read as follows:
" Art. 5. (1
st
paragraph). The registered office of the Company is established in Luxembourg."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six hundred Euro (€ 600.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary who
understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded
in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarized deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille neuf, le deux avril.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
52393
- Tishman Speyer European Real Estate Venture VI Holdings S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembour-
geois ayant son siège social à 34-38 avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.407.
- TSCAI International Extension Real Estate Venture V, L.P., un limited partnership organisé selon les lois du Delaware,
USA, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County
of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, enregistré sous le numéro 3816514.
- TST International Fund V CV-A, GP, L.L.C., une limited liability company ayant son siège social au National Registered
Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis
d'Amérique, mais exerçant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d'Amérique,
enregistrée sous le numéro 3801167.
- Stichting TST Dutch IA Foundation, une société ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,
Pays-Bas, enregistré auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 342 07 066.
- TST International Fund V CV-II, GP, L.L.C., une limited liability company ayant son siège social au National Registered
Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis
d'Amérique, mais exerçant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d'Amérique,
enregistrée sous le numéro 3447230.
- Stichting TST Dutch Foundation II, une société ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,
Pays-Bas, enregistré auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 34176985.
- TST Netherlands V GP, L.L.C., une limited liability company ayant son siège social au National Registered Agents,
Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique,
mais exerçant son activité principale au 45 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée
sous le numéro 3412615.
- Stichting TST Netherlands-Europe Investments V, une société ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK,
Amsterdam, Pays-Bas, enregistré auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34164080. ici re-
présentés par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, en
vertu de huit (8) procurations données le 30 mai 2008.
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de "TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l." (la "Société"), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg section B, sous le numéro 110.295 et ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, constituée
par un acte du notaire instrumentaire reçu en date du 16 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1416 le 20 décembre 2005 modifiée par une assemblée générale extraordinaire des associés tenue
devant le notaire instrumentaire le 6 septembre 2005 et publiée au Memorial C, Recueil des sociétés et associations
numéro 171 en date du 25 janvier 2006.
II. Les associés décident de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 34-38
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
IV. Suite au transfert du siège social ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié
pour avoir désormais la teneur suivante:
" Art. 5. (1
er
paragraphe). Le siège social de la Société est établi à Luxembourg."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents Euro (€ 600,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 avril 2009. Relation: LAC/2009/13794. Reçu soixante-quinze euros (75, €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
52394
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009061295/211/128.
(090071443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Moto Pazzia, Société Anonyme.
Siège social: L-5440 Remerschen, 124, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 144.775.
Im Jahre zwei tausend neun,
den sechsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,
der Aktiengesellschaft MOTO PAZZIA, mit Sitz in L-5444 Schengen, 5, rue Baachergaass, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 144.775 (NIN 2009 2201 881),
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Karin REUTER, mit dem Amtssitze in Redange/Attert, am 3.
Februar 2009, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 542 vom 12. März 2009.
Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) und ist eingeteilt in einunddreissig
(31) Aktien mit einem Nennwert von je ein tausend Euro (€ 1.000.-).
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Thierry HELLERS, Wirtschaftsberater, beruflich ansässig in L-1273
Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
Er beruft zum Schriftführer Frau Juliette BEICHT, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-1273 Luxemburg, 19, rue de
Bitbourg,
und zum Stimmzähler Herr Gernot KOS, Wirtschaftsberater, beruflich ansässig in L-1273 Luxemburg, 19, rue de
Bitbourg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Schengen nach Remerschen und dementsprechende Abänderung des ersten
Absatzes von Artikel 2 der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten.
Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.
2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-5440 Remerschen, 124, route du Vin.
3.- Abberufung des bestehenden Kommissars mit Entlastung für die Ausübung seines Mandates.
4.- Ernennung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung G.T. Experts Comptables S.à r.l., mit Sitz in L-1273 Luxem-
bourg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
121.917, zum neuen Kommissar der Gesellschaft, ihr Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung
des Jahres 2014.
5.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der An-
wesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitglie-
dern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.
V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die einunddreissig (31) Aktien mit einem Nennwert von je ein tausend
Euro (€ 1.000.-), welche das gesamte Kapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) darstellen, bei der gegenwär-
tigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammen-
gesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.
Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie
rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende
Beschlüsse gefasst:
52395
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Schengen nach Remerschen zu verlegen und dem-
gemäss den ersten Absatze von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-5440 Remerschen, 124,
route du Vin.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den bestehenden Kommissar abzuberufen und erteilt ihm Entlastung für die Au-
sübung seines Mandates.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft mit beschränkter Haftung G.T. Experts Comptables S.à r.l., mit
Sitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter
der Nummer B 121.917, zum neuen Kommissar der Gesellschaft zu ernennen, ihr Mandat endend bei Gelegenheit der
jährlichen Generalversammlung des Jahres 2014.
<i>Fünfter Beschlussi>
Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: T. HELLERS, G. KOS, J. BEICHT, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 11 mai 2009. Relation: ECH/2009/582. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.
Echternach, den 14. Mai 2009.
Henri BECK.
Référence de publication: 2009061270/201/78.
(090071498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Tomkins Investments Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 115.563.
In the year two thousand and nine, on the second of April.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
Tomkins American Investments S.a r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-25, rue
Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company under number B 86.645, here
represented by Mr. Gael Toutain, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 26, 2009.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under
the name of "Tomkins Investments Company S.a r.l." (the "Company"), with registered office at 23-25, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 115.563, incorpo-
rated pursuant to a deed of the undersigned notary on March 9, 2006, published in the Memorial C n° 1225 of June 24,
2006 and whose articles have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of August 20, 2008
published in the Memorial C n° 2305 of September 20, 2008.
II. The sole shareholder resolved to:
52396
1) Amend article 7 of the Company's articles of association to give it the following content:
" Art. 7. The capital may be changed at any time by an extraordinary general meeting of the shareholders held in
presence of a notary, in compliance with article 14 of the Articles."
2) Change the Company's accounting year-end to the fourth of April of each year, the accounting year having started
on the twenty-first of August 2008 closing on the fourth of April 2009.
3) Restate article 15 of the Company's articles of association pursuant to the above change of accounting year-end
which is amended and shall henceforth read as follows:
" Art. 15. The Company's financial year starts on the fifth of April of each year and ends on the fourth of April of the
subsequent year."
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the presently stated change of accounting year end are estimated at seven hundred and fifty Euro (€ 750.-). There
being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le deux du mois d'avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Tomkins American Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25, rue Notre-
Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 86.645,
ici représentée par Monsieur Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736
Senningerberg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 26 mars 2009.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de "Tomkins Investments Company S.à r.l." (la "Société") ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.563,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 9 mars 2006, publié au Mémorial C n° 1225 du 24 juin
2006, et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 20 août 2008 publié
au Mémorial C n°2305 du 20 septembre 2008.
II. L'associé unique décide de:
1. Modifier l'article 7 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:
" Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision d'une assemblée générale extraordinaire des
associés tenue devant notaire, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts."
2. Changer la fin de l'exercice social de la Société au quatre avril de chaque année, l'exercice social ayant commencé
le vingt et un août 2008 clôturera le quatre avril 2009.
3. En conséquence de ce changement de la fin de l'exercice social, l'article 15 des statuts de la Société est modifié
comme suit:
" Art. 15. L'exercice social de la Société commence le cinq avril de chaque année et se termine le quatre avril de l'année
suivante".
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante Euro (€ 750.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
52397
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: G. TOUTAIN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 avril 2009. Relation: LAC/2009/13801. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations.
Luxembourg, le 21 avril 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009061265/211/91.
(090071811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Paul MN Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 144.467.
In the year two thousand and nine, on the first of April.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
there appeared
Paul Capital Partners IX, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the state of Delaware,
United States of America, having its registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, County of New Castle, 19801,
United States of America, registered with the register of the state of Delaware under registration number 061182197,
here represented by Miss Catherine Willemyns, licenciée en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in San Francisco, United States of America, on 26 March 2009.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole member of Paul MN Holdings, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under section B, number 144.467, incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 January 2009, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 425 of 26 February 2009 (hereafter the "Company").
The appearing party representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of
the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Conversion of the currency of the share capital from euro into US Dollars;
2. Increase of the share capital from its current value of ninety-seven thousand three hundred and one US Dollars
(USD 97,301) up to three hundred thousand US Dollars (USD 300,000) by the issuance of two hundred two thousand
six hundred ninety-nine (202,699) new shares, having a nominal value of one US Dollar (USD 1) against a contribution in
cash;
3. Subsequent amendment of article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company.
The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, then takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole member decides to convert the share capital of the Company from euro into US Dollars at an exchange rate
of 1.297343 US Dollars for one euro (EUR 1).
The current share capital of an amount of seventy-five thousand euro (EUR 75,000) is therefore converted into ninety-
seven thousand three hundred and one US Dollars (USD 97,301), divided into ninety-seven thousand three hundred and
one (97,301) shares having a nominal value of one US Dollar (USD 1) each.
<i>Second resolutioni>
The sole member decides to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred two thousand
six hundred ninety-nine euro (EUR 202,699) so as to raise it from its current amount of ninety-seven thousand three
52398
hundred and one US Dollars (USD 97,301), represented by ninety-seven thousand three hundred and one (97,301) shares
having a nominal value of one US Dollar (USD 1) each, up to an amount of three hundred thousand US Dollars (USD
300,000), by the issuance of two hundred two thousand six hundred ninety-nine (202,699) shares, having a nominal value
of one US Dollar (USD 1) each.
All of the two hundred two thousand six hundred ninety-nine (202,699) new shares are subscribed by the sole member
Paul Capital Partners IX, L.P., aforementioned, represented as stated above, at a total price of two hundred two thousand
six hundred ninety-nine US Dollars (USD 202,699), all of which are allocated to the share capital.
The subscribed shares are fully paid up in cash by Paul Capital Partners IX, L.P., aforementioned, so that the aggregate
amount of two hundred two thousand six hundred ninety-nine US Dollars (USD 202,699) is as of now at the free disposal
of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 5.1, of the articles of incorporation of the Company is amended
and shall henceforth read as follows:
"5.1 The Company's share capital is set at three hundred thousand US Dollars (USD 300,000) represented by three
hundred thousand (300,000) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1) each."
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder signed together
with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le premier avril.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire, de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Paul Capital Partners IX, L.P., une société constituée et existante sous les lois de l'état du Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique,
inscrite au registre de l'état du Delaware sous le numéro d'inscription 061182197,
représentée par Mademoiselle Catherine Willemyns, licenciée en droit, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à San Francisco, Etats-Unis d'Amérique, le 26 mars 2009.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est la seule associée de Paul MN Holdings, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
section B numéro 144.467, constituée suivant acte notarié en date du 23 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 425 du 26 février 2009 (ci après la "Société").
La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre
du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Conversion de la devise du capital social d'euros en US Dollars;
2. Augmentation du capital social de son montant actuel de quatre-vingt-dix-sept mille trois cent un US Dollars (USD
97.301) jusqu'à trois cent mille US Dollars (USD 300.000) par l'émission de deux cent deux mille six cent quatre-vingt-
dix-neuf (202.699) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, en échange d'un
apport en numéraire;
3. Modification subséquente du paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société.
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend ensuite les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de convertir la devise du capital social d'euros en US Dollars au taux de conversion de
1,297343 US Dollars pour un euro (EUR 1).
52399
En conséquence, le capital social actuel de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000) est converti en quatre-vingt-dix-
sept mille trois cent un US Dollars (USD 97.301), représenté par quatre-vingt-dix-sept mille trois cent une (97.301) parts
sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune.
<i>Seconde résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent deux mille six cent quatre-vingt-
dix-neuf euros (EUR 202.699) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-sept mille trois cent un US Dollars
(USD 97.301), représenté par quatre-vingt-dix-sept mille trois cent une (97.301) parts sociales ayant une valeur nominale
d'un US Dollar (USD 1) chacune, jusqu'à un montant de trois cent mille US Dollars (USD 300.000), par l'émission de
deux cent deux mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (202.699) parts sociales, d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD
1) chacune.
L'intégralité des deux cent deux mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (202.699) parts sociales nouvelles est souscrite
par l'associée unique Paul Capital Partners IX, L.P., prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, pour un montant
global de deux cent deux mille six cent quatre-vingt-dix-neuf US Dollars (USD 202.699), dont l'intégralité est affectée au
capital social.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire par Paul Capital Partners IX, L.P., prénom-
mée, et le montant total de deux cent deux mille six cent quatre-vingt-dix-neuf US Dollars (USD 202.699) est dès à
présent à la libre disposition de la Société, tel qu'il a été démontré au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précédent, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de trois cent mille US Dollars (USD 300.000) représenté par trois cent
mille (300.000) parts sociales, d'une valeur d'un US Dollar (USD 1) chacune.".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: C. WILLEMYNS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 avril 2009. LAC/2009/14221. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 14 mai 2009.
*.
Référence de publication: 2009061262/7241/128.
(090071742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
PGM LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 146.100.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend neun, den achtundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Herr Wilhelm GEISLER, Geschäftsmann, geboren in Wuppertal, am 15. Juni 1959, wohnhaft in D-54311 Trierweiler,
Koppbach, 7
Welcher Komparent den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche er hiermit grün-
det, zu beurkunden wie folgt:
Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung "PGM LUX" wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Esch-sur-Alzette.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
52400
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geei-
gnet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit
nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches
unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Distanzhandel für Eigenbedarf oder für Dritte, der Erstellung, Konzeption,
Verwirklichung und das Handeling, von Marketingkampagnen unter allen bestehenden Formen (mailing, Werbung, E-
commerce, Radio, TV, usw).
Die Gesellschaft hat weiterhin zum Zweck die Vermarktung von Produkten und die Erbringung von administrativen
Verwaltungsleistungen welche damit verbunden sind (Beherbergung, Bestellungsaufnahmen, Telefonzentrale, Frimenfüh-
rung, usw).
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben. Die Gesellschaft hat ebenso
zum Zweck die Beteiligung und den Beteiligungshandel an anderen Gesellschaften. Sie kann alle Arten von Wertpapieren
und Rechten insbesondere Patente und sonstige Nutzungsrechte erwerben, dieselben verwalten und verwerten. Die
Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben, welche mittelbar oder unmittelbar mit Ihrem Ge-
sellschaftszweck zusammenhängen.
Titel II - Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310)
Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesell-
schaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die société anonyme à
Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat ("directoire et conseil de surveillance") und die Einmannaktiengesell-
schaft ("société anonyme unipersonnelle"). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter"
bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher
Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Titel III - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-
schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter
oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt,
kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („ad-
ministrateur unique") bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem
Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft
erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen entweder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwal-
tungsrates oder durch die Kollektivunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates und eines anderen Verwaltungs-
ratsmitgliedes rechtmäßig verpflichtet.
52401
Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.
Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen
und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft
vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag des Monats Juni um 10.30 Uhr
am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden
Befugnisse aus.
Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar eines jeden Jahres bis zum 31. Dezember des selben Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abs-
chreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen
und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrie-
ben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn die Rücklage zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch ge-
nommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder
mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden
ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2010 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, erklärt der Komparent, die Gesamtheit des Gesellschaftska-
pitals, das heißt dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie, zu
zeichnen und voll und ganz einzuzahlen, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreißigtausend Euro
(31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde, welcher dieses
bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro zu deren Zahlung
der Gründer sich persönlich verpflichtet.
52402
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Alsdann hat der vorgenannte Komparent, welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingesellschafter folgende
Beschlüsse gefasst:
1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Liberation.
2.- Zum alleinigen Verwalter wird ernannt:
Herr Wilhelm GEISLER, vorbenannt, welcher die Gesellschaft in jedem Falle durch seine alleinige Unterschrift vertreten
kann.
3.- Zum Prüfungskommissar wird ernannt:
Dame Christine DENYS, geboren in Etterbeek (B) am 20. August 1959, berufsansässig in in L-4210 Esch-sur-Alzette,
69, rue de la Liberation.
4.- Der alleinige Verwalter wird auf unbestimmte Zeit genannt und das Mandat des Kommissars endet sofort nach der
jährlichen Generalversammlung von 2014.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,
dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: W. GEISLER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2009. Relation: LAC/2009/16507. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 6. Mai 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2009061306/206/147.
(090071478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Tomkins Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 110.750,00.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 86.644.
In the year two thousand and nine, on the second of April.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
- Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-25, rue
Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
102.555, and
- Tomkins Finance Luxembourg Limited, a limited company with registered office at East Putney House, 84 Upper
Richmond Road, London SW15 2ST, United-Kingdom, inscribed under company number 6625828, both here represented
by Mr. Gael Toutain, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of two (2) proxies given on March 26, 2009.
The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company existing in Luxembourg under
the name of "Tomkins Luxembourg S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 86.644, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary of February 28, 2002, published in the Memorial C n° 963 of June 25, 2002,
and whose articles have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of January 9, 2009, not yet
published in the Mémorial C.
II. The sole shareholders resolved to:
1) Amend article 7 of the Company's articles of association to give it the following content:
" Art. 7. The capital may be changed at any time by an extraordinary general meeting of the shareholders held in
presence of a notary, in compliance with article 14 of the Articles."
2) Change the Company's accounting year-end to the fourth of April of each year, the accounting year having started
on the twenty-first of August 2008 closing on the fourth of April 2009.
52403
3) Restate article 15 of the Company's articles of association pursuant to the above change of accounting year-end
which is amended and shall henceforth read as follows:
" Art. 15. The Company's financial year starts on the fifth of April of each year and ends on the fourth of April of the
subsequent year ".
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the presently stated change of accounting year end are estimated at seven hundred fifty Euro (€ 750.-). There being
no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le deux du mois d'avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
- Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25, rue Notre-
Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 102.555, et
- Tomkins Finance Luxembourg Limited, une limited company de droit britannique avec siège social à East Putney
House, 84 Upper Richmond Road, Londres SW15 2ST, Royaume-Uni, inscrite sous le numéro de société 6625828,
ici représentées par Monsieur Gael Toutain, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg,
en vertu de deux (2) procurations données le 26 mars 2009.
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-
mination de "Tomkins Luxembourg S.à r.l." (la "Société") ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 86.644, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C n° 963 du 25 juin 2002 et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 9 janvier 2009, non
encore publié au Mémorial C.
II. Les associées uniques décident de:
1. Modifier l'article 7 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:
" Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision d'une assemblée générale extraordinaire des
associés tenue devant notaire, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts."
2. Changer la fin de l'exercice social de la Société au quatre avril de chaque année, l'exercice social ayant commencé
le vingt et un août 2008 clôturera le quatre avril 2009.
3. En conséquence de ce changement de la fin de l'exercice social, l'article 15 des statuts de la Société est modifié
comme suit:
" Art. 15. L'exercice social de la Société commence le cinq avril de chaque année et se termine le quatre avril de l'année
suivante".
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante Euros (€ 750,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
52404
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: G. TOUTAIN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A. C. le 8 avril 2009. Relation: LAC/2009/13804. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 21 avril 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009061292/211/96.
(090071381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Forum Europa, Fondation.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg G 57.
<i>Bilanz zum 31.12.2008i>
AKTIVA
31.12.2008 (EUR)
31.12.2007
(X 1.000 EUR)
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.975,00
16,1
II. Finanzanlagen
Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,00
0,0
Wertpapiere des Anlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
578.305,63
735,3
B. Umlaufvermögen
I. Sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.273,00
0,0
II. Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.143,72
64,4
645.699,35
815,8
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Stiftungskapital
1. Grundstockvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000,00
500,0
2. Vermögensumschichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-143.020,64
0,0
3. Zustiftungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,00
200,0
II. Ergebnisrücklagen
Kapitalerhaltungsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.500,00
39,0
III. Mittelvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.480,60
53,7
B. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.700,00
15,4
C. Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.039,39
7,7
645.699,35
815,8
<i>Aufwands- und Ertragsrechnung für den Zeitraum 1.1.-31.12.2008i>
A. Erträge
2008 (EUR)
2007
(X 1.000 EUR)
1. Erhaltene Zuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260.000,00
266,5
2. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.772,93
0,0
3. Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.443,80
20,1
4. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.063,40
2,9
B. Aufwendungen
1. Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-149.676,72
-136,3
2. Abschreibungen auf Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-5.100,00
-5,1
52405
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-146.096,03
-0,0
4. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-150.120,32
-152,1
C. Jahresfehlbetrag/-überschuss
-160.712,94
-4,0
D. Ergebnisverwendung
1. Mittelvortrag aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.672,90
66,7
2. Vermögensumschichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143.020,64
0,0
3. Einstellung in die Kapitalerhaltungsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-8.500,00
-9,0
E. Mittelvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.480,60
53,7
<i>Bescheinigungi>
"Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Grundsätzen einer
ordnungsgemäßen Rechnungslegung."
Dillingen, den 26.01.2009.
W+ST Wirtschafts- und Steuerberatung AG
<i>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
i>Pfefferle, Withum
<i>Wirtschaftsprüferi>
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde vom Verwaltungsrat anläßlich seiner Sitzung vom 30.04.2009
in Luxemburg angenommen.
<i>Budget 2009i>
A. Einnahmen
1. Mittelvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,00
2. Zuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265.000,00
3. Kapitalerträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,00
300.000,00
B. Ausgaben
1. Personalkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.000,00
2. Raumkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.000,00
3. PKW- und Reisekosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.500,00
4. Kommunikations- und Dokumentationskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.500,00
5. Material- und Bewirtungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000,00
6. Buchhaltungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000,00
7. Fördermittel für Projekte in der EAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000,00
8. Sonstige Projekt- und Fördermittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000,00
300.000,00
Nota bene: Da etwa 2/3 aller Ausgaben projektgebunden sind, beläuft sich der Gesamtaufwand für Projekte auf fast
230.000,00 EUR.
Das Budget 2009 wurde vom Verwaltungsrat anläßlich seiner Sitzung vom 30.04.2009 in Luxemburg angenommen.
Référence de publication: 2009061232/80.
(090071907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
TBU-1 International S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 107.950.
In the year two thousand and nine, on the second day of April,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme TBU-1 International S.A. (the
"Company") having its registered office in L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve, incorporated by deed of
the undersigned notary on 2
nd
May, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémo-
rial"), number C-955 of 28
th
September 2005. The articles of incorporation of the Company have been amended several
times and for the last time by deed of the undersigned notary on 10
th
April, 2008, published in the Mémorial, number
C-1318 on 29
th
May, 2008.
The meeting was presided over by Mr Naïm Gjonaj, director of the Company, professionally residing in Luxembourg.
52406
The chairman appointed as secretary Mr Patrick Santer master at Laws, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Pierre Stemper, director, residing in Luxembourg. The chairman declared and
requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration
authorities.
II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that
the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and
may validly deliberate on the agenda set out below:
1. Increase of the authorised share capital of the Company from currently forty million eight hundred seventy-six
thousand seven hundred twenty-one Euro and twenty-five cents (€40,876,721.25) to forty million nine hundred seventy-
nine thousand six hundred ninety Euro (€ 40,979,690) consisting of thirty-two million seven hundred eighty-three
thousand seven hundred fifty-two (32,783,752) additional authorised shares, each with a nominal value of one Euro
twenty-five cents (€1.25.-) per share; and acknowledgement and approval of the report by the board of directors of the
Company made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies (as amended)
(the "Law") concerning the price, if any, at which the shares of the Company may be issued if issued against a consideration
in cash to the extent such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of the existing
shareholders.
2. Increase of the issued share capital of the Company from currently four hundred forty-four thousand nine hundred
twenty-two Euro and fifty cents (€444,922.50) to four hundred forty-six thousand and forty-seven Euro and fifty cents
(€446,047.50) by the issue to new subscribers, the preferential subscription rights of the existing shareholders being
waived and the existing shareholders waiving their preferential subscription rights, of nine hundred (900) shares each
with a nominal value of one Euro twenty-five cents (€1.25.-) for a total subscription price of one thousand three hundred
fifty-two Euro and forty-seven cents (€1,352.47), of which thousand one hundred twenty-five Euro (€1,125) would be
allocated to the issued share capital account and the balance to the freely distributable share premium account, and
acknowledgement and approval of the report by the board of directors of the Company made in accordance with article
32-3 (5) of the Law regarding the limitation of the preferential subscription rights.
3. Consequential amendment of first two paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of the Company so
as to read as follows:
" Art. 5. Capital - Shares and Share certificates. The issued capital of the Company is set at four hundred forty-six
thousand and forty-seven Euro and fifty cents (€446,047.50) divided into three hundred fifty-six thousand eight hundred
thirty-eight (356,838) shares, each with a nominal value of one Euro twenty-five cents (€1.25.-) per share and all of said
shares being fully paid.
The authorised capital of the Company is fixed at additional forty million nine hundred seventy-nine thousand six
hundred ninety Euro (€ 40,979,690) consisting of thirty-two million seven hundred eighty-three thousand seven hundred
fifty-two (32,783,752) additional shares, each with a nominal value of one Euro twenty-five cents (€1.25.-) per Share."
4. Deletion of the fourth paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company.
After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to increase the authorised share capital of the Company from currently forty million eight
hundred seventy-six thousand seven hundred twenty-one Euro and twenty-five cents (€40,876,721.25) to forty million
nine hundred seventy-nine thousand six hundred ninety Euro (€ 40,979,690) consisting of thirty-two million seven hun-
dred eighty-three thousand seven hundred fifty-two (32,783,752) additional authorised shares, each with a nominal value
of one Euro twenty-five cents (€1.25.-) per share.
The meeting acknowledged and approved a report by the board of directors, drafted in accordance with article 32-3
(5) of the Law concerning the price if any at which the shares of the Company may be issued, if issued against a consi-
deration in cash to the extent such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of existing
Shareholders. The meeting resolved that such report complied with said article 32-3(5).
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from currently four hundred forty-four
thousand nine hundred twenty-two Euro and fifty cents (€444,922.50) to four hundred forty-six thousand and forty-seven
Euro and fifty cents (€446,047.50) by the issue of nine hundred (900) shares, each with a nominal value of one Euro
twenty-five cents (€1.25.-) for a total subscription price of one thousand three hundred fifty-two Euro and forty-seven
cents (€1,352.47).
52407
The meeting acknowledged and approved a report by the board of directors, drafted in accordance with article 32-3
(5) of the Law regarding the limitation of the preferential subscription rights, and resolved that such report complied with
said article 32-3(5).
The meeting resolved to limit the preferential subscription rights of the existing shareholders in relation to the shares
issued and it noted that the existing shareholders had waived their pre-emptive subscription rights with respect to such
issue of shares.
Such increase of share capital has been subscribed and paid in cash, by Mr. Jan Adriaan Van Rooyen, of Regency
Entertainment S.A., P.O. Box "Macedonia" Airport 551 03, Thessaloniki, Greece, pursuant to a subscription form which
having been signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to
be filed with the registration authorities.
The meeting resolved to allocate one thousand one hundred twenty-five Euro (€1,125) to the issued share capital
account and two hundred and twenty-seven Euro and forty-seven cents (€227.47) to the freely distributable share pre-
mium account.
Evidence of such payments has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
Consequently, the meeting resolved to amend the first two paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of
the Company so as to read as follows:
" Art. 5. Capital - Shares and Share certificates. The issued capital of the Company is set at four hundred forty-six
thousand and forty-seven Euro and fifty cents (€446,047.50) divided into three hundred fifty-six thousand eight hundred
thirty-eight (356,838) shares, each with a nominal value of one Euro twenty-five cents (€1.25.-) per share and all of said
shares being fully paid.
The authorised capital of the Company is fixed at additional forty million nine hundred seventy-nine thousand six
hundred ninety Euro (€ 40,979,690) consisting of thirty-two million seven hundred eighty-three thousand seven hundred
fifty-two (32,783,752) additional shares, each with a nominal value of one Euro twenty-five cents (€1.25.-) per Share."
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolved to delete the fourth paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred Euro.
There being no further business on the agenda the meeting was closed.
Whereof, done in Luxembourg, on the day said before.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le deuxième jour du mois d'avril,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TBU-1 International S.A.
(la "Société") avec siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve, constituée suivant acte passé par
devant le notaire soussigné le 2 mai 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"),
numéro C-955 du 28 septembre 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois
par acte du notaire soussigné le 10 avril 2008, publié au Mémorial, numéro C-1318 le 29 mai 2008.
L'assemblée est présidée par M. Naïm Gjonaj, administrateur de la Société, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Patrick Santer, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur Mr. Pierre Stemper, administrateur, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux figurent sur la
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.
Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui
aux formalités de l'enregistrement.
52408
II. Il ressort de la liste de présence que l'entièreté du capital social est représentée à cette assemblée et les actionnaires
déclarent être dûment informés de l'ordre du jour de sorte que la présente assemblée générale est régulièrement con-
stituée et pourra délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour décrit ci-après:
1. Augmentation du capital autorisé de la Société d'actuellement quarante millions huit cent soixante-seize mille sept
cent vingt-et-un Euro et vingt-cinq centimes (€40.876.721,25) à quarante millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six
cent quatre-vingt-dix Euro (€40.979.690) consistant en trente-deux millions sept cent quatre-vingt trois mille sept cent
cinquante-deux (32.783.752) actions autorisées supplémentaires, chacune ayant une valeur nominale d'un Euro et vingt-
cinq centimes (€ 1,25); et prise de connaissance et approbation du rapport fait par le conseil d'administration de la Société
conformément à l'article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la "Loi") relatif
au prix, s'il y a lieu, auquel les actions de la Société pourront être émises, si émises en contrepartie d'espèces, dans la
mesure où ces émissions seront faites sans être soumises au droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.
2. Augmentation du capital social émis de la Société d'actuellement quatre cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-
deux Euro et cinquante centimes (€ 444.922,50) à quatre cent quarante-six mille quarante-sept Euro et cinquante centimes
(€ 446.047,50) par l'émission à de nouveaux souscripteurs, les droits préférentiels de souscription des actionnaires exi-
stant étant limités et les actionnaires existants renonçant à leur droit préférentiel de souscription, de neuf cent (900)
actions ayant chacune une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes (€ 1,25-) pour un prix total de souscription
de mille trois cent cinquante-deux Euro et quarante-sept centimes (€1.352,47), duquel mille cent vingt-cinq Euro(€1.125)
seraient alloués au compte capital social et le solde au compte prime d'émission librement distribuable, et prise de
connaissance et approbation du rapport du conseil d'administration de la Société rédigé conformément l'article 32-3 (5)
de la Loi concernant la limitation des droits préférentiels de souscription.
3. Modification conséquente des deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur
suivante:
" Article 5. Capital, Actions et Certificats d'actions.
Le capital émis de la Société est fixé à quatre cent quarante-six mille quarante-sept Euro et cinquante centimes (€
446.047,50) divisé en trois cent cinquante-six mille huit cent trente-huit (356.838) actions avec une valeur nominale d'un
Euro et vingt-cinq centimes (€ 1,25-) par action et toutes ces actions étant entièrement libérées. Le capital autorisé de
la Société est fixé à quarante millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix Euro (€40.979.690)
supplémentaires constitué en trente-deux millions sept cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante-deux
(32.783.752) actions supplémentaires, toutes avec une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes (€ 1,25-) par
action."
4. Suppression du quatrième alinéa de l'article 5 des statuts de la Société.
Après avoir approuvé ce qui précède, l'assemblée a de manière unanime pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital autorisé de la Société d'actuellement quarante millions huit cent soixante-
seize mille sept cent vingt-et-un Euro et vingt-cinq centimes (€40.876.721,25) à quarante millions neuf cent soixante-dix-
neuf mille six cent quatre-vingt-dix Euro (€40.979.690) consistant en trente-deux millions sept cent quatre-vingt-trois
mille sept cent cinquante-deux (32.783.752) actions, chacune ayant une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes
(€ 1,25-).
L'assemblée a pris connaissance et a approuvé le rapport fait par le conseil d'administration, préparé conformément
à l'article 32-3(5) de la Loi concernant le prix, s'il y a lieu, auquel les actions peuvent être émises, si émises en contrepartie
d'espèces, dans la mesure où ces émissions sont faites sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants. L'assemblée a décidé que ledit rapport est conforme audit article 32-3(5).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'actuellement quatre cent quarante-quatre mille
neuf cent vingt-deux Euro et cinquante centimes (€ 444.922.50) à quatre cent quarante-six mille quarante-sept Euro et
cinquante centimes (€ 446.047,50) par l'émission de neuf cents (900) actions chacune ayant une valeur nominale d'un
Euro et vingt-cinq centimes (€ 1,25-) pour un prix total de souscription de mille trois cent cinquante-deux Euro et
quarante-sept centimes (€1.352,47).
L'assemblée a pris connaissance et a approuvé le rapport du conseil d'administration de la Société rédigé conformément
l'article 32-3 (5) de la Loi concernant la limitation des droits préférentiels de souscription et a décidé que ce rapport était
conforme audit article 32-3 (5).
L'assemblée a décidé de limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants concernant les actions
émises et a noté que les actionnaires existants avaient renoncé à leurs droits préférentiels de souscription concernant
l'émission de telles actions.
Cette augmentation de capital a été souscrite et payée en espèces par M. Jan Adriaan Van Rooyen, p.a. Regency
Entertainment S.A., P.O. Box "Macedonia" Airport 551 03, Thessaloniki, Grèce, conformément à un bulletin de souscri-
ption signé par tous les comparants et par le notaire soussigné qui restera annexé au présent acte pour être soumis avec
lui aux formalités d'enregistrement.
52409
L'assemblée a décidé d'allouer mille cent vingt-cinq Euro(€1.125) au compte capital social et deux cent vingt-sept Euro
et quarante-sept centimes (€227,47) au compte prime d'émission librement distribuable.
La preuve de ces paiements a été fournie au notaire.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence, l'assemblée a décidé de modifier les deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts de la Société pour
leur donner la teneur suivante:
" Art. 5. Capital actions et Certificats d'actions. Le capital émis de la Société est fixé à quatre cent quarante-six mille
quarante-sept Euro et cinquante centimes (€ 446.047,50) divisé en trois cent cinquante-six mille huit cent trente-huit
(356.838) actions avec une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes (€ 1,25-) par action et toutes ces actions
étant entièrement libérées. Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante millions neuf cent soixante-dix-neuf mille
six cent quatre-vingt-dix Euro (€40.979.690) supplémentaires constitué en trente-deux millions sept cent quatre-vingt-
trois mille sept cent cinquante-deux (32.783.752) actions supplémentaires, toutes avec une valeur nominale d'un Euro et
vingt-cinq centimes (€ 1,25-) par action."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée a décidé de supprimer le quatrième alinéa de l'article 5 des statuts de la Société.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués à la somme de mille quatre cents Euro.
Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate qu'à la requête des parties comparantes, cet acte a été
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes la version anglaise
fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.
Signé: N. GJONAJ, P. SANTER, P. STEMPER, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 06 avril 2009. Relation: LAC/2009/13449. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 AVR. 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009061239/211/210.
(090071637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Buurschter Jangeli S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9183 Schlindermanderscheid, 30, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 104.183.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2009061125/14.
(090071363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
EPI Orange Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 103.548.
In the year two thousand and nine, on the eighth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of "EPI Orange Holdings S.à.r.l.", a "société à responsabilité
limitée", having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5 Allée Scheffer, incorporated by a notarial deed enacted on
the 5
th
day of October 2004, registered on October 25, 2004 at the Luxembourg trade register section B number
52410
103.548, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1293 of December 16,
2004 whose articles of association have been amended by deed enacted on November 3, 2004, published in the Luxem-
bourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 108 of February 5, 2005, and by a notarial deed enacted
on June 3, 2005, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1349 of December
8, 2005, and by a notarial deed enacted on August 30, 2005, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 229 of February 1, 2006, and by a notarial deed enacted on the December 21, 2005, published
in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1112 of June 8, 2006, and by a notarial deed
enacted on the July 3, 2006, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1822
of September 29, 2006, and by a notarial deed enacted on the July 27, 2006, published in the Luxembourg Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 1929 of October 13, 2006, and by a notarial deed enacted on the March 28,
2007, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1448 of July 13, 2007, and
by a notarial deed enacted on the June 28, 2007, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2216 of October 5, 2007, and by a notarial deed enacted on the July 11, 2008, published in the
Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2135 of September 3, 2008, and by a notarial deed
enacted on December 12
th
, 2008, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
655 of March 26
th
, 2009.
The meeting is presided by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert JANSSEN, lawyer, residing professionally in
Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner represented and the number of units held by him are shown on an attendance list. That list and
proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 137,411 (one hundred thirty seven thousand four hundred eleven) units
of EUR 1.- (one euro) each representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting is validly
constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda of which the partners have been informed
beforehand.
III.- That the agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 9,114.- (nine thousand one hundred and fourteen euros) so
as to raise it from its present amount of EUR 137,411.- (one hundred thirty seven thousand four hundred eleven euros)
to EUR 146,525.- (one hundred forty-six thousand five hundred twenty-five euros) by the issue of 9,114 (nine thousand
one hundred and fourteen) class E units having a par value of EUR 1.- (one euros) each.
2. Subscription and full payment of the new units by contribution in cash by the sole partner European Property
Investors, L.P.
3. Amendment of article eight of the articles of association of the Company in accordance with the above.
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 9,114.- (nine thousand one hundred and
fourteen euros) so as to raise it from its present amount of EUR 137,411.- (one hundred thirty seven thousand four
hundred eleven euros) to EUR 146,525.- (one hundred forty-six thousand five hundred twenty-five euros) by the issue
of 9,114 (nine thousand one hundred and fourteen) class E shares having a par value of EUR 1.- (one euros) each., to
subscribe in cash by the sole partner of the Company, European Property Investors, L.P. a limited partnership incorporated
under the laws of the United-Kingdom having its registered office at 33 Jermyn Street, London SW1Y 6DN, registered
by the London trade register under the number LP 009339.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon the prenamed subscriber, represented by Mrs Rachel UHL, prenamed, by virtue of the aforementioned
proxy;
declared to subscribe to the 9,114 (nine thousand one hundred and fourteen) new class E shares and to have them
fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR
9,114,- (nine thousand one hundred and fourteen euros) as was certified to the undersigned notary by a banking certificate.
<i>Second resolutioni>
In view of the above resolution, the meeting resolves to amend article eight of the articles of association to read as
follows:
52411
" Art. 8. The Company's capital is set at EUR 146,525.- (one hundred forty-six thousand five hundred and twenty-five
euros) represented by 5,000 (five thousand) class A shares, 15,000 (fifteen thousand) class B shares, 28,850 (twenty eight
thousand eight hundred fifty) class C shares, 6,500 (six thousand five hundred) class D shares, 18,114 (eighteen thousand
one hundred and fourteen) class E shares, 13,000 (thirteen thousand) class F shares, 12,700 (twelve thousand seven
hundred) class G shares, 1,490 (one thousand four hundred ninety) class H shares, 18,400 (eighteen thousand four
hundred) class I shares, 27,471 (twenty seven thousand four hundred seventy one) class J shares, with a par value of EUR
1.- (one euros) each."
There being nothing further on the agenda the meeting is terminated.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company as a result
of the present deed, are estimated at approximately thousand euros.
There being no further business before the meeting, the meeting is terminated.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le huit avril.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "EPI Orange Holdings
S.à.r.l.", ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5 Allée Scheffer, constituée suivant acte notarié reçu le 5 octobre
2004, inscrite le 25 octobre 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
103.548, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1293 du 16 décembre 2004, dont les statuts
ont été modifiés suivant acte notarié reçu le 3 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 108 du 5 février 2005, suivant acte notarié reçu le 3 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1349 du 8 décembre 2005, et suivant acte notarié reçu le 30 août 2005, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 229 du 1
er
février 2006, et suivant acte notarié reçu le 21 décembre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1112 du 8 juin 2006, suivant acte notarié reçu le 3
juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1822 du 29 Septembre 2006, suivant acte
notarié reçu le 27 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1929 du 13 Octobre
2006, suivant acte notarié reçu le 28 Mars 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1448
du 13 Juillet 2007, suivant acte notarié reçu le 28 Juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2216 du 5 Octobre 2007, et suivant acte notarié reçu le 11 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2135 du 3 Septembre 2006, et suivant acte notarié reçu le 12 décembre 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 655 du 26 mars 2009.
L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette
liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 137.411 (cent trente sept mille quatre cent onze) parts sociales d'une
valeur de EUR 1,- (un euro) chacune représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 9.114.- (neuf mille cent quatorze euros) pour
le porter de son montant actuel de EUR 137.411.- (cent trente sept mille quatre cent onze euros) à EUR 146.525.- (cent
quarante-six mille cinq cent vingt-cinq euros) par l'émission de 9.114 (neuf mille cent quatorze) parts sociales de classe
E d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euros) chacune.
2.- Souscription et paiement des nouvelles parts par un apport en numéraire par l'associé unique European Property
Investors, L.P.
52412
3.- Modification de l'article huit des statuts conformément à ce qui précède.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 9.114,- (neuf mille cent quatorze
euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 137.411,- (cent trente sept mille quatre cent onze euros) à EUR
146.525,- (cent quarante-six mille cinq cent vingt-cinq euros) par l'émission de 9.114 (neuf mille cent quatorze) parts
sociales de classe E d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euros) chacune, souscrites intégralement et libérées par un
apport en cash par l'associé unique European Property Investors, L.P., constituée suivant les lois du Royaume-Uni ayant
son siège social au 33 Jermyn Street, Londres SW1Y 6DN, inscrite au Registre de Londres sous le no LP 009339.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par Madame Rachel UHL, prénommée, en vertu d'une procuration dont
mention ci-avant;
a déclaré souscrire aux 9.114 (neuf mille cent quatorze) parts sociales nouvelles de classe E et les libérer intégralement
en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 9.114.- (neuf
mille cent quatorze euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Au regard de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
" Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 146.525,- (cent quarante-six mille cinq cent vingt-cinq euros) représenté par
5.000, (cinq mille) parts sociales de classe A, 15.000 (quinze mille) parts sociales de classe B, 28.850 (vingt huit mille huit
cent cinquante) parts sociales de classes C, 6.500 (six mille cinq cent) parts sociales de classe D, 18.114 (dix-huit mille
cent quatorze) parts sociales de classe E, 13.000 (treize mille) parts sociales de classe F, 12.700 (douze mille sept cent)
parts sociales de classe G, 1.490 (mille quatre cent quatre vingt dix) parts sociales de classe H, 18.400 (dix huit mille
quatre cent) parts sociales de classe I, 27.471 (vingt sept mille quatre cent soixante et onze) parts sociales de classe J,
d'une valeur de EUR 1,- (un euros) chacune."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa contribution, s'élève à environ mille cinq cents Euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 avril 2009. Relation: LAC/2009/14528. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009061240/211/163.
(090071779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Petrusse Capital Markets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 140.134.
L'an deux mille neuf, le vingt-deux avril.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PETRUSSE CAPITAL MARKETS
S.A.", ayant son siège social à Luxembourg 19 avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg section B numéro 140134, constituée
suivant acte reçu le 9 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1899 du 1
52413
er
août 2008; dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 9 octobre 2008, publié au Mémorial C numéro 2938
du 10 décembre 2008.
L'assemblée est présidée par Jean-Baptiste Chauvel, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antoine Bourrouilh, de-
meurant à Paris.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II- Il appert de la liste de présence que les 800 (huit cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification du nombre et de la valeur nominale des actions.
2.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 88.889,- (quatre-vingt huit mille huit cent
quatre-vingt neuf Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 800.000,- (huit cent mille Euro) à EUR 888.889,-
(huit cent quatre-vingt huit mille huit cent quatre-vingt neuf Euro) par l'émission de 88.889,- (quatre-vingt huit mille huit
cent quatre-vingt neuf) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, par apport en numéraire.
3.- Souscription- Libération
4.- Modification subséquente des alinéas 1 et 3 de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions représentant le capital social afin que le
capital soit représenté par 800.000 actions d'une valeur nominale de EUR 1,-. chacune
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 88.889,- (quatre-vingt huit mille huit cent
quatre-vingt neuf Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 800.000,- (huit cent mille Euro) à EUR 888.889,-
(huit cent quatre-vingt huit mille huit cent quatre-vingt neuf Euro) par l'émission de 88.889,- (quatre-vingt huit mille huit
cent quatre-vingt neuf) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, par apport en numéraire.
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée, après avoir constaté que les actionnaires en place ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,
décide d'admettre à la souscription des 88.889,- (quatre-vingt huit mille huit cent quatre-vingt neuf) actions nouvelles:
Monsieur Antoine Bourrouilh.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite Monsieur Antoine Bourrouilh prénommé, a déclaré souscrire aux 88.889,- (quatre-vingt huit mille huit cent
quatre-vingt neuf) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant
à sa libre et entière disposition la somme de EUR 88.889,- (quatre-vingt huit mille huit cent quatre-vingt neuf Euro), ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les
premier et troisièmes alinéas de l'article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:
" Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 888.889,- (huit cent quatre-vingt huit mille huit cent quatre-
vingt neuf Euro) euros, représenté par 888.889 (huit cent quatre-vingt huit mille huit cent quatre-vingt neuf) actions de
EUR 1,- (un Euro) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.
" Art. 5. 3
ème
alinéa. Le capital autorisé est fixé à un million deux cent mille (1.200.000,-) euros, qui sera représenté
par un million deux cent mille (1.200.000) actions de un (EUR1,-) euro chacune.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
52414
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J-B. CHAUVEL, A. BOURROUILH, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 avril 2009. Relation: LAC/2009/15923. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 30 AVR. 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009061237/211/70.
(090071540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Real Properties (Luxembourg) Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 142.000.
In the year two thousand and nine, on the fourth day of March.
Before us Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Real Properties (Luxembourg) Holdco S.à r.l., with registered office in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de
Gaulle,
here represented by Mr Luc HANSEN, "licencié en administration des affaires", with professional address in L-1653
Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole member of Real Properties (Luxembourg) Two S. à r. l., hereafter "the Company", a
société à responsabilité limitée, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 142.000, incorporated on September
24, 2008, pursuant to a deed of the notary Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
published on October 16, 2008 in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2537.
The appearing party, represented as stated hereabove, holding one hundred percent (100%) of the share capital of the
Company, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole member decides to delete the face value of the corporate units and to convert, with retroactive effect as of
September 24, 2008, the Company's share capital currency into GBP at the conversion rate as at September 24, 2008 of
EUR 1 = 0,79169141 GBP.
<i>Second resolutioni>
The sole member decides to amend 1st paragraph of article 5 of the by-laws of the Company, which henceforth will
read as follows:
"5.1 The share capital is fixed at nine thousand eight hundred and ninety-six pounds Sterling and fourteen pence (GBP
9,896.14) represented by one hundred (100) corporate units without nominal value."
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder, known to the notary
by his surname, Christian name, civil status and residence, signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mil neuf, le quatre mars.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Real Properties (Luxembourg) Holdco S.à r.l., ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,
52415
ici représentée par M. Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, avec adresse professionnelle à L-1653
Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée Real Properties (Luxembourg) Two S. à r. l.,
ci-après "la Société", ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 142.000, constituée le 24 septembre 2008
suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
publié le 16 octobre 2008 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2537.
La comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour cent (100%) du capital de la Société, prend les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales et de convertir, avec effet rétroactif au
24 septembre 2008, la devise du capital social en GBP au taux de conversion au 24 septembre 2008 de EUR 1 = 0,79169141
GBP.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée Unique décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur
suivante:
" 5.1. Le capital social est fixé à neuf mille huit cent quatre-vingt-seize livres sterling et quatorze pence (GBP 9.896,14)
représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale."
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. HANSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 06 mars 2009. Relation: LAC/2009/8607. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 17 MARS 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009061227/211/78.
(090071704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
TH Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 443, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 137.518.
Durch Abtretungsvertrag unter Privatschrift vom 27.2.2009 hat Herr Harald KELLNER 50 Gesellschaftsanteile an
Herrn Tahir ERKUS , Bauleiter, geboren am 1. Januar 1969 in Arguvan (Türkei), wohnhaft in L-3428 Dudelange, 21A,
route de Boudersberg, übertragen.
Die Gesellschaftsanteile der Gesellschaft sind somit wie folgt verteilt:
Herr Harald KELLNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Anteile
Herr Tahir ERKUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Anteile
Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Anteile
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Référence de publication: 2009061143/607/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2009, réf. LSO-DD06094. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090071683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
52416
Barendina S.A.
Baus-Agri S.C.
Buurschter Jangeli S.à.r.l.
Cetus Investments S.à r.l.
Conical SPF S.A.
DHL Express (Luxembourg) S.A.
D.M. Investments S.A.
EECF Moravia S.A.
EECF Moravia S.A.
EPI Orange Holdings S.à r.l.
EPI Orange Holdings S.à r.l.
Etablissements Locanord S.A.
Financière d'Ancône
Finarch S.à r.l.
FLOBONA Co Limited
FLOBONA Co Limited
Forum Europa
Gate Gourmet Holding I S.à r.l.
Gestair International Council S.à r.l.
Grus Investments S.à r.l.
Homilux Holding S.A.
Initiatives Céramiques S.à r.l.
Langerheights S.A.
Meteor Investment Fund S.A., SICAV-SIF
Moto Pazzia
Net Lux S.à r.l.
New Quasar S.à.r.l.
Novalux G.m.b.h.
OI-Clothing S.A.
Panfret S.à r.l.
Paul MN Holdings, S.à r.l.
Pendragon Holding S.A.
Petrusse Capital Markets S.A.
PGM LUX
PPG Luxembourg Finance S.àr.l.
Protect S.à r.l.
Rainforest Capital S.A.
Real Properties (Luxembourg) Two S.à r.l.
Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A.
Sanderlux S.A.
Shon Invest
Shon Invest
Sludge Investments S.A.
Sonafi S.A.
SPGF Holding S.A.
Sublime Investments S.à r.l.
Sublime Investments S.à r.l.
Taillerie Luxembourgeoise de Pierres Précieuses
TBU-1 International S.A
TH Construction S.à r.l.
The Turquoise II Fund
Tomkins Investments Company S.à r.l.
Tomkins Luxembourg S.à r.l.
Tous Travaux Lux S.à r.l.
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à.r.l.
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. & Partners, S.C.S
UBAM
Vameca S.A.
Vega Investments S.à r.l.
Vega Investments S.à r.l.
Vega Investments S.à r.l.
Vireos Investment Funds S.A., SICAV-SIF
VisuConcept S.à r.l.
Wellness Center Luxembourg S.à r.l.