logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1022

18 mai 2009

SOMMAIRE

A.C.G. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49010

Achem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49010

Auberge du Musée SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49053

Bellgrove Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

49050

Bersy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49019

Blackburn Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49051

Datogon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49013

Datogon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49030

Deka International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49029

Deka International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49035

DWS Renten Direkt 2014 III  . . . . . . . . . . . .

49027

DWS Renten Direkt 2014 III  . . . . . . . . . . . .

49027

DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014

III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49026

DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014

III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49026

Eclaircie s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49049

EDM International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49025

Entreprise de Construction Claude Jans SA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49056

Entreprise de Construction Claude Jans SA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49052

F.A.M. Personal Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49012

Fuchs Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49024

Garage Jeannot SCHWEIG S.à.r.l.  . . . . . . .

49052

G&P Invest Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49025

Ingenium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49026

In Tempo by Luc Leroi  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49027

International Fund Management S.A.  . . . .

49029

International Fund Management S.A.  . . . .

49030

KBL Key Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49011

MD'S Import Export  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49055

Metro International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

49017

MFS Meridian Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49010

Microtron Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

49050

Millicom International Cellular S.A. . . . . . .

49014

MU Aberdeen Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49011

Nordbat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49051

Paris VIIIe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49012

Promotions C. Jans & Associés S.A. . . . . . .

49053

QS Italy SICAR S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49024

Quiksilver Deluxe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

49052

R.B.M. Pose S.A. - Revêtement Bâtiment

Marbre Pose S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49053

Revaler 21 Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

49054

Revaler 54 Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

49055

Sales Points Center S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

49051

Securialis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49049

Servizi Finanziari Internazionali S.A. . . . . .

49011

S.u.P. Premium III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49054

Transcom WorldWide S.A.  . . . . . . . . . . . . .

49020

Universal-Investment-1 SICAV-FIS  . . . . . .

49037

University Holding S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

49030

Valartis German Residential Health Care

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49037

Valartis German Residential Health Care

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49035

Varama Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

49014

Vontobel Exchange Traded Structured

Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49013

Wine Trade International . . . . . . . . . . . . . . .

49055

49009

Achem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 54, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 83.384.

Les actionnaires sont priés d' assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le mercredi <i>10 juin 2009 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice clos au

31 décembre 2008;

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Décision à prendre quant à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009057687/8492/17.

A.C.G. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 25.415.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>9 juin 2009 à 11.30 heures, pour délibérer

sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009058298/550/17.

MFS Meridian Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 39.346.

We have the pleasure of inviting you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders, which will be held on <i>June 15, 2009 at 10.00 a.m. (Lux time) at the offices of State Street Bank

Luxembourg S.A., 49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the Letter from the Chairman and approval of the Independent Auditor's report.
2. Approval of the Balance Sheet, Profit &amp; Loss Account as of January 31, 2009 and allocation of the net results.
3. Discharge to be granted to the Directors for the year ended January 31, 2009.
4. Re-election of the following persons as Directors until the next Annual General Meeting to be held in 2010:

Mr. Martin E. Beaulieu
Ms. Maria F. Dwyer
Ms. Robin A. Stelmach

5. Re-election of Ernst &amp; Young S.A. as Independent Auditor until the next Annual General Meeting to be held in

2010.

6. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

49010

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be

taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.

Should you not be able to attend the meeting, kindly date, sign and return the enclosed form of proxy by fax or by

mail 48 hours before the Meeting to the attention of Candice Mayembo.

- Fax number: (+352) 46.40.10.413.
- Address: State Street Bank Luxembourg S.A., 49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2009058667/755/29.

MU Aberdeen Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion de MU ABERDEEN FUND a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2009.

MUGC LUX MANAGEMENT S.A.
Signature

Référence de publication: 2009057085/11.
(090066577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

KBL Key Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 63.616.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>3 juin 2009 à 15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles

au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions un jour ouvrable avant la date de

l'assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009058670/755/21.

Servizi Finanziari Internazionali S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 112.064.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le <i>27 mai 2009 à 8 heures 30, pour délibérer

sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et son approbation.
2. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006, au 31

décembre 2007 et au 31 décembre 2008.

49011

4. Décision à prendre quant à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

SERVIZI FINANZIARI INTERNAZIONALI S.A.

Référence de publication: 2009053002/545/20.

Paris VIIIe, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 18.952.

Convocation à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du <i>27 mai 2009 à 15.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire;
2. Approbation du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 2008;
3. Affectation à donner aux résultats sociaux;
4. Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire aux comptes;
5. Divers.

F. CARPIAUX
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009050788/17.

F.A.M. Personal Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 72.628.

Le rapport annuel de F.A.M. PERSONAL FUND (ci-après « la Société ») n'ayant pas été disponible pour l'Assemblée

Générale Annuelle tenue le 19 janvier 2009, le président a décidé de reporter la réunion à une date ultérieure. Le rapport
annuel étant maintenant disponible, les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

de la Société qui aura lieu le mercredi <i>3 juin 2009 à 10h30, au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 30 septembre 2008.
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises.
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2008.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 30 septembre 2008.
6. Nominations statutaires.
7. Divers

Pour tenir valablement l'Assemblée Générale Ordinaire, aucun quorum de présence n'est requis. Les décisions seront

votées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Les actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de F.A.M. PERSONAL FUND (ci-après «la Société») qui se tiendra au siège social de la Société, le <i>3 juin 2009 à 14h00,

afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Nomination de Deloitte (auditeur de la Société) en tant que réviseur à la liquidation.
4. Divers.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital de la Société

est représentée. Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée seront adoptées si elles réunissent les deux tiers au
moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

49012

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée en date du 06 juillet

2009 à 11.00 heures ou à toute autre date décidée par un administrateur avec le même ordre du jour. La seconde
Assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée et les résolutions, pour être valables,
devront réunir respectivement les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires seront admis à ces Assemblées sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs

au moins avant l'assemblée, fait connaître leur intention de prendre part à l'assemblée.

Les actionnaires qui ne pourront pas assister à ces Assemblées peuvent librement se faire représenter en renvoyant

la procuration dont le formulaire est disponible sur demande au siège social de la Société. Les procurations dûment
complétées et signées doivent être envoyées au plus tard le 2 juin 2009 à 14.00 heures.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009058671/755/43.

Vontobel Exchange Traded Structured Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.940.

Da den Aktionären des VONTOBEL EXCHANGE TRADED STRUCTURED FUND zur jährlichen Generalversamm-

lung am 8. Dezember 2008 ein geprüfter Jahresbericht nicht vorgelegt werden konnte, hat der Vorsitzende beschlossen,
über die Tagesordnungspunkte 1, 2, 3 und 4 bei einer zweiten, neu einberufenen Generalversammlung zu beschliessen.

Die Aktionäre des VONTOBEL EXCHANGE TRADED STRUCTURED FUND werden daher hiermit zur Teilnahme

an der zweiten

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre (die "Generalversammlung") geladen, die am <i>3. Juni 2009 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der

RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, mit folgender Tagesordnung statt-
findet:

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2007/2008

2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007/2008
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das abgeschlossene Geschäftsjahr
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird

und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-

nisatorischen  Gründen  bis  zum  29.  Mai  2009  bei  Vontobel  Exchange  Traded  Structured  Fund,  zu  Händen  von  Frau
Christiane Berthold, 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (fax +352 2460 3331) anzumelden.

Vontobel Exchange Traded Structured Fund
DER VERWALTUNGSRAT

Référence de publication: 2009058674/584/30.

Datogon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 127.767.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 04.05.2009

Es wird beschlossen, PricewaterhouseCoopers S.àr.l., mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, zum Kom-

missar für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 4. Mai 2009.

Datogon S.A.
Wolfgang Dürr / Paul Diederich

Référence de publication: 2009056605/14.
(090067952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

49013

Varama Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 73.091.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>28 mai 2009 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009053077/802/17.

Millicom International Cellular S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 40.630.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

("2009 AGM") of the shareholders of MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. ("Millicom") is convened to be

held at the Château de Septfontaines, 330, rue de Rollingergrund, Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg, on
Tuesday, <i>26 May 2009 at 4.00 p.m. Central European Time ("CET"), to consider and vote on the following resolutions:

<i>Agenda:

1. To acknowledge the delegation by the Chairman of the Board of Directors of the duty to preside the 2009 AGM.
2. To elect the Secretary and the Scrutineer of the 2009 AGM.
3. To receive the Directors' Report (Rapport de Gestion) and the Report of the external auditor on the consolidated

and parent company (Millicom) accounts at 31 December 2008.

4. To approve the consolidated accounts and the parent company (Millicom) accounts for the year ended 31 De-

cember 2008.

5. To allocate the results of the year ended 31 December 2008. On a parent company basis, Millicom generated a

profit of USD 1,383,410,071 for the year ended 31 December 2008. Of this amount, USD 880,366 is proposed to
be allocated to the legal reserve in accordance with the requirements of the Luxembourg Law on commercial
companies  dated  10  August  1915,  as  amended  (the  "1915  Law")  and  the  remaining  part  of  the  profit  of  USD
1,382,529,705 is proposed to be carried forward.

6. To discharge all the current directors of Millicom for the performance of their mandate during the year ended 31

December 2008.

7. To set the number of Directors at 7 Directors.
8. To re-elect Mr. Kent Atkinson as Director for a term ending on the day of the annual general meeting to take place

in 2010 (the "2010 AGM").

9. To re-elect Ms. Maria Brunell Livfors as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.

10. To re-elect Ms. Donna Cordner as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
11. To re-elect Mr. Daniel Johannesson as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
12. To re-elect Mr. Michel Massart as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
13. To re-elect Mr. Allen Sangines-Krause as Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
14. To elect Mr. Paul Donovan as a new Director for a term ending on the day of the 2010 AGM.
15. To re-elect PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg as the external auditor of Millicom for a term ending on

the day of the 2010 AGM.

16. To approve the Directors' fee-based compensation for the period from the 2009 AGM to the 2010 AGM and

share-based compensation from the period from the 2009 AGM to the 2010 AGM, such shares to be issued within
Millicom's authorised share capital exclusively in exchange for the allocation from the premium reserve i.e. for nil
consideration from the relevant Directors.

49014

17. (a) To authorise the Board of Directors, at any time between 26 May 2009 and the day of the 2010 AGM, provided

the required levels of distributable reserves are met by Millicom at that time, to engage in a share repurchase plan
of Millicom's shares (the "Share Repurchase Plan"), either directly or through a subsidiary or a third party, using its
available cash reserves in an amount not exceeding the lower of (i) ten percent (10%) of Millicom's issued and
outstanding share capital as of the date of the 2009 AGM (i.e., approximating a maximum of 10,800,000 shares
corresponding to USD 16,200,000 in nominal value) or (ii) the then available amount of Millicom's distributable
reserves on a parent company basis, in the open market on NASDAQ and OMX Nordic Exchange Stockholm AB,
at an acquisition price which may not be less than USD 5 per share nor exceed the higher of (x) the published bid
that is the highest current independent published bid on a given date or (y) the last independent transaction price
quoted or reported in the consolidated system on the same date, regardless of the market or exchange involved.
(b) To approve the Board of Directors' decision to give joint authority to Millicom's Chief Executive Officer and
the Chairman of the Board of Directors to (i) decide, within the limits of the authorisation set out in (a) above, the
timing and conditions of any Millicom's Share Repurchase Plan according to market conditions and (ii) give mandate
on behalf of Millicom to one or more designated broker-dealers to implement a Share Repurchase Plan.
(c) To authorise Millicom, at the discretion of the Board of Directors, in the event the Share Repurchase Plan is
done through a subsidiary or a third party, to (a) purchase the bought back Millicom shares from such subsidiary
or third party, (b) pay the bought back Millicom shares using either distributable reserves or funds from its share
premium account, (c) transfer all or part of the purchased Millicom shares to employees of the Millicom Group in
connection with any existing or future Millicom long-term incentive plan, and/or (d) use the purchased shares as
consideration for merger and acquisition purposes, including joint ventures and the buy-out of minority interests
in Millicom's subsidiaries, as the case may be, in accordance with the limits set out in articles 49-2, 49-3, 49-4, 49-5
and 49-6 of the 1915 Law.
(d) To further grant all powers to the Board of Directors with the option of sub-delegation to implement the above
authorisation, conclude all agreements, carry out all formalities and make all declarations with regard to all autho-
rities  and,  generally,  do  all  that  is  necessary  for  the  execution  of  any  decisions  made  in  connection  with  this
authorization.

NOTES REGARDING THE NOTICE
CHAIRMAN OF THE MEETING (2009 AGM - item 1)
Pursuant to paragraph 8 of Millicom's Articles, the Chairman of the Board of Directors delegates the duty of presiding

the 2009 AGM to Mr. Jean-Michel Schmit, attorney at law (avocat à la Cour), having his offices in Luxembourg-City.

ELECTION OF THE SECRETARY AND SCRUTINEER (2009 AGM - item 2)
It is proposed that Ms. Candida Gillespie, employee of Millicom, is elected Scrutineer and Mr. Lars Swenningsson, also

employee of Millicom, is elected Secretary of the 2009 AGM.

ELECTION OF THE DIRECTORS (2009 AGM - item 8-14)
The Nominations Committee proposes that, until the 2010 AGM, Mr. Kent Atkinson, Ms. Maria Brunell Livfors, Ms.

Donna Cordner, Mr. Daniel Johannesson, Mr. Michel Massart and Mr. Allen Sangines-Krausen be re-elected as Directors
of Millicom and that Mr. Paul Donovan be elected as new Director of Millicom.

Mr. Paul Donovan, born 1958, has significant telecom management and senior leadership experience from several

markets in the world, including Asia Pacific and Africa.

Mr. Donovan's most recent executive position was Chief Executive, EMAPA Region for the Vodafone Group which

he held until 2008.

Mr. Donovan's background includes a decade in fast moving consumer goods before he moved into the technology

sector, principally with BT and Vodafone.

His career with Vodafone started 10 years ago and for the last five years, he has overseen Vodafone's operations in

subsidiaries in Eastern Europe, Middle East and Asia Pacific. Africa, the US, India and China were added to his remit in
2006. As part of his role, he sat on the boards of numerous subsidiaries and joint ventures during this period.

He holds a BA (with Honors) from University College, London and an MBA from the Bradford University Management

Centre with a specialization in Finance and Business Policy.

He presently does not have any other board assignments.
Mr. Donovan would qualify as an "independent" director of Millicom as defined in the NASDAQ Stock Market, Inc.

Marketplace Rules.

A more detailed description of Mr. Donovan's background can be found on Millicom's web page (www.millicom.com)

under "AGM 2009".

ELECTION OF THE AUDITOR (2009 AGM - item 15)
The Board of Directors, supported by the Audit Committee, proposes that PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxem-

bourg, be re-elected as external auditor for a term ending at the 2010 AGM.

DIRECTORS' FEES (2009 AGM - item 16)

49015

The Nominations Committee proposes a total of EUR 343,500 as fee-based compensation for the seven Directors

expected to serve from the 2009 AGM to the 2010 AGM with such total amount to be split between the Directors in
accordance with a key proposed by the Nominations Committee.

The Nominations Committee also proposes share-based compensation for the period from the 2009 AGM to the

2010 AGM in the form of fully paid-up shares of Millicom common stock. The number of shares issued to the Chairman
of the Board of Directors to be USD 82,500 divided by the Millicom share closing price on NASDAQ on the 2009 AGM
date provided that shares shall not be issued below the par value. The number of shares issued to each of the six other
Directors to be USD 50,000 divided by the Millicom share closing price on NASDAQ on the 2009 AGM date provided
that shares shall not be issued below the par value.

In respect of Directors who did not serve an entire term, the share-based compensation will be pro-rated pro rata

temporis.

SHARE REPURCHASE PLAN (2009 AGM - item 17)
The Board of Directors of Millicom proposes that the meeting approve a Share Repurchase Plan and authorises the

Board of Directors of Millicom, with the option to delegate, to acquire and dispose of the Millicom's shares under the
abovementioned Share Repurchase Plan as further detailed below.

a) Objectives:
The Share Repurchase Plan will be carried out for all purposes allowed or which would become authorised by the

laws and regulations in force, and in particular the 1915 Law and in accordance with the objectives, conditions, and
restrictions as provided by the European Commission Regulation No. 2273/2003 of 22 December 2003.

The purpose of the Share Repurchase Plan will be in particular to reduce the Millicom's share capital (in value or in

number of the shares) or to meet obligations arising from any of the following:

(a) debt financial instruments exchangeable into equity instruments;
(b) employee share option programmes or other allocations of shares to employees of the issuer or of an associate

company;

(c) consideration for merger and acquisition purposes.
The transactions over the shares under the Share Repurchase Plan may be carried out by any means, on or off the

market or by the use of derivative financial instruments, listed on a regulated stock exchange or transacted by mutual
agreement subject to all applicable laws and stock exchange regulations.

b) Maximum proportion of the share capital that may be repurchased
- The maximum aggregate number of shares authorised to be purchased is an amount not exceeding the lower of (i)

ten percent (10%) of Millicom's issued and outstanding share capital as of the date of the 2009 AGM (i.e., approximating
a maximum of 10,800,000 shares corresponding to USD 16,200,000 in nominal value) or (ii) the then available amount
of  Millicom's  distributable  reserves  on  a  parent  company  basis  in  the  open  market  on  NASDAQ  and  OMX  Nordic
Exchange Stockholm AB. The nominal value or, in the absence thereof, the accountable par of the acquired shares,
including shares previously acquired by Millicom and held by it (including the stakes held by other group companies
referred to in Article 49bis of the 1915 Law), and shares acquired by a person acting in his own name but on Millicom's
behalf, may not exceed ten percent (10%) of the issued share capital it being specified that (i) such limit applies to a number
of shares that shall be, as necessary, adjusted in order to take into account transactions affecting the share capital following
the 2009 AGM as further detailed under c) below (ii) that the acquisitions carried out by Millicom may in no event cause
it to hold, directly or indirectly, more than ten percent (10%) of the share capital, (iii) the aggregate amount that Millicom
may assign to the buyback of its own shares shall be set in accordance with the provisions of the 1915 Law.

- The acquisitions may not have the effect of reducing Millicom's net assets below the amount of the subscribed share

capital plus those reserves, which may not be distributed under law or Millicom's Articles.

- Only fully paid-up shares may be included in the transactions.

c) Price and volume considerations
The minimum and maximum purchase prices at which the Company may repurchase respectively its shares to be set

at:

- Minimum repurchase price: USD 5
- Maximum repurchase price not to exceed the higher of: (x) the published bid that is the highest current independent

published bid on a given date or (y) the last independent transaction price quoted or reported in the consolidated system
on the same date, regardless of the market or exchange involved.

The 2009 AGM grants all powers to the Board of Directors to proceed with unit price adjustments and the maximum

number of securities to be acquired in proportion to the variation in the number of shares or their nominal value resulting
from possible financial operations by Millicom such as but not limited to capital increase by incorporation of reserves and
free allocation of shares or in case of splitting or regrouping of shares et sq.

Any transaction undertaken by Millicom under the Share Repurchase Plan as to price and volume will be undertaken

in accordance with all legal requirements, including those of the European Commission Regulation No. 2273/2003 of 22

49016

December 2003 or any accepted market practices as defined under the Directive 2003/6/EC dated 28 January 2003 on
insider dealing and market manipulation and recognized by the Swedish competent authority for the purposes of the
abovementioned Directive.

d) Duration
Such a Share Repurchase Plan will start no earlier than 26 May 2009, and end no later than at the earliest of (i) the

next AGM to take place in 2010, (ii) the moment on which the aggregate value of shares repurchased by Millicom since
the start of this Share Repurchase Plan reaches the limits indicated under (b) above; (iii) the moment on which Millicom'
shareholding (including the stakes held by other group companies referred to in Article 49bis of the 1915 Law and shares
acquired by a person acting in his own name but on Millicom's behalf) reaches 10 per cent of the subscribed share capital
in accordance with article 49-2 (1) of the 1915 Law or (iv) within eighteen months as of the date of the 2009 AGM.

QUORUM AND MAJORITY
There is no quorum of presence requirement for the 2009 AGM. The 2009 AGM agenda items are adopted by a simple

majority of the shares present or represented.

OTHER INFORMATION
Millicom has issued 108,046,548 outstanding shares with a nominal value of USD 1.50 and with one vote attached to

each such share.

Millicom's consolidated accounts and the parent company (Millicom) accounts as at and for the year ended 31 De-

cember 2008, as well as the Directors' Report and the Report of the external auditor, will be available from 11 May 2009
at Millicom's registered office and copies available upon request by e-mail to: information@millicom.com.

Participation in the 2009 AGM is reserved to shareholders who (i) are registered in the shareholders' register kept

by Millicom and/or Euroclear Sweden AB (Formerly VPC AB) and/or AST as of Tuesday, 19 May 2009, and (ii) give notice
of their intention to attend the 2009 AGM by mail or return a duly completed power of attorney form so that it is received
at Millicom's registered office no later than Friday, 22 May 2009, 5:00 p.m. CET. Forms are available on Millicom's website
(www.millicom.com)  or  upon  request  at  Millicom's  registered  office,  at  the  following  address  and  contact  numbers:
Millicom International Cellular S.A., 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg, attention: Cândida Gillespie,
telephone: + 352 27 759 702, fax: + 352 27 759 353. The shares of any holder who wishes to attend the 2009 AGM will
not be transferable between May 19, 2009 and the date of the AGM.

Shareholders holding their shares through a third party such as a broker or bank and wishing to attend the AGM or

to be represented at the AGM by power of attorney may have to contact such third party in order to exercise their
shareholder's rights at the AGM.

Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend the 2009 AGM or to be represented at the AGM by power

of attorney have to give notice to, and request a power of attorney form from, HQ Bank AB, with mailing address: 103
71 Stockholm, Sweden, and visiting address: Hovslagargatan 3, Stockholm, Sweden, telephone: + 46 8 463 85 00, or
download it from Millicom's website (www.millicom.com) and send it duly completed to HQ Bank AB at the address
indicated above, so that it is received no later than 5:00 p.m. CET on Friday, 22 May 2009. Holders of Swedish Depository
Receipts having registered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily register the
Swedish Depository Receipts in their own name in the records maintained by Euroclear Sweden AB (Formerly VPC AB)
in order to exercise their shareholders' rights at the 2009 AGM. Such registration must be completed no later than
Tuesday, 19 May 2009.

May 2009.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009053383/10005/195.

Metro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 73.790.

Convening notice is hereby given to the shareholders of Metro to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Metro's shareholders (the "AGM") that will be held on <i>26 May 2009 at 5:00 p.m. CET at Château de Septfontaines,

330, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Election of Chairman of the AGM.
2. Presentation of the reports of the board of directors of Metro and of the external auditor of Metro on (i) the

annual accounts of Metro for the financial year ended 31 December 2008 and (ii) the consolidated annual accounts
for the financial year ended 31 December 2008.

3. Approval of the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2008.

49017

4. Allocation of the results as of 31 December 2008.
5. Discharge of the liability of the members of the board of directors of Metro for, and in connection with, the financial

year ended 31 December 2008.

6. Appointment of the members of the board of directors of Metro.
7. Appointment of the external auditor of Metro.
8. Determination of the directors' fees.
9. Approval of the procedure for the Nomination Committee of Metro.

10. Miscellaneous.

INFORMATION

ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING (AGM item 1)
The Nomination Committee proposes that the attorney at law (avocat à la Cour), Christian Kremer, be elected

Chairman of the AGM.

ALLOCATION OF THE RESULTS AS OF 31 DECEMBER 2008 (AGM item 4)
The board of directors of Metro acknowledges that the profit and loss account for the period starting January 1, 2008

and ending December 31, 2008 shows a loss and decides to propose to the AGM the allocation of the loss to the losses
carried forward account.

APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF METRO (AGM item 6)
The Nomination Committee proposes that, until the close of the annual general meeting of the shareholders of the

Company to take place in 2010 (the "2010 AGM"), Ms Mia Brunell Livfors, Mr Nigel Cooper, Mr Henry Guy, Mr Mario
Queiroz and Ms Cristina Stenbeck, be re-appointed directors of Metro and that Mr Didier Breton and Mr Erik Mitteregger
be elected directors of Metro.

Mr Didier Breton, born in 1953, is a member of the senior team of Pamoja Capital, a private equity business founded

in 2006 that creates value through long-term, socially-responsible, global investments across a number of industry sectors,
and he is responsible for the operations relating to the investee companies of Pamoja Capital. Previously, Didier was the
Chief Operating Officer of Trader Classified Media, one of the largest classified advertising companies in the world, a
position he held from 2000 until the company was sold in 2006 for €1.3bn. Prior to joining Trader, Didier was President
of the Infrastructure &amp; Systems Division at Groupe Bull. His previous roles include managing international operations at
Hewlett Packard and Valeo. He holds an MBA from the Institut Supérieur des Affaires and an Engineering degree from
ICAM. Didier is a French national.

Mr Erik Mitteregger, born in 1960, is a member of the board of Investment AB Kinnevik since 2004. Erik also serves

as Chairman of the board of Wise Group AB, and is a member of the board of Firefly AB. Erik has been Head of Equity
Research and member of the Management Board at Alfred Berg Fondkommission 1989-1995. He has also been founding
partner and fund manager at Brummer &amp; Partners Kapitalförvaltning AB 1995-2002. Erik holds a degree in Business
Administration from Stockholm School of Economics. Erik is a Swedish national.

The Nomination Committee further proposes that Ms Mia Brunell Livfors be appointed as the Chairman of the board

of directors of Metro, and that a Remuneration Committee and an Audit Committee are appointed at a board meeting
following the AGM.

APPOINTMENT OF THE EXTERNAL AUDITOR OF METRO (AGM item 7)
As recommended by the Audit Committee, the Nomination Committee proposes that KPMG Audit Sàrl, Luxembourg

be re-appointed as external auditor for a term ending at the 2010 AGM. The remuneration of the auditor shall be paid
in accordance with an approved bill, which specifies time, persons who worked and tasks performed.

DETERMINATION OF DIRECTORS' FEES (AGM item 8)
The Nomination Committee proposes that the AGM resolves that the fees for the members of the board of directors

of Metro (including remuneration for the work in the committees of the board of directors Metro) for the period until
the end of the 2010 AGM be a total of EUR 294,500 and with such amount to be split as follows: the Chairman of the
board of directors of Metro, fees in an amount of EUR 65,000 (whereof EUR 32,500 in cash and 32,500 in shares of
Metro); each of the six ordinary directors of the board of directors of Metro, fees in an amount of EUR 32,500 (whereof
EUR 16,250 in cash and 16,250 in shares of Metro); and in total EUR 34,500 as remuneration for the work within the
Audit Committee and the Remuneration Committee. The Nomination Committee also proposes, for work within the
Audit Committee, fees of EUR 16,000 that shall be allocated to its Chairman and of EUR 4,500 to each of the other
members, and for work within the Remuneration Committee fees of EUR 4,500 that shall be allocated to its Chairman
and of EUR 2,500 to each of the other members.

The Nomination Committee also proposes that the AGM approves an additional remuneration in arrears for the

period from the 2008 AGM to the AGM of EUR 7,000 to the Chairman of the Audit Committee due to the amount of
work and engagement that this committee assignment has required during the period.

The share-based compensation in relation to the period from the AGM to 2010 AGM will take the form of fully paid-

up shares of Metro common stock to be issued within Metro's authorised share capital to the members of the board of

49018

directors of Metro who will serve until the 2010 AGM. The shares shall be issued in equal number of Class A and Class
B shares (or equivalent shares in case of conversion, merger or transaction having the same effect) based on the Class A
and Class B share closing price on the OMX Nordic Exchange Stockholm on the day of the AGM. Such shares shall be
issued subject to a one-year lock-up period as of their respective date of issue.

APPROVAL OF THE PROCEDURE FOR THE NOMINATION COMMITTEE (AGM item 9)
The Nomination Committee proposes that the AGM approves the following procedure for preparation of the election

of the Board of Directors and the auditor of Metro. The work of preparing a proposal on the members of the board of
directors of Metro and the auditor of Metro, and their remuneration, as well as the proposal on the Chairman of the
2010 AGM shall be performed by a Nomination Committee. The Nomination Committee will be formed during October
2009 in consultation with the largest shareholders of Metro as at September 30, 2009. The Nomination Committee will
consist of at least three members representing the larger shareholders of Metro. The Nomination Committee is appointed
for a term of office commencing at the time of the announcement of the third quarter report in 2009 and ending when
a new Nomination Committee is formed. The majority of the members of the Committee may not be directors of the
Board of Directors or employed by Metro. If a member of the Committee resigns during the Nomination Committee
term before the work is concluded, a replacement member can be appointed in the corresponding manner. A represen-
tative of the largest shareholder at the time of the announcement will be a member of the Committee and will also act
as its convenor. The members of the Committee will appoint the Committee Chairman at their first meeting. The No-
mination Committee shall have the right to upon request receive personnel resources such as secretarial services from
Metro, and to charge Metro with costs for recruitment consultants if deemed necessary.

The above proposals of the Nomination Committee are supported by shareholders representing more than 50% of

the votes in Metro including among others Investment AB Kinnevik, Emesco AB, Fjärde AP-fonden and Orkla ASA.

QUORUM AND MAJORITY

The share capital of Metro is composed of 264,385,212 Class A voting shares and 263,427,379 Class B non-voting

shares. No specific quorum is required for the indication of the valid deliberation or acknowledgement of the AGM. The
resolutions will be validly adopted at a simple majority of the votes cast by the Class A shareholders.

OTHER INFORMATION

Participation in the AGM is reserved for shareholders who file their intention to attend the AGM by mail and/or return

of a duly completed power of attorney form to the following address: Metro International S.A., 2-4, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg, Tel: +352 - 27 751 350, Fax: + 352 - 27 751 312, so that it shall be received not later than Friday,
22 May 2009, 5.00 p.m. CET. Power of attorney forms for the AGM are available at the same address and on the Metro's
website, www.metro.lu.

Holders of Swedish Depository Receipts (SDRs) wishing to attend the AGM or to be represented at the AGM via

power of attorney must give notice to and request a power of attorney form from HQ Bank AB, with mailing address:
Box 16027, SE-103 21 Stockholm, Sweden, and visiting address: Hovslagargatan 3 Stockholm, Sweden, Tel: +46 - 8 463
85 00. Holders of SDRs wanting to be represented at the AGM have to send the power of attorney duly completed to
HQ Bank AB at the same address, so that it shall be received not later than Friday, 22 May 2009, 5.00 p.m. CET.

Those holders of SDRs having registered their SDRs in the name of a nominee must temporarily register the SDRs in

their  own  name  in  the  records  maintained  by  Euroclear  Sweden  AB  (formerly  VPC  AB),  in  order  to  exercise  their
shareholders' rights at the AGM. Such registration must be completed no later than Tuesday, 19 May 2009, 5.00 p.m.
CET.

Power of attorney forms for the AGM can also be found on Metro's website, www.metro.lu and on HQ Bank AB's

website, www.hq.se.

Luxembourg, on 7 May 2009.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009054199/1092/117.

Bersy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 55.219.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 mai 2009 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Presentation and approval of the annual accounts of the Company for the year ended December 31, 2008 and of

the report of the statutory auditor;

2. Allocation of the results;

49019

3. Discharge of the Board of Directors and Statutory Auditor for the accounting year ended December 31, 2008;
4. Statutory elections;
5. Miscellaneous.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009054695/581/17.

Transcom WorldWide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Luxembourg, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 59.528.

I/ Annual General Meeting of the Shareholders

Convening notice is hereby given to the shareholders of Transcom to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Transcom's shareholders (the "AGM") that will be held on <i>26 May 2009, at 3.00 p.m. CET at Château de

Septfontaines, 330, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg, which will have the following agenda:

<i>Agenda:

1. Election of Chairman of the AGM.
2. Presentation of the reports of the board of directors of Transcom and of the external auditor of Transcom on (i)

the annual accounts of Transcom for the financial year ended 31 December 2008 and (ii) the consolidated annual
accounts for the financial year ended 31 December 2008.

3. Approval of the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2008.
4. Allocation of the results as of 31 December 2008.
5. Discharge of the liability of the members of the board of directors of Transcom for, and in connection with, the

financial year ended 31 December 2008.

6. Appointment of the members of the board of directors of Transcom.
7. Appointment of the external auditor of Transcom.
8. Determination of the directors' fees.
9. Approval of the procedure of the Nomination Committee of Transcom.

10. Approval of the share repurchase plan of Transcom (the "Share Repurchase Plan").
11. Miscellaneous.

INFORMATION

ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING (AGM item 1)
The Nomination Committee proposes that the attorney at law (avocat à la Cour), Christian Kremer, be elected

Chairman of the AGM.

ALLOCATION OF THE RESULTS AS OF 31 DECEMBER 2008 (AGM item 4)
The Board acknowledges that the profit and loss account for the period starting January 1, 2008 and ending December

31, 2008 shows a loss of EUR 1,975,502 and decides to propose to the AGM the allocation of such results to the profits
carried forward account.

APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TRANSCOM (AGM item 6)
The Nomination Committee proposes that, until the end of the annual general meeting to be held in 2010 (the "2010

AGM"), the number of directors of Transcom will be set at 7 directors. The Nomination Committee proposes (i) to re-
elect Mr James Beers, Ms Mia Brunell Livfors, Ms Sandra Frimann-Clausen, Ms Torun Litzén, Mr Roel Louwhoff and Mr
William Walker as directors of Transcom, and (ii) to elect Mr Henning Boysen as new director of Transcom.

Henning Boysen, born in 1946, is an experienced international executive with significant operational experience of the

travel industry. Henning is currently Chairman of Kuoni, one of Europe's leading leisure travel companies. He has been
Chairman since 2006 having joined the Board in 2003. He is also Chairman of Global Refund Group, a market leading
supplier of financial services for the merchant market in their interactions with foreign customers, and Apodan Nordic,
a Danish-based supplier and distributor of products primarily to the Scandinavian public healthcare sector. Previously,
Henning was President and CEO of Gate Gourmet between 1996 and 2004. During this period he transformed Gate
Gourmet from a mid-sized European company into a truly global organisation before selling the business to Texas Pacific
Group. Before becoming President and CEO he held leadership roles in a number of the company's subsidiaries. Before
joining Gate Gourmet, Henning was COO and Deputy President of Saudia Catering in Saudi Arabia between 1988 and
1992 and before that he held a succession of increasingly senior management positions with SAS Service Partner A/S
between 1974 and 1988. He began his career with Booz Allen Hamilton as a management consultant. Henning holds a
Masters in Economics from Aarhus University, Denmark. Henning is a Danish national.

49020

The Nomination Committee further proposes that the board of directors of Transcom appoints Mr William Walker

to be Chairman of the board of directors of Transcom, and that a Remuneration Committee and an Audit Committee
are appointed at a board meeting following the AGM.

APPOINTMENT OF THE EXTERNAL AUDITOR OF TRANSCOM (AGM item 7)
As recommended by the Audit Committee, the Nomination Committee proposes that Ernst &amp; Young S.A., Luxem-

bourg be re-appointed as external auditor for a term ending at the 2010 AGM. The remuneration of the auditor shall be
paid in accordance with an approved bill which specifies time, persons who worked and tasks performed.

DIRECTORS' FEES (AGM item 8)
The Nomination Committee proposes that the meeting resolves that the fees for the members of the board of di-

rectors of Transcom (including remuneration for the work in the committees of the board of directors of Transcom) for
the period until the end of the 2010 AGM be a total of EUR 359,500 and with such amount to be split as follows: Mr.
William Walker, Chairman of the board of directors of Transcom, fees in an amount of EUR 90,000 (whereof EUR 45,000
in cash and 45,000 in shares of Transcom) and the six directors of Transcom, fees in the amount of EUR 40,000 (whereof
EUR 20,000 in cash and 20,000 in shares of Transcom) for each; and remuneration for the work in the committees of
the board of directors of Transcom shall be a total of EUR 29,500. For the work of the Audit Committee, fees of EUR
20,000 will be split as follows: EUR 10,000 for the Chairman of the Audit Committee and EUR 5,000 for each of the two
Audit Committee members. For the work of the Remuneration Committee, fees of EUR 9,500 will be split as follows:
EUR 4,500 to the Chairman of the Remuneration Committee and EUR 2,500 for each of the two Remuneration Com-
mittee members.

The share-based compensation in relation to the period from AGM and the 2010 AGM will take the form of fully paid-

up shares of the Transcom common stock to be issued within the Transcom's authorised share capital to the directors
of Transcom who will serve until the 2010 AGM. The number of shares issued to the Chairman will be EUR 45,000
divided by the Transcom share closing price on the NASDAQ OMX Stockholm on the day of the AGM provided that
shares shall not be issued below the par value. The shares shall be issued in equal number of Class A and Class B shares
based on the Class A and Class B share closing price on the NASDAQ OMX Stockholm on the day of the AGM. Such
shares shall be issued subject to a one-year lock-up period as of their respective date of issue.

APPROVAL OF THE PROCEDURE FOR THE NOMINATION COMMITTEE (AGM item 9)
The Nomination Committee proposes that the AGM approves the following procedure for preparation of the election

of the board of directors and auditor of Transcom. The work of preparing a proposal on the directors of the board and
auditor, and their remuneration, as well as the proposal on the Chairman of the 2010 AGM shall be performed by a
Nomination Committee. The Nomination Committee will be formed during October 2009 in consultation with the largest
shareholders of Transcom as at September 30, 2009. The Nomination Committee will consist of at least three members
representing the larger shareholders of Transcom. The Nomination Committee is appointed for a term of office com-
mencing at the time of the announcement of the third quarter report in 2009 and ending when a new Nomination
Committee is formed. The majority of the members of the Committee may not be directors of the board of directors
or employed by Transcom. If a member of the Committee resigns during the Nomination Committee term before the
work is concluded, a replacement member can be appointed in the corresponding manner. A representative of the largest
shareholder at the time of the announcement will be a member of the Committee and will also act as its convenor. The
members of the Committee will appoint the Committee Chairman at their first meeting. The Nomination Committee
shall have the right to upon request receive personnel resources such as secretarial services from Transcom, and to
charge Transcom with costs for recruitment consultants if deemed necessary.

The above proposals of the Nomination Committee are supported by shareholders representing more than 50% of

the votes in Transcom including among others Investment AB Kinnevik, Emesco AB, Swedbank Robur fonder, Catella
fonder and Fjärde AP-fonden.

APPROVAL OF THE SHARE REPURCHASE PLAN (AGM item 10)
The board of directors of Transcom proposes to the meeting to approve the Share Repurchase Plan and to authorise

the board of directors of Transcom, with the option to delegate, to acquire and dispose of the Transcom's Class A voting
shares and Class B non-voting shares under the abovementioned Share Repurchase Plan as further detailed below.

a) Objectives:
The Share Repurchase Plan will be carried out for all purposes allowed or which would become authorised by the

laws and regulations in force, and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
"1915 Law") and in accordance with the objectives, conditions, and restrictions as provided by the European Commission
Regulation No. 2273/2003 of 22 December 2003.

The purpose of the Share Repurchase Plan will be in particular to reduce the Transcom's share capital (in value or in

number of Class A shares and/or Class B shares) or to meet obligations arising from any of the following:

(a) debt financial instruments exchangeable into equity instruments;
(b) employee share option programmes or other allocations of shares to employees of the issuer or of an associate

company.

49021

The transactions over the Class A and/or Class B shares under the Share Repurchase Plan may be carried out by any

means, on or off the market or by the use of derivative financial instruments, listed on a regulated stock exchange or
transacted by mutual agreement subject to all applicable laws and stock exchange regulations.

b) Maximum proportion of the share capital that may be repurchased
- The maximum aggregate number of shares authorised to be purchased is up to 3,662,631 Class A shares and 3,662,341

Class B shares respectively but such numbers being capped at 10% of the issued and outstanding share capital as of the
date of the AGM it being specified that (i) such limit applies to a number of shares that shall be, as necessary, adjusted in
order to take into account transactions affecting the share capital following this AGM as further detailed under c) below
(ii) that the acquisitions carried out by Transcom may in no event cause it to hold, directly or indirectly, more than 10%
of the share capital, (iii) the aggregate amount that Transcom may assign to the buyback of its own shares shall be set in
accordance with the provisions of the 1915 Law.

- The acquisitions may not have the effect of reducing the Transcom's net assets below the amount of the subscribed

capital plus those reserves, which may not be distributed under law or the Articles.

- Only fully paid-up Class A Shares and Class B Shares may be included in the transactions.

c) Price and volume considerations
The minimum and maximum purchase prices at which Transcom may repurchase respectively its Class A shares and

its Class B shares at mid market price within the share price quoted on the NASDAQ OMX Stockholm, where share
price interval means the difference between the highest buying price and lowest selling price as of the date preceding the
buy back and subject to the terms of this Share Repurchase Plan.

d) Duration
The Share Repurchase Plan will start no earlier than 27 May 2009 and end no later than at the earliest of (i) the 2010

AGM, (ii) the moment on which the aggregate par value of Class A shares and Class B shares repurchased by Transcom
since the start of this Share Repurchase Plan reaches EUR 3,145,760 (iii) the moment on which Transcom' shareholding
(including the stakes held by other group companies referred to in article 49bis of the 1915 Law and shares acquired by
a person acting in his own name but on the Transcom's behalf) reaches 10 per cent of the subscribed share capital in
accordance with article 49-2 (1) of the 1915 Law or (iv) within eighteen months as of the date of the AGM.

The meeting further grants all powers to the board of directors of Transcom with the option of sub-delegation to

implement the present authorisation, conclude all agreements, carry out all formalities and make all declarations with
regard to all authorities and, generally, do all that is necessary for the execution of any decisions made in connection with
this authorisation. The board of directors of Transcom shall inform the shareholders of Transcom of any transactions
performed in accordance with applicable regulations.

QUORUM AND MAJORITY

The share capital of Transcom is composed of thirty-six millions six hundred twenty-six thousand three hundred

fourteen (36,626,314) Class A voting shares and thirty six millions six hundred twenty-three thousand four hundred
thirteen (36,623,413) Class B non-voting shares. No specific quorum is required for the indication of the valid deliberation
or acknowledgement of the AGM. The resolutions will be validly adopted at a simple majority of the votes cast by the
Class A shareholders.

II/ Extraordinary General Meeting of the Shareholders

Convening notice is hereby given to the shareholders of Transcom to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Transcom's shareholders (the "EGM") that will be held on <i>26 May 2009 , immediately after the AGM, in front

of a Luxembourg public notary, in order to amend the articles of association of Transcom (the "Articles"), which will have
the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to fix the nominal value of the shares in Transcom to EUR 0.43 (forty-three cents) per each Class A and

Class B share and for that purpose, reduce the value of the share capital of Transcom by an amount of two hundred
fifty-one thousand eight hundred ninety-six Euro and two cents (EUR 251,896.02), without cancellation of any share
and without any reimbursement to the shareholders of Transcom, so that the share capital of Transcom will amount
to thirty one million four hundred ninety-seven thousand three hundred eighty-two Euro sixty-one cents (EUR
31,497,382.61),  divided  into  thirty  six  millions  six  hundred  twenty-six  thousand  three  hundred  fourteen
(36,626,314) Class A voting shares, each with a nominal value of EUR 0.43 (forty-three cents) and thirty six millions
six hundred twenty-three thousand four hundred thirteen (36,623,413) Class B non-voting shares, each with no-
minal value of EUR 0.43 (forty-three cents).

2. Decision to allocate the amount of two hundred fifty-one thousand eight hundred ninety-six Euro and two cents

(EUR 251,896.02), resulting from the above share capital value decrease, to the foreign exchange reserve of Trans-
com.

49022

As a consequence of the above-mentioned decisions, the first and the second paragraphs of article 5 of the Articles
shall read as follows:
"The Company has an issued capital of thirty one million four hundred ninety-seven thousand three hundred eighty-
two Euro sixty-one cents (EUR 31,497,382.61), divided into thirty six millions six hundred twenty-six thousand
three hundred fourteen (36,626,314) Class A voting shares, each with a nominal value of EUR 0.43 (forty-three
cents) and thirty six millions six hundred twenty-three thousand four hundred thirteen (36,623,413) Class B non-
voting shares, each with nominal value of EUR 0.43 (forty-three cents) all shares being fully paid-in.
The authorised share capital is set at six hundred fifty-two million seven hundred ninety-three thousand four hun-
dred Euro (EUR 652,793,400) divided into eight hundred million (800,000,000) Class A voting shares and seven
hundred and fifty million (750,000,000) Class B non-voting shares, each with a nominal value of EUR 0.43 (forty-
three cents)."

3. Decision to amend and restate the first paragraph of article 17 of the Articles.

As a consequence of the above mentioned decision, the first paragraph of article 17 of the Articles shall read as
follows:
"The annual general meeting will be held in the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Wednesday of May
of each year, at 10 a.m.."

4. Decision to add a new paragraph at the end of the Articles.

As a consequence of the above mentioned decision, the latest paragraph of the Articles shall read as follows:
«In case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.»

5. Decision to amend and restate the third paragraph of article 21 of the French version of the Articles in order to

comply it with article 21 of the English version of the Articles.
As a consequence of the above mentioned decision, the third paragraph of article 21 of the French version of the
Articles shall read as follows:
«Les actionnaires de Classe B auront droit à la plus grande des valeurs entre (i) un dividende préférentiel cumulatif
correspondant à 0.5% de la valeur nominale comptable des actions de Classe B dans la Société et (ii) 2% du montant
global des dividendes versés endéans une année.»

6. Decision to renew the authorised share capital in the Articles for a period ending on 26 May 2014 with authorisation

to the board of directors to cancel or limit the preferential subscription rights of the shareholders.
As a consequence, the second and the subsequent paragraphs of article 5 of the Articles shall read as follows:
«The authorised share capital is set at six hundred sixty-six million five hundred thousand Euro (EUR 666,500,000)
divided  into  eight  hundred  million  (800,000,000)  Class  A  voting  shares  and  seven  hundred  and  fifty  million
(750,000,000) Class B non-voting shares, each with a nominal value of EUR 0.43 (forty-three cents).
The board of directors is authorised and empowered to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive
tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other
manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of
the subscription of and paying up of the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue of shares against payment
in cash.

This authorisation is valid for a period expiring 5 (five) years after 26 May 2009 and it may be renewed by a general

meeting of shareholders for those shares of the authorised corporate capital which up to then will have not been issued
by the board of directors.

Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first

paragraph of Article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic
form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose."

Presentation of the special report of the board of directors of Transcom issued in accordance with Article 32-3 (5)

of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Law") to waive and, to the extent appro-
priate,  cancel  or  limit  the  preferential  subscription  rights  of  the  shareholders  in  relation  to  the  above-mentioned
authorised share capital of Transcom.

7. Miscellaneous.

QUORUM AND MAJORITY

The share capital of Transcom is composed of thirty-six millions six hundred twenty-six thousand three hundred

fourteen (36,626,314) Class A voting shares and thirty six millions six hundred twenty-three thousand four hundred
thirteen (36,623,413) Class B non-voting shares. Considering the decisions to be taken, the EGM shall not validly deliberate
unless at least one half of the Class A shareholders and at least one half of the Class B shareholders are present or
represented. The resolutions at the EGM will only be validly adopted by the favorable vote of a majority of the two thirds
(2/3) of the votes cast by the Class A shareholders and by the favorable vote of a majority of the two thirds (2/3) of the
votes cast by the Class B shareholders.

49023

OTHER INFORMATION

Participation at the AGM/EGM of shareholders is reserved for shareholders who file their intention to attend the

AGM/EGM by mail and/or return a duly completed power of attorney form to the following address: Transcom World-
Wide S.A., 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, Tel: + 352 - 27 755 012, Fax: + 352 - 27
755 007, so that it shall be received not later than Monday, 25 May 2009, 12:00 p.m. CET. Power of attorney forms for
the AGM/EGM are available at the same address and on the Transcom's website, www.transcom.com.

Holders of Swedish Depository Receipts (SDRs) wishing to attend the AGM/EGM or be represented at the AGM/

EGM via power of attorney must give notice to and request a power of attorney form from HQ Bank AB, with mailing
address: Box 16027, SE-103 21 Stockholm, Sweden, and visiting address: Hovslagargatan 5 Stockholm, Sweden, Tel: +46
- 8 463 85 00. Holders of SDRs wanting to be represented at the AGM/EGM have to send the power of attorney duly
completed to HQ Bank AB at the same address, so that it shall be received not later than Thursday, 21 May 2009, 12.00
p.m CET. Those holders of SDRs having registered their SDRs in the name of a nominee must temporarily register the
SDRs in their own name in the records maintained by Euroclear Sweden AB (formerly VPC AB) in order to exercise
their shareholders' rights at the AGM/EGM. Such registration must be completed not later than Tuesday, 19 May 2009,
5.00 p.m CET. Power of attorney forms for the AGM/EGM can also be found on the HQ Bank AB's website, www.hq.se.

Visit our website: www.transcom.com.

Luxembourg, on 8 May 2009,

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009054177/1092/243.

Fuchs Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 93.660.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav FUCHS INVEST à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2009 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009054478/7/20.

QS Italy SICAR S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 106.582.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of QS ITALY SICAR S.A. for the financial year ended on <i>31 December 2008 (the "Meeting") will be held at the registered

office of the Company in Luxembourg, 84, Grand-Rue, on 27 May 2009 at 11:00 a.m. (Luxembourg time) for the purpose
of considering the following agenda :

<i>Agenda:

1. To approve the report of the board of directors (collectively referred to as the "Board", each member being

individually referred to as a "Director") and the report of the independent auditor (the "Auditor") for the financial
year ended on 31 December 2008.

2. To approve the annual accounts for the financial year ended on 31 December 2008.
3. To grant discharge to the Directors with respect to the performance of their respective duties for the financial

year ended on 31 December 2008.

49024

4. To re-appoint the Auditor and the Directors for the period ending on 31 December 2009.
5. To address any other business, which may be properly brought before the Meeting.
The shareholders are advised that no quorum is required to resolve on the items set out in the agenda of the Meeting

and that resolutions will be taken on simple majority of the shares present or represented and favourably voting for such
resolutions at the Meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy form is available at the Company's registered office at 84,

Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (fax: +352 22 60 56).

Proxy forms should be returned to the registered office of the Company to the attention of Jean-Benoît Lachaise

before 05.00 p.m. (Luxembourg time) on May 25, 2009 as further detailed on the proxy form.

<i>For and on behalf of QS ITALY SICAR S.A.
The Board

Référence de publication: 2009054203/260/29.

EDM International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 50.523.

Notice is hereby given to the shareholders, that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of EDM INTERNATIONAL will be held at the offices of RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14,

Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette on <i>May 26, 2009 at 9.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December

31, 2008;

3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and  that  decisions  will  be  taken  on  a  simple  majority  of  the  shares  present  or  represented  at  the  Meeting  with  no
restrictions.

In order to attend the Meeting of EDM INTERNATIONAL the owners of bearer shares will have to deposit their

shares five clear days before the Meeting with Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470
Luxembourg.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009054468/584/25.

G&amp;P Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 111.408.

Die Aktionäre der G&amp;P Invest SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>27. Mai 2009 um 14.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2008 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2008 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Ertragsverwendung
6. Verschiedenes

49025

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der G&amp;P Invest SICAV (DZ BANK

International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4009
angefordert werden.

Luxemburg, im Mai 2009.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009054465/755/30.

Ingenium, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.032.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav INGENIUM à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 mai 2009 à 11.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009054479/7/20.

DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014 III, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 17.03.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil wurde beim Registre de

Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009052756/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08234. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014 III, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 17.03.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de

Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

49026

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009052758/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08232. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

DWS Renten Direkt 2014 III, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 17.03.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil wurde beim Registre de

Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009052767/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08198. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090062125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

DWS Renten Direkt 2014 III, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 17.03.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de

Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009052772/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08195. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090062121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2009.

In Tempo by Luc Leroi, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8460 Eischen, 13A, rue de Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 145.946.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg

Ont comparu:

1) Madame Brigitte BERTRAND, épouse de Monsieur Luc LEROI, employée privée, demeurant à L-8460 Eischen, 13a,

rue de Clairefontaine, née à Sint Truiden (Belgique), le 3 mai 1963, et

2) Monsieur Luc LEROI, employé privé, demeurant à L-8460 Eischen, 13a, rue de Clairefontaine, né à Rocourt (Bel-

gique), le 26 octobre 1965.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le commerce comprenant l'import, l'export, l'achat et la vente de tous articles liés à la

maison et au jardin.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de "In Tempo by Luc Leroi", société à responsabilité limitée.

49027

Art. 5. Le siège social est établi à Eischen.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 100 (cent) parts sociales de EUR

1.000,- (mille euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription et Libération

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1) Monsieur Luc LEROI, prénommé: UNE part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) Madame Brigitte BERTRAND, prénommée: QUATRE-VINGT-DIX-NEUF parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 100.000,- (cent mille euros)

se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

49028

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille neuf.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la Société à raison de sa constitution à EUR 1.200,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale et ont pris à

l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) L'Assemblée désigne comme gérante pour une durée indéterminée:
- Madame Brigitte BERTRAND, prénommée, avec pouvoir de signature individuelle.
En cas de nomination de plusieurs gérants, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.
2) Le gérant pourra nommer des agents, directeurs et fondés de pouvoir et déterminera leurs pouvoirs.
3) Le siège social de la société est fixé à L-8460 Eischen, 13a, rue de Clairefontaine.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. BERTRAND, L. LEROI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 avril 2009. Relation: LAC/2009/15968. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009054255/242/94.
(090064130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Deka International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 28.599.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 04.05.2009

Es wird beschlossen, PricewaterhouseCoopers S.àr.l., mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, zum Wirt-

schaftsprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 4. Mai 2009.

Deka International S.A.
Holger Hildebrandt / Eugen Lehnertz

Référence de publication: 2009056608/14.
(090067940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

International Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 8.558.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 04.05.2009

Es wird beschlossen, PricewaterhouseCoopers S.àr.l., mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, zum Wirt-

schaftsprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 4. Mai 2009.

International Fund Management S.A.
Holger Hildebrandt / Eugen Lehnertz

Référence de publication: 2009056614/14.
(090067932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2009.

49029

International Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 8.558.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2008.

Holger Hildebrandt / Eugen Lehnertz.

Référence de publication: 2009056633/10.
(090065975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

Datogon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 127.767.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2009.

Wolfgang Dürr / Paul Diederich.

Référence de publication: 2009056634/10.
(090065972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

University Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 146.033.

STATUTES

In the year two thousand nine, the twenty-first day of April.
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ZEPHYR MEXICO EDUCATION INVESTMENT GP LLC, with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400,

County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., acting as general partner of ZEPHYR MEXICO EDUCA-
TION INVESTMENT B, LP,

duly represented by Mr Guy HORNICK, maître en sciences économiques, residing professionally at 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated April 14 

th

 , 2009.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is "UNIVERSITY HOLDING S. à r. l."

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever except by way of public offer. The company may grant to the com-

panies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of
August 10, 1915.

49030

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) divided into 200

(two hundred) corporate units with a nominal value of USD 100 (one hundred US Dollars) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may

only be done in accordance with the law on commercial companies.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by two managers or more who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory manager or by the individual signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In its
current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature
legally commits the company.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on

commercial companies.

Art. 15. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

Art. 16. Every year on December 31 

st

 , the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution

will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31 

st

 , 2009.

<i>Subscription and Payment

The 200 (two hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, ZEPHYR MEXICO EDU-

CATION INVESTMENT B, LP, acting through its general partner ZEPHYR MEXICO EDUCATION INVESTMENT GP
LLC.

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of USD

20,000 (twenty thousand US Dollars) as was certified to the notary executing this deed.

49031

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

one thousand and two hundred fifty euro.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

Are appointed managers of the company with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:

<i>A signatory manager:

1. Mr Cesar URREA, investment manager, born on March 10, 1971 in Mexico, residing professionally at Paseo de la

Reforma 2608, 18 

th

 Floor, 11950 Mexico City, Mexico,

<i>B signatory managers:

2. Mr Luc HANSEN, "licencié en administration des affaires", born on June 8, 1969 in Luxembourg, residing profes-

sionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3. Mr Guy HORNICK, "maître en sciences économiques", born on March 29, 1951 in Luxembourg, residing profes-

sionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy of the appearing party, whom is known to the notary by his surname,

Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, Notary, the present original deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mille neuf, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ZEPHYR MEXICO EDUCATION INVESTMENT GP LLC, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400,

County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis, agissant en tant que "general partner" de ZEPHYR
MEXICO EDUCATION INVESTMENT B, LP,

ici représenté par Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 14 avril 2009.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société

à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de "UNIVERSITY HOLDING S. à r. l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

49032

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra, dans les limites

fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances
ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à USD 20.000 (vingt mille dollars américains) représenté par 200 (deux cents) parts

sociales d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars américains) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

49033

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Paiement

Les 200 (deux cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, ZEPHYR MEXICO EDUCA-

TION  INVESTMENT  B,  LP,  agissant  par  l'intermédiaire  de  son  "general  partner"  ZEPHYR  MEXICO  EDUCATION
INVESTMENT GP LLC.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de USD

20.000 (vingt mille dollars américains) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été
donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cent cinquante

euro.

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:

<i>Gérant de catégorie A:

1. Monsieur Cesar URREA, gestionnaire d'investissements, né le 10 mars 1971 à Mexico, demeurant professionnelle-

ment au 2608, Paseo de la Reforma, 18 

th

 Floor, 11950 Mexico, Mexique,

<i>Gérants de catégorie B:

2. Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant pro-

fessionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3. Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant pro-

fessionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Guy Hornick, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2009, LAC/2009/15485. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009058272/9127/228.
(090068706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

49034

Deka International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 28.599.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2009.

Holger Hildebrandt / Eugen Lehnertz.

Référence de publication: 2009056636/10.
(090065944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

Valartis German Residential Health Care, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.957.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of April.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Valartis German Residential Health Care", SICAV-

FIS incorporated as a public limited liability company (société anonyme) (the "Company"), having its registered office at
5, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Trade and Companies under number B 132.957 and incorporated pursuant to a deed dated 24 October 2007 drawn up
by the Luxembourg notary Maître Patrick SERRES, acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, published in
the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, under number 2560 dated 10 November 2007, page 122837.

The meeting is opened at 14.00 CET and is presided by Mr Jean-Paul SCHAUL, professionally residing in L-2163

Luxembourg,

who appoints as secretary Mr Marcel MARBACH, professionally residing in L-2163 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Kai SCHOLER, residing in D-66701 Beckingen.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that out of nine thousand five hundred thirty-one (9'531) registered shares in

circulation, nine thousand thirty-one (9.031) shares are represented in this extraordinary general meeting. The convening
notices have been sent to the shareholders by registered mail in compliance with the provisions of the articles of incor-
poration of the Company.

The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the

meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

(1) Decision to change the date of the annual general meeting to be forthwith held on the fourth Friday of the month

of April and for the first time in 2009 and amendment of article 22 of the articles of incorporation of the Company to
reflect such change;

(2) Deletion in its entirety of article 32 of the articles of incorporation of the Company;
(3) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting of the shareholders of

the Company:

<i>First resolution

The meeting RESOLVES to amend the date of the annual general meeting of shareholders of the Company to be

forthwith held on the fourth Friday of the month of April and to consequently amend article 22, sixth paragraph, of the
Company's articles of incorporation, which shall read as follows:

Art. 22. (...) The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg, at such

place and time as specified in the notice of meeting, on the fourth Friday of April each year. (...)"

<i>Second resolution

The meeting RESOLVES to apply the new date for the annual general meeting for the first time in 2009.

49035

<i>Third resolution

The meeting RESOLVES to amend the Company's articles of incorporation by deleting article 32 of the articles of

incorporation in its entirety.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-duché de Luxembourg,

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Valartis German Residential Health Care",

SICAV-FIS constituée sous forme d'une société anonyme (la "Société"), ayant son siège social au 5, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 132.957 et constituée en vertu d'un acte du notaire Maître Patrick SERRES, agissant en remplacement
de notaire Maître Jean-Joseph WAGNER, du 24 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations sous le numéro 2560 daté du 10 novembre 2007, page 122837.

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures CET et présidée par Monsieur Jean-Paul SCHAUL, demeurant professionnel-

lement à L-2163 Luxembourg,

lequel désigne comme secrétaire Monsieur Marcel MARBACH, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Kai SCHOLER, demeurant à D-66701 Beckingen.
Les comparants de l'assemblée ayant été désignés, le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que sur les neuf mille cinq cent trente et une (9.531) actions nominatives en

circulation, neuf mille trente et une (9.031) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
Les avis de convocation ont été envoyés aux actionnaires par lettre recommandée conformément aux dispositions des
statuts de la Société. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous
les points figurant à son ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

(1) Décision de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le quatrième vendredi du

mois d'avril et pour la première fois en 2009 et modification de l'article 22 des statuts de la Société pour refléter ce
changement;

(2) Suppression dans son entièreté de l'article 32 des statuts de la Société;
(3) Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires

de la Société:

<i>Première résolution

L'assemblée DECIDE de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra

désormais le quatrième vendredi du mois d'avril et de modifier en conséquence l'article 22, paragraphe 6 des statuts de
la Société qui sera rédigé comme suit:

Art. 22. (...) L'assemblée générale annuelle se tiendra, conformément au droit luxembourgeois, à Luxembourg au lieu

et à l'heure indiqués dans l'avis de convocation, le quatrième vendredi du mois d'avril, chaque année. (...)."

<i>Seconde résolution

L'assemblée DECIDE d'appliquer la nouvelle date pour l'assemblée générale annuelle pour la première fois en 2009.

<i>Troisième résolution

L'assemblée DECIDE de modifier les statuts de la Société en supprimant l'article 32 des statuts dans son entièreté.

49036

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.P. SCHAUL, M. MARBACH, K. SCHOLER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 avril 2009. Relation: EAC/2009/4890. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 2 mai 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009057081/239/111.
(090064836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

Valartis German Residential Health Care, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.957.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 4 mai 2009.

J.-J. WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009057083/239/13.
(090064837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

Universal-Investment-1 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-

ment Spécialisé.

Siège social: L-5365 Münsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 146.032.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, den dreißigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

"Universal-Investment-Luxembourg, S. A.", eine als "société anonyme" nach Luxemburger Recht gegründete Gesell-

schaft, welche ihren Gesellschaftssitz in 18-20, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach hat, im Luxemburger Handels-
register eingetragen ist unter Nummer B 75.014,

hier vertreten durch Herrn Stefan Rockel, beruflich niedergelassen in Erlenstraße 2, 60325 Frankfurt am Main und

Herrn Alain Nati, beruflich niedergelassen in 18-20, Parc d`Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,

in ihrer Eigenschaft als geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der "Universal-Investment-Luxembourg S.A.", und

beide zusammen zeichnungsberechtigt für die "Universal-Investment-Luxemburg, S.A.".

1. Definitionen.
- Aktien bezeichnen die Aktien der Gesellschaft;
- Aktionäre bezeichnet die Aktionäre der Gesellschaft;
- Aktienklasse bezeichnet eine Aktienklasse oder Aktienklassen eines Teilfonds, welche sich im Hinblick auf die Ge-

bührenstruktur, die Mindestanlagebeträge, die Ausschüttungspolitik, die von den Anlegern zu erfüllenden Voraussetzun-
gen, die Referenzwährung oder durch sonstige besondere Merkmale unterscheiden;

- Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag (ausgenommen Samstag und Sonntag) an dem die Banken für normale Geschäfte

in Luxemburg und Frankfurt am Main geöffnet sind;

- Bewertungstag hat die Bezeichnung, welche in Artikel 24 der Satzung Erläuterung findet;
- Depotbank bezeichnet die Depotbank der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes von 2007;

49037

- Geeigneter Anleger bezeichnet einen Anleger, welcher im Sinne des Artikel 2 des Gesetzes von 2007 als geeigneter

Anleger gilt. Geeignete Anleger sind hierbei insbesondere, institutionelle Anleger, professionelle Anleger und jeder andere
Anleger der die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- er hat schriftlich sein Einverständnis zu seiner Einordnung als Geeigneter Anleger erklärt, und
- er investiert mindestens 125.000 EUR, oder
- er verfügt über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapie-

runternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/
EG, welche ihm seinen Sachverstand, seine Erfahrung und die Kenntnisse bescheinigt, um auf angemessene Weise eine
Anlage in einen Spezialfonds einschätzen zu können;

- Gesellschaft bezeichnet Universal-Investment-1 SICAV-FIS;
- Gesetz von 1915 bezeichnet das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgen-

der Änderungen und Ergänzungen;

-  Gesetz  von  2002  bezeichnet  das  Gesetz  vom  20.  Dezember  2002  über  Organismen  für  gemeinsame  Anlagen,

einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;

- Gesetz von 2007 bezeichnet das Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, einschließlich

nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;

- Nettoinventarwert bezeichnet den Nettoinventarwert, dessen Berechnung wie in Artikel 24 der Satzung beschrieben

erfolgt;

- OGA bezeichnet Organismen für gemeinsame Anlagen;
- Emissionsdokument bezeichnet das Emissionsdokument der Gesellschaft;
- Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft;
- Teilfonds bezeichnet einen Teilfonds im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes von 2007;
- Verwaltungsrat bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft;
- Verwaltungsratsmitglied bezeichnet ein Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

2. Name.
2.1 Hiermit besteht eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem

Kapital - spezialisierter Investmentfonds ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé")
unter dem Namen "Universal-Investment-1 SICAV-FIS."

2.2 Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie

dieser Satzung. Im Falle eines Konflikts zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 gilt vorrangig das
Gesetz von 2007.

2.3 Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär oder mehrere Aktionäre haben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs

wird die Gesellschaft nicht infolge des Todes, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder Liquidation des al-
leinigen Gesellschafters aufgelöst.

2.4  Jeder  Hinweis  zu  den  Aktionären  meint  den  alleinigen  Aktionär  der  Gesellschaft,  sollte  lediglich  ein  alleiniger

Aktionär vorhanden sein.

3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet, wobei die Gesellschaft automatisch liquidiert wird, sobald ein

Teilfonds aufgelöst wird und keine weiteren Teilfonds mehr bestehen.

3.2 Die Gesellschaft kann, durch einen Beschluss der Aktionäre, welcher gemäß den für eine Satzungsänderung vor-

geschriebenen Bedingungen gefasst wird, jederzeit aufgelöst werden.

4. Gesellschaftszweck.
4.1 Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren, Investment-

fonds, Geldmarktinstrumenten, liquiden Mitteln und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz
der Risikostreuung mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen
zu lassen.

4.2 Die Gesellschaft kann ferner jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfül-

lung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im Weitesten Sinne entsprechend dem
Gesetz von 2007.

5. Sitz.
5.1 Der Gesellschaftssitz befindet sich in Munsbach (Gemeinde Schuttringen), Großherzogtum Luxemburg. Er kann zu

jeder  Zeit,  durch  Beschluss  einer  außerordentlichen  Gesellschafterversammlung,  in  irgendeine  andere  Ortschaft  des
Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

5.2 Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland

durch einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden.

49038

5.3 Falls der Verwaltungsrat feststellt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche, soziale oder militärische Ent-

wicklungen  stattgefunden  haben  oder  bevorstehen,  welche  die  normale  Geschäftsabwicklung  der  Gesellschaft  am
Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen,
kann er vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Umstände den Sitz der Gesellschaft ins Ausland
verlegen. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz
der vorübergehenden Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleibt.

6. Gesellschaftskapital - Teilfonds - Aktienklassen.
6.1 Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und entspricht jederzeit dem Nettoin-

ventarwert  der  Aktien  der  Gesellschaft.  Das  Gründungskapital  beträgt  fünfzigtausend  Euro  (50.000,-  EUR),  ist  voll
einbezahlt und repräsentiert durch fünfhundert (500) Aktien ohne Nennwert. Das Kapital der Gesellschaft muss min-
destens eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR) betragen und dieses Mindestgesellschaftskapital
muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach dem
Gesetz von 2007 erreicht werden.

6.2 Der Verwaltungsrat darf jederzeit, unbegrenzt weitere voll eingezahlte Aktien der Gesellschaft ausgeben, ohne den

alten Aktionären ein Bezugsrecht auf die zusätzlich auszugebenden Aktien einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes
Verwaltungsratsmitglied oder jeden Angestellten der Gesellschaft oder andere Personen ermächtigen, Zeichnungen an-
zunehmen und den Preis für die neuen Aktien entgegenzunehmen.

6.3 Der Verwaltungsrat kann im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes von 2007 einen oder mehrere Teilfonds bilden.

Die Vermögenswerte jedes Teilfonds können in Wertpapieren, Investmentfonds, Geldmarktinstrumenten, flüssigen Mit-
teln  oder  anderen  zulässigen  Vermögenswerten  angelegt  werden.  Die  Teilfonds  können  sich  durch  ihre  Anlageziele,
Anlagepolitik, Referenzwährung oder sonstige Merkmale, welche der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit in Bezug auf jeden
Teilfonds festlegt, unterscheiden. Der Verwaltungsrat kann auch beschließen, Teilfonds zu errichten, deren Aktien in
unterschiedlichen geographischen Regionen vertrieben werden.

6.4 Die Gesellschaft besitzt eigene Rechtspersönlichkeit. Die Rechte der Aktionäre und Gläubiger im Hinblick auf einen

Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds
stehen, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds.

6.5 Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Aktionäre in diesem Teil-

fonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung,
Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder
Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt.

6.6 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Aktienklassen auszugeben, deren

Vermögenswerte gemeinsam angelegt werden, welche sich jedoch im Hinblick auf die Gebührenstruktur, die Mindestan-
lagebeträge, die Ausschüttungspolitik, die von den Anlegern zu erfüllenden Voraussetzungen, die Referenzwährung oder
sonstige besondere Merkmale, welche der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit in Bezug auf eine Aktienklasse festlegt, un-
terscheiden.

6.7 Aktien werden ausschließlich an Geeignete Anleger ausgegeben.
6.8 Die Jahresrechnungen der Gesellschaft werden in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d. h. in

Euro, aufgestellt. Zur Bestimmung des Gesellschaftskapitals wird das Nettovermögen der Teilfonds, welches nicht in Euro
ausgedrückt ist, rechnerisch in Euro umgewandelt.

7. Form der Aktien.
7.1 Die Gesellschaft wird nur Aktien in Form von Namensaktien ausgeben.
7.2 Alle ausgegebenen Namensaktien der Gesellschaft werden in das Aktienregister eingetragen, welches von der

Gesellschaft oder von einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses
Register wird die Namen jedes Aktionärs, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend den Angaben gege-
nüber der Gesellschaft und die Zahl der von ihm gehaltenen Namensaktien und den auf Aktienbruchteile bezahlten Betrag
enthalten.

7.3 Der Verwaltungsrat wird darüber beschließen, ob ein Zertifikat über einen solchen Eintrag an den Aktionär aus-

gestellt werden soll, oder ob der Aktionär eine schriftliche Bestätigung über seinen Aktienbesitz erhält.

7.4 Die Übertragung von Namensaktien erfolgt,
(i) sofern Aktienzertifikate ausgegeben wurden, durch Übergabe des Zertifikats oder der Zertifikate, die diese Aktien

gegenüber der Gesellschaft vertreten, zusammen mit anderen Unterlagen, die die Übertragung der Gesellschaft gegenüber
in zufrieden stellender Weise nachweisen, und,

(ii) sofern keine Aktienzertifikate ausgegeben wurden, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, die in das

Aktienregister einzutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend bevollmächtigten
Personen datiert und unterzeichnet werden muss. Jede Übertragung von Namensaktien wird in das Aktienregister ein-
getragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder durch eine oder mehrere
sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigte Person(en) unterzeichnet.

49039

7.5 Aktienzertifikate werden durch zwei Verwaltungsratsmitglieder oder einen vom Verwaltungsrat zu diesem Zweck

ordnungsgemäß ermächtigten Agenten unterzeichnet. Die Unterschriften der Verwaltungsratsmitglieder können entwe-
der handschriftlich erfolgen oder in gedruckter Form erscheinen. Die Unterschriften der ermächtigten Person müssen
handschriftlich erfolgen. Die Gesellschaft kann vorläufige Aktienzertifikate in einer vom Verwaltungsrat zu beschließenden
Form ausgeben.

7.6 Aktien werden lediglich bei Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Zeichnungspreises ausge-

geben. Aktionäre müssen der Gesellschaft eine Anschrift mitteilen, an welche sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen
gerichtet werden können. Diese Anschrift wird in das Aktienregister eingetragen. Bei Miteigentum an den Aktien wird
nur eine Anschrift eingetragen, und alle Mitteilungen werden ausschließlich an diese Anschrift gesandt.

7.7 Sofern ein Aktionär keine Anschrift angibt, kann die Gesellschaft es zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in

das Aktienregister eingetragen wird. Als Anschrift des Aktionärs gilt in diesem Fall die Anschrift des eingetragenen Sitzes
der Gesellschaft beziehungsweise eine andere von der Gesellschaft jeweils eingetragene Anschrift, und zwar solange, bis
der Aktionär der Gesellschaft eine andere Anschrift mitteilt. Ein Aktionär kann zu jeder Zeit die im Aktienregister ein-
getragene Anschrift durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche
von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.

7.8 Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Aktie an. Sofern ein oder mehrere Aktien im gemeinsamen

Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an einer Aktie strittig ist, kann die Gesellschaft, nach
Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung, eine der Personen, welche eine Berechtigung an einer
solchen Aktie behauptet, als rechtmäßigen Vertreter dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft ansehen.

7.9 Berechtigt eine Zahlung von einem Zeichner zu einem Aktienbruchteil, wird dieser Aktienbruchteil im Aktienre-

gister eingetragen. Solche Aktienbruchteile verleihen kein Stimmrecht, es sei denn, dass sie zusammengenommen eine
volle Aktie ergeben; allerdings ist der Aktionär, soweit die Gesellschaft dies vorsieht, zu anteiligen Ausschüttungen be-
rechtigt und im Falle einer Liquidation zu dem anteiligen Liquidationserlös.

8. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten.
8.1 Sofern ein Aktionär zur Zufriedenheit der Gesellschaft nachweisen kann, dass sein Aktienzertifikat abhanden ge-

kommen ist, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf Antrag des Aktionärs ein Duplikat nach den Bedingungen und unter
Stellung der Sicherheiten, wie dies von der Gesellschaft festgelegt wird, ausgegeben werden. Mit Ausgabe des neuen
Aktienzertifikates, welches als Duplikat gekennzeichnet wird, verliert das ursprüngliche Aktienzertifikat, welches durch
das neue ersetzt wird, seine Gültigkeit.

8.2 Beschädigte Aktienzertifikate können von der Gesellschaft für ungültig erklärt und durch neue Zertifikate ersetzt

werden. Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen dem Aktionär die Kosten für die Erstellung eines Duplikates oder
eines neuen Aktienzertifikates sowie sämtliche angemessenen Auslagen, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang
mit der Ausgabe und der Eintragung dieses Zertifikates oder im Zusammenhang mit der Ungültigerklärung des ursprün-
glichen Aktienzertifikates getragen wurden, dem Aktionär auferlegen.

9. Erwerbsbeschränkungen für die Aktien.
9.1 Aktien der Gesellschaft dürfen nur von Geeigneten Anlegern erworben werden und sind nur zwischen Geeigneten

Anlegern frei übertragbar, soweit keine zusätzlichen Erwerbs- oder Übertragungsbestimmung, wie ggf. im Emissionsdo-
kument dargelegt, verletzt werden.

Falls der Verwaltungsrat feststellt, dass Aktien von nicht Geeigneten Anlegern erworben wurden, können diese Aktien

zwangsweise von der Gesellschaft zurückgekauft werden. Zudem hält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, einen Teil-
fonds aufzulösen, falls er feststellen sollte, dass alle Aktien von nicht Geeigneten Anlegern gehalten werden.

9.2 Die Gesellschaft kann jederzeit und nach freiem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen, die Ausgabe von

Aktien zeitweilig einschränken, aussetzen oder vollständig einstellen, die Umschreibung im Aktienregister verweigern,
oder Aktien zum Rückkaufpreis zwangsweise zurückkaufen, falls sie der Ansicht ist, dass dies im Interesse der Aktionäre
ist oder zum Schutz der Gesellschaft oder der Aktionäre notwendig ist. In diesem Fall wird die Depotbank unverzüglich
Zahlungen auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge zinslos zurückerstatten. Insbesondere kann der Verwaltungsrat den
Erwerb oder Besitz von Aktien eines jeden Teilfonds durch natürliche oder juristische Personen einschränken, um zu
verhindern, dass ein solcher Erwerb oder Besitz eine Verletzung luxemburgischer oder ausländischer Rechtsgrundsätze
zur Folge hätte oder soweit durch einen solchen Erwerb oder Besitz die Gesellschaft steuerlichen Verbindlichkeiten
ausgesetzt ist oder mit anderen Nachteilen zu rechnen hat, denen sie andernfalls nicht ausgesetzt worden wäre.

9.3 Mit Abschluss der Rückkaufstransaktion endet das Eigentum des bisherigen Aktionärs. In der Folge wird der Name

des Aktionärs aus dem Aktienregister gestrichen.

9.4 Der Verwaltungsrat erlaubt zudem keine "Market Timing" Praktiken. Solche Praktiken können die effiziente Ver-

waltung der Gesellschaft beeinträchtigen und sich nachteilig auf die Interessen der anderen Aktionäre und der Gesellschaft
auswirken. Daher behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, Zeichnungsanträge zurückzuweisen, sofern bei einem
Anleger der Verdacht auf "Market Timing" Praktiken besteht. Bei Verdacht auf "Market-Timing" Praktiken wird der Ver-
waltungsrat geeignete Maßnahmen ergreifen, um die übrigen Aktionäre der Gesellschaft zu schützen.

49040

10. Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre.
10.1 Eine ordnungsgemäß gebildete Gesellschafterversammlung der Aktionäre vertritt die Gesamtheit der Aktionäre

der Gesellschaft (Generalversammlung). Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der
Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

(i) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers sowie die Festsetzung

ihrer Vergütungen;

(ii) Genehmigung des Jahresabschlusses;
(iii) Entlastung des Verwaltungsrates;
(iv) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses (unter Berücksichtigung der bereits vom Verwaltungsrat

gezahlten Vorabausschüttungen);

(v) Änderung der Satzung;
(vi) Auflösung der Gesellschaft.
10.2 Die Aktionäre eines Teilfonds/einer Aktienklasse können zu jeder Zeit eine Gesellschafterversammlung abhalten,

um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds/diese Aktienklasse betreffen.

10.3 Artikel 12 dieser Satzung findet entsprechende Anwendung sofern nicht die Gegebenheiten ein anderes Verfahren

erforderlich machen.

11. Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre - Andere Gesellschaftergeneralversammlungen.
11.1 Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger

Rechts in Luxemburg an einem in der Einladung angegebenen Ort am zweiten Dienstag im Monat Mai um 10.00 Uhr
abgehalten.

11.2 Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg, so findet die ordentliche Generalver-

sammlung der Aktionäre am nächstfolgenden Bankarbeitstag statt. Die ordentliche Generalversammlung kann im Ausland
abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass Umstände höherer Gewalt dies
erfordern. Andere Gesellschafterversammlungen der Aktionäre können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abge-
halten werden, wie dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird.

12. Beschlussfähigkeit, Abstimmung und Einberufung.
12.1 Der Ablauf der Versammlungen der Aktionäre muss, soweit die vorliegende Satzung nichts anderes bestimmt, in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Jede Aktie berechtigt, unabhängig vom Nettoinventarwert
per Aktie innerhalb eines Teilfonds/einer Aktienklasse zu einer Stimme, im Einklang mit den Vorschriften des Luxemburger
Rechts und dieser Satzung.

12.2 Jeder Aktionär kann sich aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche auch durch Telegramm oder Telefax

erstellt werden kann, durch einen anderen Aktionär oder eine andere Person vertreten lassen.

12.3 Sofern das Gesetz oder die vorliegende Satzung nichts Gegenteiliges anordnen, werden die Entscheidungen der

ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden
oder vertretenen und mitbestimmenden Aktionäre gefasst. Die Aktionäre können auch im Wege einer telefonischen
Konferenzschaltung  oder  durch  ähnliche  Kommunikationsmittel,  welche  ermöglichen,  dass  die  entsprechend  teilneh-
menden Personen identifiziert werden können, sowie dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung durchgehend einander
hören und miteinander sprechen können, teilnehmen. Die Aktionäre, die auf diesem Wege an der Gesellschafterver-
sammlung teilnehmen, gelten als anwesend im Sinne der vorstehenden Bestimmungen. Der Verwaltungsrat kann andere
Bedingungen festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um an den Gesellschafterversammlungen teilnehmen zu
können.

12.4 Die Gesellschafterversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen. Sie kann auch auf Antrag von

Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, zusammentreten. Wird die Gesell-
schafterversammlung  binnen  eines  Monats  nach  Antragstellung  nicht  abgehalten,  so  können  die  Aktionäre,  welche
wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, die Bennennung eines Bevollmächtigten durch den
Vorsitzenden der Handelskammer des Luxemburger Bezirksgerichts verlangen, welcher dann die Einberufung der Ge-
sellschafterversammlung  veranlasst.  Die  Einberufung  der  Gesellschafterversammlung  erfolgt  in  der  gesetzlich  vorges-
chriebenen Form.

12.5 Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, haben ferner das Recht, bis

fünf Tage vor Abhaltung der einberufenen Gesellschafterversammlung, durch eingeschriebenen Brief weitere Punkte auf
die Tagesordnung setzen zu lassen.

12.6 Sofern sämtliche Aktionäre der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß

einberufen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Gesellschafterversammlung ohne schriftliche
Einladung stattfinden.

13. Verwaltungsrat.
13.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus

mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Verwaltungsrat wird von der

49041

Gesellschafterversammlung bestellt. Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungs-
ratsmitglieder sowie die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder.

13.2 Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären im Rahmen der jährlichen Gesellschafterversammlung für eine

Amtsdauer von höchstens sechs Jahren durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gewählt. Die
Mitglieder des Verwaltungsrates können wieder gewählt werden. Die Gesellschafterversammlung kann ein Mitglied des
Verwaltungsrates jederzeit, ohne Angabe von Gründen, abberufen. Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmit-
gliedes  können  die  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  die  freie  Stelle  zeitweilig  besetzen;  die  Aktionäre
werden bei der nächsten Gesellschafterversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

Sofern eine juristische Person zum Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person einen per-

manenten  Vertreter  benennen,  um  die  Funktion  des  Verwaltungsratsmitglieds  im  Namen  der  juristischen  Person  zu
erfüllen. Dieser Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Pflichten und trägt die gleiche Haftung, als würde er
die Aufgabe auf eigene Rechnung erfüllen, unabhängig von der gemeinsamen Haftung des Vertreters und der juristischen
Person. Die juristische Person kann den Vertreter nicht zurückziehen ohne gleichzeitig einen neuen Vertreter zu benen-
nen.

14. Verwaltungsratssitzungen.
14.1 Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter bestimmen. Bei

Gründung der Gesellschaft wird der erste Vorsitzende durch die erste Gesellschafterversammlung bestimmt. Der Ver-
waltungsratsvorsitzende  leitet  die  Verwaltungsratssitzungen  und  in  seiner  Abwesenheit  können  die  Aktionäre  oder
Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates mit der Leitung beauftragen.

14.2 Der Verwaltungsrat kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der

die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwal-
tungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen. Die
Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem
entsprechenden Datum schriftlich eingeladen. In Dringlichkeitsfällen jedoch muss diese Frist nicht eingehalten werden.
Auf diese Einladung kann schriftlich von allen Verwaltungsratsmitgliedern verzichtet werden, wobei eine einstimmige
Entscheidung erforderlich ist. Eine Mitteilung ist nicht notwendig, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied bei der Sitzung
anwesend oder ordnungsgemäß vertreten ist. Eine Mitteilung ist auch nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeit-
punkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

14.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung aufgrund schriftlicher Erklärung

(Brief, Telefax, E-Mail oder ein ähnliches Kommunikationsmittel) durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten
lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann
an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche
ermöglichen, dass die entsprechend teilnehmenden Personen identifiziert werden können, sowie dass sämtliche Teilneh-
mer an der Sitzung durchgehend einander hören und miteinander sprechen können, teilnehmen. Diese Teilnahme steht
einer persönlichen durchgehenden Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

14.4 Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die

Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden
oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsrats-
sitzung das entscheidende Stimmrecht zu. Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder eines Stellvertreters und im Einvers-
tändnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren
des Umlaufbeschlusses ist nur zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der
vorgeschlagenen Beschlüsse einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses
gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, E-Mail oder per ähnlicher Kommunikationsmittel.

15. Interessenkonflikte.
15.1 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den In-

teressen  der  Gesellschaft  entgegen  gesetztes  persönliches  Interesse  hat,  wird  dieses  Verwaltungsratsmitglied  dem
Verwaltungsrat dieses entgegen gesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäfts-
vorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen. Dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche
Interesse des Verwaltungsratsmitglieds auf der nächstfolgenden Gesellschafterversammlung berichtet. Falls ein Quorum
des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht
werden kann, werden die Beschlüsse durch eine Mehrheit der nicht betroffenen Verwaltungsratsmitglieder, welche bei
einer solchen Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.

15.2 Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen

wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein
persönliches Interesse an dem Vertrag oder anderen Geschäft haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter,
Teilhaber, Prokuristen oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind.

15.3 Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäfts-

führer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt
oder sonst wie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft

49042

oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine
Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

16. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.
16.1 Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungs-

ratssitzung oder zwei der anderen Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Jegliche Vollmachten werden an die Proto-
kolle angeheftet.

16.2 Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren erstellt

werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unter-
zeichnen.

17. Befugnisse des Verwaltungsrates.
17.1 Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rah-

men des Gesellschaftszweckes auszuüben. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915
oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, können durch den Verwal-
tungsrat getroffen werden.

17.2 Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
17.3 Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die gemeinschaftliche

oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden wird die Gesellschaft
Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

17.4 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten

Aufgaben ernennen.

17.5 Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der

Gesellschaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten. Die Übertragung dieser
Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen,
erfolgen. Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten für Ein-
zelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

18. Vergütung des Verwaltungsrates.
Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt. Auslagen und

sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller
Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, werden zurückerstattet, es sei denn, diese sind durch vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds veranlasst worden.

19. Anlagepolitik.
19.1 Die Vermögenswerte sämtlicher Teilfonds sind nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der

Anlagepolitik und -grenzen, wie sie im Emissionsdokument beschrieben werden, anzulegen.

Das Fondsvermögen eines jeden Teilfonds kann bis zu 100 % in einen anderen regulierten inländischen oder auslän-

dischen Investmentfonds investiert werden. Insbesondere kann das Fondsvermögen eines jeden Teilfonds auch bis zu 100
% in inländische oder ausländische Spezialfonds (spezialisierte Investmentfonds) investiert werden.

Bis zu 10% eines jeden Nettoteilfondsvermögens können in Genussrechte, Schiffsbeteiligungen (einschließlich Contai-

ner), Flugzeugbeteiligungen oder in eine Kombination aus diesen Anlagekategorien investiert werden. Die Anlagen in
Genussrechte, Schiffsbeteiligungen (einschließlich Container) und Flugzeugbeteiligungen können direkt oder aber indirekt
(z.B. über die Zwischenschaltung von Investmentfonds) vorgenommen werden.

Des Weiteren können für Rechnung eines jeden Teilfonds Direktanlagen in Liegenschaften (Immobilien und Grunds-

tücke) und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften vorgenommen werden.

Die Gesellschaft darf ferner im Rahmen der im Emissionsdokument beschriebenen Anlagegrenzen Techniken und

Instrumente verwenden.

19.2 Der Verwaltungsrat ist für die Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik zuständig. Im

Emissionsdokument der Gesellschaft können Beschränkungen oder Bedingungen festgelegt werden, welche durch den
Verwaltungsrat beachtet werden müssen. Eine Änderung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik eines
bestimmten Teilfonds kann nur, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, durch eine Gesellschafterversammlung der Aktionäre
des betroffenen Teilfonds entschieden werden. Die Entscheidung betreffend die Änderung der Anlagepolitik wird durch
die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitbestimmenden Aktionäre gefasst.

20. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer

("réviseur d'entreprises agréé") geprüft, welcher von der Gesellschafterversammlung ernannt und von der Gesellschaft
bezahlt wird. Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007.

21. Ausgabe von Aktien.
21.1 Die Ausgabe von Aktien erfolgt grundsätzlich an dem im Emissionsdokument festgesetzten Bewertungstag. Wenn

immer die Gesellschaft Aktien eines Teilfonds/einer Aktienklasse zur Zeichnung anbietet, so entspricht der Preis pro

49043

Aktie, zu welchem diese Aktien angeboten und verkauft werden, dem Nettoinventarwert des entsprechenden Teilfonds/
der entsprechenden Aktienklasse, zuzüglich einer vom Verwaltungsrat festgelegten Gebühr für Steuern und Kosten (in-
klusive  Stempel  und  andere  Steuern,  Taxen,  behördliche  Kosten,  Maklerkosten,  Bankkosten,  Überweisungskosten,
Eintragungs- und Zertifikatskosten und andere ähnliche Kosten) ("Handelskosten"), welche anfallen würden, wenn das
sich im Besitz der Gesellschaft befindliche Vermögen, welches in Betracht gezogen werden müsste für eine Schätzung,
gekauft werden müsste zu den in der Schätzung angenommenen Preisen, und unter der zusätzlichen Berücksichtigung
aller anderen Faktoren, die nach Meinung des Verwaltungsrates berücksichtigt werden müssen, zuzüglich der in dem
Emissionsdokument festgelegten Verkaufsgebühren. Die Vergütung jedes mit dem Verkauf dieser Aktien beauftragten
Agenten wird aus dieser Gebühr bezahlt. Der auf diese Weise festgelegte Preis ist binnen einer Zeitspanne, die im Emis-
sionsdokument dargelegt ist und vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit bestimmt werden kann, zahlbar.

21.2 Die Gesellschaft kann, gemäß den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein

Bewertungsgutachten durch einen Wirtschaftsprüfer zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren aus-
geben, vorausgesetzt, dass solche Wertpapiere mit den Anlagezielen, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen
des jeweiligen Teilfonds im Einklang stehen.

22. Rücknahme von Aktien.
22.1 Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Aktien zu jedem Zeitpunkt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bes-

chränkungen zurückzunehmen. Jeder Aktionär kann (falls im Emissionsdokument vorgesehen) die Rücknahme aller oder
eines Teiles seiner Aktien durch die Gesellschaft nach den Bestimmungen und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat
festgelegt werden, und innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen, verlangen.

22.2 Der Rücknahmepreis pro Aktie wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche

im Emissionsdokument veröffentlicht wird und voraussetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene Aktienzertifikate und sons-
tige Unterlagen zur Übertragung von Aktien bei der Gesellschaft eingegangen sind. Der Rücknahmepreis entspricht, sofern
im Emissionsdokument nicht anders vorgesehen, dem Nettoinventarwert pro Aktie des entsprechenden Teilfonds/der
entsprechenden Aktienklasse gemäß Artikel 24 dieser Satzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen ents-
prechend den vom Verwaltungsrat getroffenen Bestimmungen, welche im Emissionsdokument Erwähnung finden. Der
Verwaltungsrat kann jederzeit, unter den Voraussetzungen des Artikels 9, Aktien zwangsweise zurückkaufen.

22.3 Sofern die Zahl oder der gesamte Nettoinventarwert von Aktien, welche durch einen Aktionär in einem Teilfonds/

einer Aktienklasse gehalten werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde,
welcher gegebenenfalls vom Verwaltungsrat im Emissionsdokument festgelegt wurde, kann die Gesellschaft bestimmen,
dass dieser Antrag als Antrag auf Rücknahme des gesamten Aktienbesitzes des Aktionärs in diesem Teilfonds/dieser
Aktienklasse behandelt wird.

22.4 Der Verwaltungsrat hat das Recht, nach seinem alleinigen Ermessen (und unter Berücksichtigung der Interessen

der verbleibenden Aktionäre) bei umfangreichen Rücknahmeanträgen (d. h., bei Rücknahmeanträgen, deren Wert einen
im Emissionsdokument gegebenenfalls festgelegten Prozentsatz des Nettoinventarwertes eines Teilfonds übersteigt) die
Anzahl der Aktien der einzelnen Rücknahmeanträge anteilig zu verringern. Soweit ein Antrag auf Grund der Ausübung
der Befugnis zur anteiligen Verringerung an einem Bewertungstag nicht in vollem Umfang ausgeführt wird, muss er im
Hinblick auf den nicht ausgeführten Teil so behandelt werden, als habe der Aktionär für den nächsten Bewertungstag
einen weiteren Antrag gestellt. Solche Anträge werden gegenüber späteren Anträgen, soweit sie für die darauf folgenden
Bewertungstage eingehen, vorrangig bearbeitet.

23. Zeitweilige Aussetzung der Nettoinventarwert - Berechnung sowie Ausgabe und Rücknahme von Aktien.
23.1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Bewertung der Nettovermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds und

die Bewertung pro Aktie sowie die Ausgabe und die Rücknahme von Aktien in folgenden Fällen zeitweilig einzustellen:

(i) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, an der/auf dem ein wesentlicher Teil der Ver-

mögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds notiert ist oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an Wochenenden
oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse oder auf diesem Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;

(ii) in Notlagen, wenn ein oder mehrere Teilfonds über Vermögenswerte nicht verfügen kann/können, oder es für

diesen oder diese Teilfonds unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die
Berechnung des Nettoinventarwertes ordnungsgemäß durchzuführen;

(iii) während einer Zeit, in welcher die gewöhnlich verwendeten Kommunikationsmittel oder Hilfsmittel für die Net-

toinventarwertberechnung eines oder mehrerer Teilfonds oder für die Kursberechnung an den Börsen oder auf den
Märkten, an/auf denen ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds notiert ist/gehandelt
wird, unterbrochen sind;

(iv) wenn die Gesellschaft Kenntnis davon hat, dass die Bewertung einiger Anlagen eines oder mehrerer Teilfonds, die

sie zuvor zur Berechnung des Nettoinventarwertes eines oder mehrerer Teilfonds erhalten hatte, in einem wesentlichen
Punkt falsch war und dies nach Auffassung des Verwaltungsrates der Gesellschaft eine Neuberechnung des entsprechen-
den Nettoinventarwertes rechtfertigt (jedoch unter der Bedingung, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft unter keinen
Umständen zur Änderung oder Neuberechnung eines zuvor berechneten Nettoinventarwertes, aufgrund dessen Zeich-
nungen oder Rücknahmen vorgenommen worden sein können, verpflichtet ist).

49044

23.2 Die Gesellschaft wird die Aktionäre in angemessener Weise über die Aussetzung unterrichten. Aktionäre, die

einen Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme von Aktien der betroffenen Teilfonds eingereicht haben, für welche die
Nettoinventarwertermittlung ausgesetzt wurde, werden eingehend über den Anfang und das Ende der Aussetzungspe-
riode unterrichtet.

24. Ermittlung des Nettoinventarwertes.
24.1 Der Nettoinventarwert der Gesellschaft entspricht zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert der Gesamtheit der

Teilfonds.

24.2 Der Aktienwert jedes Teilfonds/jeder Aktienklasse wird durch die Gesellschaft in der Frequenz berechnet, die

vom Verwaltungsrat bestimmt wird. Der Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, wird in vorliegender Satzung
als Bewertungstag bezeichnet.

24.3 Der Aktienwert wird in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds/der jeweiligen Aktienklasse (welche im

Emissionsdokument festgelegt ist) ausgedrückt und wird an jedem Bewertungstag ermittelt, indem das Nettovermögen
des jeweiligen Teilfonds/der jeweiligen Aktienklasse, d. h. der Wert der Vermögenswerte abzüglich der diesem Teilfonds/
dieser Aktienklasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten, durch die Zahl der dann im Umlauf befindlichen Aktien dividiert
wird. Der Aktienwert kann auf die nächste Untereinheit der jeweiligen Währung auf- oder abgerundet werden. Sofern
seit Bestimmung des Aktienwertes wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten, auf welchen ein
wesentlicher Anteil der Vermögensanlagen eines jeweiligen Teilfonds gehandelt oder notiert sind, erfolgen, kann die
Gesellschaft im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine weitere Bewertung
vornehmen. Die Bewertung des Nettoinventarwertes der Aktien sämtlicher Teilfonds/Aktienklassen wird wie folgt vor-
genommen:

24.4 Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:
(i) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden zum zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert,

ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.

(ii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum letzten verfüg-

baren Kurs bewertet.

(iii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem

anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt
werden, werden zu dem letzten verfügbaren Kurs bewertet.

(iv) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten

Markt gehandelt werden, werden zu ihrem jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

(v) Schiffsbeteiligungen werden von einem oder mehreren unabhängigen Schiffsachverständigen, der / die nach Ein-

schätzung  des  Verwaltungsrates  über  eine  ausreichende  fachliche  Qualifikation  verfügt/verfügen,  um  die  Preise  für
Schiffsbeteiligungen einschätzen zu können, bewertet.

(vi) Liegenschaften (Grundstücke und Immobilien) werden von einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen,

der/die nach Einschätzung des Verwaltungsrates über eine ausreichende fachliche Qualifikation verfügt/verfügen, um die
Preise für Grundstücke und Immobilien einschätzen zu können, bewertet.

(vii) Flugzeugbeteiligungen werden von einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen, der/die nach Einschä-

tzung des Verwaltungsrates über eine ausreichende fachliche Qualifikation verfügt/verfügen, um die Preise für Flugbetei-
ligungen einschätzen zu können, bewertet.

(viii) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert und ggf. zuzüglich Zinsen bewertet.
(ix) Bei Derivaten ist im Hinblick auf die Nettoinventarwertberechnung zu unterscheiden:
(a) An der Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelte Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu

deren letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Marktpreisen bewertet.

(b) Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger

Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewer-
tungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft aner-
kannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist nachvollzogen.

(x) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen soweit sie sich

nicht im Kurswert ausdrücken.

(xi) Alle anderen und zulässigen Vermögenswerte, sowie die vorgenannten Vermögenswerte, für die eine Bewertung

gemäß der vorstehenden Bestimmungen nicht möglich oder durchführbar wäre, oder bei denen eine solche Bewertung
nicht ihren angemessenen Wert wiedergeben würde, werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, der in gutem
Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat vorgeschriebenen Verfahren ermittelt wird.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß der oben aufgeführten Kriterien unmöglich

oder unsachgerecht werden lassen, ist die Gesellschaft ermächtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu und Glauben
festgelegte, von Wirtschaftsprüfern nachvollziehbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung zu
erreichen.

49045

24.5 Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:
(i) sämtliche Darlehen, sämtliche aufgelaufene Zinsen aus Krediten der Gesellschaft (einschließlich Kreditaufnahme-

kosten) und andere anfällige Beträge;

(ii) sämtliche fällige oder anfallende Kosten (einschließlich Verwaltungs- und Managementgebühren, Beratungsgebüh-

ren, Depotbankgebühren, sonstige Vertretergebühren etc.), die der Gesellschaft zugeordnet werden;

(iii) sämtliche bekannte, gegenwärtige und zukünftige Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverbindlichkeiten auf

Geld oder Sachwerte aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden
der Gesellschaft;

(iv) angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen und sonstige vom Verwaltungsrat genehmigte und

angenommene Rückstellungen, sowie Rücklagen als Vorsorge für sonstige Verbindlichkeiten der Gesellschaft;

(v) sämtliche sonstige Verbindlichkeiten der Gesellschaft jeglicher Art, die in Übereinstimmung mit luxemburgischem

Recht ausgewiesen werden;

(vi) Liquidationskosten für die Auflösung der Gesellschaft, sobald diese erkennbar ist.
24.6 Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und sonstige Kosten regelmäßiger oder wiederkehrender Art auf der Grund-

lage geschätzter Zahlen für jährliche oder andere Perioden im Voraus ansetzen und kann diese in gleichen Raten über
einen solchen periodischen Zeitraum zusammenfassen.

24.7 Die Vermögenswerte werden wie folgt zugeteilt:
(i) Das Entgelt aus der Ausgabe von Aktien eines Teilfonds/einer Aktienklasse wird in den Büchern der Gesellschaft

dem entsprechenden Teilfonds/der entsprechenden Aktienklasse zugeordnet und der entsprechende Betrag wird den
Anteil am Nettovermögen des Teilfonds/der Aktienklasse entsprechend erhöhen und Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten sowie Einkünfte und Aufwendungen werden dem jeweiligen Teilfonds/der jeweiligen Aktienklasse nach den
Bestimmungen dieses Artikels zugeschrieben;

(ii) Vermögenswerte, welche auch von anderen Vermögenswerten abgeleitet sind, werden in den Büchern der Ge-

sellschaft demselben Teilfonds/derselben Aktienklasse zugeordnet, wie die Vermögenswerte, von welchen sie abgeleitet
sind und zu jeder Neubewertung eines Vermögenswertes wird die Werterhöhung oder Wertminderung dem entspre-
chenden Teilfonds/der entsprechenden Aktienklasse zugeordnet;

(iii) Sofern die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, welche im Zusammenhang mit einem bestimmten Vermö-

genswert  eines  bestimmten  Teilfonds/einer  bestimmten  Aktienklasse  oder  im  Zusammenhang  mit  einer  Handlung
bezüglich eines Vermögenswertes eines bestimmten Teilfonds/einer bestimmten Aktienklasse steht, wird diese Verbind-
lichkeit dem entsprechenden Teilfonds/der entsprechenden Aktienklasse zugeordnet;

(iv) Wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einem bestimmten Teilfonds/einer

bestimmten Aktienklasse innerhalb eines Teilfonds zuzuordnen ist, so werden dieser Vermögenswert bzw. diese Ver-
bindlichkeit allen Teilfonds/Aktienklassen innerhalb eines Teilfonds im Verhältnis des Nettovermögens der entsprechen-
den Teilfonds/Aktienklassen innerhalb eines Teilfonds oder in einer anderen Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu
und Glauben festlegt, zugeteilt;

(v) Nach Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre eines Teilfonds/einer Aktienklasse wird der Nettovermö-

genswert dieses Teilfonds/dieser Aktienklasse um den Betrag der Ausschüttungen vermindert. Sämtliche Bewertungsre-
geln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu treffen und auszulegen.

24.8 Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden Bestimmungen:
(i) Zur Rücknahme ausstehende Aktien der Gesellschaft gemäß Artikel 22 dieser Satzung werden als bestehende Aktien

behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, der vom Verwaltungsrat an dem entsprechenden Bewertungstag, an
welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt. Von diesem Zeitpunkt an bis zur
Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft besteht eine entsprechende Verbindlichkeit der Gesellschaft;

(ii) Auszugebende Aktien werden ab dem Zeitpunkt, der vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewertungstag, an

welchem die Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, als ausgegebene Aktien behandelt. Von diesem Zeitpunkt
an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Gesellschaft besteht eine Forderung zugunsten der Gesellschaft;

(iii) Alle Vermögensanlagen, Kassenbestände und sonstige Vermögenswerte, die auf andere Währungen als der Wäh-

rung der jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Tag und zu dem Zeitpunkt der Aktienwertberechnung geltenden
Marktkursen oder Devisenkursen bewertet;

(iv) An jedem Bewertungstag gelten folgende Grundsätze:
(A) Sofern die Gesellschaft die Verpflichtung zum Kauf eines Vermögenswertes eingegangen ist, wird der Wert der zu

erbringenden Gegenleistung für diesen Vermögenswert als Verbindlichkeit der Gesellschaft ausgewiesen und der Wert
des zu erwerbenden Vermögenswertes wird als Vermögenswert der Gesellschaft ausgewiesen.

(B) Sofern die Gesellschaft sich verpflichtet hat, einen Vermögenswert zu veräußern, wird der Wert der Gegenleistung,

welche die Gesellschaft für diesen Vermögenswert zu erhalten berechtigt ist, als Vermögenswert der Gesellschaft aus-
gewiesen, und der zu liefernde Vermögenswert wird nicht in den Aktiva der Gesellschaft ausgewiesen. Die vorstehenden
Regeln stehen unter dem Vorbehalt, dass der Wert der vorerwähnten Gegenleistung bzw. des Vermögenswertes von

49046

der Gesellschaft geschätzt werden kann, sofern der genaue Wert oder die Art dieser Gegenleistung oder des Vermö-
genswertes an dem jeweiligen Bewertungstag nicht bekannt sind.

25. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Januar eines jeden Jahres und endet am 31.

Dezember. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft werden in Euro beziehungsweise in der
oder den vom Verwaltungsrat bestimmten anderen Währungen erstellt.

26. Ausschüttungen.
26.1 Die Gesellschafterversammlung der Aktionäre wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates und innerhalb der ge-

setzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie die Erträge der Gesellschaft zu verwenden sind. Sie kann zu gegebener Zeit
Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen. Es kann keine Ausschüttung vorgenommen wer-
den, falls durch eine solche Ausschüttung das Gesellschaftskapital unter das vom Gesetz festgelegte Mindestkapital fällt.
Bei  der  Bestimmung  des  auszuschüttenden  Betrages  ist  auf  eine  angemessene  Liquiditätsreserve  zur  Bestreitung  der
Kosten und Ausgaben der Gesellschaft zu achten.

26.2 Des Weiteren kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen

beschließen.

26.3 Ausschüttungen können in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds/der jeweiligen Aktienklasse oder in

einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit
bestimmt. Der Verwaltungsrat kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraus-
setzungen und Bedingungen, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beschließen.

26.4 Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt

zugunsten der entsprechenden Aktienklasse/des entsprechenden Teilfonds. Auf Ausschüttungen, welche von der Gesell-
schaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden, erfolgen keine Zinszahlungen.

26.5 Die Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgt an deren im Aktienregister eingetragene Adressen.

27. Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft.
27.1 Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung und vorbehaltlich des Quo-

rums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 29 dieser Satzung aufgelöst werden. Sofern das Gesellschaftskapital
unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 6 dieser Satzung fällt, wird die Frage der Auflösung
durch den Verwaltungsrat der Gesellschafterversammlung vorgelegt. Die Gesellschafterversammlung, welche ohne Quo-
rum  entscheiden  kann,  wird  mit  der  einfachen  Mehrheit  der  auf  der  Gesellschafterversammlung  vertretenen  Aktien
entscheiden.

27.2 Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des Weiteren der Gesellschafterversammlung vorgelegt, sofern

das Gesellschaftskapital unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 6 dieser Satzung fällt; in diesem
Falle wird die Gesellschafterversammlung ohne Quorumerfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktio-
näre  entschieden  werden,  welche  ein  Viertel  der  auf  der  Gesellschafterversammlung  vertretenen  stimmberechtigten
Aktien halten.

27.3 Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung

der Tatsache, dass das Nettogesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums
gefallen ist, abgehalten wird.

27.4 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, welche ihrerseits natürliche oder

juristische Personen sein können und ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Gesellschafter-
versammlung ernannt werden müssen. Letztere bestimmt auch über Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren. Im Falle
einer Auflösung wird der/werden die Liquidator/en die Vermögenswerte der Gesellschaft unter Wahrung der Interessen
der Aktionäre verwerten, und die Depotbank wird den Nettoliquidationserlös (nach Abzug sämtlicher Kosten der Li-
quidation) auf Anweisung des/der Liquidators/Liquidatoren an die Aktionäre der einzelnen Aktienklassen/Teilfonds im
Verhältnis ihrer jeweiligen Rechte verteilen. Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts wird der Liquidationserlös
für Aktien, die nicht zur Rückzahlung eingereicht wurden, nach Abschluss der Liquidation bei der "Caisse de Consignation"
verwahrt. Werden diese nicht eingefordert, verfallen sie nach 30 Jahren.

28. Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds.
28.1 Sofern aus irgendeinem Grund der Gesamtnettoinventarwert eines Teilfonds unter den Wert gefallen ist oder

den Wert nicht erreicht hat, der vom Verwaltungsrat als Mindestwert für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses
Teilfonds festgesetzt wurde, sowie im Falle einer wesentlichen Änderung im politischen, wirtschaftlichen oder geldpoli-
tischen Umfeld oder im Rahmen einer Rationalisierung, kann der Verwaltungsrat beschließen, alle Aktien des entspre-
chenden Teilfonds zum Aktienwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und Realisierungskosten
der Anlagen) des Bewertungstages oder -zeitpunktes, zu welchem der entsprechende Beschluss wirksam wird, zurück-
zunehmen und den Teilfonds aufzulösen.

28.2 Die Gesellschaft wird die Aktionäre von Aktien des entsprechenden Teilfonds vor dem Wirksamkeitszeitpunkt

der Auflösung entsprechend in Kenntnis setzen, wobei die Gründe und das Verfahren für die Auflösung aufgeführt werden.
Die Aktionäre werden schriftlich informiert.

49047

28.3 Vorbehaltlich einer anderweitigen Entscheidung im Interesse der Aktionäre oder zur Wahrung der Gleichbe-

handlung aller Aktionäre können die Aktionäre des betreffenden Teilfonds die Rücknahme ihrer Aktien vor Wirksam-
werden  der  Auflösung  weiterhin  kostenfrei  beantragen  (allerdings  unter  Berücksichtigung  der  tatsächlichen  Realisie-
rungskurse und Realisierungskosten der Anlagen).

28.4 Nach Abschluss der Liquidation eines Teilfonds verbleiben die Liquidationserlöse für Aktien, die nicht eingereicht

wurden, für eine Frist von höchstens sechs Monaten ab dem Datum des Abschlusses des Liquidationsverfahrens bei der
Depotbank; danach werden die übrigen Liquidationserlöse bei der "Caisse de Consignation" hinterlegt.

28.5 Alle zurückgenommenen Aktien werden gelöscht.
28.6 Unter denselben Umständen wie im ersten Absatz geschildert, kann der Verwaltungsrat beschließen, die Ver-

mögenswerte eines Teilfonds einem anderen bestehenden Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen OGA oder
einem anderen Teilfonds innerhalb eines solchen OGA, zuzuteilen und die Aktien der betroffenen Teilfonds als Aktien
eines anderen Teilfonds (nach einer Aufteilung oder Konsolidierung, soweit erforderlich und der Auszahlung der Ak-
tienbruchteile an die Aktionäre) neu zu bestimmen.

28.7 Diese Entscheidung wird den Aktionären in derselben Weise wie im ersten Absatz beschrieben einen Monat vor

ihrer Wirksamkeit mitgeteilt, wobei die Mitteilung Angaben zu dem neuen Teilfonds enthalten wird, um den Aktionären
während dieser Frist die kostenfreie Rücknahme ihrer Aktien zu ermöglichen.

28.8 Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds in einen "fonds commun de place-

ment" oder in einen Investmentfonds, der nicht in Luxemburg seinen Gesellschaftssitz hat, erfolgt nur in Bezug auf die
Aktien von Aktionären, die dieser Einbringung zugestimmt haben.

28.9 Die Auflösung und Verschmelzung eines Teilfonds kann jedoch auch, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, durch

eine Gesellschafterversammlung der Aktionäre der betroffenen Teilfonds entschieden werden. Die Entscheidung betref-
fend  die  Auflösung  oder  Verschmelzung  wird  durch  die  einfache  Mehrheit  der  anwesenden  oder  vertretenen  und
mitbestimmenden Aktionäre gefasst.

29. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Gesellschafterversammlung der Aktionäre, welche den

Quorum und Mehrheitserfordernissen des Gesetzes von 1915 entsprechen, geändert werden. Jede Änderung, welche
die Rechte der Aktionäre eines Teilfonds gegenüber denen eines anderen Teilfonds beeinträchtigt, unterliegt ebenfalls
den genannten Quorum- und Mehrheitserfordernissen hinsichtlich jedes Teilfonds.

30. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank

im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (Depotbank) abschließen. Die Depotbank wird die
Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies im Gesetz von 2007 vorgesehen ist.

31. Anwendbares Recht. Die Gesellschaft unterliegt ausschließlich Luxemburger Recht.

32. Begriffsbestimmungen. Maskuline Bezeichnungen dieser Satzung schließen die korrespondierende feminine Be-

zeichnung ein und Bezüge auf Personen oder Aktionäre erfassen auch juristische Personen, Personengemeinschaften oder
sonstige organisierte Personenvereinigungen, unabhängig davon, ob sie Rechtspersönlichkeit besitzen oder nicht.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Rechnungsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
2. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre wird am zweiten Dienstag im Monat Mai des Jahres

2010 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung des Gründungskapitals

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:
"Universal-Investment-Luxembourg S.A.", vorgenannt, zeichnet 500 Aktien ohne Nennwert zum Gegenwert von fünf-

zigtausend (50.000,-) Euro.

Damit  beträgt  das  Gründungskapital  insgesamt  fünfzigtausend  Euro  (50.000,-  EUR).  Die  Einzahlung  des  gesamten

Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

<i>Gründungskosten

Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf dreitausend Euro veranschlagt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes von 1915 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind,

und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Gründungsversammlung der Gesellschaft

Die oben angeführte Partei, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unverzüglich eine Gesell-

schafterversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennt, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

I. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.

49048

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
1. Herr Stefan Rockel, beruflich ansässig in Erlenstrasse 2, 60325 Frankfurt am Main,
2. Herr Alain Nati, beruflich ansässig in 18-20, Parc d`Activité Syrdall, L-5365 Munsbach;
3. Herr Bernd Vorbeck, beruflich ansässig in 60325 Frankfurt am Main, Erlenstrasse 2.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre die

im Jahre 2014 stattfinden wird.

II. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
"KPMG Audit", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (R.C.S.

Luxemburg, Sektion B Nummer 103 590) ernannt.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre des Jahres

2010.

III. Sitz der Gesellschaft ist in 18-20, Parc d´Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde mit

dem Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: S. ROCKEL, A. NATI, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 5. Mai 2009. Relation: EAC/2009/5157. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

<i>Der Einnehmer

 (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Ge-

sellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 5. Mai 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009058274/239/675.
(090068691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2009.

Securialis, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 99.180.

RECTIFICATIF

Les dépôts N° L070134556.05 du 04.10.2007 et L080034719.5 du 04.03.2008 sont erronés, Madame Michèle Berger,

Madame Elena Alexandri, Monsieur Vassilios Damouras et Monsieur Benoît Paquay n'ayant pas été nommés délégués à
la gestion journalière.

<i>Pour Securialis
Pictet Funds (Europe) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009055555/52/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04915. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090064603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Eclaircie s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 121.861.

L'an deux mille neuf, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

a comparu:

Monsieur Jacques VERCAUTEREN, administrateur de sociétés, né à Etterbeek (Belgique) le 19 octobre 1949, (matr:

1949 10 19 673) demeurant à L-8813 Bigonville, 14, rue du Village,

ici représenté par Monsieur Stéphane IMBRECHTS, sans état, né à Etterbeek (Belgique) le 15 mars 1982, demeurant

à B-1480 Tubize, 7, rue du Pont des Pierres,

en vertu d'une procuration sous seing privée datée le 14 avril 2009 à Bigonville, laquelle procuration, après avoir été

signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentées pour être enregistrée
avec lui,

49049

actuellement seul associé de la société unipersonnelle à responsabilité limitée "ECLAIRCIE S.à.r.l.", avec siège social à

L-8814 Bigonville, commune de Rambrouch, 34, rue principale, (matr: 2006 24 46 375),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, page 20.173 de l'année 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 121861,

lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social de la susdite société, s'est constitué en assemblée générale

extraordinaire et a pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de 34, rue principale à L-8814 Bigonville, à L-8813 Bigonville

14, rue du Village.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ trois cents euros (300,00 €).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. IMBRECHTS, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 22 avril 2009. DIE/2009/4151. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

Ettelbruck, le 5 mai 2009.

POUR COPIE CONFORME
Pierre PROBST
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009056766/4917/39.
(090065817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

Microtron Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, 46, avenue des Alliés.

R.C.S. Luxembourg B 108.252.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS, et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009055584/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 22 avril 2009, réf. DSO-DD00177. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090064102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Bellgrove Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 19.657,00.

Siège social: L-8085 Bertrange, 29, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 138.349.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 27 avril 2009, que l'Actionnaire a pris les décisions suivantes:
1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 27 avril 2009:
Manacor (Luxembourg) S.A., immatriculée sous le numéro B 9098 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés

du Luxembourg, et dont le siège social se situe 46A, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Démission du Gérant suivant à compter du 27 avril 2009:
Madame Helena Margareta Friberg, née le 10 septembre 1962 à Bromma, en Suède, ayant pour adresse professionnelle

46A, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

49050

BELLGROVE HOLDING S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2009056448/683/22.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00196. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090065043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

Sales Points Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9094 Ettelbruck, 4, rue Tschiderer.

R.C.S. Luxembourg B 104.261.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS, et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009055585/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 30 avril 2009, réf. DSO-DD00251. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090064104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Nordbat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R.C.S. Luxembourg B 102.693.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS, et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009055586/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 6 avril 2009, réf. DSO-DD00076. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090064108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Blackburn Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 19.657,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 138.293.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 27 avril 2009, que l'Actionnaire a pris les décisions suivantes:
1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 27 avril 2009:
Manacor (Luxembourg) S.A., immatriculée sous le numéro B 9098 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés

du Luxembourg, et dont le siège social se situe 46A, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Démission du Gérant suivant à compter du 27 avril 2009:
Monsieur Allard Fontein, né le 13 mai 1967 à Amstelveen, aux Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

49051

BLACKBURN HOLDING S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2009056461/683/22.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00200. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090065046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

Entreprise de Construction Claude Jans SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R.C.S. Luxembourg B 99.506.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS, et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009055587/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 30 avril 2009, réf. DSO-DD00252. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090064110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Garage Jeannot SCHWEIG S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 6, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 95.445.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS, et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009055590/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 22 avril 2009, réf. DSO-DD00179. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090064116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Quiksilver Deluxe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.176.650,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 108.360.

<i>Extract of the written resolution taken by the sole shareholder on April 14, 2009

It is resolved to appoint Mr. Pierre BOCCON-LIAUDET, born on January 7, 1969 in Versailles, France residing at 3

Avenue du Dr. Fourcade, F-64100 Bayonne, France as type A manager of the Company in replacement of Mr. Sébastien
Loux with immediate effect.

49052

Suit la traduction française de ce qui précède:

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 14 avril 2009

Il est décidé de nommer M. Pierre BOCCON-LIAUDET, né le 7 janvier 1969 à Versailles, France résidant au 3, avenue

du Dr. Fourcade, F-64100 Bayonne, France comme gérant de type A de la société en remplacement de M. Sébastien Loux
avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009056473/9396/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08612. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090065139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

Promotions C. Jans &amp; Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R.C.S. Luxembourg B 95.173.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS, et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009055591/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 30 avril 2009, réf. DSO-DD00253. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090064118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Auberge du Musée SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9275 Vianden, 79, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 94.526.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS, et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY
53, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2009055592/832/16.
Enregistré à Diekirch, le 6 avril 2009, réf. DSO-DD00069. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090064119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

R.B.M. Pose S.A. - Revêtement Bâtiment Marbre Pose S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8226 Mamer, 6, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 103.365.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 mars 2009

1. La révocation du commissaire Didier PILIER, demeurant à 13b rue de Céroux B-1380 Lasne, est acceptée.
2. STRATEGO INTERNATIONAL Sàrl, avec son siège à 370, route de Longwy L-1940 Luxembourg, est nommé

commissaire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2014.

49053

Pour extrait conforme
D. FONTAINE

Référence de publication: 2009055974/13.
(090065399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

S.u.P. Premium III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 132.899.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung

Die Ordentliche Generalversammlung vom 8. April 2009 der S.u.P. Premium III hat folgende Beschlüsse gefasst:
Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2010 werden folgende Personen ge-

wählt:

Herr Nikolaus Rummler (Vorsitzender)
Herr Ulrich Juchem (stellvertretender Vorsitzender)
Herr Jürgen Wieland (Mitglied)
Herr Dieter Baumann (Mitglied)
Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
Die Aktionäre beschließen einstimmig bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung die ifb-Lux-Audit Sàrl als

Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. April 2009.

DZ BANK International S.A.
<i>für S.u.P. Premium III
V. Augsdörfer / T. Haselhorst

Référence de publication: 2009056154/1239/25.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2009, réf. LSO-DD08985. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090064656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Revaler 21 Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.191.

<i>Auszug aus der Anteileabtretung vom 26. Februar 2009

Es geht aus einer Anteileabtretung vor Notar Roger ARRENSDORFF mit dem Amtssitz zu Bad-Mondorf vom 26.

Februar 2009, betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Revaler 21 Holding S.à.r.l. mit Sitz zu L-1840 Lu-
xemburg, 11A, boulevard Joseph II, eingetragen im Handels- und Firmenregister unter der Nummer B141.191, folgendes
hervor:

- Die Gesellschaft F I I F INTERNATIONAL S.A., mit Sitz zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
Eigentümerin von einhundert (100) Anteilen der vorgenannten Gesellschaft, erklärt andurch unter der gesetzlichen

Gewähr Rechtens abzutreten an die Gesellschaft International Education Management AG, IBC Nr. 031706 (Seychellen),
mit Sitz zu Victoria, Mahe (Seychellen), Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street,

Einhundert (100) Anteile der genannten Gesellschaft zum Preise von zwölftausend fünfhundert EURO (12.500.- EUR).
- Schließlich hat die alleinige Anteilinhaberin ihr Einverständnis zu der hiervor gemachten Abtretung geben.
Enregistré à Remich, le 12 mars 2009. REM 2009 / 336. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 6 mai 2009.

Roger ARRENSDORFF
<i>Notaire

Référence de publication: 2009055975/218/24.
(090065292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

49054

Revaler 54 Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.192.

<i>Auszug aus der Anteileabtretung vom 26. Februar 2009

Es geht aus einer Anteileabtretung vor Notar Roger ARRENSDORFF mit dem Amtssitz zu Bad-Mondorf vom 26.

Februar 2009, betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Revaler 54 Holding S.à.r.l., mit Sitz zu L-1840 Lu-
xemburg, 11A, boulevard Joseph II, eingetragen im Handels- und Firmenregister unter der Nummer B141.192, folgendes
hervor:

- Die Gesellschaft F I I F INTERNATIONAL S.A., mit Sitz zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
Eigentümerin von einhundert (100) Anteilen der vorgenannten Gesellschaft, erklärt andurch unter der gesetzlichen

Gewähr Rechtens abzutreten an die Gesellschaft International Education Management AG, IBC Nr. 031706 (Seychellen),
mit Sitz zu Victoria, Mahe (Seychellen), Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street,

Einhundert (100) Anteile der genannten Gesellschaft zum Preise von zwölftausend fünfhundert EURO (12.500.- EUR).
- Schließlich hat die alleinige Anteilinhaberin ihr Einverständnis zu der hiervor gemachten Abtretung geben.
Enregistré à Remich, le 12 mars 2009. REM 2009 / 338. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): MOLLING.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 6 mai 2009.

Roger ARRENTSDORFF
<i>Notaire

Référence de publication: 2009055976/218/24.
(090065276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

Wine Trade International, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 83.926.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 mars 2009

1. La révocation du commissaire Didier PILIER, demeurant 13b, rue de Céroux B-1380 Lasne, est acceptée.
2. STRATEGO INTERNATIONAL Sàrl, avec son siège à 370, route de Longwy L-1940 Luxembourg, est nommé

commissaire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2014.

Pour extrait conforme
D. FONTAINE

Référence de publication: 2009055977/13.
(090065397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

MD'S Import Export, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8120 Bridel, 31, rue de Biergerkraeiz.

R.C.S. Luxembourg B 136.346.

L'an deux mil neuf, le vingt-six mars.
Par devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

La société MD'S INVEST s.à r.l. avec siège à Luxembourg, 11a, avenue Monterey, RCSL B 140.357,
Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 04 juillet 2008, publié au Mémorial C

numéro 1958 du 11 août 2008,

Représentée par ses deux gérants, savoir:
- Monsieur Mathieu DEBEAUMONT, administrateur de sociétés, né à Boulogne-Billancourt, France, le 16 mai 1979,

demeurant à L-2163 Luxembourg, 11a, avenue Monterey, et

- Madame Marie-Lies DESODT, restauratrice, née à leper, Belgique, le 23 avril 1982, demeurant à L-2163 Luxembourg,

11a, avenue Monterey,

nommés à cette fonction et habilités à engager la société sous leur signature conjointe en vertu de la décision prise

en assemblée générale constitutive.

49055

Ces comparants, ès qualités qu'ils agissent, après avoir établi au moyen de l'acte de constitution reçu par Maître

Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 janvier 2008, publié au Mémorial C numéro 670 du 18
mars 2008, suivi de contrats de cession de parts sous seing privé,

Que la société MD'S INVEST s.à r.l. possède toutes les 100 parts de la société à responsabilité limitée MD'S IMPORT

EXPORT s.à r.l., avec siège à Luxembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 136.346, et après avoir déclaré que les
statuts n'ont pas encore été modifiés,

Se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les résolutions

suivantes:

<i>Parts sociales:

L'assemblée prend acte de la cession par:
- Monsieur Mathieu DEBEAUMONT de toutes ses 34 parts sociales,
- Monsieur Timothée DEBEAUMONT de toutes ses 33 parts sociales et
- Monsieur Julien DEBEAUMONT de toutes ses 33 parts sociales,
à la société MD'S INVEST s.à r.l., avec siège à Luxembourg, 11a, avenue Monterey, RCSL B 140.357, qui devient dès

lors, l'associée unique de la société.

<i>Transfert du siège social:

Le siège social est transféré à L-8120 Bridel, 31, rue de Biergerkreitz.
La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée comme suit:
"Le siège social est établi à Bridel."

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants

ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Debeaumont, M.-L. Desodt, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 30 mars 2009. Relation: CAP/2009/1003. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial C.

Capellen, le 7 avril 2009.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009056457/225/47.
(090065893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

Entreprise de Construction Claude Jans SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R.C.S. Luxembourg B 99.506.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Eschweiler extraordinairement en date

<i>du 29 avril 2009 à 10.30 heures

Le mandat du réviseur d'entreprises EWA REVISION S.A., avec siège à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy et

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 38 937 étant venu à échéance,
l'assemblée générale renouvelle son mandat pour une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2012.

Eschweiler, le 29 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2009055593/832/18.
Enregistré à Diekirch, le 30 avril 2009, réf. DSO-DD00250. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090064123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

49056


Document Outline

A.C.G. S.A.

Achem S.A.

Auberge du Musée SA

Bellgrove Holding S.à r.l.

Bersy S.A.

Blackburn Holding Sàrl

Datogon S.A.

Datogon S.A.

Deka International S.A.

Deka International S.A.

DWS Renten Direkt 2014 III

DWS Renten Direkt 2014 III

DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014 III

DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014 III

Eclaircie s.à.r.l.

EDM International

Entreprise de Construction Claude Jans SA

Entreprise de Construction Claude Jans SA

F.A.M. Personal Fund

Fuchs Invest

Garage Jeannot SCHWEIG S.à.r.l.

G&amp;P Invest Sicav

Ingenium

In Tempo by Luc Leroi

International Fund Management S.A.

International Fund Management S.A.

KBL Key Fund

MD'S Import Export

Metro International S.A.

MFS Meridian Funds

Microtron Luxembourg S.à r.l.

Millicom International Cellular S.A.

MU Aberdeen Fund

Nordbat S.A.

Paris VIIIe

Promotions C. Jans &amp; Associés S.A.

QS Italy SICAR S.A.

Quiksilver Deluxe S.à r.l.

R.B.M. Pose S.A. - Revêtement Bâtiment Marbre Pose S.A.

Revaler 21 Holding S.à.r.l.

Revaler 54 Holding S.à.r.l.

Sales Points Center S.A.

Securialis

Servizi Finanziari Internazionali S.A.

S.u.P. Premium III

Transcom WorldWide S.A.

Universal-Investment-1 SICAV-FIS

University Holding S.àr.l.

Valartis German Residential Health Care

Valartis German Residential Health Care

Varama Investment S.A.

Vontobel Exchange Traded Structured Fund

Wine Trade International