logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 886

27 avril 2009

SOMMAIRE

2F Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42513

4I Invest Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42502

AIG Multilabel Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42488

AIG Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42488

Arlon Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

42514

Avixia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42505

Blue Bell S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42496

Blue Sage S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42494

British Marine Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

42515

Bull Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42500

Compagnie de Conseil et d'Investissement

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42505

Convest21 Umbrella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42493

Corporate II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42493

Corporate III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42492

Corporate IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42492

Corporate Special  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42491

Croswell Real Estate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

42512

Dawning International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

42521

DWS Garant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42485

E2P S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42502

EasyETF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42503

Eurolux Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42484

European Fashion Group S.A.  . . . . . . . . . . .

42512

Europe Invest Corporation S.A.  . . . . . . . . .

42514

Fedi Européenne d'Investissement Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42514

Financière de Magonette S.A.  . . . . . . . . . . .

42502

Gefip Euroland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42499

Gest Lease & Trust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42504

Global Brands S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42490

HAIG Asahi-Investmentfund  . . . . . . . . . . . .

42503

Health Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42506

Helios Solar SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42484

Insinger de Beaufort Holdings  . . . . . . . . . . .

42498

Intesa Euroglobal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42490

Kimbol Kompany Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . .

42506

Klammer Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

42528

Kronos Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42497

Les Etangs de l'Abbaye  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42501

LGIG 2 Property C3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

42512

LGIG 2 Property C3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

42508

Marguerite S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42502

Midicon Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42514

Mobad S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42528

Nextra International Sicav  . . . . . . . . . . . . . .

42490

Nord-Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42506

Oriflame Cosmetics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

42482

PEH Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42501

Piguet Strategies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42500

Platina G.T. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

42508

Poolfin Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42502

Post Office Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42520

Rhodes Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42502

RREEF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42491

SAF-Holland S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42485

Samafil Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42519

Selectra Investments Sicav . . . . . . . . . . . . . .

42500

SEPRIM - Société d'Etude et de Promotion

Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42506

Serbeloni n°1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42524

Socimmo Construction et Cie S.e.c.s  . . . .

42527

Socimmo S.A. et Cie Lorentzweiler  . . . . .

42527

Stirovest Management Holdings S.A.  . . . .

42504

Swiss Life Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42521

Triglia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42504

Tuyauterie Développement Exploitation

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42525

UBS Luxembourg Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .

42489

Ulixes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42513

Utopia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42499

Valueinvest Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42489

Veracruz Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42521

Violin Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42520

42481

Oriflame Cosmetics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 8.835.

The ANNUAL GENERAL MEETING

("AGM") of Oriflame Cosmetics S.A. (the "Company") in relation to items 1 to 14 of the agenda below will be held at

the offices of Wildgen, 69 Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg on <i>19 May 2009 at 11 a.m.

<i>Agenda:

1. Approval of the Nomination Committee's proposal that Pontus Andreasson be chairman of the AGM;
2. Reading of the report of the Board of Directors relating to conflicting interests of directors;
3. Approval of the reports of the Board of Directors and of the independent auditor ("réviseur d'entreprises") relating

to the accounts of the Company as at 31 December 2008;

4. Approval of the balance sheet and of the profit and loss statement of the Company as at 31 December 2008 and

of the Consolidated Accounts as at 31 December 2008;

5. Allocation of results of the Company for the financial year ending 31 December 2008 whereby the Board has

proposed that the profit for the financial year 2008 will be carried forward;

6. Approval of the Board of Director's resolution that a dividend distribution of EUR 1.25 per share (or the Swedish

Krona equivalent per Swedish Depository Receipt) shall be paid in cash out of the profits and that 25 May 2009
shall be the record date in respect of such dividend. The payment of cash dividend is expected to occur through
Euroclear Sweden AB (previously VPC AB) on 28 May 2009;

7. Presentation of the work of the Board and the Board committees;
8. Discharge to the directors and the independent auditor (''réviseur d'entreprises") in respect of carrying out their

duties during the financial year ending 31 December 2008;

9. Statutory elections including election of the Chairman of the Board.

- 9.1. The Nomination Committee (Carlos von Hardenberg (Templeton), Per Hesselmark (Stichting af Jochnick
Foundation),  Robert  af  Jochnick,  Åsa  Nisell  (Swedbank  Robur),  Cari  Rosén  (2nd  AP-Fund)  and  Thomas  Ehlin
(Nordea Investment Funds), together representing more than 25 per cent of the number of votes and shares in
the Company) has proposed that all current directors be re-elected, being: Robert af Jochnick, Lennart Björk,
Magnus Brännstrôm, Marie Ehrling, Lilian Fossum, Alexander af Jochnick, Jonas af Jochnick, Helle Kruse Nielsen and
Christian Salamon;
- 9.2. The Nomination Committee further proposes that Robert af Jochnick be re-elected Chairman of the Board;
- 9.3. Approval of the Nomination Committee's proposal to appoint KPMG Audit S.à r.l, with registered offices in
L-2520 Luxembourg, 31 allée Scheffer, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 103590
as independent auditor (''réviseur d'entreprises") for a period ending at the next annual general meeting to be held
in order to approve the accounts of the Company for the year ending 31 December 2009;

10. Approval of the Board of Director's proposal that the Company shall continue to have a nomination committee

("Committee") and approval of the proposed procedure for appointment of the members of the Committee whe-
reby the Board proposes:
that there shall exist a Committee to prepare and make proposal to the AGM regarding the election of the Chairman
of the AGM, Chairman of the Board of Directors, Directors and, if applicable, auditors, as well as the Board of
Directors' fees;
that the Chairman of the Board of Directors shall convene the five largest shareholders of the Company, as it is
known by the Company at that time, at the end of the third quarter of the year. These shareholders then have the
right to appoint one member each to the Committee. If any of the five largest shareholders declines its right to
appoint a member of the Committee, or if a member resigns from the Committee and is not replaced by a new
member appointed by the same shareholder, the shareholder next in size shall be given the opportunity to appoint
a member of the Committee. If several of the shareholders decline their right to appoint members of the Com-
mittee, no more than the eight largest shareholders need to be contacted. The Committee should be chaired by
one of its members. No more than two of the Committee's members should also be members of the Board of
Directors. If any of the shareholders having appointed a member to the Committee sells a not insignificant part of
its shares in the Company and ceases to qualify as a large shareholder with rights to appoint a member to the
Committee, the respective member should resign from the Committee, and a new member should be appointed
by the shareholder next in size. The chairman of the Board of Directors shall, as part of the Committees' work,
present any matters regarding the Board of Directors' work that may be of importance for the Committee's work,
including an evaluation of the work of the Board of Directors and the requirements and skills set to be represented
by the Directors, to the Committee;
that individual shareholders shall have the possibility to give suggestions regarding members of the Board of Di-
rectors to the Committee for further assessment within its scope of work;

42482

that information regarding the composition of die Committee shall be made public at least six months before the
annual general meeting;
that the Committee shall have the right to charge the Company costs for recruitment consultants, if it is deemed
necessary to get an adequate selection of candidates for members of the Board of Directors;

11. Approval  of  the  Nomination  Committee's  proposal  regarding directors'  and committee  fees.  The  Nomination

Committee has proposed that the remuneration to the directors and committee members remain unchanged,
whereby the directors' and committee fees will be allocated as follows: EUR 62,500 to the Chairman of the Board,
EUR 25,000 to each respective remaining non-executive director, EUR 10,000 to each member of the Audit Com-
mittee and EUR 5,000 to each member of the Remuneration Committee;

12. Approval of the Board of Director's proposal on principles of remuneration to members of the Company's top

management. The Board of Directors proposal for principles of remuneration and other terms of employment for
members of the Company's top management entails in essence that Oriflame shall offer competitive salaries ac-
cording  to  position  and  market  in  order  to  attract  and  retain  the  best  individuals  for  the  positions  and  that
remuneration shall consist of the items listed in (i) through (iv):
(i) Fixed base salary: The members of the Company's management shall be offered fixed salaries that are competitive
and which are based on the respective individual's responsibilities and performance;
(ii) Variable compensation: Oriflame allocates 6.5 per cent of any increase to operating profit to profit sharing to
be shared among the Company's top management, however for each individual no more than an equivalent of 12
months salary. The allocation is according to position and performance during the year. The 6.5 per cent includes
company costs for social charges. Moreover, the Company offers a Share Incentive Plan which covers the top
approximately 200 Executives and Managers. Each year the individuals are invited to invest in a number of shares
at the current market price. In return for this they will receive between 0 and 4 free shares in three years time,
depending on the increase of the operating profit of the Company;
(iii) Pensions; Members of the Company's top management and certain other Executives are offered pension benefits
that are competitive in the country where the individual is resident Oriflame pays pensions into an independent
defined contribution scheme. In addition, Oriflame has defined contribution schemes for some of the employees
in compliance with pension requirements in the countries in which the Company operates;
(iv) Non-monetary benefits: Members of the Company's top management and certain other Executives are entitled
to customary non-monetary benefits such as company cars and company health care. Moreover, certain individuals
may be offered company housing and other benefits including school fees.
The proposal coincides with the principles adopted at the 2008 Annual General Meeting.

13. Information relating to the cost calculation of the Oriflame 2005 Share Incentive Plan allocations, as well as infor-

mation relating to the cost calculation of the proposed allocations of Investment Shares in 2009 under the 2008
Share Incentive Plan.

14. Miscellaneous

Notice to shareholders
Shareholders who wish to attend the AGM must
i. be registered as shareholders in the share register of the Company on 8 May 2009
ii. notify the Company of their intention to attend the AGM no later than 5 p.m. on 13 May 2009
Shareholders who are able to prove that they are registered shareholders of the Company as at 8 May 2009 may

attend the AGM.

Shareholders who wish to attend the AGM must give notice of intention to attend by sending attendance cards (avai-

lable on www.oriflame.com under the heading "Attendance Cards for Shareholders") to the registered address of the
Company as stated above of this Convening Notice or by fax (+352 26 20 32 34). They may also send the attendance
card by email to the Company (corporate.governance@oriflame.com). Ail attendance cards must be received by the
Company no later than 5 p.m. on 13 May 2009. The attendance card must be completed in full and signed.

Holders of bearer shares wishing to attend and vote at the AGM in person or by proxy must deposit their bearer

shares at the Company's registered offices no later than 5 p.m. on 15 May 2009 and shall obtain a receipt from the
Company confirming such deposit. Neither a holder of bearer shares nor his or her proxy shall be permitted to attend
or vote at the AGM except upon delivery at the meeting of the receipt confirming such deposit.

Shareholders may vote by proxy. Proxy cards (available on www.oriflame.com under the heading "Proxy Cards for

Shareholders") must be used. In order to be included in the votes, fully completed and signed proxy cards must be received
by the Company at the registered address of the Company as stated above of this Convening Notice or by fax (+352 26
20 32 34) no later than 5 p.m. on 13 May 2009.

Please observe that conversion from shares into SDRs and vice versa is not allowed during the period between 9 May

2009 and 19 May 2009.

The AGM can be validly held without any specifie quorum and resolutions shall be validly adopted at the AGM if

approved by a majority of the shares present or represented and authorized to vote.

Notice to SDR holders
Holders of Swedish Depository Receipts of the Company ("SDRs") who wish to attend the AGM must:

42483

i. be registered in the register kept by Euroclear Sweden AB ("Euroclear") on 8 May 2009
ii. notify Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") their intention to attend the AGM no later than 5 p.m. on

13 May 2009

Only directly registered SDRs are registered in the name of the holder in the register kept by Euroclear. SDR holders

registered in the name of a nominee (which may be a broker or a bank) must have their SDRs registered in their own
names in the Euroclear register to be entitled to give instructions to SEB to vote at the AGM. SDR holders whose holdings
are registered with a nominee should therefore request their nominee to request a temporary owner registration (so-
called voting-right registration) well ahead of 8 May 2009 if they wish to vote.

Only SDR holders who are directly registered in the Euroclear register or who have a voting-right registration by 8

May 2009 may attend the AGM. SDR holders must be able to prove that they are SDR holders as at 8 May 2009 if they
wish to attend the AGM.

SDR holders who are directly registered in the Euroclear register or who have a voting-right registration by 8 May

2009 who wish to attend the AGM must give notice of their intention to attend by sending attendance cards (available
on www.oriflame.com under the heading "Attendance Cards for SDR Holders") to Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ), Issue Department, RB6, SE-106 40 Stockholm, Sweden. They may also send the attendance card by email to SEB
Merchant Bankning (issuedepartment(5)seb,se) All attendance cards must be received by SEB no later than 5 p.m. on 13
May 2009. The attendance card must be completed in full and signed.

SDR holders who are directly registered in the Euroclear register or who have a voting-right registration by 8 May

2009  may  vote  by  proxy.  Voting  is  not  carried  out  by  attending  the  AGM  in  person.  Proxy  cards  (available  on
www.oriflame.com under the heading "Proxy Cards for SDR Holders") must be used. Fully completed and signed proxy
cards must, in order to be included in the votes, be received by Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Issue Depart-
ment, RB6, SE-106 40 Stockholm, Sweden no later than 5 p.m. on 13 May 2009.

SDR  holders  that  have  not  given  SEB  instruction  as  to  the  exercise  of  the  voting  rights  pertaining  to  the  shares

represented by their respective SDRs at the AGM by sending/delivering SEB a completed and signed proxy card, shall be
deemed to have instructed SEB to give a proxy to a person designated by the Company to vote for the shares in the
same manner and in the same proportion as ail other shares in the Company represented by SDRs that are being voted
for at the AGM. However, no such instruction from the SDR holders to SEB shall be deemed given with respect to any
matter where giving such instructions and/or discretionary proxy would not be permitted by applicable bw.

Please observe that conversion from SDRs into shares and vice versa is not allowed during the period between 8 May

2009 and 19 May 2009.

The AGM can be validly held without any specific quorum and resolutions shall be validly adopted at the AGM if

approved by a majority of the shares present or represented and authorized to vote.

Référence de publication: 2009046448/280/152.

Eurolux Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 85.928.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra au siège social le <i>22 mai 2009 à 10h00 et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de 250.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 100.000,- EUR

à 350.000,- EUR, par la création et l'émission de 25.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,- EUR,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009046478/607/17.

Helios Solar SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

R.C.S. Luxembourg B 135.785.

Die Aktionäre werden hiermit zur

42484

GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Dienstag <i>12. Mai 2009, um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden

wird:

<i>Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. Dezember 2008.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statutarische Ernennung.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.
Er kann sich auf Grund schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Référence de publication: 2009046483/21.

DWS Garant, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 130.754.

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Garant werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. Mai 2009 um 12.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2009049196/1352/26.

SAF-Holland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.090.

All shareholders of SAF-HOLLAND S.A. (the "Company") are hereby given notice that the

ANNUAL GENERAL MEETING

(the "Meeting") will be held on <i>May 14, 2009 at 11:00 a.m. (CEST) at the Chambre de Commerce, 7, Rue Alcide de

Gasperi, L-2981 Luxembourg.

<i>Agenda:

1. Presentation of the statutory Management Report and consolidated Management Report for the fiscal year ended

31 December 2008.
The Board of Directors proposes that both management reports in respect of the fiscal year ended 31 December
2008 be APPROVED by the shareholders.

42485

2. Presentation of the reports by the auditors of the Company in respect of the statutory financial statements of the

Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its group, for the fiscal year
ended 31 December 2008.
The Board of Directors proposes that the reports by the auditors in respect of both the statutory and the con-
solidated financial statements for the fiscal year ended 31 December 2008 be APPROVED by the shareholders.

3. Approval of the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2008.

The Board of Directors proposes that the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended
31 December 2008 be APPROVED by the shareholders.

4. Approval of the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year ended 31 De-

cember 2008.
The Board of Directors proposes that the consolidated financial statements of the Company and its group, for the
fiscal year ended 31 December 2008 be APPROVED by the shareholders.

5. Resolution concerning the allocation of the results of the Company for the fiscal year ended 31 December 2008

and approval of distributions.
An amount equal to 5% of the net profits of the Company for the year 2008 is required to be allocated to the legal
reserve of the Company under Luxembourg law until such legal reserve reaches 10% of the issued share capital of
the Company. It is not proposed by the Board of Directors that a dividend be distributed in respect of the results
for the financial year 2008. The Board of Directors recommends that the loss amounting to -11.746 EUR be carried
forward.

6. Discharge to all the directors of the Company who have been in office during the fiscal year ended 31 December

2008.
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE to discharge all the Directors of the Company
who have been in office during the fiscal year ended 31 December 2008 with view to their mandate carried out
during the fiscal year ended 31 December 2008.

7. Discharge to the external auditor of the Company, ERNST &amp; YOUNG S.A. for, and in connection with their

mandate carried out as external auditor pertaining to the financial year ended 31 December 2008.
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE the discharge to Ernst &amp; Young S.A. for, and in
connection with, the financial year ended 31 December 2008.

8. Elections to the Board of Directors

The Board of Directors proposes that the co-optation of Dr Reiner Beutel, CEO of the SAF-HOLLAND Group
GmbH, residing in Ludwigsburg, Germany, to the Board of Directors of the Company with effect from 1 February
2009 until the Meeting be APPROVED and that he be elected as director of the Company from the date of the
Meeting until 23 April 2011.
Dr Reiner Beutel is member of the Supervisory Boards statutorily established or of comparable supervisory com-
mittees of the following companies:
- Mirror Controls International, Montfoort, The Netherlands
- Haldex AB, Stockholm, Sweden
- KUKA AG/IWKA AG, Augsburg, Germany
- Fischer Maschinenbau GmbH, Gemmrigheim, Germany
He will not receive any remuneration in respect of his activity as director of the Company.
It is further proposed by the Board of Directors that Mr Richard Muzzy and Mr Martin Schwab whose mandates
as directors of the Company will end on 18 June 2009 be re-appointed as directors from 19 June 2009 to 23 April
2011.

9. Acknowledgement of the appointment of Dr. Reiner BEUTEL as Chief Executive Officer of the Company's group,

and the election of Bernhard Schneider as Chairman of the Board of Directors of the Company.
The Board of Directors proposes that the appointment of Dr Reiner BEUTEL as Chief Executive Officer of the
Company's group, and the election of Bernhard Schneider as Chairman of the Board of Directors of the Company
be acknowledged.

10. Renewal of the mandate of the external auditor of the Company, ERNST &amp; YOUNG S.A. until the annual general

meeting of the shareholders of the Company in respect of the financial year 2009.
The Board of Directors proposes that ERNST &amp; YOUNG S.A. be re-elected as external auditors until the annual
general meeting of the shareholders of the Company in respect of the financial year 2009.

11. Miscellaneous.

Quorum and majority requirements

There is no quorum of presence requirement for the Meeting. The agenda items are adopted by a simple majority of

the voting rights duly present or represented and expressed during the Meeting.

Share capital and voting rights

At the point of convening of the Meeting, the Company's subscribed share capital equals EUR 207,022.75 and it is

divided into 20,702,275 shares having a par value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up.

Attendance and registration procedures

42486

According to Luxembourg law, the right to vote at the Meeting is restricted to shareholders of the Company. Share-

holders must, therefore, be able to evidence that they are shareholders as at 14 May 2009 in order to attend the Meeting.

Pursuant  to  article  6.5  of  the  articles  of  association  of  the  Company,  all  shareholders  owning  share(s)  which  are

registered in the shareholder's register of the Company in the name of a depositary or owning bearer shares deposited
with a depositary and which shareholders wish to participate in the Meeting and to exercise the right to vote at the
Meeting in person, by proxy or by voting by correspondence shall request an attestation from their depository bank
stating the number of shares held by the shareholder as of the date of issuance of the attestation and that the shares are
blocked in the account of the shareholder until the close of the Meeting, and the attestation shall be sent to the Company,
so that it shall be received by the Company no later than Tuesday, 12 May 2009, at 11:59 p.m. CEST at the following
address:

SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany.

The attestation must be made in text form in German or English.
Shareholders who have submitted the attestation to the Company so that the attestation is received by the Company

prior to 8 May 2009, at 11:59 p.m. CEST, will receive their admission tickets by mail. Shareholders who have submitted
the attestation to the Company so that the attestation is received by the Company later than 8 May 2009, 11:59 p.m.
CEST, but prior to 12 May 2009, at 11:59 p.m. CEST, will receive their admission tickets at the registration area to the
Meeting.

Proxy Voting Representatives
Shareholders who do not wish to participate in the Meeting themselves may arrange to be represented at the Meeting

and for their votes to be cast by any authorized agent, including but not limited to a bank or shareholders' association,
by conferring the appropriate written proxy. The authorised agent will have to identify himself by submitting the admission
ticket of the shareholder and by presenting a duly signed written power of attorney at the Meeting.

In order to simplify the execution of their voting rights, the Company provides the option of appointing a proxy voting

representative named by the Company and bound by the instructions of the shareholder prior to the Meeting. Share-
holders who wish to appoint the proxy voting representative named by the Company to vote on their behalf, shall send
a duly completed and signed proxy form to the Company, so that it shall be received by the Company no later than
Tuesday 12 May 2009, at 11:59 p.m. CEST at the following address:

SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany.

Shareholders who will receive their admission tickets by mail will receive a form for proxy votes. Forms for proxy

votes can also be downloaded on the Company's website at www.safholland.de. In addition, forms will be sent upon
written request to the Company at the following address:

SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany.

Vote by correspondence
Shareholders who wish to vote by correspondence must request a form for voting by correspondence from the

Company at the following address

SAF-HOLLAND S.A.
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany,
or alternatively download the form from the Company's website at www.safholland.de, and send the duly completed

and signed form to the above mentioned address so that it shall be received by the Company no later than Wednesday
13 May 2009, at 11:59 p.m. CEST.

42487

Miscellaneous
Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January

2008 on transparency requirements for issuers of securities, there is no limit to the maximum number of votes that may
be exercised by the same person, whether in its own name or by proxy.

The Meeting's shareholders documentation (i.e. inter alia the agenda, the annual report containing the 2008 annual

financial statements, the management reports and the auditor reports on the statutory and consolidated accounts) is
available on the Company's website at www.safholland.de and at the Company's registered office in Luxembourg.

For further information you can contact the service provider, Haubrok Corporate Events GmbH, by dialing +49.(0)

89.210.27.222 (Mon. - Fri. 9:00 a.m. to 5:00 p.m. CEST).

Luxembourg, in April 2009.

<i>Board of Directors.

Référence de publication: 2009048145/141.

AIG Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.227.

Die JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber der AIG SICAV wird am Gesellschaftssitz am <i>15. Mai 2009 um 15.00 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2009
6. Sonstiges

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Hauptversammlung kein Quorum verlangt wird

und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber an der Hauptversammlung
gefasst werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049188/584/21.

AIG Multilabel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.052.

Die JÄHRLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber der AIG MULTILABEL SICAV wird am Gesellschaftssitz am <i>15. Mai 2009 um 15.00 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2009
6. Sonstiges

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Hauptversammlung kein Quorum verlangt wird

und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber an der Hauptversammlung
gefasst werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049189/584/21.

42488

UBS Luxembourg Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.778.

Shareholders are kindly convened to attend the

GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on <i>13 May, 2009 at 11:30 a.m.

with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Notice on the ordinary general meeting of 15 April 2009, which was not held on the specified statutory date as

the financial statements as of November 30, 2008 were not provided in due time

2. Reports of the Board of Directors and of the Auditors
3. Approval of the financial statements as of November 30, 2008
4. Decision on allocation of net profits
5. Discharge of the Directors and of the Auditors in respect of the carrying out of their duties during the financial

year ended November 30, 2008

6. Election and Remuneration of the Board Members
7. Appointment of the Auditor
8. Miscellaneous

<i>Voting

Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the

Meeting.

<i>Notes

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
* in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A.,

which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on May 11, 2009.

* by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as

aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS LU-
XEMBOURG SICAV c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. at the latest on May 11, 2009.

Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009049191/755/33.

Valueinvest Lux, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 83.606.

The Shareholders are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on <i>May 13, 2009 at 11.30 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2008 and allocation of the results.
3. Discharge to be granted to the Directors.
4. Discharge to be granted to the Conducting Officers.
5. Statutory appointments.
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the

registered office of the Sicav.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares one working day before the date

of the assembly with KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009049190/755/21.

42489

Nextra International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 51.690.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2009 à 14.00 heures au siège social de la SICAV, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation et ratification du projet de fusion daté du 12 mars 2009;
2. Approbation de la fusion par absorption de Nextra International Sicav (NIS) par Eurizon Investment Sicav (EIS);
3. Dissolution de Nextra International Sicav (NIS) de la fusion par absorption;
4. Décharge donnée au Conseil d'Administration et à l'expert indépendant mandaté pour la fusion par absorption;
5. Divers.

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour s'est réunie le 23 avril 2009 mais

n'a pu délibérer valablement faute de quorum de présence suffisant. La présente assemblée décidera quelle que soit la
portion du capital représentée et les décisions seront adoptées à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée

générale auprès de Sanpaolo Bank SA, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009049192/755/22.

Intesa Euroglobal, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 66.810.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2009 à 14.00 heures au 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation et ratification du projet de fusion daté du 12 mars 2009;

Approbation de la fusion par absorption de Intesa EuroGlobal par Eurizon Investment Sicav-Strategic Europe.

2. Dissolution de Intesa EuroGlobal de la fusion par absorption;
3. Décharge donnée au Conseil d'Administration et à l'expert indépendant mandaté pour la fusion par absorption;
4. Divers.

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour s'est réunie le 23 avril 2009 mais

n'a pu délibérer valablement faute de quorum de présence suffisant. La présente assemblée décidera quelle que soit la
portion du capital représentée et les décisions seront adoptées à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée

générale auprès de Sanpaolo Bank SA, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Les actionnaires souhaitant être représentés lors de cette assemblée peuvent obtenir le formulaire de procuration

auprès du même organisme.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009049193/755/25.

Global Brands S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 70.673.

Following  a  written  requisition  of  shareholders  representing  more  than  one-tenth  of  the  capital  of  the  Company

requiring the board of directors of the Company (the Board) to convene an ordinary general meeting of the shareholders
of the Company (a Meeting) and in accordance with article 70 § 2 of the law dated 10 August 1915 related to commercial
companies, as amended, and in accordance with article 17.5 (b) of the articles of association of the Company, the Board
accepted such a requisition by resolutions dated 23 April 2009.

42490

Consequently, the Board has the honour to invite you to attend the

MEETING

of the shareholders of the Company, which will be held on 14 May 2009 at 4 pm in Luxembourg, at the registered

office of the Company in order to decide on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Convening formalities;
2. Decision to dismiss Mr Yair Hasson and Mr Amir Hasson as members of the Board;
3. Decision to appoint special proxies; and
4. Miscellaneous.

For the general meeting of the shareholders to be validly held, no minimum quorum of outstanding shares must be

present or represented and the resolutions have to be approved by a majority of shareholders.

We invite you to send a duly completed and signed proxy form to Global Brands S.A., 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148

Luxembourg, to the attention of Mr Jean Lambert, so as to reach it prior to 11 May 2009.

Luxembourg, 27 April 2009.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009049194/755/25.

RREEF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 118.790.

The shareholders of SICAV RREEF are hereby invited to the

ORDINARY GENERAL MEETING

which will take place on <i>May 15, 2009 at 10 AM at the company's business premises.

<i>Agenda:

1. Report by the board of directors and auditor's report.
2. Approval of the balance sheet and statement of income submitted by the board of directors for the fiscal year

ended December 31, 2008.

3. Discharge of the board of directors.
4. Allocation of annual profits.
5. Appointment of the auditor.
6. Statutory appointments.
7. Miscellaneous.
Participation in the ordinary general meeting and voting rights are limited to those shareholders who submit to the

company a securities account statement from a bank before May 11, 2008 which shows that the shares are blocked until
the end of the annual general meeting. Shareholders may appoint proxies to act on their behalf. Such appointments must
be made in writing.

A duly called general meeting represents all of the shareholders. The presence of a minimum number of shareholders

is not required. Resolutions are passed by simple majority of the shares that are represented.

Luxembourg, April 2009.

The board of directors.

Référence de publication: 2009049195/1352/25.

Corporate Special, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 132.035.

Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>15. Mai 2009 um 13.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.

42491

6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049197/1352/26.

Corporate IV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 141.161.

Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. Mai 2009 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049198/1352/26.

Corporate III, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 131.532.

Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. Mai 2009 um 12.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft

42492

einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049199/1352/26.

Corporate II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 131.531.

Die Anteilinhaber der SICAV Corporate II werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. Mai 2009 um 11.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2008.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-

linhaber  berechtigt,  die  bis  spätestens  11.  Mai  2009  die  Depotbestätigung  eines  Kreditinstitutes  bei  der  Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im April 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009049201/1352/26.

Convest21 Umbrella, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.101.

Die JÄHRLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber der CONVEST21 UMBRELLA wird am Gesellschaftssitz am <i>15. Mai 2009 um 15.30 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2009
6. Sonstiges
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Hauptversammlung kein Quorum verlangt wird

und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber an der Hauptversammlung
gefasst werden.

CONVEST21 UMBRELLA
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2009049202/584/0.
Référence de publication: 2009049202/584/23.

42493

Blue Sage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.102.

The shareholders of Blue Sage S.A. (the "Company") have been convened, in accordance with article 70 of the Lu-

xembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by registered mail sent on 31 March
2009 (the "First Convening Notice") to an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the "First
Meeting"), which was held on 8 April 2009 before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.

It resulted from the attendance list that out of 600 (six hundred) shares representing the whole corporate capital, one

hundred forty-eight (148) shares, i.e. less than half of the shares issued by the Company, were duly represented at the
First Meeting and that therefore the legally required quorum in order for the First Meeting to be able to deliberate and
decide validly on the agenda, had not been satisfied.

It was therefore decided to adjourn the First Meeting and to reconvene a second meeting of the shareholders of the

Company with the same agenda as the First Meeting.

Therefore, in accordance with article 67-1 of the Law, the board of directors of the Company invites the shareholders

of the Company to attend a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company, which will be held in front of the Luxembourg notary public Mr. Paul Decker,

residing professionally at 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>18 May 2009 at
11.00 am (Luxembourg time) (the "Extraordinary Shareholders Meeting").

The Extraordinary Shareholders Meeting will have the following agenda which is the same as for the First Meeting:

<i>Agenda:

1. To take notice of the loss of the Company in the amount of EUR 163,948.95 (one hundred sixty-three thousand

nine hundred forty-eight Euro and ninety-five Cent) brought forward for the financial year 2007, ending 31 De-
cember 2007, and in the amount of EUR 29,656,418.96 (twenty-nine million six hundred fifty-six thousand four
hundred eighteen Euro and ninety-six Cent) for the financial year 2008, ending 31 December 2008, and pursuant
to article 100 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), decision
to approve the continuation of the Company notwithstanding the fact that the net assets of the Company are below
25% of the share capital of the Company.

2. Decision to decrease the par value of the existing shares of the Company from EUR 50,000 (fifty thousand Euro)

each to EUR 1 (one Euro) each and subsequently, as a result, to convert the existing 600 (six hundred) shares
representing the Company's current share capital into 30,000,000 (thirty million) shares with a par value of EUR 1
(one Euro) each.

3. Decision  to  reduce  the  Company's  share  capital  by  an  amount  of  EUR  29,700,000  (twenty-nine  million  seven

hundred thousand Euro) in order to bring it from its current amount of EUR 30,000,000 (thirty million Euro) to
EUR 300,000 (three hundred thousand Euro) by reduction of the par value of the Company's shares from EUR 1
(one Euro) each to EUR 0.01 (one Cent) each in order to partially offset losses of the Company pursuant to Art.
69 paragraph 4 of the Law and to amend article 5 of the Company's Articles accordingly.

4. Decision to approve, in addition to the existing authorised capital of the Company, an authorised share capital of

a maximum amount of EUR 8,538,463.58 (eight million five hundred thirty-eight thousand four hundred sixty-three
Euro and fifty-eight Cent) and a minimum amount of EUR 6,403,846.93 (six million four hundred three thousand
eight hundred forty-six Euro and ninety-three Cent) for a period not exceeding 12 (twelve) months as of the date
of today (the "Authorised Capital") authorising the Company's board of directors (the "Board of Directors") to
issue, within the limits of the Authorised Capital and in accordance with the terms and conditions as set out below,
a maximum amount of EUR 853,846,358 (eight hundred fifty-three million eight hundred forty-six thousand three
hundred fifty-eight) new shares with a par value of EUR 0.01 (one Cent) each, and a minimum amount of 640,384,693
(six hundred forty million three hundred eighty-four thousand six hundred ninety-three) new shares with a par
value of EUR 0.01 (one Cent) each, having the same rights and obligations as the existing shares for contribution
in cash (the "New Shares").
Declaration by the Shareholders that they have received the special report of the Board of Directors foreseen by
article 32-3 (5) of the Law, to limit their preferential rights to subscription with respect to the issue of the New
Shares and decision to accept this special report of the Board of Directors and to limit the preferential subscription
rights of the existing shareholders with respect to the issue of the New Shares as follows:
- the right of the existing shareholders to subscribe to the New Shares is limited to a period starting two working
days following the Extraordinary General Meeting to be held on or about 8 April 2009 (or on or about 8 May 2009
if the quorum is not met on the first meeting) and lasting twenty (20) consecutive days, which may be renewed at
the discretion of the Board of Directors (the "Shareholders Subscription Period"), it being understood that the
period will expire at 12.00 a.m. on the last day of the Shareholders Subscription Period;

42494

- at the end of the Shareholders Subscription Period, the Board of Directors shall offer unsubscribed New Shares
to third party investors, selected by the Board of Directors, for a period of 1 (one) week, which may be renewed
at the discretion of the Board of Directors (the "Third Parties Subscription Period" and together with the Share-
holders Subscription Period the "Subscription Period").

5. Decision to authorise the Board of Directors to determine at the end of the Subscription Period the date of the

issue and the number of New Shares having to be eventually subscribed and issued, it being understood that in case
the minimum amount of EUR 6,403,846.93 (six million four hundred three thousand eight hundred forty-six Euro
and ninety-three Cent) for the share capital increase is not reached, no share capital increase will take place.

6. Decision to authorise the Board of Directors (i) to do all things necessary to amend article 5 of the Articles in

order to record the change of share capital following an increase pursuant to the issue of the New Shares, (ii) to
take or authorize the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with
the Law, (iii) to delegate to the chairman or any director of the Company or to any other duly authorised person,
the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the New Shares representing all of such increased
amounts of capital and (iv) to enact the issue of the New Shares by a Luxembourg notary or, as the case may be,
to declare that the capital increase has not taken place.

7. Miscellaneous.

In conformity with article 32-3 (5) of the Law, we draw your attention especially to point 4 of the above-mentioned
agenda which foresees that the Extraordinary Shareholders Meeting will resolve to limit the preferential subscrip-
tion rights of the existing shareholders of Blue Sage with respect to the issue of the New Shares. In this respect
we refer to the Special Board Report (enclosed in the First Convening Notice) setting out the reasons for the
existing shareholders of Blue Sage to limit their preferential subscription rights.
In conformity with article 69 (1) of the Law, we hereby also stress that the purpose of the share capital reduction
foreseen in point 3 of the above-mentioned agenda is to offset losses incurred by Blue Sage pursuant to Art. 69 (4)
of the Law and that the share capital reduction will be carried out by reducing the par value of Blue Sage's shares
from EUR 1 (one Euro) each to EUR 0.01 (one Cent) each.
Please find below the general rules which govern the holding of the Extraordinary Shareholders Meeting of the
Company:
Convening notices
Since the legally required quorum for the First Meeting was not satisfied, a second shareholders meeting may be
convened pursuant to article 67-1 (2) of the Law by means of notices published twice, at fifteen days interval at
least and fifteen days before the shareholders meeting in the Luxembourg official gazette (the Mémorial) and in two
Luxembourg newspapers. Such convening notices shall reproduce the agenda and indicate the date and results of
the previous meeting.
Quorum and Majority
Please note that pursuant to articles 67-1 (2) of the Law, the Extraordinary Shareholders Meeting shall validly
deliberate regardless of the proportion of the share capital represented.
The resolutions on the above-mentioned agenda will only be validly adopted pursuant to article 67-1 (2) of the
Law, if they are adopted by at least two-thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attached to
shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank
or invalid vote.
Pursuant to article 67 (4) of the Law, each share gives the right to one vote.
Representation - Power of attorney
Pursuant to article 67 (3) of the Law, every shareholder shall be entitled to vote personally or by proxy.
If you cannot be personally present at the Extraordinary Shareholders Meeting and wish to be represented, we
would kindly ask you to return, before 18 May 2009, 8.00 am, the power of attorney enclosed to the First Convening
Notice duly completed and signed by sending a pdf-copy of the proxy to the attention of Mr. Fabrice Geimer at
FGeimer@Citco.com with the original proxy to follow to the following address:
Blue Sage, S.A.
2-8, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
For your convenience, the power of attorney enclosed to the First Convening Notice will be resent to you by
registered mail.
For the avoidance of doubt, any power of attorney granted for the First Meeting will remain valid for the Extraor-
dinary Shareholders Meeting unless otherwise expressed by you.

Référence de publication: 2009044483/710/116.

42495

Blue Bell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.105.

The shareholders of Blue Bell S.A. (the "Company") have been convened, in accordance with article 70 of the Luxem-

bourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by registered mail sent on 31 March
2009 (the "First Convening Notice") to an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the "First
Meeting"), which was held on 8 April 2009 before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.

It resulted from the attendance list that out of 320 (three hundred and twenty) shares representing the whole corporate

capital, forty-nine (49) shares, i.e. less than half of the shares issued by the Company, were duly represented at the First
Meeting and that therefore the legally required quorum in order for the First Meeting to be able to deliberate and decide
validly on the agenda, had not been satisfied.

It was therefore decided to adjourn the First Meeting and to reconvene a second meeting of the shareholders of the

Company with the same agenda as the First Meeting.

Therefore, in accordance with article 67-1 of the Law, the board of directors of the Company invites the shareholders

of the Company to attend a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company, which will be held in front of the Luxembourg notary public Mr. Paul Decker,

residing professionally at 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on  <i>18 May 2009 at
11.30 am (Luxembourg time) (the "Extraordinary Shareholders Meeting").

The Extraordinary Shareholders Meeting will have the following agenda which is the same as for the First Meeting:

<i>Agenda:

1. To take notice of the loss of the Company in the amount of EUR 39,805,436.41 (thirty-nine million eight hundred

five thousand four hundred thirty-six Euro and forty-one Cent), and pursuant to article 100 of the Luxembourg
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), decision to approve the continuation
of the Company notwithstanding the fact that the net assets of the Company are below 25% of the share capital
of the Company.

2. Decision to decrease the par value of the existing shares of the Company from EUR 50,000 (fifty thousand Euro)

each to EUR 1 (one Euro) each and subsequently, as a result, to convert the existing 320 (three hundred and twenty)
shares representing the Company's current share capital into 16,000,000 (sixteen million) shares with a par value
of EUR 1 (one Euro) each.

3. Decision to reduce the Company's share capital by an amount of EUR 15,840,000 (fifteen million eight hundred

forty thousand Euro) in order to bring it from its current amount of EUR 16,000,000 (sixteen million Euro) to EUR
160,000 (hundred sixty thousand Euro) by reduction of the par value of the Company's shares from EUR 1 (one
Euro) each to EUR 0.01 (one Cent) each in order to partially offset losses of the Company pursuant to Art. 69
paragraph 4 of the Law and to amend article 5 of the Company's Articles accordingly.

4. Decision to approve, in addition to the existing authorised capital of the Company, an authorised share capital of

a maximum amount of EUR 11,461,537.42 (eleven million four hundred sixty-one thousand five hundred thirty-
seven Euro and forty-two Cent) and a minimum amount of EUR 8,596,153.70 (eight million five hundred ninety-six
thousand one hundred fifty-three Euro and seventy Cent) for a period not exceeding 12 (twelve) months as of the
date of today (the "Authorised Capital") authorising the Company's board of directors (the "Board of Directors")
to issue, within the limits of the Authorised Capital and in accordance with the terms and conditions as set out
below, a maximum amount of 1,146,153,742 (one billion one hundred forty-six million one hundred fifty-three
thousand seven hundred forty-two) new shares with a par value of EUR 0.01 (one Cent) each, and a minimum
amount of 859,615,370 (eight hundred fifty-nine million six hundred fifteen thousand three hundred seventy) new
shares with a par value of EUR 0.01 (one Cent) each, having the same rights and obligations as the existing shares
for contribution in cash (the "New Shares").
Declaration by the Shareholders that they have received the special report of the Board of Directors foreseen by
article 32-3 (5) of the Law, to limit their preferential rights to subscription with respect to the issue of the New
Shares and decision to accept this special report of the Board of Directors and to limit the preferential subscription
rights of the existing shareholders with respect to the issue of the New Shares as follows:
- the right of the existing shareholders to subscribe to the New Shares is limited to a period starting two working
days following the Extraordinary General Meeting to be held on or about 8 April 2009 (or on or about 8 May 2009
if the quorum is not met on the first meeting) and lasting twenty (20) consecutive days, which may be renewed at
the discretion of the Board of Directors (the "Shareholders Subscription Period"), it being understood that the
period will expire at 12.00 a.m. on the last day of the Shareholders Subscription Period;
- at the end of the Shareholders Subscription Period, the Board of Directors shall offer unsubscribed New Shares
to third party investors, selected by the Board of Directors, for a period of 1 (one) week, which may be renewed

42496

at the discretion of the Board of Directors (the "Third Parties Subscription Period" and together with the Share-
holders Subscription Period the "Subscription Period").

5. Decision to authorise the Board of Directors to determine at the end of the Subscription Period the date of the

issue and the number of New Shares having to be eventually subscribed and issued, it being understood that in case
the minimum amount of EUR 8,596,153.70 (eight million five hundred ninety-six thousand one hundred fifty-three
Euro and seventy Cent) for the share capital increase is not reached, no share capital increase will take place.

6. Decision to authorise the Board of Directors (i) to do all things necessary to amend article 5 of the Articles in

order to record the change of share capital following an increase pursuant to the issue of the New Shares, (ii) to
take or authorize the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with
the Law, (iii) to delegate to the chairman or any director of the Company or to any other duly authorised person,
the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the New Shares representing all of such increased
amounts of capital and (iv) to enact the issue of the New Shares by a Luxembourg notary or, as the case may be,
to declare that the capital increase has not taken place.

7. Miscellaneous.

In conformity with article 32-3 (5) of the Law, we draw your attention especially to point 4 of the above-mentioned
agenda which foresees that the Extraordinary Shareholders Meeting will resolve to limit the preferential subscrip-
tion rights of the existing shareholders of Blue Bell with respect to the issue of the New Shares. In this respect we
refer to the Special Board Report (enclosed in the First Convening Notice) setting out the reasons for the existing
shareholders of Blue Bell to limit their preferential subscription rights.
In conformity with article 69 (1) of the Law, we hereby also stress that the purpose of the share capital reduction
foreseen in point 3 of the above-mentioned agenda is to offset losses incurred by Blue Bell pursuant to Art. 69 (4)
of the Law and that the share capital reduction will be carried out by reducing the par value of Blue Bell's shares
from EUR 1 (one Euro) each to EUR 0.01 (one Cent) each.
Please find below the general rules which govern the holding of the Extraordinary Shareholders Meeting of the
Company:
Convening notices
Since the legally required quorum for the First Meeting was not satisfied, a second shareholders meeting may be
convened pursuant to article 67-1 (2) of the Law by means of notices published twice, at fifteen days interval at
least and fifteen days before the shareholders meeting in the Luxembourg official gazette (the Mémorial) and in two
Luxembourg newspapers. Such convening notices shall reproduce the agenda and indicate the date and results of
the previous meeting.
Quorum and Majority
Please note that pursuant to articles 67-1 (2) of the Law, the Extraordinary Shareholders Meeting shall validly
deliberate regardless of the proportion of the share capital represented.
The resolutions on the above-mentioned agenda will only be validly adopted pursuant to article 67-1 (2) of the
Law, if they are adopted by at least two-thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attached to
shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank
or invalid vote.
Pursuant to article 67 (4) of the Law, each share gives the right to one vote.
Representation - Power of attorney
Pursuant to article 67 (3) of the Law, every shareholder shall be entitled to vote personally or by proxy.
If you cannot be personally present at the Extraordinary Shareholders Meeting and wish to be represented, we
would kindly ask you to return, before 18 May 2009, 8.00 am, the power of attorney enclosed to the First Convening
Notice duly completed and signed by sending a pdf-copy of the proxy to the attention of Mr. Fabrice Geimer at
FGeimer@Citco.com with the original proxy to follow to the following address:
Blue Bell, S.A.
2-8, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
For your convenience, the power of attorney enclosed to the First Convening Notice will be resent to you by
registered mail.
For the avoidance of doubt, any power of attorney granted for the First Meeting will remain valid for the Extraor-
dinary Shareholders Meeting unless otherwise expressed by you.

Référence de publication: 2009044484/710/114.

Kronos Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.839.

Le Conseil d'Administration de KRONOS FUND (la "Sicav") a décidé de soumettre la question de la dissolution de la

SICAV à l'Assemblée Générale des actionnaires.

42497

En conséquence, les actionnaires de la SICAV sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tiendra le vendredi <i>8 mai 2009 à 11.00 heures au siège social de la SICAV, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la SICAV;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur;
4. Nomination de KPMG Audit S.à r.l. en tant que réviseur à la liquidation;
5. Divers.

Conformément aux dispositions de l'Article 13 des statuts de la SICAV, le calcul de la valeur nette d'inventaire, l'émis-

sion, le rachat et la conversion des actions de la SICAV peuvent être suspendus dès la publication de l'avis de convocation
d'une assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer sur la dissolution de la SICAV. Par conséquent, les action-
naires sont informés que le calcul de la valeur nette d'inventaire des actions et l'émission, le rachat et la conversion
d'actions de la SICAV sont suspendus à partir du mercredi 15 avril 2009.

L'Assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les

résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres auprès

de la Banque Degroof Luxembourg S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Luxembourg, le 15 avril 2009.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009044933/584/27.

Insinger de Beaufort Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 49.429.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company will be held at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg on <i>6 May 2009 2008 at 12.00 h for the

purpose of considering and resolving on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the reduction of the ordinary share capital of the Company from 14,897,872 Ordinary Shares of EUR

2.00 each to 9,931,915 Ordinary Shares of EUR 2.00 each via the redemption of 1 Ordinary Share for every 3
Ordinary Shares at an amount of up to EUR 10.50 per share redeemed, and cancellation of the Ordinary Shares
redeemed;

2. Proxy to the Directors to determine and implement the re-imbursement of the redemption amount of 4,965,957

Ordinary Shares pursuant to resolution (1) above including the payment to Ordinary Shareholders of up to EUR
10.50 per Ordinary Share redeemed in the form of a reduction of capital out of which EUR 2.00 will be funded out
of share capital and the remainder of up to EUR 8.50 will be funded out of distributable reserves;

3. Change of the name from Insinger de Beaufort Holdings S.A. to IdB Holdings S.A.;
4. Removal from the articles of association of the Company of the requirement for shareholders of the Company

with an interest in the Company of 10% or more to obtain approval from De Nederlandsche Bank to hold such
shares and exercise the voting powers in relation thereto, as set out in article 9.9 of the articles of association.

5. Amendment of articles 1, 5 and 9 to reflect the amendments which have been resolved upon pursuant to resolutions

1, 3 and 4.

Dated 14 April 2009.

<i>The Board of Directors.

<i>Notes

(1) Shareholders registered as such on 29 April 2009 after Closing are entitled to attend and cast votes at the EGM,

regardless of whether they are shareholders at the time of the EGM.

(2) Ordinary Shares can be held in two ways:
a. as registered shares (the shareholders are included in the Company's shareholders'register);
b. in an account with an account holder of Euroclear or Clearstream. These shares are included in the Company's

shareholders' register in the name of Euroclear or Clearstream.

42498

Under the articles of association of the Company, only shareholders included in the shareholders' register of the

Company are permitted to attend and vote at the EGM. They may alternatively be represented by a proxy in writing.

(3) Shareholders holding their shares through Euroclear or Clearstream who wish to attend the EGM, or want Euro-

clear or Clearstream to vote on their behalf should contact their custodian bank to establish I the correct procedure to
attend and vote at the above meeting or appoint a proxy.

(4) A form of Proxy is available at the website of the Company (www.insinger.com). The form of Proxy, to be valid,

must be received at the registered office of the Company before 17.00 p.m. (CET) on 4 May 2009.

(5)  The  resolutions contained  under  the agenda  will be  validly taken  if  at  least 50% of  the issued shares (i.e.  the

outstanding Ordinary Shares) are present or represented and voted in favour of by at least two thirds of the Ordinary
Shares so present or represented.

(6) The Proxy is specially authorised to vote in favor of the items on the above agenda.
Référence de publication: 2009046128/250/45.

Gefip Euroland, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 52.100.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires ("l'Assemblée") qui se tiendra le mercredi <i>6 mai 2009 à 11.00 heures, au siège de la Société et qui

aura pour:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
5. Composition du conseil d'administration.
6. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur

doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de BNP Paribas Luxembourg, 10A,
boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, où des formulaires de procuration sont disponibles.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009046167/755/24.

Utopia S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 5.254.090,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 29.756.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu jeudi, le <i>7 mai 2009 à 10.00 heures au siège social de la société, 45, avenue J.F. Kennedy, à Luxembourg-

Kirchberg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé de l'exercice 2008
2. Lecture des rapports du réviseur d'entreprises
3. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2008
4. Affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs
6. Désignation du réviseur d'entreprises
7. Nominations statutaires
8. Prolongation de l'autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions

42499

9. Divers

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l'article 17 des statuts, déposer leurs

titres pour mercredi, le 29 avril 2009 au plus tard, auprès de la Dexia Banque Internationale à Luxembourg.

Les actionnaires peuvent se faire représenter dans les conditions déterminées par l'article 17 des statuts; les procu-

rations doivent être déposées auprès du siège social pour mercredi, le 29 avril 2009 au plus tard.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Nico Simon / Alain Huberty
<i>Administrateur-Délégué / Président

Référence de publication: 2009046304/6257/28.

Selectra Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 136.880.

The Shareholders are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on <i>May 5, 2009 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2008 and allocation of the results.
3. Discharge to the Directors.
4. Discharge to the Conducting Officers.
5. Statutory appointments.
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the

registered office of the Sicav.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares one business day before the date

of the assembly, with KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009046170/755/21.

Piguet Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.807.

The Board of Directors convenes the Shareholders of PIGUET STRATEGIES to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office on <i>6 May 2009 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2008
3. Allocation of the results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Auditor
6. Statutory elections.

The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the

votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav.

<i>For the Board of Directors.

Référence de publication: 2009046180/7/19.

Bull Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 91.846.

42500

The Board of Directors convenes the Shareholders of BULL FUND to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the company on <i>6 May 2009 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2008
3. Allocation of results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Auditor
6. Statutory elections.

The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav.

<i>For the Board of Directors.

Référence de publication: 2009046393/7/19.

PEH Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.128.

Die Aktionäre der PEH SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>6. Mai 2009 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2008
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrat
7. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz
der Gesellschaft erhältlich.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende

Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der
ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der

ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009046179/7/27.

Les Etangs de l'Abbaye, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 45.610.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>6 mai 2009 à 10.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

42501

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009046400/833/18.

E2P S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 66.110.

Rhodes Enterprise, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 56.142.

Financière de Magonette S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 81.819.

Marguerite S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 59.045.

4I Invest Ltd, Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 60.097.

Poolfin Inc., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 61.188.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

<i>Extrait

Par jugements rendus en date du 2 avril 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation des sociétés E2P S.A., dont
le siège social à L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Charles Marx, a été dénoncé en date du 29 décembre 2006; RHODES
ENTERPRISE S.A., dont le siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été dénoncé en date du 1 

er

 décembre

2006; FINANCIERE DE MAGONETTE S.A., dont le siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, a dénoncé en date
du 30 novembre 2006; MARGUERITE S.A., dont le siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, a été dénoncé en
date du 30 novembre 2006; 4I INVEST Ltd S.A., dont le siège social à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks, a été dénoncé
en date du 29 décembre 2006; POOLFIN INC. S.A., dont le siège social à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks, a été dénoncé
en date du 29 décembre 2006.

Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, et liquidateur Maître Jonathan BURGER, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à

Luxembourg avant le 24 avril 2009.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg.

42502

Pour extrait conforme
Maître Jonathan BURGER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047876/8870/53.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01228. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01230. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01231. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01232. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01233. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01234. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090050579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.
(090050583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.
(090050584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.
(090050585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.
(090050586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.
(090050587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.

EasyETF, Fonds Commun de Placement.

Le Règlement de Gestion coordonné du Fonds Commun de Placement EasyETF, a été déposé au Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2009.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Dominique-Emmanuelle OTTAVI
<i>Directeur Général Adjoint

Référence de publication: 2009047068/2300/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02589. - Reçu 124,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

HAIG Asahi-Investmentfund, Fonds Commun de Placement.

Das Sondervermögen HAIG Asahi-Investmentfund wurde von der Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet
(''Gesetz von 2002'').

Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 1. April 2009 in Kraft trat und zwecks Veröffentlichung am

27. April 2009 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt
wurde.

Luxemburg, 1. April 2009.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009047071/1346/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03459. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

42503

Stirovest Management Holdings S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 60.445.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement du 2 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a

prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:

- la société anonyme STIROVEST MANAGEMENT HOLDINGS S.A., dont le siège social établi à L-2346 Luxembourg,

20, rue de la Poste, a été dénoncé en date du 15 décembre 2006, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60445;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY et liquidateur Maître Asel COURMON-

TAGNE, avocat, demeurant 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2009.

Pour extrait conforme

e

 Asel Courmontagne

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047861/1035/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02060. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Triglia S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 41.878.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de TRIGLIA S.A., société anonyme avec siège social au, 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
dénoncé en date du 4 décembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41.878.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur Maître Nicolas BO-

NORA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2009.

Maître Nicolas BONORA
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047856/10119/21.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02182. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

Gest Lease &amp; Trust S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 72.130.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de GEST LEASE &amp; TRUST S.A., société anonyme avec siège social au, 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg dénoncé en date du 4 décembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 72.130.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur Maître Nicolas BO-

NORA, avocat, demeurant à Luxembourg.

42504

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2009.

Maître Nicolas BONORA
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047857/10119/22.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02180. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090051855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

Avixia S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 73.318.

Compagnie de Conseil et d'Investissement S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 50.276.

<i>Liquidations judiciaires

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- AVIXIA S.A., avec siège social à L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris, dénoncée en date du 23 octobre 2006,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur des sociétés susmentionnées, Maître Fatiha DAHOU, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
Maître Fatiha DAHOU
<i>Le liquidateur

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- COMPAGNIE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la

Gare, dénoncée en date du 20 septembre 2006,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur des sociétés susmentionnées, Maître Fatiha DAHOU, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
Maître Fatiha DAHOU
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047854/10101/37.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00683. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00686. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090049653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2009.

(090049652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2009.

42505

Kimbol Kompany Soparfi S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 68.174.

SEPRIM - Société d'Etude et de Promotion Immobilière S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 75.735.

<i>Liquidations judiciaires

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- KIMBOL KOMPANY SOPARFI S.A., avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, dénoncée en

date du 2 mai 2006,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur des sociétés susmentionnées, Maître Fatiha DAHOU, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
Maître Fatiha DAHOU
<i>Le liquidateur

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- SEPRIM - SOCIETE D'ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9,

rue Schiller, dénoncée en date du 6 décembre 2006,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur des sociétés susmentionnées, Maître Fatiha DAHOU, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
Maître Fatiha DAHOU
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047853/10101/38.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00679. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00681. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090049644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2009.
(090049645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2009.

Nord-Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 37.445.

Health Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 100.457.

PROJET DE FUSION

L'an deux mil neuf, le huit avril.
Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Madame Stéphanie SALIN, employée, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme NORD-FINANCE S.A., ayant son

siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 37.445, constituée suivant acte notarié reçu en date du 3 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 586 de 1992, page 28097 (ci-après, "NORD-FINANCE S.A."),

42506

en vertu d'une procuration elle conférée par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 19 mars 2009

dont une copie, après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera
annexée au présent acte aux fins de formalisation, et

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme HEALTH INVEST S.A., ayant son

siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 100.457, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch,
en date du 19 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 629 du 18 juin 2004 (ci-
après, "HEALTH INVEST S.A."),

en vertu d'une procuration elle conférée par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 19 mars 2009

dont une copie, après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera
annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle comparante, dans sa qualité décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui

suit:

<i>Projet de fusion

1) Lors de leurs réunions du 19 mars 2009, les conseils d'administration des sociétés prémentionnées ont pris la

décision de réaliser une fusion par absorption de HEALTH INVEST S.A par NORD-FINANCE S.A., ayant pour effet de
transférer l'ensemble des éléments d'actif et de passif de HEALTH INVEST S.A à NORD-FINANCE S.A., conformément
aux Articles 259 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

2) NORD-FINANCE S.A. a un capital social qui est fixé à 1.551.813,47 EUR (un million cinq cent cinquante et un mille

huit cent treize euros quarante-sept cents) représenté par 6.260 (six mille deux cent soixante) actions sans désignation
de valeur nominale, entièrement souscrites et libérés, et détient l'intégralité du capital social de HEALTH INVEST S.A et
s'élevant à cinquante-trois mille Euros (EUR 53.000,-) représenté par cinq cent trente (530) actions sans désignation de
valeur nominale.

3) NORD-FINANCE S.A. (la "Société Absorbante") entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278

et 279 de la Loi et les textes subséquents, avec HEALTH INVEST S.A (la "Société Absorbée" et, ensemble avec la Société
Absorbante, les "Sociétés Fusionnantes") par absorption de cette dernière.

4) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable

comme accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée au 31 mars 2009.

5) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a d'actionnaires titulaires de droits spéciaux ou détenteurs de titres autres que

les actions.

6) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des Sociétés Fusion-

nantes.

7) La fusion prendra effet entre parties et vis-à-vis des tiers au 31 mars 2009, après publication du présent projet de

fusion au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi.

8) L'actionnaire de la Société Absorbante a le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations du projet de fusion, de prendre connaissance au siège social, des documents indiqués
à l'article 267 (1) a) b) et c) de la Loi et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

9) L'actionnaire de la Société Absorbante, qui disposera de plus de 5% des actions du capital souscrit, a le droit de

requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de
la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

10) A défaut de réquisition d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive,

comme indiqué ci-avant au point 7) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi, à l'exception du
paragraphe (1) (b) de cet article.

11) La fusion s'effectuera sur base de la valeur comptable.
12) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société Absorbée prennent fin à la date de

la fusion et décharge pleine et entière est accordée aux organes de la Société Absorbée.

13) La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations de la Société Absorbée vers la Société Absorbante.

14) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société

Absorbante.

<i>Remises de titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de

tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres
de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les
valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments de
droit apportés.

42507

<i>Frais et droits

Les dépenses, frais, honoraires, rémunérations et charges de toutes espèces dus au titre de la fusion seront supportés

par la Société Absorbante et sont estimés à environ 1.000,- EUR.

La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, de l'existence et

de la légalité des actes et des formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes ainsi que du présent projet de fusion.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. SALIN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 avril 2009. Relation: LAC/2009/14492. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 20 avril 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009047831/206/90.
(090057229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

Platina G.T. Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 53.282.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de PLATINA G.T. HOLDING S.A., société anonyme avec siège social au 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg dénoncé en date du 21 novembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 53 282.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur, Maître Nicolas BO-

NORA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2009.

Maître Nicolas BONORA
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047858/10119/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02181. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

LGIG 2 Property C3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.323.

In the year two thousand and nine, on the seventh of April.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing

under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register und number B 122.032,
having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lu-

xembourg on 6 April 2009.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

42508

Such appearing party is the sole shareholder of "LGIG 2 Property C3 S.à r.l." (the "Acquiring Company"), a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.323, having a share capital of twenty-nine thousand
five hundred and fifty euros (EUR 29,550.-), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 31 July 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1986, page 95285 of 14 September 2007. The
articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 October 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2891, page 138733 on 3 December 2008. The
articles of incorporation have not been amended since then.

The appearing party, representing the entire share capital of the Acquiring Company and having waived any notification

requirements, requires the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder acknowledges having full knowledge of:
- the written report as prepared by the board of managers of the Acquiring Company on 15 December 2008, explaining

and legally and economically justifying the proposed cross-border merger between the Absorbing Company and GIG 2
Objekt MK 12 GmbH, a German limited liability company, registered with the Commercial Register at the Lower Court
of Munich under number HRB 165.183, having its place of management at Alter Hof 5, D-80331 Munich (the "Absorbed
Company"), being a wholly-owned direct subsidiary of the Sole Shareholder;

- the written report explaining and legally and economically justifying the proposed merger, as prepared by the managers

of the Absorbed Company on 17 December 2008;

- the joint cross-border merger project (the "Merger Project"), initially retained and approved by the board of managers

of the Acquiring Company on 12 December 2008, as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 3043 on 31 December 2008 and as notified by the managers of the Absorbed Company on 14 January 2009 to
the commercial register of the Lower Court of Munich, Germany;

- the resolutions of the Sole Shareholder of the Acquiring Company and the Absorbed Company renouncing the

preparation of the examination of the joint merger project and the preparation of the report of an independent expert
in this respect dated 29 January 2009;

- the interim balance sheet of the Absorbed Company as of 8 December 2008 (the "Closing Balance Sheet"), the annual

accounts and management reports of the Absorbed Company relating to the financial years ended 31 December 2007
and 31 December 2006, the interim balance sheet of the Acquiring Company as of 8 December 2008 and the annual
accounts and management reports of the Acquiring Company relating to the financial year ended on 31 December 2007.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Acquiring Company decides to approve the merger

between the Acquiring Company and the Absorbed Company in accordance with the provisions of the Merger Project
and the related documents as well as the valuation of the assets and liabilities transferred and the consideration.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder acknowledges and approves that, in exchange for the contribution of all the assets and liabilities

of the Absorbed Company, the Acquiring Company will issue new shares to the Sole Shareholder in accordance with the
exchange ratio as determined in the Merger Project.

Consequently, the Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Acquiring Company by an amount of

two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-), so as to raise it from it current amount of twenty-nine thousand five
hundred and fifty euros (EUR 29,550.-) up to thirty-two thousand and fifty euros (EUR 32,050.-) through the issue of one
hundred (100) new shares, having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each (the "New Shares").

All of the New Shares shall be allocated to the Sole Shareholder according to the provisions of the Merger Project.
Upon  the  above-mentioned  issue  of  the  New  Shares  to  the  Sole  Shareholder,  all  of  the  shares  of  the  Absorbed

Company are hereby cancelled.

From an accounting perspective, the operations of the Absorbed Company will be considered having been accom-

plished for the Acquiring Company as from 9th December 2008, 0.00 a.m.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above-mentioned capital increase, the Sole Shareholder decides to amend the first paragraph

of Article 5 of the articles of incorporation which shall now read as follows:

Art. 5. The subscribed capital of the Company is set at thirty-two thousand fifty euros (EUR 32,050.-) divided into

one thousand two hundred and eighty-two (1,282) shares, with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each."

42509

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder decides that, due to the fact of and as from (i) the allocation of the New Shares to the Sole

Shareholder, and (ii) the cancellation of the shares of the Absorbed Company, the Absorbed Company will be automa-
tically dissolved without liquidation.

Consequently, the Sole Shareholder acknowledges that no liquidation proceeding will be followed for the Absorbed

Company as the entirety of the assets and liabilities of the latter company are transferred to the Acquiring Company.

The Sole Shareholder further acknowledges that the merger shall in accordance with article 273bis (3) of the law on

commercial companies as of 10 August 1915, as amended (the "Company Law") become effective vis-à-vis third parties
upon publication of the present deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Acquiring Company and

charged to it by reason of the present deed are assessed to thousand euros.

The undersigned notary has verified and hereby confirms having received (i) a certificate issued by the commercial

register of the lower court of Munich dated 24 March 2009 and conclusively attesting to the proper completion of the
pre-merger conditions under the laws of Germany, and (ii) a copy of the minutes of the extraordinary general meeting
of the Absorbed Company approve the merger in accordance with the terms of the Merger Project.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Merger Project and of the compliance with

all formalities being incumbent upon the Acquiring Company under Luxembourg law.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the proxy holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le sept avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

"LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et existant

selon les lois de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 122.032, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Alexander Olliges, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé donnée à Luxembourg, le 6 avril 2009,

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de la "LGIG 2 Property C3 S.à r.l." (la "Société Absorbante"), une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.323, ayant un capital social de vingt-
neuf mille cinq cent cinquante euros (EUR 29.550,-), constituée selon acte reçu par le notaire soussigné le 31 juillet 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1986, page 95285 en date du 14 septembre 2007.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu selon acte reçu par le notaire soussigné le 28 octobre 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2891, page 138733 en date du 3 décembre 2008. Les statuts n'ont pas
été modifiés depuis lors.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société Absorbante et ayant renoncé à toute

notification, a requis le notaire instrumentant de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique reconnaît avoir entière connaissance:
- du rapport écrit préparé par le conseil de gérance de la Société Absorbante en date du 15 décembre 2008, expliquant

et justifiant du point de vue juridique et économique la fusion transfrontalière proposée entre la Société Absorbante et
GIG 2 Objekt MK 12 GmbH, une société à responsabilité limitée allemande, enregistrée auprès du Registre de Commerce
auprès du tribunal d'instance (Amtsgericht) de Munich sous le numéro HRB 165.183, ayant son lieu de direction au Alter
Hof 5, D-80331 Munich (la "Société Absorbée"), étant une filiale directe détenue entièrement par l'Associé Unique;

- du rapport écrit expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique la fusion proposée, tel que préparé

par les gérants de la Société Absorbée en date du 17 décembre 2008;

42510

- du projet de fusion transfrontalière joint (le "Projet de Fusion"), initialement retenu et approuvé par le conseil de

gérance de la Société Absorbante le 12 décembre 2008, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 3034 le 31 décembre 2008 et tel que notifié par les gérants de la Société Absorbée le 14 janvier 2009 au Registre
de Commerce auprès du tribunal d'instance (Amtsgericht) de Munich, Allemagne;

- des résolutions de l'Associé Unique de la Société Absorbante et de la Société Absorbée renonçant à la préparation

de l'examen du projet de fusion joint et à la préparation du rapport de l'expert indépendant à ce sujet en date du 29
janvier 2009;

- du bilan intermédiaire de la Société Absorbée en date du 8 décembre 2008 (le "Bilan de Clôture"), les comptes

annuels et rapports de gestion de la Société Absorbée relatifs aux années sociales terminées le 31 décembre 2007 et le
31 décembre 2006, le bilan intérimaire de la Société Absorbante en date du 8 décembre 2008 et les comptes annuels et
les rapports de gestion de la Société Absorbante relatifs à l'année sociale terminée le 31 décembre 2007.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique, dans sa qualité d'associé unique de la Société Absorbante, décide d'approuver la fusion entre la

Société Absorbante et la Société Absorbée conformément aux dispositions du Projet de Fusion et aux documents y
relatifs de même que l'évaluation de l'actif et du passif transférés et la rémunération.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique reconnaît et approuve que, en échange pour la contribution de tous les actifs et du passif de la Société

Absorbée,  la  Société  Absorbante  émettra  de  nouvelles  parts  sociales  à  l'Associé  Unique  conformément  au  rapport
d'échange tel que déterminé dans le Projet de Fusion.

Par conséquent, l'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société Absorbante d'un montant de deux

mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) afin de l'augmenter de son montant actuel de vingt-neuf mille cinq cent cinquante
euros (EUR 29.550,-) jusqu'à trente-deux mille cinquante euros (EUR 32.050,-) par l'émission de cent (100) nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (les "Nouvelles Parts").

Toutes les Nouvelles Parts sont attribuées à l'Associé Unique conformément aux stipulations du Projet de Fusion.
Suite à l'émission susmentionnée des Nouvelles Parts à l'Associé Unique, toutes les parts sociales de la Société Ab-

sorbée sont par la présente annulées.

D'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront considérées avoir été accomplies pour la

Société Absorbante à partir du 9 décembre 2008 à 0.00 heures a.m.

<i>Quatrième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'Associé Unique décide de modifier le premier alinéa de l'article

5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 5 . Le capital social de la Société est fixé à trente-deux mille cinquante euros (EUR 32.050,-) représenté par mille

deux cent quatre-vingt-deux (1.282) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. "

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide que, dû au fait que et suite à (i) l'attribution des Nouvelles Parts à l'Associé Unique, et (ii)

l'annulation des parts sociales de la Société Absorbée, la Société Absorbée sera automatiquement dissoute sans liquidation.

Par conséquent, l'Associé Unique reconnaît qu'aucune procédure de liquidation ne s'ensuivra pour la Société Absorbée

comme la totalité de l'actif et du passif de cette dernière est transférée à la Société Absorbante.

L'Associé Unique reconnaît que la fusion prendra effet à l'égard des tiers à partir de la date de la publication du présent

acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations conformément à l'article 273bis (3) de la loi sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi sur les Sociétés").

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont

mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à mille euros.

Le notaire soussigné a vérifié et confirme par la présente avoir reçu (i) un certificat émis par le registre de commerce

du tribunal d'instance (Amtsgericht) de Munich daté au 24 mars 2009 et attestant l'accomplissement de toutes les con-
ditions  préalables  à  la  fusion  selon  les  lois  de  l'Allemagne,  et  (ii)  une  copie  du  procès-verbal  de  l'assemblée  général
extraordinaire de la Société Absorbée approuvant la fusion conformément aux conditions du Projet de Fusion.

Le notaire soussigné certifie par la présente l'existence et la légalité du Projet de Fusion et le respect de toutes les

formalités qui incombent à la Société Absorbante en droit luxembourgeois.

Dont acte passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.

42511

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. OLLIGES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 avril 2009. Relation: EAC/2009/4243. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Belvaux, le 15 avril 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009047832/239/185.
(090056814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

LGIG 2 Property C3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.323.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 15 avril 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009047833/239/12.
(090056817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

Croswell Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 86.582.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de CROSWELL REAL ESTATE S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social au 7,
Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg dénoncé en date du 20 décembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 86582.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur, Maître Nicolas BO-

NORA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2009.

Maître Nicolas BONORA
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047859/10119/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02183. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

European Fashion Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 32.930.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement du 2 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a

prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:

- la société anonyme EUROPEAN FASHION GROUP S.A., dont le siège social établi à L-2086 Luxembourg, 23, avenue

Monterey, a été dénoncé en date du 5 octobre 2006, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 32930;

42512

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY et liquidateur Maître Asel COURMON-

TAGNE, avocat, demeurant 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2009.

Pour extrait conforme

e

 Asel Courmontagne

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047862/1035/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02057. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090053919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Ulixes S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 51.045.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement du 2 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a

prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:

- la société anonyme ULIXES S.A., dont le siège social établi à L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, a été dénoncé

en date du 23 octobre 2006, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 51045;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY et liquidateur Maître Asel COURMON-

TAGNE, avocat, demeurant 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2009.

Pour extrait conforme

e

 Asel Courmontagne

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047863/1035/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02061. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

2F Finance S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 85.545.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement du 2 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a

prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:

- la société anonyme 2F FINANCE S.A., dont le siège social établi à Luxembourg, 6-12, Place d'Armes, a été dénoncé

en date du 19 décembre 2006, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 84545;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY et liquidateur Maître Asel COURMON-

TAGNE, avocat, demeurant 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

42513

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2009.

Pour extrait conforme

e

 Asel Courmontagne

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047864/1035/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02055. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

Arlon Participations S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 94.712.

Europe Invest Corporation S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 51.125.

Midicon Holdings S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 86.777.

<i>Liquidations judiciaires

Par jugements rendus en date du 02 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation des sociétés suivantes:

- société anonyme ARLON PARTICIPATIONS S.A., dont le siège social à L-1628 Luxembourg, 1, Rue des Glacis, a

été dénoncé en date du 26 juillet 2006, (N 

o

 R.C.S.B 94 712)

- société anonyme EUROPE INVEST CORPORATION S.A., en abrégé EURINCO S.A., dont le siège social à L-2227

Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, a été dénoncé en date du 04 décembre 2006, (N 

o

 R.C.S. B 51 125)

- société anonyme MIDICON HOLDINGS S.A., dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal, a été

dénoncé en date du 08 décembre 2006, (No R.C.S.B 86 777)

Les mêmes jugements ont nommé Juge-Commissaire Monsieur Gilles MATHAY, Juge au Tribunal d'Arrondissement

de et à Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Emilie MELLINGER, avocat, demeurant à L-4170 Esch-sur-
Alzette, 24, Bd Kennedy.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe du Tribunal de

commerce.

Pour extrait conforme
Emilie MELLINGER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047866/4193/36.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02854. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02856. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02857. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
(090053103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
(090053104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.

Fedi Européenne d'Investissement Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 76.558.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugements rendus en date du 2 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- S.A. FEDI EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT HOLDING, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-

mont, dénoncé en date du 3 novembre 2006.

42514

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY et liquidateur Maître Emilie Macchi, avocat,

demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Luxembourg, le 2 avril 2009.

Pour extrait conforme
Maître Emilie Macchi
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047867/10112/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01568. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090051214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

British Marine Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 17.655.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.026.

In the year of two thousand and nine,
on the fifteenth day of the month of April.
Before us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

QBE Insurance (Europe) Limited, a company incorporated and existing under the UK Companies Acts and having its

registered office at Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3 BD, registered with the Companies House,
London under number 176561, (hereinafter referred to as the "Absorbing Company").

hereby represented by Maître Jean Hoss, avocat à la Cour, residing in Luxembourg by virtue of a proxy dated 13 

th

February 2009, such proxy being registered together with the present deed,

being the sole shareholder of
British Marine Luxembourg S.A., a société anonyme, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 71026, incorporated
as a société anonyme by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 27 

th

 July 1999, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 787 of 21 

st

 October 1999 (hereinafter referred to as the

"Company").

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of Maître Joseph Gloden, notary

residing in Grevenmacher on 6 

th

 October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 2244 of 30 

th

 November 2006.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
I. The sole shareholder represented as above mentioned holds all eight million eight hundred twenty-seven thousand

five hundred (8,827,500) shares of the Company representing the entire issued share capital of the Company, presently
set at seventeen million six hundred fifty-five thousand USD ($ 17,655,000,-), so that the sole shareholder can validly
decide on all the items of the agenda.

The Board of Directors of the Company has approved at its meeting of 30 

th

 September 2008 the draft terms of

Merger in order to merge the Company together with British Marine Holdings S.A., a société anonyme with registered
office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and entered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg
under number B 70495 and British Marine Holdings II S.A., a société anonyme with registered office at 3, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg and entered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 71234
into the Absorbing Company. The draft terms of Merger have been drawn up and signed by the Absorbed Companies
on 2 

nd

 September 2008 and by the Absorbing Company on 28 

th

 November 2008 and published on 22 

nd

 December

2008 and on 13 

th

 March 2009 (rectification) in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3002/2008,

page 144079, and number 548/2009, page 26274.

II. The agenda of the meeting is the following:
1) approval of the terms of Merger dated 2 

nd

 September 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number 3002 on 22 

nd

 December 2008, page 144079 and number 548, on 13 

th

 March 2009, page 26274

(rectification);

42515

2) approval of the Merger between the Company and the sole shareholder by way of a cross border Merger and

absorption without liquidation of the Company by the sole shareholder;

3) approval and confirmation of a certificate issued by the Company on 29 

th

 November 2008 according that the

following documents have been put on display for inspection by the sole shareholder:

i) Terms of Merger
ii) Interim accounts per 30 

th

 June 2008

iii) Annual accounts for the last three years
iv) The articles of association of the Absorbing Company
v) Certificate of incorporation of the Absorbing Company
vi) Certificate confirming the change of name
The provisions regarding Mergers of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915

Law") have been fulfilled:

a) Publications on 22 

nd

 December 2008 and 13 

th

 March 2009 (rectification) of the following documents: draft terms

of Merger dated 2 

nd

 September 2008 and 28 

th

 November 2008 respectively together with the articles of association of

the Absorbing Company, a certificate of incorporation and the certificate confirming the change of name as appendices
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3002/2008, page 144079, and number 548/2009, page
26274, at least one month before the date of the general meeting of shareholders of the Company convened to decide
on the Merger.

b) Pursuant to Art. 278 of the 1915 Law no written report by the board of directors of each of the merging companies

explaining the draft terms of Merger and in particular the share exchange ratio is required.

c) Pursuant to Art. 266,1 and Art. 278 of the 1915 Law, no independent expert report is required in connection with

the Merger and no such report has been prepared.

d) The draft terms of Merger specify all the information required by Art. 261 of the 1915 Law.
e) Deposit of the following documents: draft terms of Merger, interim accounts per 30 

th

 June 2008, annual accounts

for the last three years, the articles of association of the Absorbing Company, certificate of incorporation of the Absorbing
Company, certificate confirming the change of name, required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of
the Company at least one month before the date of the general meetings of the merging companies.

After the sole shareholder approved the foregoing, the sole shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder declared that it had knowledge of the draft terms of Merger as published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number 3002, page 144079 of 22 December 2008 and number 548, page 26274 of
13 

th

 March 2009 (rectification), pursuant to which the Company and the Absorbing Company will merge.

The Merger between the Company and the Absorbing Company shall be implemented through the absorption of the

Company and the taking over of all its assets and liabilities, rights and obligations, without exception or reserves.

To the extent that the Absorbing Company holds 100 % of the issued share capital of the Company, the Merger will

be implemented pursuant to the provisions of articles 278 to 280 of the 1915 Law.

The sole shareholder noted and acknowledged that the draft terms of Merger have been duly approved and executed

by the board of directors of the Company on 2 

nd

 September 2008 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, number 3002, page 144079 of 22 December 2008 and number 548, page 26274 of 13 

th

 March 2009

(rectification), in accordance with the provisions of article 262 of the 1915 Law.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to approve the Merger pursuant to the draft terms of Merger as published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3002, page 144079, of 22 December 2008, and number 548,
page 26274, of 13 

th

 March 2009, (rectification), without exception but with the following reservation:

The approval of the Merger is final and irrevocable only if:
i) the consent by the Luxembourg Minister of Finance authorising the transfer of the insurance portfolio of the Company

to the Absorbing Company has been granted; and

ii) the Merger becomes valid and effective under the laws of England and Wales for the Absorbing Company and all

consents of the judiciary or otherwise required for the transborder Merger into the undersigned have been obtained.

The sole shareholder resolved to merge the Company into the Absorbing Company in accordance with the provisions

of articles 278 to 280 of the 1915 Law.

The sole shareholder resolved to approve the Merger between the Company and the Absorbing Company by way of

a cross border Merger and absorption without liquidation of the Company by the sole shareholder.

42516

All assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company will, without exception, be transferred to the

Absorbing Company by virtue of law without regard as to the period at which they were acquired or assumed.

The date as of which the Merger shall become effective for accounting purposes is fixed at the 1 

st

 January 2009.

<i>Third resolution

The sole shareholder confirmed and resolved to approve the certificate issued by the Company on 29 

th

 November

2008 according that the following documents have been put on display for inspection by the sole shareholder:

i) Terms of Merger
ii) Interim accounts per 30 

th

 June 2008

iii) Annual accounts for the last three years
iv) The articles of association of the Absorbing Company
v) Certificate of incorporation of the Absorbing Company
vi) Certificate confirming the change of name

<i>Statements

The undersigned notary notes and confirms the existence and the legality of the deeds and formalities of the Merger

executed by the Absorbing Company and the Company, and the draft terms of Merger.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Absorbing Company

as a result of this Merger are estimated at approximately forty thousand Euro (€ 40,000).

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
party in case of discrepancies between the English and French text, the English version will prevail.

Done in Luxembourg-City on the day mentioned at the beginning of these minutes.
After reading these minutes to the appearing party such appearing party signed together with the notary the present

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quinzième jour du mois d'avril.
Par devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

QBE INSURANCE (Europe) Limited, une société immatriculée en Grande-Bretagne et régie par la loi anglaise ("UK

Companies Acts") et ayant son siège social à Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3 BD, immatriculée
au "Companies House", Londres, sous le numéro 176561 (ci-après la "Société Absorbante".

Ici représentée par Maître Jean Hoss, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du

13 février 2009, cette procuration étant enregistrée ensemble avec le présent acte, étant l'actionnaire unique de British
Marine Luxembourg S.A., une société anonyme avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 71026, constituée en tant que société anonyme
en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 juillet 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 787 du 21 octobre 1999 (ci-après la "Société").

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de

résidence à Grevenmacher le 6 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2244
du 30 novembre 2006.

Le comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant de noter que:
I. L'actionnaire unique représenté comme mentionné ci-avant détient la totalité des huit millions huit cents vingt-sept

mille cinq cents (8.827.500) actions émises de la Société représentant la totalité du capital social émis de la Société, fixé
à présent à dix sept millions six cents cinquante-cinq mille USD (17.655.000 USD) de sorte que l'actionnaire unique peut
valablement prendre des décisions sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration de la Société a approuvé, lors de sa réunion du 30 septembre 2008, le projet de fusion afin

de fusionner la Société ensemble avec British Marine Holdings S.A., une société anonyme avec siège social au 3, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 70495
et British Marine Holdings II S.A., une société anonyme avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 71234 dans la Société Absorbante.
Le projet de fusion a été établi et signé par les sociétés absorbées le 2 septembre 2008 et par la Société Absorbante le
28 novembre 2008 et publié le 22 décembre 2008 et le 13 mars 2009 (rectification) au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 3002/2008, page 144079 et numéro 548/2009, page 26274.

42517

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) approbation du projet de fusion du 2 septembre 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 3002 du 22 décembre 2008, page 144079 et numéro 548 du 13 mars 2009, page 26274;

2) Approbation de la fusion entre la Société et l'actionnaire unique en passant par une fusion transfrontalière par

absorption sans liquidation de la Société par l'actionnaire unique;

3) Approbation et confirmation d'un certificat émis par la Société le 29 novembre 2008 selon lequel les documents

suivants ont été mis à disposition pour inspection par l'actionnaire unique:

i) Projet de fusion
ii) Etat comptable arrêté au 30 juin 2008
iii) Comptes annuels des trois dernières années
iv) Les statuts de la Société Absorbante
v) Certificat d'immatriculation de la Société Absorbante
vi) Certificat confirmant le changement de dénomination sociale
Les dispositions relatives aux fusions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-

après la "Loi de 1915") ont été accomplies:

a) Publication le 22 décembre 2008 et le 13 mars 2009 (rectification) des documents suivants: projet de fusion en date

du 2 septembre 2008 respectivement du 28 novembre 2008 ensemble avec les statuts de la Société Absorbante, un
certificat d'immatriculation et un certificat confirmant le changement de dénomination sociale en tant qu'annexes, au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3002/2008, page 144079, et numéro 548/2009, page 26274,
au moins un mois avant la date de réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion.

b) Conformément à l'article 278 de la Loi de 1915, aucun rapport écrit par le conseil d'administration de chacune des

sociétés participant à la fusion, expliquant le projet de fusion et en particulier le ratio d'échange des actions, n'est exigé.

c) Conformément à l'article 266,1 et l'article 278 de la Loi de 1915, aucun rapport d'un expert indépendant en relation

avec la fusion n'est exigé et un tel rapport n'a pas été préparé.

d) Le projet de fusion contient toutes les informations requises par l'article 261 de la Loi de 1915.
e) Dépôt des documents suivants: projet de fusion, état comptable arrêté au 30 juin 2008, comptes annuels des trois

dernières années, les statuts de la Société Absorbante, certificat d'immatriculation de la Société Absorbante, un certificat
confirmant le changement de la dénomination sociale de la Société Absorbante, documents requis par l'article 267 de la
Loi de 1915 et déposés au siège social de la Société au moins un mois avant la date de réunion des assemblées générales
des sociétés fusionnantes.

Après l'acceptation par l'actionnaire unique de ce qui précède, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique a déclaré qu'il avait connaissance du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 3002, page 144079, le 22 décembre 2008 et numéro 548, page 26274, le 13 mars 2009
(rectification), par lequel la Société et la Société Absorbante vont fusionner.

La fusion entre la Société et la Société Absorbante devrait être réalisée par l'absorption de la Société et la reprise de

tous ses avoirs, passifs, droits et obligations sans exceptions ni réserves.

Dans la mesure où la Société Absorbante détient 100% du capital social émis par la Société la fusion sera réalisée

conformément aux dispositions des articles 278 à 280 de la Loi de 1915.

L'actionnaire unique a constaté et reconnu que le projet de fusion a été dûment approuvé et exécuté par le conseil

d'administration de la Société le 2 septembre 2008 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
3002, page 144079, le 22 décembre 2008 et numéro 548, page 26274, le 13 mars 2009 (rectification), conformément aux
dispositions de l'article 262 de la Loi de 1915.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique a décidé d'approuver la fusion conformément au projet de fusion de la Société, tel que publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3002, page 144079 le 22 décembre 2008 et numéro 548, page
26274 le 13 mars 2009 (rectification), sans exceptions mais avec la réserve suivante:

L'approbation de la fusion est définitive et irrévocable seulement si:
i) l'accord du Ministre des Finances autorisant le transfert du portefeuille des assurances de la Société à la Société

Absorbante a été obtenu, et

ii) la fusion devient valable et effective sous les lois d'Angleterre et du Pays de Galles pour la Société Absorbante et

que tous les accords de l'autorité judiciaire ou autres requis pour la fusion transfrontalière dans la Société Absorbante
ont été obtenus.

L'actionnaire unique a décidé de fusionner la Société dans la Société Absorbante conformément aux dispositions des

articles 278 à 280 de la Loi de 1915.

42518

L'actionnaire unique a décidé d'approuver la fusion entre la Société et la Société Absorbante en passant par une fusion

transfrontalière par absorption sans liquidation de la Société par l'actionnaire unique.

Tous les avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société vont, sans exception, être transférés à la Société

Absorbante de plein droit sans égard à la période à laquelle ils ont été acquis ou assumés.

La date à partir de laquelle la fusion devrait être effective pour les besoins comptables est fixée au 1 

er

 janvier 2009.

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique a confirmé et décidé d'approuver le certificat émis par la Société le 29 novembre 2008 selon

lequel les documents suivants ont été mis à disposition pour inspection par l'actionnaire unique:

i) Projet de fusion
ii) Etat comptable arrêté au 30 juin 2008
iii) Comptes annuels des trois dernières années
iv) Les statuts de la Société Absorbante
v) Certificat d'immatriculation de la Société Absorbante
vi) Certificat confirmant le changement de dénomination sociale

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate et confirme, l'existence et la légalité des actes et des formalités de la fusion exécutés

par la Société Absorbante et la Société, et le projet de fusion.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelques formes que ce soit, incombant à la Société Absorbante

en raison de cette fusion sont évalués

à approximativement à quarante mille euros (€ 40.000.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît et parle l'anglais constate qu'à la requête du comparant ci-avant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'à la requête du même comparant, en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite des présentes, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. HOSS, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2009. Relation: GRE/2009/1518. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Grevenmacher, le 21 avril 2009.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2009048685/213/239.
(090057759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2009.

Samafil Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 43.480.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugements rendus en date du 2 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- S.A. SAMAFIL HOLDING, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, dénoncé en date du 3 novembre

2006.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY juge et liquidateur Maître Emilie Macchi,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

42519

Luxembourg, le 2 avril 2009.

Pour extrait conforme
Maître Emilie Macchi
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047869/10112/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01566. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

Violin Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 76.610.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugements rendus en date du 2 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- S.A. VIOLIN INVESTMENTS, avec siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'eau, dénoncé en date du 17 octobre

2006.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY juge, et liquidateur Maître Emilie Macchi,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Luxembourg, le 2 avril 2009.

Pour extrait conforme
Maître Emilie Macchi
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047870/10112/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01564. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

Post Office Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 68.621.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugements rendus en date du 2 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- S.A. POST OFFICE HOLDING, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, dénoncé en date du 6

novembre 2006.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY juge, et liquidateur Maître Emilie Macchi,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Luxembourg, le 2 avril 2009.

Pour extrait conforme
Maître Emilie Macchi
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047872/10112/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01563. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

42520

Dawning International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 58.889.

<i>Liquidation judiciaire

Par jugements rendus en date du 2 avril 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- S.A. DAWNING INTERNATIONAL, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, dénoncé en date

du 3 janvier 2007.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY juge, et liquidateur Maître Emilie Macchi,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal.

Luxembourg, le 2 avril 2009.

Pour extrait conforme
Maître Emilie Macchi
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047874/10112/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01569. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

Veracruz Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 90.371.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 26 mars 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- VERACRUZ HOLDING S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare, dénoncée en date du

12 décembre 2006,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur des sociétés susmentionnées, Maître Fatiha DAHOU, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2009 au greffe de la sixième chambre

de ce Tribunal,

Pour extrait conforme
Maître Fatiha DAHOU
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009047877/10101/21.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00678. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090049642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2009.

Swiss Life Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 141.910.

In the year two thousand nine, on the second day of April.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company "Swiss Life

Solutions S.A." a société anonyme incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-8009 Strassen,
25, route d'Arlon

incorporated by a deed of the undersigned notary, on September 17 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, Number 2495 of October 11 

th

 , 2008

42521

registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B 141.910
The meeting was opened at 3.00 p.m. and was presided by Mrs Diana HOFFMANN, employee, residing professionally

in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Hans Herbert MÜLLER, director of companies, residing at L-1260 Luxembourg,

87, rue de Bonnevoie.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting is the following:
1.- To transfer the registered office to L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg and subsequent to amend the first

paragraph of article 2 of the articles of incorporation.

2.- To amend the corporate object of the company and in consequence to amend article 3 of the articles of incorpo-

ration.

3.- Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraor-

dinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted

by unanimous vote.

<i>First resolution

The general meeting decides to transfer the registered office to L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg and subse-

quent to amend the first paragraph of article 2 of the articles of incorporation which shall have the following wording:

"   Art. 2. Registered Office. (1 

st

 paragraph).   The  Company  will  have  its  registered  office  in  the  municipality  of

Luxembourg-City."

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the corporate object of the Company and to amend in consequence article 3

of the articles of incorporation, which shall have the following wording:

Art. 3. Corporate Object. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or

indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the
management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company will be able to have activities of insurance agency through individuals duly authorized as insurance agent.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension."

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 3.20 p.m.

<i>Valuation

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at EUR 1,000.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

42522

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille neuf, le deux avril.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Swiss Life Solutions S.A." une

société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 17 septembre 2008, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 2495 du 11 octobre 2008

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B 141.910
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Melle Diana HOFFMANN,

employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente nomme comme secrétaire M. Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur M. Hans Herbert MÜLLER, directeur de sociétés, demeurant à L-1260 Luxem-

bourg, 87, rue de Bonnevoie.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social vers L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et subséquent modification du premier

paragraphe de l'article 2 des statuts.

2.- Changement de l'objet social de la société et en conséquence modification de l'article 3 des statuts.
3.- Divers.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l'unanimité des voix.

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social vers L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et subséquent

de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 2. Siège social. (1 

er

 paragraphe).  Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société et en conséquence de modifier l'article 3 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

La société pourra avoir des activités d'agence d'assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 15.20 heures.

42523

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte sont évalués à environ 1.000,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. HOFFMANN, M. MAYER, H. H. MÜLLER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 avril 2009. Relation: LAC/2009/13170. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 10 avril 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009047274/206/133.
(090054602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Serbeloni n°1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 114.342.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the thirty-first day of March.
Before the undersigned, Maître Marc Lecuit, residing in Mersch.

THERE APPEARED:

"Benvolio Investments S.A.", a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with re-

gistered office at L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes,

represented by Mrs. Valérie Turri, employee, professionally residing in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,
by virtue of a proxy given on March 30 

th

 , 2009.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
that the company "Serbeloni n°1, S.à r.l" (hereafter the Company), having its principal office in L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes, has been incorporated pursuant to a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, on December 16 

th

 ,

2005, published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 934 of May 12th, 2006,

that  the  capital  of  the  Company  is  fixed  at  TWELVE  THOUSAND  AND  FIVE  HUNDRED  EURO  (12.500.-EUR)

represented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25, EUR) each, fully paid,

that the appearing party, "Benvolio Investments S.A.", has become the sole owner of the shares and has decided to

dissolve the company "Serbeloni n°1, S.à r.l." with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

that "Benvolio Investments S.A." being the sole owner of the shares and liquidator of "Serbeloni n°1, S.à r.l.", declares:
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of " Serbeloni n°1, S.à r.l.", is to be considered closed;
that full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandates;
that the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

42524

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le trente et un mars.
Pardevant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU:

"Benvolio Investments S.A.", une société constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg dont le siège est

établi à L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes,

ici représentée par Madame Valérie Turri, employée, demeurant professionnellement à L-2636 Luxembourg, 12, rue

Léon Thyes,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 mars 2009.
Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter:
que la société "Serbeloni n°1, S.à r.l.", (ci-après "la Société") ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon

Thyes, a été constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner en date du 16 décembre 2005, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations numéro 934 du 12 mai 2006;

que le capital social de la Société s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) repré-

senté  par  CINQ  CENTS  (500)  parts  sociales  d'une  valeur  nominale  de  VINGT  CINQ  EURO  (25.-EUR)  chacune,
entièrement libérées;

que "Benvolio Investments S.A." étant devenue seule propriétaire des parts sociales de la société "Serbeloni n°1, S.à

r.l." dont il s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la Société, celle-ci ayant cessé toute activité;

que "Benvolio Investments S.A." agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu'en tant qu'associée unique,

déclare:

- que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associée unique,
de sorte que la liquidation de la société "Serbeloni n°1, S.à r.l." est à considérer comme clôturée;
que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société, pour l'exercice de leurs mandats;
que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: V. TURRI, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 1 

er

 avril 2009. Relation: MER/2009/599. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 avril 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009047521/243/81.
(090054608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Tuyauterie Développement Exploitation S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 73, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 145.653.

STATUTS

L'an deux mille neuf.
Le vingt-six mars.
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU

42525

Madame Virginie REICHERT, gérante de sociétés, née à Algrange (France), le 24 juin 1973, demeurant à L-4391 Pont-

pierre, 73, rue de Luxembourg.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

TUYAUTERIE DEVELOPPEMENT EXPLOITATION S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet la chaudronnerie ainsi que la mécanique générale et toutes activités commerciales s'y

rattachant.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rat-

tachant directement ou indirectement en tout ou partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le
développement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Pontpierre.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-), représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Madame Virginie REICHERT, prénommée, CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de DOUZE MILLE QUATRE

CENTS EUROS (€ 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE EUROS (€ 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, la comparante, unique associée de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommée gérant de la société: Madame Virginie REICHERT, prénommée.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

42526

III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4391 Pontpierre, 73, rue de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Reichert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 mars 2009. Relation: EAC/2009/3636. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur ff. (signé): N. Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 31 mars 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009047576/219/72.
(090054698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Socimmo Construction et Cie S.e.c.s, Société en Commandite simple,

(anc. Socimmo S.A. et Cie Lorentzweiler).

Siège social: L-8069 Strassen, 32, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 61.828.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2009

Ont comparu:

1.- l'associée commanditée la société anonyme SOCIMMO CONSTRUCTION (anciennement SOCIMMO S.A.) ayant

son siège social à L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon (RCS Luxembourg N° B 42.031), ici valablement
représentée par deux de ses administrateurs savoir Monsieur Angelo CRAPANZANO et Monsieur Constant LESS

2.1.- l'associé commanditaire Monsieur Constant Less, technicien diplômé, demeurant à L-7381 Bofferdange, 211, Cité

Roger Schmitz, et

2.2.- l'associé commanditaire Monsieur Angelo Crapanzano, entrepreneur, demeurant à L-7362 Bofferdange, 32, an

de Strachen.

Lesquels sont les seuls associés, représentant l'intégralité du capital social de la société en commandite simple "SO-

CIMMO S.A. et Cie Lorentzweiler ", établie et ayant son siège social à L-8069 Strassen, 32, rue de l'Industrie

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B sous le numéro 61.828
Lesquels déclarent que la société ne possède pas d'immeuble.
Que suite a deux cessions de parts sous seing privé du 17 février 2009, Monsieur Constant LESS a acquis 2 parts ayant

appartenues à feu Monsieur Jean NICOLAS et Monsieur Angelo CRAPANZANO a également 1 part ayant appartenue
à feu Monsieur Jean NICOLAS, et la société Socimmo Construction a également 1 part ayant appartenue à feu Monsieur
Jean NICOLAS.

Ensuite les associés, présents, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, pour laquelle ils se reconnaissent

valablement convoqués, et ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes prises à l'unanimité des
voix comme suit:

<i>Première résolution

Les associés constatent que le nom de l'associée commandité/gérant a changé de SOCIMMO S.A. en SOCIMMO

CONSTRUCTION et décident en conséquence de modifier le nom de la société et l'article 3 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

Art. 3. Raison sociale. La société en commandite simple existe sous la raison sociale SOCIMMO CONSTRUCTION

et Cie S.E.C.S.

Elle agira sous le nom commercial SOCIMMO C CONSTRUCTION.

<i>Deuxième résolution

Les associés convertissent le capital social de deux cent mille anciens francs luxembourgeois (200.000,- LUF) en quatre

mille neuf cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-sept cents (4.957,87 EUR) et augmentent le capital de quarante-deux
euros et treize cents (42,13 EUR) pour le porter à un montant de cinq mille euros (5.000,- EUR) sans émission ni création
de nouvelles parts et en fixant la valeur nominale des parts à un montant de deux cent cinquante euros (250,- EUR)
chacune.

En conséquence de ce qui précède, l'article 6 des statuts est modifié comme suit:

42527

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé cinq mille euros (5.000,- EUR) représentée par vingt (20) parts d'une

valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune répartis comme suit:

1.- l'associée commanditée SOCIMMO CONSTRUCTION, deux parts commanditées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2.- l'associé commanditaire Monsieur Angelo CRAPANZANO, neuf parts commanditaires . . . . . . . . . . . . . . . .

9

3.- l'associé commanditaire Monsieur Constant LESS, neuf parts commanditaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Total: vingt parts dont une part commanditée et dix-neuf parts commanditaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Signé: A. CRAPANZANO. C. LESS, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mars 2009. Relation: LAC/2009/8244. Reçu € 75,- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009047781/206/53.
(090055097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

Klammer Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.319.

<i>Extrait des résolutions prises

<i>lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 avril 2009

- Conformément à la Loi du 25 août 2006 - «Art. 51 &amp; 51bis», publié au MEMORIAL, Journal Officiel du Grand-Duché

de Luxembourg (Recueil de Législation) sous le n° A-N° 152 du 31 août 2006, l'assemblée générale accepte de désigner
comme représentant permanent pour une durée indéterminée en remplacement de Mme Sandrine ANTONELLI, avec
prise d'effet au 16 avril 2008:

Mlle Claire SABBATUCCI, employée privée, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), demeurant professionnellement

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Mademoiselle Claire SABBATUCCI exécutera sa mission de représentant permanent au nom et pour le compte de la

société ADVISA S.A.

- L'Assemblée Générale accepte et approuve à compter de ce jour à la démission de:
Claudine BOULAIN, chef comptable, née le 2 janvier 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnelle-

ment 207, route d'Arlon, à L-1150 Luxembourg.

- L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, en remplacement de Mme Claudine BOULAIN:
M. Michael ZERBIB, directeur de sociétés, né le 6 juin 1971 à Pantin (France), demeurant professionnellement 207,

route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

Extrait sincère et conforme
KLAMMER INVESTMENTS S.A.
<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009047394/1022/30.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03529. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090054611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Mobad S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4032 Esch-sur-Alzette, 9, rue Bessemer.

R.C.S. Luxembourg B 121.285.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Robert SCHUMAN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009047683/237/11.
(090054797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

42528


Document Outline

2F Finance S.A.

4I Invest Ltd

AIG Multilabel Sicav

AIG Sicav

Arlon Participations S.A.

Avixia S.A.

Blue Bell S.A.

Blue Sage S.A.

British Marine Luxembourg S.A.

Bull Fund

Compagnie de Conseil et d'Investissement S.A.

Convest21 Umbrella

Corporate II

Corporate III

Corporate IV

Corporate Special

Croswell Real Estate S.à r.l.

Dawning International S.A.

DWS Garant

E2P S.A.

EasyETF

Eurolux Real Estate S.A.

European Fashion Group S.A.

Europe Invest Corporation S.A.

Fedi Européenne d'Investissement Holding S.A.

Financière de Magonette S.A.

Gefip Euroland

Gest Lease &amp; Trust S.A.

Global Brands S.A.

HAIG Asahi-Investmentfund

Health Invest S.A.

Helios Solar SA

Insinger de Beaufort Holdings

Intesa Euroglobal

Kimbol Kompany Soparfi S.A.

Klammer Investments S.A.

Kronos Fund

Les Etangs de l'Abbaye

LGIG 2 Property C3 S.à r.l.

LGIG 2 Property C3 S.à r.l.

Marguerite S.A.

Midicon Holdings S.A.

Mobad S.àr.l.

Nextra International Sicav

Nord-Finance

Oriflame Cosmetics S.A.

PEH Sicav

Piguet Strategies

Platina G.T. Holding S.A.

Poolfin Inc.

Post Office Holding S.A.

Rhodes Enterprise

RREEF

SAF-Holland S.A.

Samafil Holding S.A.

Selectra Investments Sicav

SEPRIM - Société d'Etude et de Promotion Immobilière S.A.

Serbeloni n°1 S.à r.l.

Socimmo Construction et Cie S.e.c.s

Socimmo S.A. et Cie Lorentzweiler

Stirovest Management Holdings S.A.

Swiss Life Solutions S.A.

Triglia S.A.

Tuyauterie Développement Exploitation S.àr.l.

UBS Luxembourg Sicav

Ulixes S.A.

Utopia S.A.

Valueinvest Lux

Veracruz Holding S.A.

Violin Investments S.A.