logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 874

24 avril 2009

SOMMAIRE

AI Silver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41945

AI Silver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41952

Allianz Global Strategy Defensive  . . . . . . .

41940

Allianz Global Strategy Dynamic  . . . . . . . .

41934

Amhurst Corporation  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41912

Bayside International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

41908

Berenberg Fund-of-Funds  . . . . . . . . . . . . . . .

41950

Bluestar International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

41914

Calypso Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41911

Capstar Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41914

CEGEDEL société anonyme (Compagnie

Grand-Ducale d'Electricité du Luxem-
bourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41915

Celfloor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41913

Compagnie Maritime Luxembourgeoise

S.A., en abrégé C.M.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41906

Destiny Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41909

Eowyn S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41912

European Investments Associates (E.I.A.)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41952

Firad S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41906

Galux S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41911

Generali Hedge Funds Sicav . . . . . . . . . . . . .

41919

Global Funds Management S.A.  . . . . . . . . .

41951

Immo Inter Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

41907

ISS Facility Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41951

JamaicaLux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41910

Karlix S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41912

Legg Mason Managed Solutions SICAV  . .

41910

Lhjrwing Dench S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . .

41911

Nextam Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41915

Nordea 1 SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41951

Nucifera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41909

Old Town  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41916

Parts Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41906

PEH Quintessenz Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41914

PEH Trust Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41918

PG Silver A S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41923

PG Silver A S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41952

PG Silver B S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41934

Polifontaine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41907

Sabarel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41907

Shivling Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41913

Silcart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41940

Silcart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41951

Siltarc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41919

Spoleto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41916

Sterling Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41929

Sterling Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41952

SWIP Holdings (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

41923

SWIP (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

41929

Tenaris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41917

Transfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41913

Velafi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41908

Winning Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41908

WM Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41945

Woodlander Project S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

41909

41905

Firad S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 28.212.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>15 mai 2009 2008 à 11.00 heures, pour

délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009036954/657/17.

Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L., Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 25.179.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 mai 2009 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048615/1023/18.

Parts Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 99.238.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 mai 2009 à 18.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Nominations statutaires.
5. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048620/1023/18.

41906

Sabarel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 78.408.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>May 12, 200 <i>9 at 15.00 p.m.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2008 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending December 31, 2008.

4. Continuation of the activity of the Company despite a loss of more than the third quarters of the capital of the

Company.

5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009048622/1023/18.

Immo Inter Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 31.321.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 mai 2009 à 11h au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur;
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
3. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31/12/2008;
4. Affectation du résultat;
5. Délibération conformément à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
6. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009047840/322/18.

Polifontaine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 16.974.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 mai 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048621/1023/17.

41907

Bayside International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.780.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>May 12, 200 <i>9 at 15.30 p.m.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2008 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending December 31, 2008.

4. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009048611/1023/16.

Velafi Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 62.341.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>13 mai 2009 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation  des  comptes  annuels  au  31  décembre  2006  et  au  31  décembre  2007  et  des  rapports  du  conseil

d'administration et du commissaire aux comptes y relatifs.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048610/534/16.

Winning Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 78.249.

Les actionnaires sont invités à assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING Luxembourg au 46-48, route d'Esch à L-2965 Luxembourg, le jeudi <i>14 mai

<i>2009 à 10.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux siège et

agences de ING Luxembourg et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant
l'Assemblée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048604/584/21.

41908

Nucifera, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 83.970.

Les actionnaires sont priés d'assister à :

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur le <i>11 mai 2009 à 20 heures, pour

délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit :

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commis-

saire.

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2008
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009029721/9378/20.

Woodlander Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 62.226.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 mai 2009 à 15:30 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009046439/696/17.

Destiny Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 77.236.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 mai 2009 à 14:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009046440/696/16.

41909

JamaicaLux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 128.026.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

de la Société JamaicaLux SA qui se tiendra le <i>13 mai 2009 à 16.00 heures à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston

Diderich pour délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel établi par le conseil d'administration concernant les comptes annuels du 31 dé-

cembre 2007 et 31 décembre 2008;

2. Approbation du rapport annuel établi par le contrôle légal des comptes concernant les mêmes exercices;
3. Approbation du bilan, les comptes de pertes et profits et les notes afférentes aux états financiers des 31 décembre

2007 et 31 décembre 2008;

4. Communiqué de toute responsabilité de l'administration ainsi que du contrôle légal des comptes de l'exercice clos

les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008;

5. Approbation des résultats de fin d'année;
6. Décision à prendre selon l'article 100 de la Loi 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée
7. Divers.

Luxembourg, le 22 avril 2009.

<i>Le conseil d'administration
Marco Sterzi

Référence de publication: 2009047943/9125/24.

Legg Mason Managed Solutions SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 60.118.

We are pleased to invite the Shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of Legg Mason Managed Solutions SICAV (The "Company") which will be held at the registered office

of the Company, 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, on <i>19th May 2009 at 11.00 a.m.

<i>Agenda:

1. Review and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2008;
2. Review and approval of the report of the Auditors for the fiscal year ended 31st December 2008;
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at 31st December 2008;
4. Allocation of net results;
5. Discharge of liabilities to the Directors and to the Auditors for the exercise of their mandate;
6. Statutory appointments;
7. Remuneration of the Directors;
8. Miscellaneous.

No quorum is required and decisions will be taken by the majority votes of the Shareholders present or represented.
Shareholders wishing to participate at the Meeting must confirm their attendance by registered mail to the Company

at the above address to arrive no later than 18th May 2009.

In order to attend and vote at the Meeting, the holders of bearer Shares are requested to deposit their Shares at the

registered office of the Company, or at Citibank Belgium S.A. - 263g, boulevard Général Jacques at 1050 Bruxelles - and
at all Citibank offices in Belgium, Citibank Belgium S.A. performing financial services for the Sicav in Belgium, by 11th May
2009 at the latest

The annual report can be obtained on request at the registered office of the Company or at Citibank Belgium S.A.
The present convening notice is also sent by mail to all nominative shareholders.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2009048631/755/29.

41910

Galux S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 17.771.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2009 à 15.00 heures en l'Etude de Maître Baden à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la Société,
2. Nomination du Liquidateur, Monsieur Pierre SCHILL.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048628/755/15.

Calypso Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 93.712.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>26 mai 2009 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2008 et de l'affectation des résultats
3. Dividendes
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Décharge à donner aux Dirigeants
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles

au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur au plus tard un jour

ouvrable avant l'assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048627/755/22.

Lhjrwing Dench S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 65.124.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2009 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048619/1023/16.

41911

Amhurst Corporation, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 18.301.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>14 mai 2009 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la Société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048625/29/18.

Eowyn S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 109.287.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 mai 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048617/1023/16.

Karlix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 32.887.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>18 mai 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048630/755/19.

41912

Shivling Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 31.938.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>11 mai 2009 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048623/1023/17.

Transfin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 21.182.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the head office, on <i>May 11, 2009 at 10.00 a.m.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2008 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending December 31, 2008.

4. Ratification of the co-optation of a new Director.
5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009048624/1023/17.

Celfloor, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 4.544.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>12 mai 2009 à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire de surveillance concernant l'exercice social

arrêté le 31 décembre 2008.

2. Approbation du bilan et du compte des pertes et profits arrêtés le 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes concernant l'exécution de leur mandat pendant

l'exercice social arrêté au 31 décembre 2008.

5. Remplacement du commissaire aux comptes.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009047589/19.

41913

Bluestar International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 103.013.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2009 à 16:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009046438/696/17.

Capstar Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.102.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 mai 2009 à 09.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2008.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048613/1023/16.

PEH Quintessenz Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 38.269.

Die Aktionäre der PEH QUINTESSENZ SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>14. Mai 2009 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2008
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz
der Gesellschaft erhältlich.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende

Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der

41914

ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der

ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009048606/7/28.

CEGEDEL société anonyme (Compagnie Grand-Ducale d'Electricité du Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 4.513.

Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Cegedel, société anonyme, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>12 mai 2009 à 10 h 30, au siège social, 2, rue Thomas Edison à Strassen, à l'effet de délibérer

sur les objets suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion et rapport consolidé de gestion du conseil d'administration sur l'évolution des affaires en 2008
2. Rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2008

3. Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2008
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux administrateurs
6. Nominations statutaires
7. Autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions
8. Divers

Conformément à l'article 35 des statuts, les propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister à l'assemblée

générale ou s'y faire représenter doivent faire le dépôt de leurs titres au plus tard le 6 mai 2009 au siège social ou à l'un
des établissements ci-après:

DANS LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:
1) à la BGL, à Luxembourg;
2) à la Dexia - Banque Internationale à Luxembourg, à Luxembourg;
3) à la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, à Luxembourg;
4) à la Banque de Luxembourg, à Luxembourg;
5) à la Société Générale Bank &amp; Trust, à Luxembourg;
ou à leurs succursales et agences.

EN BELGIQUE:
1) à la Fortis Bank, à Bruxelles;
2) à la Dexia Banque Belgique, à Bruxelles;
ou à leurs succursales et agences.
Les procurations devront être déposées au siège social de la société au plus tard le 8 mai 2009.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009046443/2846/36.

Nextam Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 126.927.

Notice is hereby given to the shareholders of Nextam Partners, SICAV (the "Company") that the

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the Registered Office of the Company on <i>May 14th 2009 at 14.30 CET (the"Meeting"), with the following

agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of both Board of Directors and Auditor Report for the fiscal year ended December 31st, 2008.

41915

2. Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended December 31st, 2008.
3. Allocation of net results.
4. Discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial

year ended 31 December 2008.

5. Statutory appointments.
6. Miscellaneous.
The resolutions on the agenda may be passed without quorum, by a majority of the votes cast thereon at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy. Proxy forms can be obtained from
the Registered Office of the Company.

In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that the Company has been informed,

for organisational reasons, in writing of his intention to attend the Meeting by May 7th 2009, 17:00 CET at the latest.
Shareholders not attending the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to arrive
no later than May 13th 2009, 17.00.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2009048632/755/26.

Spoleto S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 40.344.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>14 mai 2009 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Ratification de la cooptation de M. Jacques CLAEYS comme administrateur, décidée par le conseil d'administration

en  date  du  16  décembre  2008  et  nomination  de  M.  Jacques  CLAEYS  comme  administrateur  jusqu'à  l'issue  de
l'assemblée générale statutaire de 2013.

6. Ratification de la cooptation de M. Sébastien ANDRE comme administrateur, décidée par le conseil d'administration

en date du 22 décembre 2008 et nomination de M. Sébastien ANDRE comme administrateur jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2013.

7. Décharge à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, M. Cornelius Martin BECH-

TEL, quant à l'exercice de ses mandats.

8. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Sinan SAR, quant à l'exercice de son mandat.
9. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009048626/29/25.

Old Town, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 6.734.

Our Shareholders are invited to attend on Wednesday, <i>May 20, 2009, at 11.00 a.m. in Luxembourg at 22-24 Boulevard

Royal, the

ORDINARY MEETING

of Shareholders with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Directors' Reports
2. Auditors' Reports
3. Approval of the "Parent Only" Financial Statements for the year ended December 31, 2008
4. Appropriation of the 2008 net income of the parent company
5. Discharge of Directors and Auditors
6. Election of the Auditors for a period of one year

41916

7. Election of Directors
8. Remuneration of Directors
9. Authorisation to the Board of Directors for the Company to repurchase Company's shares."

The owners of bearer shares who have so far not applied for having these shares converted to registered shares are

reminded that pursuant to the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders held on Thursday, May
4, 2006, all rights attaching to the non-converted bearer shares, including more in particular the right to vote and the
right to receive dividend, are suspended.

However, they can still at any time apply for such conversion.
Those shareholders who would wish to now convert their bearer shares should, seven clear days before the date of

the meeting apply in writing for the entry of their shares in the shareholders' register. To that effect they must complete
and sign the form of application which is available at the following address with Dexia Banque Internationale à Luxembourg,
Corporate Actions, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Attn Angela Reding - Tel: 00352 4590 5295 - Fax: 00352 4590
4218.

<i>THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2009046441/5231/31.

Tenaris S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 85.203.

Notice is hereby given to holders of shares of common stock of Tenaris S.A. (the "Company") that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held on <i>June 3, 2009, at 11:00 a.m. (Central European Time). The meeting will be held at 46A,

avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg. In the Annual General Meeting, shareholders will vote with respect to the
items listed below under the heading "Annual General Meeting of Shareholders".

<i>Agenda:

Annual General Meeting of Shareholders

1. Consideration of the Board of Directors' and independent auditors' reports on the Company's consolidated fi-

nancial statements. Approval of the Company's consolidated financial statements for the years ended December
31, 2008, 2007 and 2006.

2. Consideration of the Board of Directors' and independent auditors' reports on the Company's annual accounts.

Approval of the Company's annual accounts as at December 31, 2008.

3. Allocation of results and approval of dividend payment.
4. Discharge to the members of the Board of Directors for the exercise of their mandate during the year ended

December 31, 2008.

5. Election of the members of the Board of Directors.
6. Compensation of the members of the Board of Directors.
7. Appointment of the independent auditors for the fiscal year ending December 31, 2009 and approval of their fees.
8. Authorisation to the Board of Directors and the board of directors or other governing bodies of the Company's

subsidiaries to acquire Company shares.

9. Authorisation to the Board of Directors to cause the distribution of all shareholder communications, including its

shareholder meeting and proxy materials and annual reports to shareholders, by such electronic means as is per-
mitted by any applicable laws or regulations.

Pursuant to the Company's Articles of Association, resolutions at the Annual General Meeting of Shareholders will be

passed by simple majority vote, irrespective of the number of shares present or represented.

Procedures for Attending the Meeting
Holders of shares wishing to attend the meeting must obtain an admission ticket by depositing their certificates re-

presenting  their  common  stock,  not  later  than  4:00  p.m.  (local  time)  on  May  29,  2009,  at  the  Company's  office  in
Luxemburg or at the offices of any of the Company's subsidiaries set forth below:

Luxembourg: 46A, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Attn: Adélia Soares
Argentina: c/o Siderca S.A.I.C.
Carlos María della Paolera 299, piso 16°
(C1001ADA) Buenos Aires
Attn: Horacio de las Carreras and/or Eleonora Cimino

41917

Italy: c/o Dalmine S.p.A.
Piazza Caduti 6 luglio 1944 n. 1 24044
Dalmine (BG)
Attn: Marco Tajana and/or Teresa Gaini
Mexico: c/o Tubos de Acero de México, S.A.
Campos Elíseos 400-17
Col. Chapultepec Polanco
11560 México D.F.
Attn: Félix Todd and/or Luis Armando Leviaguirre
Holders of shares holding their shares through fungible securities accounts wishing to attend the meeting must present

a certificate (issued by the financial institution or professional depositary holding such shares) evidencing such deposit
and certifying the number of shares recorded in the relevant account as of May 29, 2009. Such certificate must be filed
not later than 4:00 p.m. (local time) on May 29, 2009, at any of the addresses indicated above and, in the case of shares
held in Mexico, with S.D. Indeval, S.A. de C.V. (Paseo de la Reforma #255, 2o. y 3er. piso Col. Cuauhtémoc, Mexico City).

Holders of shares as of May 29, 2009, may also vote by proxy. To vote by proxy, holders must file the required

certificate evidencing their holdings of shares and a completed proxy form not later than 4:00 p.m. (local time) on May
29, 2009 at any of the addresses indicated above or, in the case of shares held in Mexico, with S.D. Indeval, S.A. de C.V,
in Mexico City.

Holders of American Depositary Receipts ("ADRs") as of April 27, 2009, which continue to hold such ADRs on May

20, 2009, are entitled to instruct THE BANK OF NEW YORK MELLON, as Depositary (the "Depositary"), as to the
exercise of the voting rights pertaining to the Company's shares of common stock represented by such holder's ADRs.
Although voting instructions are sent to holders and proxy materials are available at our website beginning on May 1,
2009, only those holders of record as of each of April 27, 2009 and May 20, 2009 will be entitled to provide the Depositary
with voting instructions. Notwithstanding that holders of ADRs must have held ADRs on each such date, in order to
avoid the possibility of double vote, only those positions on May 20, 2009, will be counted for voting instruction purposes.
Eligible ADR holders who desire to vote at the meeting must complete, date and sign a proxy form and return it to the
Depositary, at THE BANK OF NEW YORK MELLON, Proxy Processing P.O. Box 3549, S. Hackensack, NJ 07606-9249,
U.S.A., by 5:00 p.m., New York City time, on May 28, 2009.

The Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement (which contains reports on each item of the agenda for the

meeting, and further details on voting procedures) and the forms furnished by the Company in connection with the
meeting, may be obtained at any of the addresses indicated above or upon request by calling (352) 26-47-89-78 (if you
are in Luxembourg), 1-800-555-2470 (if you are in the United States), or +1-267-468-0786 (if you are in another juris-
diction), but also from the Depositary, Borsa Italiana SpA (Piazza degli Affari 6, 20123, Milan, Italy) and S.D. Indeval S.A.
de C.V., as from May 1, 2009, between 10:00 a.m. and 5:00 p.m. (local time).

Copies of the Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement and the forms are also available at www.tenaris.com/

investors. Copies of the Company's 2008 annual report (including the Company's consolidated financial statements for
the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006 and the Company's annual accounts as at December 31, 2008,
together with the independent auditors' report and management's report and certification, and the documents referred
to in the preceding sentence) may also be obtained free of charge at the Company's registered office in Luxembourg or
upon request by calling (352) 26-47-89-78 (if you are in Luxembourg), 1-800-555-2470 (if you are in the United States),
or +1-267-468-0786 (if you are in another jurisdiction).

April 24, 2009.

Cecilia Bilesio
<i>Secretary to the Board of Directors

Référence de publication: 2009047888/3746/86.

PEH Trust Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.989.

Die Aktionäre der PEH Trust SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>13. Mai 2009 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2008

41918

3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz
der Gesellschaft erhältlich.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende

Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der
ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der

ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009048608/7/28.

Generali Hedge Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 100.470.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at the registered office, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on Monday,

<i>May 11, 2009 at 3.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and the Independent Auditor
2. Approval of the financial statements as of December 31, 2008
3. Decision on allocation of net profits
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year

ended December 31, 2008

5. Appointment of the Members of the Board of Directors
6. Appointment of the Independent Auditor
7. Miscellaneous

<i>Notes

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
* in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A.

which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on May 6, 2009.

* by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as

aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of Generali
Hedge Funds Sicav c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. at the latest on May 6, 2009.

Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009048629/755/28.

Siltarc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 104.778.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of April.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-AIzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Tarc Lux S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 282, Route de Longwy, L-1940 Lu-

xembourg, and registered with the Luxembourg registre de Commerce et des Sociétés under number B 94.556 being
the sole shareholder of Siltarc S.A., a société anonyme having its registered office in L-1940 Luxembourg, 282, route de
Longwy, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 104.778, incorporated

41919

as a société anonyme by deed of M 

e

 Henri Hellinckx, notary residing at the time in Mersch, on 15 

th

 December 2004,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), n° 1308 and 1309 on 22 

nd

 December

2004 (the "Company"), represented by Mr Eddy Perrier, private employee, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy
dated 2 

nd

 April 2009.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary

on 23 March 2009, not yet published in the Mémorial.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The sole shareholder holds all F and F1 shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on

all items of the agenda.

(B) The items on which resolutions are to be passed are the following:
1. Authorisation to the board of directors of the Company to issue up to nine hundred and eleven million one hundred

and seventy thousand and six (911,170,006) redeemable convertible bonds having similar terms and conditions as re-
deemable convertible bonds issued by the Company in the past.

2. Creation of an authorised share capital of the Company of nine million one hundred and eleven thousand seven

hundred Euro and six cents (€9,111,700.06) consisting of nine hundred and eleven million one hundred and seventy
thousand six (911,170,006) shares each with a nominal value of one Euro cent (€0.01) which shall be reserved for the
conversion of nine hundred and eleven million one hundred and seventy thousand six (911,170,006) subordinated re-
deemable zero coupon convertible bonds; the board of directors of the Company is duly authorised to decide the class
of shares to be issued upon conversion of the subordinated redeemable zero coupon convertible bonds; and acknow-
ledgement and approval of the report of the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3
(5) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies (as amended) (the "Law") concerning the price, if any, at

which the shares may be issued, such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of the
existing shareholders.

3. Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation by creating a new article 5.2.
Thereafter, the following resolutions were unanimously passed.

<i>First resolution

It is resolved to authorise the board of directors of the Company to issue up to nine hundred and eleven million one

hundred and seventy thousand and six (911,170,006) redeemable convertible bonds having similar terms and conditions
as redeemable convertible bonds issued by the Company in the past.

<i>Second resolution

It is resolved to approve the creation of an authorised capital of nine million one hundred and eleven thousand seven

hundred Euro and six cents (€9,111,700.06) consisting of nine hundred and eleven million one hundred and seventy
thousand and six (911,170,006) shares each with a nominal value of one Euro cent (€0.01) which shall be reserved for
the conversion of nine hundred and eleven million one hundred and seventy thousand six (911,170,006) subordinated
redeemable zero coupon convertible bonds and to authorise the board of directors of the Company to decide the class
of shares to be issued upon conversion of the subordinated redeemable zero coupon convertible bonds.

As regards said creation of the authorised share capital of the Company, the sole shareholder acknowledged and

approved  a  report  by  the  board  of  directors  of  the  Company  made  in  accordance  with  article  32-3  (5)  of  the  Law
concerning the price, if any, at which the shares of the Company might be issued to the extent such issues were being
made without reserving any preferential subscription rights of the shareholders.

It is resolved that such report complied with said article 32-3(5).

<i>Third resolution

As a result of the preceding resolution, it is resolved to amend article 5 of the Company's articles of incorporation by

creating a new article 5.2 which shall read as follows:

Art. 5.2. The authorised capital is set at nine million one hundred and eleven thousand seven hundred Euro and six

cents (€9,111,700.06) consisting of nine hundred and eleven million one hundred and seventy thousand six (911,170,006)
shares with a nominal value of one Euro cent (0.01) per share which shall be reserved for the conversion of nine hundred
and eleven million one hundred and seventy thousand six (911,170,006) subordinated redeemable zero coupon conver-
tible bonds. The board of directors shall have the right, when issuing shares out of the authorised share capital to decide
whether the shares to be issued will be ordinary F shares or non voting preference F1 shares.

Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Memorial of the notarial deed

recording the shareholders' resolution on the authorised capital.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of shares contemplated in (i) and (ii) inclusive above. Without prejudice to the preceding paragraphs,
shares to be subscribed for in cash shall be offered on a pre-emptive basis to the shareholders in proportion of the capital
represented by their shares. The right to subscribe may be exercised within a period determined by the board of directors,

41920

which may not be less than thirty (30) days from the date of the subscription period, which shall be notified by registered
letter. The right to subscribe shall be transferable throughout the subscription period, and no restrictions may be imposed
on such transferability other than those applicable to the shares in respect of which the right arises. Subject to the
preceding paragraphs, the board of directors or delegate(s) duly appointed by the board may from time to time issue
shares out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the
board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

In case of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of any

shares shall be entitled to pre-emptive rights with respect to shares to be issued, unless waived by the general meeting
of shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the

board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments."

Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at € 1,500,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxy holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six avril.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Tarc Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 282, Route de Longwy, L-1940 Luxem-

bourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.556, étant
l'actionnaire unique de Siltarc S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de
Longwy, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la mention B 104.778,
constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte reçu de Me Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à
Mersch,  en  date  du  15  décembre  2004,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  (le  "Mémorial")
numéros 1308 et 1309 du 22 décembre 2004 (la "Société"), représentée par M. Eddy Perrier, employé privé, demeurant
à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 2 avril 2009.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire soussigné en date du 23

mars 2009, non encore publié au Mémorial. La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

(A) L'actionnaire unique détient toutes les actions F et F1 émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent

valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:
1.  Autorisation  au  conseil  d'administration  de  la  Société  d'émettre  un  maximum  de  neuf  cent  onze  millions  cent

soixante-dix mille six (911.170.006) obligations convertibles rachetables ayant les mêmes termes et conditions que les
obligations convertibles rachetables émises dans le passé par la Société.

2. Création d'un capital social autorisé de la Société de neuf millions cent onze mille sept cents Euros et six cents

(€9.111.700,06) consistant en neuf cent onze millions cent soixante-dix mille six (911.170.006) actions ayant chacune une
valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01), lesquelles sont réservées pour la conversion de neuf cent onze millions
cent soixante-dix mille six (911.170.006) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro; le conseil
d'administration de la Société est dûment autorisé à décider de la classe d'actions devant être émise au moment de la
conversion des obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro; et constat et approbation du rapport
du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (telle que modifiée) (la "Loi") en ce qui concerne le prix, le cas échéant, auquel les actions peuvent être
émises, ces émissions étant faites sans réserver de droits de souscription préférentiels aux actionnaires existants.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts en créant un nouvel article 5.2.
Ensuite, les résolutions suivantes ont été unanimement adoptées.

<i>Première résolution

Il est décidé d'autoriser le conseil d'administration de la Société d'émettre un maximum de neuf cent onze millions

cent soixante-dix mille six (911.170.006) obligations convertibles rachetables ayant les mêmes termes et conditions que
les obligations convertibles rachetables émises dans le passé par la Société.

41921

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'approuver la création d'un capital social autorisé de la Société de neuf millions cent onze mille sept cents

Euros et six cents (€9.111.700,06) consistant en neuf cent onze millions cent soixante-dix mille six (911.170.006) actions
ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01), lesquelles sont réservées pour la conversion de neuf
cent onze millions cent soixante-dix mille six (911.170.006) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon
zéro, et d'autoriser le conseil d'administration de la Société à décider de la classe d'actions devant être émise au moment
de la conversion des obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro.

En relation avec la création du capital social autorisé de la Société qui précède, l'actionnaire unique a constaté et

approuvé un rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3(5) de la Loi relative
au prix, le cas échéant, auquel les actions pourraient être émises dans la mesure où ces émissions étaient faites sans
réserver de droits de souscription préférentiels aux actionnaires existants.

Il est décidé que ce rapport est conforme audit article 32-3(5).

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société en créant

un nouvel article 5.2 qui aura la teneur suivante:

Art. 5.2. Le capital autorisé mais non émis est fixé à neuf millions cent onze mille sept cents Euros et six cents

(€9.111.700,06) consistant en neuf cent onze millions cent soixante-dix mille six (911.170.006) actions ayant une valeur
nominale d'un centime d'Euro (€0,01 ) par action, lesquelles seront réservées pour la conversion de neuf cent onze
millions cent soixante-dix mille six (911.170.006) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro. Le
conseil d'administration aura le droit, au moment de l'émission d'actions dans les limites du capital social autorisé, de
décider si les actions devant être émises seront des actions ordinaires F ou des actions privilégiées sans droit de vote F1.

Toute action autorisée mais non émise expirera cinq (5) ans après la publication dans le Mémorial de l'acte notarié

prenant acte de la résolution des actionnaires portant sur le capital autorisé.

Afin  d'éviter  tout  doute,  les  actionnaires  renoncent  expressément  à  tout  droit  de  souscription  préférentiel  qu'ils

pourraient avoir en relation avec les émissions d'actions prévues dans les limites du capital autorisé.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions devant être souscrites en espèces seront offertes aux action-

naires sur une base préemptive au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription peut être
exercé pendant une période déterminée par le conseil d'administration, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à
compter de la date de la période de souscription, laquelle sera notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscription
peut être cédé pendant la période de souscription, et aucune restriction ne pourra être imposée sur cette cession autre
que les restrictions applicables aux actions qui bénéficient de ce droit.

Sous réserve des paragraphes précédents, le conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) dûment désigné(s) par le

conseil peut de temps à autre émettre des actions dans les limites de la totalité des actions autorisées aux dates et selon
les termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le conseil ou son(ses) délégué(s) pourra(ont) déterminer à sa
(leur) discrétion.

Dans l'hypothèse d'un capital autorisé additionnel et/ou d'un renouvellement subséquent du capital autorisé, les dé-

tenteurs d'actions pourront bénéficier de droits de préemption en relation avec les actions à émettre, à moins que
l'assemblée générale des actionnaires ait renoncé à ces droits de préemption.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera enregistrée dans un acte notarié, à la demande

du conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) sur présentation des documents établissant les souscriptions et les
paiements."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Coûts et Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à € 1.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante,
en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: E. Perrier, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 07 avril 2009. Relation: EAC/2009/4081. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

41922

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009047816/272/181.
(090056786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

SWIP Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 753.400,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 104.119.

EXTRAIT

Il résulte de sa lettre de démission que Monsieur Nicholas James Patrick Ireland a démissionné de son poste d'admi-

nistrateur de la Société avec effet le 19 janvier 2009.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009046621/267/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01173. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090052285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

PG Silver A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 145.179.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of April.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of PG Silver A S.A. (the "Company"), a société anonyme

having  its  registered  office  in  L-2163  Luxembourg,  20,  avenue  Monterey,  registered  with  the  Trade  and  Companies
Register of Luxembourg under the number B 145.179, incorporated as a société anonyme by deed of the undersigned
notary, on 10 

th

 March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 24 March 2009

number 631.

The meeting was presided over by Mrs Emanuela Brero, director, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Stella Le Cras, private employee, residing in Luxembourg. The meeting

elected as scrutineer M 

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,

signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. The extraordinary general meeting was duly convened by notices sent by registered mail on 27 

th

 March 2009.

III. It appears from the attendance list that out of the 520,128,121 ordinary D shares, 432,228,531 non voting preference

D1  shares  and  5,934,271  non  voting  preference  D2  shares,  520,128,121  ordinary  D  shares,  432,228,531  non  voting
preference D1 shares and 5,934,271 non voting preference D2 shares are represented at the present meeting so that
the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

IV. The items on which resolution are to be passed are as follows:
1. Increase of the issued share capital of the Company from nine million five hundred and eighty-two thousand nine

hundred and nine Euro and twenty-three cents (€9,582,909.23) to thirty-eight million seven hundred and seven thousand
four hundred and eighty-five Euro and twenty-four cents (€38,707,485.24) by the issue of additional (i) one billion five
hundred and eighty million seven hundred and eighty-four thousand one hundred and sixteen (1,580,784,116) ordinary
D shares, (ii) one billion three hundred and thirteen million six hundred and thirty-seven thousand eight hundred and
sixty-six (1,313,637,866) non voting preference D1 shares and (iii) eighteen million thirty-five thousand six hundred and
nineteen (18,035,619) non voting preference D2 shares of a par value and subscription price of one Euro cent (€0.01)
each; subscription to the new shares by the current shareholders of the Company and full payment thereof by contribution
in cash to the Company, issue of the new shares;

2. Consequential amendment of the first paragraph of article 5.1 of the articles of incorporation;
3. Acknowledgement of the resignation of (i) Mr Pierre Stemper, Mrs Christelle Rétif, Mr Michael Andrew Twinning

and Mrs Josephine Pallett as directors of the Company with effect as from the 27 

th

 March 2009 and (ii) Mr Naim Gjonaj

41923

as director of the Company with effect as from the 6 

th

 April 2009. Confirmation of the appointment of Mrs Emanuela

Brero  and  Mrs  Bénédicte  Moens-Colleaux,  as  directors  of  the  Company  with  effect  as  from  27 

th

  March  2009  and

appointment of Mrs Delphine Tempé as director of the Company with effect as from 6 

th

 April 2009 for a period ending

on the annual general meeting of the shareholders to be held in 2010 for the approval of the annual accounts of the
financial year 2009.

Thereafter, the following resolutions were passed:

<i>First resolution

It Is resolved to increase the issued share capital of the Company from nine million five hundred and eighty-two

thousand nine hundred and nine Euro and twenty-three cents (€9,582,909.23) to thirty-eight million seven hundred and
seven thousand four hundred and eighty-five Euro and twenty-four cents (€38,707,485.24) by the issue of additional (i)
one  billion  five  hundred  and  eighty  million  seven  hundred  and  eighty-four  thousand  one  hundred  and  sixteen
(1,580,784,116) ordinary D shares, (ii) one billion three hundred and thirteen million six hundred and thirty-seven thou-
sand eight hundred and sixty-six (1,313,637,866) non voting preference D1 shares and (iii) eighteen million thirty-five
thousand six hundred and nineteen (18,035,619) non voting preference D2 shares of a par value of one Euro cent (€0.01)
each to be subscribed and paid in full in cash as set forth in the table below.

The new shares referred to above have been subscribed by and paid in full in cash as follows:

Subscriber

Number and class of shares subscribed Subscription price (€)

1. CVC Silver Nominee Limited . . . . . . . . .

1,580,784,116 ordinary D shares

15,807,841.16

1,313,637,866 non voting preference D1 shares

13,136,378.66

3,034,215 non voting preference D2 shares

30,342.15

2. Mr Paolo Gonano . . . . . . . . . . . . . . . . .

759,772 non voting preference D2 shares

7,597.72

3. Mr Giacomo Casassa . . . . . . . . . . . . . . .

759,772 non voting preference D2 shares

7,597.72

4. Mrs Maurizia Squinzi . . . . . . . . . . . . . . .

294,376 non voting preference D2 shares

2,943.76

5. Mrs Rita d'Uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

294,376 non voting preference D2 shares

2,943.76

6. Mr Angelo Novati . . . . . . . . . . . . . . . . .

605,932 non voting preference D2 shares

6,059.32

7. Mr Carlo Pappalettera . . . . . . . . . . . . . .

757,963 non voting preference D2 shares

7,579.63

8. Mr Alessandro Triscornia . . . . . . . . . . .

757,963 non voting preference D2 shares

7,579.63

9. Mr Francesco Stella . . . . . . . . . . . . . . . .

227,501 non voting preference D2 shares

2,275.01

10. Carisma S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,100,256 non voting preference D2 shares

91,002.56

11. Mr Paolo Giuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

524,910 non voting preference D2 shares

5,249.10

12. Mr Luigi Langella . . . . . . . . . . . . . . . . .

524,910 non voting preference D2 shares

2,249.10

13. Mr Giovanni Caporello . . . . . . . . . . . .

393,673 non voting preference D2 shares

3,936.73

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,580,784,116 ordinary D shares

15,807,841.16

1,313,637,866 non voting preference D1 shares

13,136,378.66

18,035,619 non voting preference D2 shares

180,356.19

(1) CVC Silver Nominee Limited, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom with

registered office in 10 Upper Bank Street, London E14 5JJ,

(2) Paolo Gonano, residing in Genova (Italy), Via Gaetano Colombo, 20 Interno 10;
(3) Giacomo Casassa, residing in Turin (Italy), Via Fossati 20/B, 18, 10138;
(4) Maurizia Squinzi, residing in Trezzano S/N Milano 20 090 (Italy), Via Ugo Bassi 21;
(5) Rita D'Uva, residing in Turin (Italy), Via Cernaia 1;
(6) Angelo Novati, residing in Rome (Italy), Via Denza;
(7) Carlo Pappalettera, residing in Milan (Italy), Via Archimede 4;
(8) Alessandro Triscornia, residing in Milan (Italy), Via Mangili 3;
(9) Francesco Stella, residing in Milan (Italy), Via Santa Margherita 32;
(10) Carisma S.p.A., a company incorporated and organized under the laws of Italy, having its registered office in Milan

(Italy), Via Crocefisso 10;

(11) Paolo Giuri, residing in Neuilly-sur-Seine 92521 (France), 27, avenue Charles de Gaulles;
(12) Luigi Langella, residing in Milan (Italy), Via Ippodromo 76;
(13) Giovanni Caporello, residing in Turin (Italy), 379 Corso Moncalieri.
Ordinary D shares D:
- Pour 520,128,121
- Contre
- Abstention

41924

Non voting preference D1 shares:
- Pour 432,228,531
- Contre
- Abstention
Non voting preference D2 shares:
- Pour 5,934,271
- Contre
- Abstention

<i>Second resolution

As a result of the preceding resolution, it is resolved to amend the first paragraph of the article 5.1 of the Company's

articles of incorporation which shall read as follows:

Art. 5.1. The issued capital is set at thirty-eight million seven hundred and seven thousand four hundred and eighty-

five Euro and twenty-four cents (€38,707,485.24) divided into

(i) 2,100,912,237 ordinary D shares (the "ordinary shares");
(ii) 1,745,866,397 non voting preference D1 shares (the "D1 shares"), and
(iii) 23,969,890 non voting preference D2 shares (the "D2 shares" and together with the D1 shares, the "non voting

preference shares"), with a nominal value of one Euro cent (€0.01) per share (the ordinary shares and the non voting
preference shares being together referred to as the "shares" and the holders thereof as the "shareholders", unless the
context otherwise requests)."

Ordinary D shares D:
- Pour 520,128,121
- Contre
- Abstention
Non voting preference D1 shares:
- Pour 432,228,531
- Contre
- Abstention
Non voting preference D2 shares:
- Pour 5,934,271
- Contre
- Abstention

<i>Third resolution

It  is  resolved to  acknowledge  the resignation  of  (i)  Mr  Pierre Stemper,  Mrs Christelle  Rétif, Mr Michael Andrew

Twinning and Mrs Josephine Pallett as directors of the Company with effect as from the 27 

th

 March 2009 and (ii) Mr

Naim Gjonaj as director of the Company with effect as from the 6 

th

 April 2009. The meeting noted the cooptation of

Mrs Emanuela Brero and Mrs Bénédicte Moens-Colleaux, and consequently resolved to confirm the appointment of Mrs
Emanuela Brero and Mrs Bénédicte Moens-Colleaux as directors of the Company with effect as from 27 

th

 March 2009

and to appoint Mrs Delphine Tempé as director of the Company with effect as from 6 

th

 April 2009 all of them for a

period ending on the annual general meeting of the shareholders to be held in 2010 for the approval of the annual accounts
of the financial year 2009.

Ordinary D shares D:
- Pour 520,128,121
- Contre
- Abstention
Non voting preference D1 shares:
- Pour 432,228,531
- Contre
- Abstention
Non voting preference D2 shares:
- Pour 5,934,271
- Contre
- Abstention
Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

41925

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at € 7,000,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six avril.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PG Silver A S.A. (la "Société"), une société anonyme

ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la mention B 145.179, constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte
reçu du notaire soussigné en date du 10 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
631 du 24 mars 2009.

L'assemblée a été présidée par Mme Emanuela Brero, administrateur, demeurant à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Mme Stella Le Cras, employée privée, demeurant à Luxembourg. L'assemblée

a élu comme scrutateur Me Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence

signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l'enregistrement.

II. L'assemblée générale extraordinaire a été valablement convoquée par des avis de convocation envoyés par lettre

recommandée en date du 27 mars 2009.

III. Il ressort de ladite liste de présence que sur les 520.128.121 actions ordinaires D, 432.228.531 actions privilégiées

sans  droit  de  vote  D1  et  5.934.271  actions  privilégiées  sans  droit  de  vote  D2,  520.128.121  actions  ordinaires  D,
432.228.531  actions  privilégiées  sans  droit  de  vote  D1  et  5.934.271  actions  privilégiées  sans  droit  de  vote  D2  sont
représentées à la présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous:

1. Augmentation du capital social émis de la Société de neuf millions cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf cent neuf

Euros et vingt-trois cents (€9.582.909,23) à trente-huit millions sept cent sept mille quatre cent quatre-vingt-cinq Euros
et vingt-quatre cents (€38.707.485,24) par l'émission de (i) un milliard cinq cent quatre-vingt millions sept cent quatre-
vingt-quatre mille cent seize (1.580.784.116) actions ordinaires D additionnelles, (ii) un milliard trois cent treize millions
six cent trente-sept mille huit cent soixante-six (1.313.637.866) actions privilégiées sans droit de vote D1 additionnelles
et (iii) dix-huit millions trente-cinq mille six cent dix-neuf (18.035.619) actions privilégiées sans droit de vote D2 addi-
tionnelles, ayant chacune une valeur nominale et un prix de souscription d'un centime d'Euro (€0,01); souscription aux
nouvelles actions par les actionnaires existants de la Société et paiement intégral par un apport en numéraire à la Société;
émission des nouvelles actions.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5.1 des statuts.
3. Constat de la démission de (i) M. Pierre Stemper, Mme Christelle Rétif, M. Michael Andrew Twinning et Mme

Josephine Pallett de leurs fonctions d'administrateurs de la Société avec effet au 27 mars 2009 et (ii) M. Naim Gjonaj de
ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 6 avril 2009. Confirmation de la nomination de Mme Emanuela
Brero et Mme Bénédicte Moens-Colleaux aux fonctions d'administrateurs de la Société avec effet au 27 mars 2009 et de
la nomination de Mme Delphine Tempé aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 6 avril 2009 pour une
période se terminant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2010 sur l'approbation des comptes
annuels de l'exercice social 2009.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de neuf millions cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf

cent neuf Euros et vingt-trois cents (€9.582.909,23) à trente-huit millions sept cent sept mille quatre cent quatre-vingt-
cinq Euros et vingt-quatre cents (€38.707.485,24) par l'émission de (i) un milliard cinq cent quatre-vingt millions sept cent
quatre-vingt-quatre mille cent seize (1.580.784.116) actions ordinaires D additionnelles, (ii) un milliard trois cent treize
millions six cent trente-sept mille huit cent soixante-six (1.313.637.866) actions privilégiées sans droit de vote D1 addi-
tionnelles et (iii) dix-huit millions trente-cinq mille six cent dix-neuf (18.035.619) actions privilégiées sans droit de vote

41926

D2 additionnelles, ayant chacune une valeur nominale et un prix de souscription d'un centime d'Euro (€0,01) qui seront
souscrites et entièrement libérées en numéraire tel que décrit dans le tableau ci-dessous.

Les nouvelles actions mentionnées ci-dessus ont été souscrites et entièrement libérées de la manière suivante:

Souscripteur

Nombre et classe d'actions souscrites

Prix de

souscription (€)

1. CVC Silver Nominee Limited . . . . . . .

1.580.784.116 actions ordinaires D

15.807.841,16

1.313.637.866 actions privilégiées sans droit de vote D1

13.136.378,66

3.034.215 actions privilégiées sans droit de vote D2

30.342,15

2. M. Paolo Gonano . . . . . . . . . . . . . . . .

759.772 actions privilégiées sans droit de vote D2

7.597,72

3. M. Giacomo Casassa . . . . . . . . . . . . .

759.772 actions privilégiées sans droit de vote D2

7.597,72

4. Mme Maurizia Squinzi . . . . . . . . . . . . .

294.376 actions privilégiées sans droit de vote D2

2.943,76

5. Mme Rita d'Uva . . . . . . . . . . . . . . . . .

294.376 actions privilégiées sans droit de vote D2

2.943,76

6. M. Angelo Novati . . . . . . . . . . . . . . . .

605.932 actions privilégiées sans droit de vote D2

6.059,32

7. M. Carlo Pappalettera . . . . . . . . . . . .

757.963 actions privilégiées sans droit de vote D2

7.579,63

8. M. Alessandro Triscornia . . . . . . . . . .

757.963 actions privilégiées sans droit de vote D2

7.579,63

9. M. Francesco Stella . . . . . . . . . . . . . . .

227.501 actions privilégiées sans droit de vote D2

2.275,01

10. Carisma S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.100.256 actions privilégiées sans droit de vote D2

91.002,56

11. M. Paolo Giuri . . . . . . . . . . . . . . . . .

524.910 actions privilégiées sans droit de vote D2

5.249,10

12. M. Luigi Langella . . . . . . . . . . . . . . . .

524.910 actions privilégiées sans droit de vote D2

2.249,10

13. M. Giovanni Caporello . . . . . . . . . . .

393.673 actions privilégiées sans droit de vote D2

3.936,73

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.580.784.116 actions ordinaires D

15.807.841,16

1.313.637.866 actions privilégiées sans droit de vote D1

13.136.378,66

18.035.619 actions privilégiées sans droit de vote D2

180.356,19

(1) CVC Silver Nominee Limited, une société constituée et existant sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège

social au 10 Upper Bank Street, Londres E14 5JJ,

(2) Paolo Gonano, demeurant à Gênes (Italie), Via Gaetano Colombo, 20 Interno 10;
(3) Giacomo Casassa, demeurant à Turin (Italie), Via Fossati 20/B, 18, 10138;
(4) Maurizia Squinzi, demeurant à Trezzanno S/N, Milan 20 090 (Italie), Via Ugo Bassi 21;
(5) Rita d'Uva, demeurant à Turin (Italie), Via Cernaia 1;
(6) Angelo Novati, demeurant à Rome (Italie), Via Denza;
(7) Carlo Pappalettera, demeurant à Milan (Italie), Via Archimede 4;
(8) Alessandro Triscornia, demeurant à Milan (Italie), Via Mangili 3;
(9) Francesco Stella, demeurant à Milan (Italie), Via Santa Margherita 32;
(10) Carisma S.p.A., une société constituée et organisée sous les lois d'Italie, ayant son siège social à Milan (Italie), Via

Crocefisso 10;

(11) Paolo Giuri, demeurant à Neuilly-sur-Seine 92521 (France), 27, avenue Charles de Gaulles;
(12) Luigi Langella, demeurant à Milan (Italie), Via Ippodromo 76;
(13) Giovanni Caporello, demeurant à Turin (Italie), 379 Corso Moncalieri.
Actions ordinaires D:
- Pour 520.128.121
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote D1:
- Pour 432.228.531
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote D2:
- Pour 5.934.271
- Contre
- Abstention

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5.1 des statuts

afin qu'il ait la teneur suivante:

41927

Art. 5.1. Le capital émis est fixé à trente-huit millions sept cent sept mille quatre cent quatre-vingt-cinq Euros et

vingt-quatre centimes (€38.707.485,24) divisé en

(i) 2.100.912.237 actions ordinaires D (les "actions ordinaires");
(ii) 1.745.866.397 actions privilégiées sans droit de vote D1 (les "actions D1"), et
(iii) 23.969.890 actions privilégiées sans droit de vote D2 (les "actions D2" et ensemble avec les actions D1, les "actions

privilégiées sans droit de vote"), ayant une valeur nominale d'un centime d'Euros (€0,01) par action (les actions ordinaires
et les actions privilégiées sans droit de vote étant ensemble désignées les "actions" et leurs détenteurs les "actionnaires",
à moins que le contexte ne le prévoit autrement)."

Actions ordinaires D:
- Pour 520.128.121
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote D1:
- Pour 432.228.531
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote D2:
- Pour 5.934.271
- Contre
- Abstention

<i>Troisième résolution

Il est décidé de constater la démission de (i) M. Pierre Stemper, Mme Christelle Rétif, M. Michael Andrew Twinning

et Mme Joséphine Pallett de leurs fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 27 mars 2009 et (ii) M. Naim
Gjonaj de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 6 avril 2009. L'assemblée a pris note de la cooptation
de Mme Emanuela Brero et Mme Bénédicte Moens-Colleaux et a décidé en conséquence de confirmer la nomination de
Mme Emanuela Brero et Mme Bénédicte Moens-Colleaux aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 27
mars 2009 et de nommer Mme Delphine Tempe aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 6 avril 2009
pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2010 sur l'approbation
des comptes annuels de l'exercice social 2009.

Actions ordinaires D:
- Pour 520.128.121
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote D1:
- Pour 432.228.531
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote D2:
- Pour 5.934.271
- Contre
- Abstention
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Coûts et Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à € 7.000,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties compa-
rantes, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: E. Brero, S. Le Cras, K. Panichi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 07 avril 2009. Relation: EAC/2009/4079. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

41928

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009047822/272/311.
(090056824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

SWIP (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 104.118.

EXTRAIT

Il résulte de sa lettre de démission que Monsieur Nicholas James Patrick Ireland a démissionné de son poste d'admi-

nistrateur de la Société avec effet le 19 janvier 2009.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009046622/267/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01164. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Sterling Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.775.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of April.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was  held  an  extraordinary  general  meeting  of  shareholders  of  Sterling  Holdings  S.A.  (the  "Company"),  a  société

anonyme having its registered office in L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey, registered with the Trade and Com-
panies Register of Luxembourg under the number B 104.775, incorporated as a société anonyme by deed of M 

e

 Henri

Hellinckx, notary residing at the time in Mersch, on 15 

th

 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations (the "Mémorial"), n° 1308 and 1309 on 22 

nd

 December 2004. The articles of incorporation of

the Company have been amended for the last time by deed of M 

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 2

nd

 March 2009, not published yet in the Mémorial.

The meeting was presided over by Mrs Emanuela Brero, director, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Stella Le Cras, private employee, residing in Luxembourg. The meeting

elected as scrutineer M 

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. The extraordinary general meeting was duly convened by notices sent by registered mail on 27 

th

 March 2009.

III. It appears from the attendance list that out of the 1,696,156,095 ordinary C shares, 1,406,383,102 non voting

preference C1 shares and 19,299,069 non voting preference C2 shares, 1,696,156,095 ordinary C shares, 1,406,383,102
non voting preference C1 shares and 19,299,069 non voting preference C2 shares are represented at the present meeting
so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Increase of the issued share capital of the Company from thirty-one million two hundred eighteen thousand three

hundred eighty-two Euro and sixty-six cents (€31,218,382.66) to sixty million seven hundred eighteen thousand two
hundred eighty-nine Euro and ninety cents (€60,718,289.90) by the issue of additional (i) one billion six hundred and two
million seven hundred eighty-seven thousand nine hundred forty-eight (1,602,787,948) ordinary C shares, (ii) one billion
three hundred twenty-eight million nine hundred sixty-six thousand sixty two (1,328,966,062) non voting preference C1
shares and (iii) eighteen million two hundred thirty-six thousand seven hundred fourteen (18,236,714) non voting pre-
ference C2 shares of a par value and subscription price of one Euro cent (€0.01) each; subscription to the new shares
by the current shareholders of the Company and full payment thereof by contribution in cash to the Company, issue of
the new shares;

41929

2. Consequential amendment of the first paragraph of article 5.1 of the articles of incorporation.
Thereafter, the following resolutions were passed:

<i>First resolution

It  is  resolved  to  increase  the  issued  share  capital  of  the  Company  from  thirty-one  million  two  hundred  eighteen

thousand three hundred eighty-two Euro and sixty-six cents (€31,218,382.66) to sixty million seven hundred eighteen
thousand two hundred eighty-nine Euro and ninety cents (€60,718,289.90) by the issue of additional (i) one billion six
hundred  and  two  million  seven  hundred  eighty-seven  thousand  nine  hundred  forty-eight  (1,602,787,948)  ordinary  C
shares, (ii) one billion three hundred twenty-eight million nine hundred sixty-six thousand sixty two (1,328,966,062) non
voting  preference  C1  shares  and  (iii)  eighteen  million  two  hundred  thirty-six  thousand  seven  hundred  fourteen
(18,236,714) non voting preference C2 shares of a par value of one Euro cent (€0.01) each to be subscribed and paid in
full in cash as set forth in the table below.

The new shares referred to above have been subscribed by and paid in full in cash as follows:

Subscriber

Number and class of shares subscribed Subscription price (€)

1. CVC Silver Nominee Limited . . . . . . . . .

1,602,787,948 ordinary C shares

16,027,879.48

1,328,966,062 non voting preference C1 shares

13,289,660.62

3,073,192 non voting preference C2 shares

30,731.92

2. Mr Paolo Gonano . . . . . . . . . . . . . . . . .

750,333 non voting preference C2 shares

7,503.33

3. Mr Giacomo Casassa . . . . . . . . . . . . . . .

750,333 non voting preference C2 shares

7,503.33

4. Mrs Maurizia Squinzi . . . . . . . . . . . . . . .

301,519 non voting preference C2 shares

3,015.19

5. Mrs Rita d'Uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

301,519 non voting preference C2 shares

3,015.19

6. Mr Angelo Novati . . . . . . . . . . . . . . . . .

615,711 non voting preference C2 shares

6,157.11

7. Mr Carlo Pappalettera . . . . . . . . . . . . . .

767,554 non voting preference C2 shares

7,675.54

8. Mr Alessandro Triscornia . . . . . . . . . . .

767,554 non voting preference C2 shares

7,675.54

9. Mr Francesco Stella . . . . . . . . . . . . . . . .

230,424 non voting preference C2 shares

2,304.24

10. Carisma S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,216,560 non voting preference C2 shares

92,165.60

11. Mr Paolo Giuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

531,646 non voting preference C2 shares

5,316.46

12. Mr Luigi Langella . . . . . . . . . . . . . . . . .

531,646 non voting preference C2 shares

5,316.46

13. Mr Giovanni Caporello . . . . . . . . . . . .

398,723 non voting preference C2 shares

3,987.23

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,602,787,948 ordinary C shares

16,027,879.48

1,328,966,062 non voting preference C1 shares

13,289,660.62

18,236,714 non voting preference C2 shares

182,367.14

(1) CVC Silver Nominee Limited, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom with

registered office in 10 Upper Bank Street, London E14 5JJ,

(2) Paolo Gonano, residing in Genova (Italy), Via Gaetano Colombo, 20 Interno 10;
(3) Giacomo Casassa, residing in Turin (Italy), Via Fossati 20/B, 18, 10138;
(4) Maurizia Squinzi, residing in Trezzano S/N Milano 20 090 (Italy), Via Ugo Bassi 21;
(5) Rita D'Uva, residing in Turin (Italy), Via Cernaia 1;
(6) Angelo Novati, residing in Rome (Italy), Via Denza;
(7) Carlo Pappalettera, residing in Milan (Italy), Via Archimede 4;
(8) Alessandro Triscornia, residing in Milan (Italy), Via Mangili 3;
(9) Francesco Stella, residing in Milan (Italy), Via Santa Margherita 32;
(10) Carisma S.p.A., a company incorporated and organized under the laws of Italy, having its registered office in Milan

(Italy), Via Crocefisso 10;

(11) Paolo Giuri, residing in Neuilly-sur-Seine 92521 (France), 27, avenue Charles de Gaulles;
(12) Luigi Langella, residing in Milan (Italy), Via Ippodromo 76;
(13) Giovanni Caporello, residing in Turin (Italy), 379 Corso Moncalieri.
Ordinary C shares:
- For 1,696,156,095
- Against
- Abstention
Non voting preference C1 shares:
- For 1,406,383,102
- Against
- Abstention

41930

Non voting preference C2 shares:
- For 19,299,069
- Against
- Abstention

<i>Second resolution

As a result of the preceding resolution, it is resolved to amend the first paragraph of the article 5.1 of the Company's

articles of incorporation which shall read as follows:

Art. 5.1. The issued capital is set at sixty million seven hundred eighteen thousand two hundred eighty-nine Euro and

ninety cents (€60,718,289.90) divided into

(i) 3,298,944,043 ordinary C shares (the "ordinary shares");
(ii) 2,735,349,164 non voting preference C1 shares (the "C1 shares"), and
(iii) 37,535,783 non voting preference C2 shares (the "C2 shares" and together with the C1 shares, the "non voting

preference shares"), with a nominal value of one Euro cent (€0.01) per share (the ordinary shares and the non voting
preference shares being together referred to as the "shares" and the holders thereof as the "shareholders", unless the
context otherwise requests)."

Ordinary C shares:
- For 1,696,156,095
- Against
- Abstention
Non voting preference C1 shares:
- For 1,406,383,102
- Against
- Abstention
Non voting preference C2 shares:
- For 19,299,069
- Against
- Abstention
Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at € 7,000,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six avril.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Sterling Holdings S.A. (la "Société"), une société

anonyme ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous la mention B 104.775, constituée sous la forme d'une société anonyme suivant
acte reçu de Me Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 15 décembre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéros 1308 et 1309 du 22 décembre 2004. Les statuts de la
Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg
en date du 2 mars 2009, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par Mme Emanuela Brero, administrateur, demeurant à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Mme Stella Le Cras, employée privée, demeurant à Luxembourg. L'assemblée

a élu comme scrutateur Me Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence

signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

41931

Ladite liste de présence ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l'enregistrement.

II. L'assemblée générale extraordinaire a été valablement convoquée par des avis de convocation envoyés par lettre

recommandée en date du 27 mars 2009.

III. Il ressort de ladite liste de présence que sur les 1.696.156.095 actions ordinaires C, 1.406.383.102 actions privilégiées

sans  droit  de  vote  C1  et  19.299.069  actions  privilégiées  sans  droit  de  vote  C2,  1.696.156.095  actions  ordinaires  C,
1.406.383.102 actions privilégiées sans droit de vote C1 et 19.299.069 actions privilégiées sans droit de vote C2 sont
représentées à la présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous:

1. Augmentation du capital social émis de la Société de trente et un millions deux cent dix-huit mille trois cent quatre-

vingt-deux Euros et soixante-six cents (€31.218.382,66) à soixante millions sept cent dix-huit mille deux cent quatre-
vingt-neuf Euros et quatre-vingt-dix cents (€60.718.289,90) par l'émission de (i) un milliard six cent deux millions sept
cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quarante-huit (1.602.787.948) actions ordinaires C additionnelles, (ii) un milliard
trois cent vingt-huit millions neuf cent soixante-six mille soixante-deux (1.328.966.062) actions privilégiées sans droit de
vote C1 additionnelles et (iii) dix-huit millions deux cent trente-six mille sept cent quatorze (18.236.714) actions privi-
légiées sans droit de vote C2 additionnelles, ayant chacune une valeur nominale et un prix de souscription d'un centime
d'Euro (€0,01); souscription aux nouvelles actions par les actionnaires existants de la Société et paiement intégral par un
apport en numéraire à la Société; émission des nouvelles actions.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5.1 des statuts.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de trente et un millions deux cent dix-huit mille trois cent

quatre-vingt-deux Euros et soixante-six cents (€31.218.382,66) à soixante millions sept cent dix-huit mille deux cent
quatre-vingt-neuf Euros et quatre-vingt-dix cents (€60.718.289,90) par l'émission de (i) un milliard six cent deux millions
sept cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quarante-huit (1.602.787.948) actions ordinaires C additionnelles, (ii) un mil-
liard trois cent vingt-huit millions neuf cent soixante-six mille soixante-deux (1.328.966.062) actions privilégiées sans droit
de vote C1 additionnelles et (iii) dix-huit millions deux cent trente-six mille sept cent quatorze (18.236.714) actions
privilégiées sans droit de vote C2 additionnelles, ayant chacune une valeur nominale et un prix de souscription d'un
centime d'Euro (€0,01) qui seront souscrites et entièrement libérées en numéraire tel que décrit dans le tableau ci-
dessous.

Les nouvelles actions mentionnées ci-dessus ont été souscrites et entièrement libérées de la manière suivante:

Souscripteur

Nombre et classe d'actions souscrites

Prix de

souscription (€)

1. CVC Silver Nominee Limited . . . . . . .

1,602,787,948 actions ordinaires C

16.027,879,48

1.328.966.062 actions privilégiées sans droit de vote C1

13.289.660,62

3.073.192 actions privilégiées sans droit de vote C2

30.731,92

2. M. Paolo Gonano . . . . . . . . . . . . . . . .

750.333 actions privilégiées sans droit de vote C2

7.503,33

3. M. Giacomo Casassa . . . . . . . . . . . . .

750.333 actions privilégiées sans droit de vote C2

7.503,33

4. Mme Maurizia Squinzi . . . . . . . . . . . . .

301.519 actions privilégiées sans droit de vote C2

3.015,19

5. Mme Rita d'Uva . . . . . . . . . . . . . . . . .

301.519 actions privilégiées sans droit de vote C2

3.015,19

6. M. Angelo Novati . . . . . . . . . . . . . . . .

615.711 actions privilégiées sans droit de vote C2

6.157,11

7. M. Carlo Pappalettera . . . . . . . . . . . .

767.554 actions privilégiées sans droit de vote C2

7.675,54

8. M. Alessandro Triscornia . . . . . . . . . .

767.554 actions privilégiées sans droit de vote C2

7.675,54

9. M. Francesco Stella . . . . . . . . . . . . . . .

230.424 actions privilégiées sans droit de vote C2

2.304,24

10. Carisma S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.216.560 actions privilégiées sans droit de vote C2

92.165,60

11. Mr Paolo Giuri . . . . . . . . . . . . . . . . .

531.646 actions privilégiées sans droit de vote C2

5.316,46

12. M. Luigi Langella . . . . . . . . . . . . . . . .

531.646 actions privilégiées sans droit de vote C2

5.316,46

13. M. Giovanni Caporello . . . . . . . . . . .

398.723 actions privilégiées sans droit de vote C2

3.987,23

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.602.787.948 actions ordinaires C

16.027.879,48

1.328.966.062 actions privilégiées sans droit de vote C1

13.289.660,62

18.236.714 actions privilégiées sans droit de vote C2

182.367,14

(1) CVC Silver Nominee Limited, une société constituée et existant sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège

social au 10 Upper Bank Street, Londres E14 5JJ,

(2) Paolo Gonano, demeurant à Gênes (Italie), Via Gaetano Colombo, 20 Interno 10;
(3) Giacomo Casassa, demeurant à Turin (Italie), Via Fossati 20/B, 18, 10138;
(4) Maurizia Squinzi, demeurant à Trezzanno S/N, Milan 20 090 (Italie), Via Ugo Bassi 21;

41932

(5) Rita d'Uva, demeurant à Turin (Italie), Via Cernaia 1;
(6) Angelo Novati, demeurant à Rome (Italie), Via Denza;
(7) Carlo Pappalettera, demeurant à Milan (Italie), Via Archimede 4;
(8) Alessandro Triscornia, demeurant à Milan (Italie), Via Mangili 3;
(9) Francesco Stella, demeurant à Milan (Italie), Via Santa Margherita 32;
(10) Carisma S.p.A., une société constituée et organisée sous les lois d'Italie, ayant son siège social à Milan (Italie), Via

Crocefisso 10;

(11) Paolo Giuri, demeurant à Neuilly-sur-Seine 92521 (France), 27, avenue Charles de Gaulles;
(12) Luigi Langella, demeurant à Milan (Italie), Via Ippodromo 76;
(13) Giovanni Caporello, demeurant à Turin (Italie), 379 Corso Moncalieri.
Actions ordinaires C:
- Pour 1.696.156.095
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées sans droit de vote C1:
- Pour 1.406.383.102
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées sans droit de vote C2:
- Pour 19.299.069
- Contre
- Abstention

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5.1 des statuts

afin qu'il ait la teneur suivante:

Art. 5.1. Le capital émis est fixé à soixante millions sept cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-neuf Euros et

quatre-vingt-dix cents (€60.718.289,90) divisé en

(i) 3.298.944.043 actions ordinaires C (les "actions ordinaires");
(ii) 2.735.349.164 actions privilégiées sans droit de vote C1 (les "actions C1"), et
(iii) 37.535.783 actions privilégiées sans droit de vote C2 (les "actions C2" et ensemble avec les actions C1, les "actions

privilégiées sans droit de vote"), ayant une valeur nominale d'un centime d'Euros (€0,01) par action (les actions ordinaires
et les actions privilégiées sans droit de vote étant ensemble désignées les "actions" et leurs détenteurs les "actionnaires",
à moins que le contexte ne le prévoit autrement)."

Actions ordinaires C:
- Pour 1.696.156.095
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées sans droit de vote C1:
- Pour 1.406.383.102
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées sans droit de vote C2:
- Pour 19.299.069
- Contre
- Abstention
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Coûts et Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à € 7.000,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties compa-
rantes, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

41933

Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: E. Brero, S. Le Cras, K. Panichi, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 07 avril 2009. Relation: EAC/2009/4080. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009047818/272/259.
(090056795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

Allianz Global Strategy Dynamic, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Allianz Global Strategy Dynamic wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im März 2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009047012/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2009, réf. LSO-DC06994. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090046736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2009.

PG Silver B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 145.180.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of April.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of PG Silver B S.A. (the "Company"), a société anonyme

having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, registered with the Trade and
Companies Register of Luxembourg under the number B 145.180, incorporated as a société anonyme by deed of the
undersigned notary, on 10 

th

 March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 23

rd

 March 2009 number 622.

The meeting was presided over by M 

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Valentina Dadda, director, residing in Luxembourg. The meeting elected as

scrutineer Mr Seiji Amino, private employee, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,

signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. The extraordinary general meeting was duly convened by notices sent by registered mail on 27 

th

 March 2009.

III. It appears from the attendance list that out of the 143,723,979 ordinary D shares, 119,435,198 non voting preference

D1  shares  and  1,639,783  non  voting  preference  D2  shares,  143,723,979  ordinary  D  shares,  119,435,198  non  voting
preference D1 shares and 1,639,783 non voting preference D2 shares are represented at the present meeting so that
the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

IV. The items on which resolution are to be passed are as follows:
1. Authorisation to the board of directors of the Company to issue up to eight hundred and six million sixty-six

thousand nine hundred and nineteen (806,066,919) subordinated redeemable zero coupon convertible bonds having
similar terms and conditions as redeemable convertible bonds issued by the Company in the past.

2. Creation of an authorised share capital of the Company of eight million sixty thousand six hundred sixty-nine Euro

and nineteen cents (€8,060,669.19) comprising eight hundred and six million sixty-six thousand nine hundred and nineteen
(806,066,919) shares each with a nominal value of one Euro cent (€0.01) each which shall be reserved for the conversion
of eight hundred and six million sixty-six thousand nine hundred nineteen (806,066,919) subordinated redeemable zero
coupon convertible bonds; the board of directors of the Company is duly authorised to decide the class of shares to be
issued upon conversion of the subordinated redeemable zero coupon convertible bonds; and acknowledgement and
approval of the report of the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the law of

41934

10 

th

 August 1915 on commercial companies (as amended) (the "Law") concerning the price, if any, at which the shares

may be issued, such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of the existing share-
holders.

3. Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation by creating a new article 5.2;
4. Acknowledgement of the resignation of (i) Mr Pierre Stemper, Mrs Christelle Rétif, Mr Michael Andrew Twinning

and Mrs Josephine Pallett as directors of the Company with effect as from the 27 

th

 March 2009 and (ii) Mr Naim Gjonaj

as director of the Company with effect as from the 6 

th

 April 2009. Confirmation of the appointment of Mr Francesco

Moglia and Mrs Valentina Dadda, as directors of the Company with effect as from 27 

th

 March 2009 and appointment of

Mr Seiji Amino as director of the Company with effect as from 6 

th

 April 2009 for a period ending on the annual general

meeting of the shareholders to be held in 2010 for the approval of the annual accounts of the financial year 2009. The-
reafter, the following resolutions were passed:

<i>First resolution

It is resolved to authorise the board of directors of the Company to issue up to eight hundred and six million sixty-

six thousand nine hundred nineteen (806,066,919) subordinated redeemable zero coupon convertible bonds having similar
terms and conditions as redeemable convertible bonds issued by the Company in the past.

Ordinary D shares:
- For 143,723,979
- Against
- Abstention
Non voting preference D1 shares:
- For 119,435,198
- Against
- Abstention
Non voting preference D2 shares:
- For 1,639,783
- Against
- Abstention

<i>Second resolution

It is resolved to approve the creation of an authorised share capital of the Company of eight million sixty thousand

six  hundred  sixty-nine  Euro  and  nineteen  cents  (€8,060,669.19)  consisting  of  eight  hundred  and  six  million  sixty-six
thousand nine hundred and nineteen (806,066,919) shares each with a nominal value of one Euro cent (€0.01) which shall
be reserved for the conversion of eight hundred and six million sixty-six thousand nine hundred nineteen (806,066,919)
subordinated redeemable zero coupon convertible bonds and to authorise the board of directors of the Company to
decide the class of shares to be issued upon conversion of the subordinated redeemable zero coupon convertible bonds.

As regards said creation of the authorised share capital of the Company, the meeting acknowledged and approved a

report by the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the Law concerning the
price, if any, at which the shares of the Company might be issued to the extent such issues were being made without
reserving any preferential subscription rights of the shareholders. It is resolved that such report complied with said article
32-3(5).

Ordinary D shares:
- For 143,723,979
- Against
- Abstention
Non voting preference D1 shares:
- For 119,435,198
- Against
- Abstention
Non voting preference D2 shares:
- For 1,639,783
- Against
- Abstention

<i>Third resolution

As a result of the preceding resolution, it is resolved to amend article 5 of the Company's articles of incorporation by

creating a new article 5.2 which shall read as follows:

41935

Art. 5.2. The authorised unissued capital is set at eight million sixty thousand six hundred and sixty-nine Euro and

nineteen cents (€8,060,669.19) consisting of eight hundred and six million sixty-six thousand nine hundred and nineteen
(806,069,919) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01) per share which shall be reserved for the conversion
of eight hundred and six million sixty-six thousand nine hundred and nineteen (806,066,919) subordinated redeemable
zero coupon convertible bonds. The board of directors shall have the right, when issuing shares out of the authorised
share capital to decide whether the shares to be issued will be ordinary D shares, non voting preference D1 shares or
non voting preference D2 shares.

Any authorised but unissued shares shall lapse (5) five years after publication in the Memorial of the notarial deed

recording the shareholder's resolution on the authorised capital.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of shares contemplated in the authorised capital.

Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash shall be offered on a pre-emptive

basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exercised
within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date of the
subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable throughout
the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability other than those applicable to the
shares in respect of which the right arises.

Subject to the preceding paragraphs, the board of directors or delegate(s) duly appointed by the board may from time

to time issue shares out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including issue
price, as the board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

In case of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of any

shares shall be entitled to pre-emptive rights with respect to shares to be issued, unless waived by the general meeting
of shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the

board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments."

Ordinary D shares:
- For 143,723,979
- Against
- Abstention
Non voting preference D1 shares:
- For 119,435,198
- Against
- Abstention
Non voting preference D2 shares:
- For 1,639,783
- Against
- Abstention

<i>Fourth resolution

It is  resolved  to acknowledge the  resignation  of  (i)  Mr  Pierre Stemper,  Mrs Christelle  Rétif, Mr Michael Andrew

Twinning and Mrs Josephine Pallett as directors of the Company with effect as from the 27 

th

 March 2009 and (ii) Mr

Naim Gjonaj as director of the Company with effect as from the 6 

th

 April 2009. The meeting noted the cooptation of

Mr Francesco Moglia and Mrs Valentina Dadda, and consequently resolved to confirm the appointment of Mr Francesco
Moglia and Mrs Valentina Dadda as directors of the Company with effect as from 27 

th

 March 2009 and to appoint Mr

Seiji Amino as director of the Company with effect as from 6 

th

 April 2009 all of them for a period ending on the annual

general meeting of the shareholders to be held in 2010 for the approval of the annual accounts of the financial year 2009.

Ordinary D shares:
- For 143,723,979
- Against
- Abstention
Non voting preference D1 shares:
- For 119,435,198
- Against
- Abstention
Non voting preference D2 shares:
- For 1,639,783

41936

- Against
- Abstention
Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at € 1,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six avril.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PG Silver B S.A. (la "Société"), une société anonyme

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la mention B 145.180, constituée sous la forme d'une société anonyme
suivant acte reçu du notaire soussigné, en date du 10 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le "Mémorial") numéro 622 du 23 mars 2009.

L'assemblée a été présidée par M 

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire Mme Valentina Dadda, administrateur, demeurant à Luxembourg. L'assem-

blée a élu comme scrutateur M. Seiji Amino, administrateur, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence

signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l'enregistrement.

II. L'assemblée générale extraordinaire a été valablement convoquée par des avis de convocation envoyés par lettre

recommandée en date du 27 mars 2009.

III. Il ressort de ladite liste de présence que sur les 143.723.979 actions ordinaires D, 119.435.198 actions privilégiées

sans  droit  de  vote  D1  et  1.639.783  actions  privilégiées  sans  droit  de  vote  D2,  143.723.979  actions  ordinaires  D,
119.435.198  actions  privilégiées  sans  droit  de  vote  D1  et  1.639.783  actions  privilégiées  sans  droit  de  vote  D2  sont
représentées à la présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous:

1. Autorisation au conseil d'administration de la Société d'émettre un maximum de huit cent six millions soixante-six

mille neuf cent dix-neuf (806.066.919) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro ayant les mêmes
termes et conditions que les obligations convertibles rachetables émises dans le passé par la Société.

2. Création d'un capital social autorisé de la Société de huit millions soixante mille six cent soixante-neuf Euros et dix-

neuf cents (€8.060.669,19) consistant en huit cent six millions soixante-six mille neuf cent dix-neuf (806.066.919) actions
ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01), lesquelles sont réservées pour la conversion de huit
cent six millions soixante-six mille neuf cent dix-neuf (806.066.919) obligations convertibles subordonnées rachetables à
coupon zéro; le conseil d'administration de la Société est dûment autorisé à décider de la classe d'actions devant être
émise au moment de la conversion des obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro; et constat et
approbation du rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la "Loi") en ce qui concerne le prix, le cas échéant, auquel
les actions peuvent être émises, ces émissions étant faites sans réserver de droits de souscription préférentiels aux
actionnaires existants.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts en créant un nouvel article 5.2.
4. Constat de la démission de (i) M. Pierre Stemper, Mme Christelle Rétif, M. Michael Andrew Twinning et Mme

Josephine Pallett de leurs fonctions d'administrateurs de la Société avec effet au 27 mars 2009 et (ii) M. Naim Gjonaj de
ses fonctions d'administrateur avec effet au 6 avril 2009. Confirmation de la nomination de M. Francesco Moglia et Mme
Valentina Dadda, aux fonctions d'administrateurs de la Société avec effet au 27 mars 2009 et nomination de M. Seiji Amino
aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 6 avril 2009 pour une durée se terminant lors l'assemblée
générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2010 pour l'approbation des comptes annuels de l'exercice social
2009.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées:

41937

<i>Première résolution

Il est décidé d'autoriser le conseil d'administration de la Société d'émettre un maximum de huit cent six millions

soixante-six mille neuf cent dix-neuf (806.066.919) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro
ayant les mêmes termes et conditions que les obligations convertibles rachetables émises dans le passé par la Société.

Actions ordinaires D:
- Pour 143.723.979
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote D1:
- Pour 119.435.198
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote D2:
- Pour 1.639.783
- Contre
- Abstention

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'approuver la création d'un capital social autorisé de la Société de huit millions soixante mille six cent

soixante-neuf Euros et dix-neuf cents (€8.060.669,19) consistant en huit cent six millions soixante-six mille neuf cent dix-
neuf (806.066.919) actions ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01), lesquelles sont réservées
pour la conversion de huit cent six millions soixante-six mille neuf cent dix-neuf (806.066.919) obligations convertibles
subordonnées rachetables à coupon zéro, et d'autoriser le conseil d'administration de la Société à décider de la classe
d'actions devant être émise au moment de la conversion des obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon
zéro.

En relation avec la création du capital social autorisé de la Société qui précède, l'assemblée a constaté et approuvé un

rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3(5) de la Loi relatif au prix, le cas
échéant, auquel les actions pourraient être émises dans la mesure où ces émissions étaient faites sans réserver de droits
de souscription préférentiels aux actionnaires existants.

Il est décidé que ce rapport est conforme audit article 32-3(5).
Actions ordinaires D:
- Pour 143.723.979
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote D1:
- Pour 119.435.198
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote D2:
- Pour 1.639.783
- Contre
- Abstention

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société en créant

un nouvel article 5.2 qui aura la teneur suivante:

Art. 5.2. Le capital autorisé mais non émis est fixé à huit millions soixante mille six cent soixante-neuf Euros et dix-

neuf cents (€8.060.669,19) consistant en huit cent six millions soixante-six mille neuf cent dix-neuf (806.066.919) actions
ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01) par action, lesquelles seront réservées pour la conversion de huit
cent six millions soixante-six mille neuf cent dix-neuf (806.066.919) obligations convertibles subordonnées rachetables à
coupon zéro. Le conseil d'administration aura le droit, au moment de l'émission d'actions dans les limites du capital social
autorisé, de décider si les actions devant être émises seront des actions ordinaires D, des actions privilégiées sans droit
de vote D1 ou des actions privilégiées sans droit de vote D2.

Toute action autorisée mais non émise expirera cinq (5) ans après la publication dans le Mémorial de l'acte notarié

prenant acte de la résolution des actionnaires portant sur le capital autorisé.

41938

Afin  d'éviter  tout  doute,  les  actionnaires  renoncent  expressément  à  tout  droit  de  souscription  préférentiel  qu'ils

pourraient avoir en relation avec les émissions d'actions prévues dans les limites du capital autorisé.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions devant être souscrites en espèces seront offertes aux action-

naires sur une base préemptive au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription peut être
exercé pendant une période déterminée par le conseil d'administration, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à
compter de la date de la période de souscription, laquelle sera notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscription
peut être cédé pendant la période de souscription, et aucune restriction ne pourra être imposée sur cette cession autre
que les restrictions applicables aux actions qui bénéficient de ce droit.

Sous réserve des paragraphes précédents, le conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) dûment désigné(s) par le

conseil peut de temps à autre émettre des actions dans les limites de la totalité des actions autorisées aux dates et selon
les termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le conseil ou son(ses) délégué(s) pourra(ont) déterminer à sa
(leur) discrétion.

Dans l'hypothèse d'un capital autorisé additionnel et/ou d'un renouvellement subséquent du capital autorisé, les dé-

tenteurs d'actions pourront bénéficier de droits de préemption en relation avec les actions à émettre, à moins que
l'assemblée générale des actionnaires ait renoncé à ces droits de préemption.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera enregistrée dans un acte notarié, à la demande

du conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) sur présentation des documents établissant les souscriptions et les
paiements."

Actions ordinaires D:
- Pour 143.723.979
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote D1:
- Pour 119.435.198
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote D2:
- Pour 1.639.783
- Contre
- Abstention

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de constater la démission de (i) M. Pierre Stemper, Mme Christelle Rétif, M. Michael Andrew Twinning

et Mme Josephine Pallett de leurs fonctions d'administrateurs de la Société avec effet au 27 mars 2009 et (ii) M. Nairn
Gjonaj de ses fonctions d'administrateur avec effet au 6 avril 2009.

L'assemblée a pris note de la cooptation de M. Francesco Moglia et Mme Valentina Dadda et a décidé en conséquence

de confirmer la nomination de M. Francesco Moglia et Mme Valentina Dadda, aux fonctions d'administrateurs de la Société
avec effet au 27 mars 2009 et de nommer M. Seiji Amino aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 6 avril
2009 pour une durée se terminant lors l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2010 pour l'ap-
probation des comptes annuels de l'exercice social 2009.

Actions ordinaires D:
- Pour 143.723.979
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote D1:
- Pour 119.435.198
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote D2:
- Pour 1.639.783
- Contre
- Abstention
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Coûts et Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à € 1.500,-.

41939

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties compa-
rantes, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: K. Panichi, V. Dadda, S. Amino, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 07 avril 2009. Relation: EAC/2009/4075. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009047828/272/321.
(090056859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

Allianz Global Strategy Defensive, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Allianz Global Strategy Defensive wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im März 2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009047015/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06971. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090046733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2009.

Silcart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 104.777.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of April.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Silcart S.A. (the "Company"), a société anonyme having

its registered office in L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, registered with the Trade and Companies Register of
Luxembourg under the number B 104.777, incorporated as a société anonyme by deed of M 

e

 Henri Hellinckx, notary

residing at the time in Mersch, on 15 

th

 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

(the "Mémorial"), n° 1308 and 1309 on 22 

nd

 December 2004. The articles of incorporation of the Company have been

amended for the last time by deed of the undersigned on 23rd March 2009, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided over by M 

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary M 

e

 Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing in Luxembourg. The

meeting elected as scrutineer Mr Eddy Perrier, private employee, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,

signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This list as well as
the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. The extraordinary general meeting was duly convened by notices sent by registered mail on 27 March 2009.
III. It appears from the attendance list that out of the 590,400,519 ordinary E shares, 439,467,436 non voting preference

E1 shares and 9,865,809 non voting preference E2 shares, 590,400,519 ordinary E shares, 439,467,436 non voting pre-
ference E1 shares and 9.865,809 non voting preference E2 shares are represented at the present meeting so that the
present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Authorisation to the board of directors of the Company to issue up to 1,705,992,963 redeemable convertible bonds

having similar terms and conditions as redeemable convertible bonds issued by the Company in the past.

2. Creation of an authorised share capital of the Company of seventeen million fifty-nine thousand nine hundred and

twenty-nine Euro and sixty-three cents (€17,059,929.63) consisting of one billion seven hundred and five million nine
hundred and ninety-two thousand nine hundred and sixty-three (1,705,992,963) shares each with a nominal value of one

41940

Euro cent (€0.01) which shall be reserved for the conversion of one billion seven hundred and five million nine hundred
and ninety-two thousand nine hundred and sixty-three (1,705,992,963) subordinated redeemable zero coupon convertible
bonds; the board of directors of the Company is duly authorised to decide the class of shares to be issued upon conversion
of the subordinated redeemable zero coupon convertible bonds; and acknowledgement and approval of the report of
the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915 on
commercial companies (as amended) (the "Law") concerning the price, if any, at which the shares may be issued, such
issues are being made without reserving any preferential subscription rights of the existing shareholders.

3. Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation by creating a new article 5.2.
Thereafter, the following resolutions were passed:

<i>First resolution

It Is resolved to authorise the board of directors of the Company to issue up to one billion seven hundred and five

million nine hundred and ninety-two thousand nine hundred and sixty-three (1,705,992,963) redeemable convertible
bonds having similar terms and conditions as redeemable convertible bonds issued by the Company in the past.

Ordinary E shares:
- For 590,400,519
- Against
- Abstention
Non voting preference E1 shares:
- For 439,467,436
- Against
- Abstention
Non voting preference E2 shares:
- For 9,865,809
- Against
- Abstention

<i>Second resolution

It is resolved to approve the creation of an authorised share capital of the Company of seventeen million fifty-nine

thousand nine thousand nine hundred and twenty-nine Euro and sixty-three cents (€17,059,929.63) consisting of one
billion seven hundred and five million nine hundred and ninety-two thousand nine hundred and sixty-three (1,705,992,963)
shares each with a nominal value of one Euro cent (€0.01) which shall be reserved for the conversion of one billion seven
hundred and five million nine hundred and ninety-two thousand nine hundred and sixty-three (1,705,992,963) subordi-
nated redeemable zero coupon convertible bonds and to authorise the board of directors of the Company to decide the
class of shares to be issued upon conversion of the subordinated redeemable zero coupon convertible bonds.

As regards said creation of the authorised share capital of the Company, the meeting acknowledged and approved a

report by the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the Law concerning the
price, if any, at which the shares of the Company might be issued to the extent such issues were being made without
reserving any preferential subscription rights of the shareholders.

It is resolved that such report complied with said article 32-3(5).
Ordinary E shares:
- For 590,400,519
- Against
- Abstention
Non voting preference E1 shares:
- For 439,467,436
- Against
- Abstention
Non voting preference E2 shares:
- For 9,865,809
- Against
- Abstention

<i>Third resolution

As a result of the preceding resolution, it is resolved to amend article 5 of the Company's articles of incorporation by

creating a new article 5.2 which shall read as follows:

41941

Art. 5.2. The authorised capital is set at seventeen million fifty-nine thousand nine hundred and twenty-nine Euro

and sixty-three cents (€17,059,929.63) consisting of one billion seven hundred and five million nine hundred and ninety-
two thousand nine hundred and sixty-three (1,705,992,963) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01) per
share which shall be reserved for the conversion of one billion seven hundred and five million nine hundred and ninety-
two thousand nine hundred and sixty-three (1,705,992,963) subordinated redeemable zero coupon convertible bonds.
The board of directors shall have the right, when issuing shares out of the authorised share capital to decide whether
the shares to be issued will be ordinary E shares, non voting preference E1 shares or non voting preference E2 shares.

Any authorised but unissued shares shall lapse (5) five years after publication in the Memorial of the notarial deed

recording the shareholder's resolution on the authorised capital.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of shares contemplated in the authorised capital.

Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash shall be offered on a pre-emptive

basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exercised
within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date of the
subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable throughout
the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability other than those applicable to the
shares in respect of which the right arises. Subject to the preceding paragraphs, the board of directors or delegate(s) duly
appointed by the board may from time to time issue shares out of the total authorised shares at such times and on such
terms and conditions, including issue price, as the board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve. In case
of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of any shares shall
be entitled to pre-emptive rights with respect to shares to be issued, unless waived by the general meeting of shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the

board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments".

Ordinary E shares:
- For 590,400,519
- Against
- Abstention
Non voting preference E1 shares:
- For 439,467,436
- Against
- Abstention
Non voting preference E2 shares:
- For 9,865,809
- Against
- Abstention
Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at € 1,500,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentionned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six avril.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Silcart S.A. (la "Société"), une société anonyme

ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la mention B 104.777, constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte
reçu de Me Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 15 décembre 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéros 1308 et 1309 du 22 décembre 2004. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire soussigné en date du 23 mars 2009, non encore publié
au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par M 

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

41942

Le président a nommé comme secrétaire M 

e

 Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur M. Eddy Perrier, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence

signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l'enregistrement.

II. L'assemblée générale extraordinaire a été valablement convoquée par des avis de convocation envoyés par lettre

recommandée en date du 27 mars 2009.

III. Il ressort de ladite liste de présence que sur les 590.400.519 actions ordinaires E, 439.467.436 actions privilégiées

sans droit de vote E1 et 9.865.809 actions privilégiées sans droit de vote E2, 590.400.519 actions ordinaires E, 439.467.436
actions privilégiées sans droit de vote E1 et 9.865.809 actions privilégiées sans droit de vote E2 sont représentées à la
présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
l'ordre du jour ci-dessous:

1. Autorisation au conseil d'administration de la Société d'émettre un maximum d'un milliard sept cent cinq millions

neuf cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-trois (1.705.992.963) obligations convertibles rachetables ayant les
mêmes termes et conditions que les obligations convertibles rachetables émises dans le passé par la Société.

2. Création d'un capital social autorisé de la Société de dix-sept millions cinquante-neuf mille neuf cent vingt-neuf Euros

et soixante-trois cents (€17.059.929,63) consistant en un milliard sept cent cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze
mille neuf cent soixante-trois (1.705.992.963) actions ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01),
lesquelles sont réservées pour la conversion d'un milliard sept cent cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze mille neuf
cent soixante-trois (1.705.992.963) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro; le conseil d'admi-
nistration de la Société est dûment autorisé à décider de la classe d'actions devant être émise au moment de la conversion
des obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro; et constat et approbation du rapport du conseil
d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales (telle que modifiée) (la "Loi") en ce qui concerne le prix, le cas échéant, auquel les actions peuvent être émises, ces
émissions étant faites sans réserver de droits de souscription préférentiels aux actionnaires existants. 3. Modification
conséquente de l'article 5 des statuts en créant un nouvel article 5.2.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé d'autoriser le conseil d'administration de la Société d'émettre un maximum d'un milliard sept cent cinq

millions neuf cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-trois (1.705.992.963) obligations convertibles rachetables
ayant les mêmes termes et conditions que les obligations convertibles rachetables émises dans le passé par la Société.

Actions ordinaires E:
- Pour 590.400.519
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote E1:
- Pour 439.467.436
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote E2:
- Pour 9.865.809
- Contre
- Abstention

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'approuver la création d'un capital social autorisé de la Société de dix-sept millions cinquante-neuf mille

neuf cent vingt-neuf Euros et soixante-trois cents (€17.059.929,63) consistant en un milliard sept cent cinq millions neuf
cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-trois (1.705.992.963) actions ayant chacune une valeur nominale d'un
centime d'Euro (€0,01), lesquelles sont réservées pour la conversion d'un milliard sept cent cinq millions neuf cent quatre-
vingt-douze mille neuf cent soixante-trois (1.705.992.963) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon
zéro, et d'autoriser le conseil d'administration de la Société à décider de la classe d'actions devant être émise au moment
de la conversion des obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro.

En relation avec la création du capital social autorisé de la Société qui précède, l'assemblée a constaté et approuvé un

rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3(5) de la Loi relative au prix, le cas

41943

échéant, auquel les actions pourraient être émises dans la mesure où ces émissions étaient faites sans réserver de droits
de souscription préférentiels aux actionnaires existants.

Il est décidé que ce rapport est conforme audit article 32-3(5).
Actions ordinaires E:
- Pour 590.400.519
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote E1:
- Pour 439.467.436
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote E2:
- Pour 9.865.809
- Contre
- Abstention

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société en créant

un nouvel article 5.2 qui aura la teneur suivante:

Art. 5.2. Le capital autorisé mais non émis est fixé à dix-sept millions cinquante-neuf mille neuf cent vingt-neuf Euros

et soixante-trois cents (€17.059.929,63) consistant en un milliard sept cent cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze
mille neuf cent soixante-trois (1.705.992.963) actions ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01) par action,
lesquelles seront réservées pour la conversion d'un milliard sept cent cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze mille
neuf cent soixante-trois (1.705.992.963) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro. Le conseil
d'administration aura le droit, au moment de l'émission d'actions dans les limites du capital social autorisé, de décider si
les actions devant être émises seront des actions ordinaires E, des actions privilégiées sans droit de vote E1 ou des actions
privilégiées sans droit de vote E2.

Toute action autorisée mais non émise expirera cinq (5) ans après la publication dans le Mémorial de l'acte notarié

prenant acte de la résolution des actionnaires portant sur le capital autorisé.

Afin  d'éviter  tout  doute,  les  actionnaires  renoncent  expressément  à  tout  droit  de  souscription  préférentiel  qu'ils

pourraient avoir en relation avec les émissions d'actions prévues dans les limites du capital autorisé.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions devant être souscrites en espèces seront offertes aux action-

naires sur une base préemptive au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription peut être
exercé pendant une période déterminée par le conseil d'administration, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à
compter de la date de la période de souscription, laquelle sera notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscription
peut être cédé pendant la période de souscription, et aucune restriction ne pourra être imposée sur cette cession autre
que les restrictions applicables aux actions qui bénéficient de ce droit.

Sous réserve des paragraphes précédents, le conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) dûment désigné(s) par le

conseil peut de temps à autre émettre des actions dans les limites de la totalité des actions autorisées aux dates et selon
les termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le conseil ou son(ses) délégué(s) pourra(ont) déterminer à sa
(leur) discrétion.

Dans l'hypothèse d'un capital autorisé additionnel et/ou d'un renouvellement subséquent du capital autorisé, les dé-

tenteurs d'actions pourront bénéficier de droits de préemption en relation avec les actions à émettre, à moins que
l'assemblée générale des actionnaires ait renoncé à ces droits de préemption.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera enregistrée dans un acte notarié, à la demande

du conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) sur présentation des documents établissant les souscriptions et les
paiements."

Actions ordinaires E:
- Pour 590.400.519
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote E1:
- Pour 439.467.436
- Contre
- Abstention
Actions privilégiées dans droit de vote E2:

41944

- Pour 9.865.809
- Contre
- Abstention
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Coûts et Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à € 1.500.-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties compa-
rantes, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: K. Panichi, A. Hermelinski-Ayache, E. Perrier, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 07 avril 2009. Relation: EAC/2009/4082. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009047814/272/268.
(090056776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

WM Fund, Fonds Commun de Placement.

Das  Sondervermögen  WM  Fund  wurde  von  der Hauck  &amp; Aufhäuser  Investment Gesellschaft  S.A. nach  Teil I des

Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die
Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. De-
zember 1985.

Für den WM Fund ist das allgemeine Verwaltungsreglement, das am 1. August 2008 in Kraft trat, integraler Bestandteil.

Dieses allgemeine Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxembourg hinterlegt, und
der diesbezügliche Hinterlegungsvermerk wurde am 29. August 2008 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
veröffentlicht.

Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des Sonderreglements des WM Fund, das am 23. März 2009 in

Kraft tritt und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Luxemburg, den 23. März 2009.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009047018/1346/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2009, réf. LSO-DC07963. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090048080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2009.

AI Silver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.776.

In the year two thousand and nine, on the sixth day of April.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of AI Silver S.A. (the "Company"), a société anonyme

having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, registered with the Trade and
Companies Register of Luxembourg under the number B 104.776, incorporated as a société anonyme by deed of M 

e

Henri Hellinckx, notary residing at the time in Mersch, on 15 

th

 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), n° 1308 and 1309 on 22 

nd

 December 2004. The articles of incorporation

of the Company have been amended for the last time by deed of the M 

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg

on 2 

nd

 March 2009, not published yet in the Mémorial.

41945

The meeting was presided over by M 

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Valentina Dadda, private employee, residing in Luxembourg. The meeting

elected as scrutineer Mr Seiji Amino, director, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,

signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. The extraordinary general meeting was duly convened by notices sent by registered mail on 27 

th

 March 2009.

III. It appears from the attendance list that out of the 318,165,479 ordinary A shares, the 263,807,426 non voting

preference B1 shares and the 3,619,497 non voting preference B2 shares, 318,165,479 ordinary A shares, 263,807,426
non voting preference B1 shares and 3,619,497 non voting preference B2 shares are represented at the present meeting
so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Authorisation to the board of directors of the Company to issue up to six hundred and seventy-three million eight

hundred and three thousand nine hundred and twenty-six (673,803,926) subordinated redeemable zero coupon conver-
tible bonds having similar terms and conditions as redeemable convertible bonds issued by the Company in the past.

2. Creation of an authorised share capital of the Company of six million seven hundred and thirty-eight thousand thirty-

nine Euro and twenty-six cents (€6,738,039.26) consisting of six hundred and seventy-three million eight hundred and
three thousand nine hundred and twenty-six (673,803,926) shares each with a nominal value of one Euro cent (€0.01)
which shall be reserved for the conversion of six hundred and seventy-three million eight hundred and three thousand
nine hundred and twenty-six (673,803,926) subordinated redeemable zero coupon convertible bonds; the board of di-
rectors of the Company is duly authorised to decide the class of shares to be issued upon conversion of the subordinated
redeemable zero coupon convertible bonds; and acknowledgement and approval of the report of the board of directors
of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies (as

amended) (the "Law") concerning the price, if any, at which the shares may be issued, such issues are being made without
reserving any preferential subscription rights of the existing shareholders.

3. Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation by creating a new article 5.2.
Thereafter, the following resolutions were passed:

<i>First resolution

It is resolved to authorise the board of directors of the Company to issue up to six hundred and seventy-three million

eight hundred and three thousand nine hundred and twenty-six (673,803,926) subordinated redeemable zero coupon
convertible bonds having similar terms and conditions as redeemable convertible bonds issued by the Company in the
past.

Ordinary A shares:
- For 318,164,479
- Against
- Abstention
Non voting preference B1 shares:
- For 263,807,426
- Against
- Abstention
Non voting preference B2 shares:
- For 3,619,497
- Against
- Abstention

<i>Second resolution

It is resolved to approve the creation of an authorised share capital of the Company of six million seven hundred and

thirty-eight thousand thirty-nine Euro and twenty-six cents (€6,738,039.26) consisting of six hundred and seventy-three
million eight hundred and three thousand nine hundred and twenty-six (673,803,926) shares each with a nominal value
of one Euro cent (€0.01) which shall be reserved for the conversion of six hundred and seventy-three million eight
hundred and three thousand nine hundred and twenty-six (673,803,926) subordinated redeemable zero coupon conver-
tible bonds and to authorise the board of directors of the Company to decide the class of shares to be issued upon
conversion of the subordinated redeemable zero coupon convertible bonds.

As regards said creation of the authorised share capital of the Company, the meeting acknowledged and approved a

report by the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the Law concerning the

41946

price, if any, at which the shares of the Company might be issued to the extent such issues were being made without
reserving any preferential subscription rights of the shareholders.

It is resolved that such report complied with said article 32-3(5).
Ordinary A shares:
- For 318,164,479
- Against
- Abstention
Non voting preference B1 shares:
- For 263,807,426
- Against
- Abstention
Non voting preference B2 shares:
- For 3,619,497
- Against
- Abstention

<i>Third resolution

As a result of the preceding resolution, it is resolved to amend article 5 of the Company's articles of incorporation by

creating a new article 5.2 which shall read as follows:

Art. 5.2. The authorised unissued capital is set at six million seven hundred and thirty-eight thousand thirty-nine Euro

and twenty-six cents (€6,738,039.26) consisting of six hundred and seventy-three million eight hundred and three thou-
sand nine hundred and twenty-six (673,803,926) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01) per share which
shall be reserved for the conversion of six hundred and seventy-three million eight hundred and three thousand nine
hundred and twenty-six (673,803,926) subordinated redeemable zero coupon convertible bonds. The board of directors
shall have the right, when issuing shares out of the authorised share capital to decide whether the shares to be issued
will be ordinary A shares, non voting preference B1 shares or non voting preference B2 shares.

Any authorised but unissued shares shall lapse (5) five years after publication in the Memorial of the notarial deed

recording the shareholder's resolution on the authorised capital.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of shares contemplated in the authorised capital.

Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash shall be offered on a pre-emptive

basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exercised
within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date of the
subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable throughout
the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability other than those applicable to the
shares in respect of which the right arises. Subject to the preceding paragraphs, the board of directors or delegate(s) duly
appointed by the board may from time to time issue shares out of the total authorised shares at such times and on such
terms and conditions, including issue price, as the board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve. In case
of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of any shares shall
be entitled to pre-emptive rights with respect to shares to be issued, unless waived by the general meeting of shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the

board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments."

Ordinary A shares:
- For 318,164,479
- Against
- Abstention
Non voting preference B1 shares:
- For 263,807,426
- Against
- Abstention
Non voting preference B2 shares:
- For 3,619,497
- Against
- Abstention
Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

41947

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at € 1,300,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentionned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six avril.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Al Silver S.A. (la "Société"), une société anonyme

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la mention B 104.776, constituée sous la forme d'une société anonyme
suivant acte reçu de Me Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 15 décembre 2004, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéros 1308 et 1309 du 22 décembre 2004. Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 2 mars 2009, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par M 

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire Mme Valentina Dadda, employée privée, demeurant à Luxembourg. L'as-

semblée a élu comme scrutateur M. Seiji Amino, administrateur, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence

signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l'enregistrement.

II. L'assemblée générale extraordinaire a été valablement convoquée par des avis de convocation envoyés par lettre

recommandée en date du 27 mars 2009.

III. Il ressort de ladite liste de présence que sur les 318.165.479 actions ordinaires A, les 263.807.426 actions privilégiées

sans  droit  de  vote  B1  et  les  3.619.497  actions  privilégiées  sans  droit  de  vote  B2,  318.165.479  actions  ordinaires  A,
263.807.426 actions privilégiées sans droit de vote B1 et 3.619.497 actions privilégiées sans droit de vote B2 sont repré-
sentées à la présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous:

1. Autorisation au conseil d'administration de la Société d'émettre un maximum de six cent soixante-treize millions

huit cent trois mille neuf cent vingt-six (673.803.926) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro
ayant les mêmes termes et conditions que les obligations convertibles rachetables émises dans le passé par la Société.

2. Création d'un capital social autorisé de la Société de six millions sept cent trente-huit mille trente-neuf Euros et

vingt-six cents (€6.738.039,26) consistant en six cent soixante-treize millions huit cent trois mille neuf cent vingt-six
(673.803.926) actions ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01), lesquelles sont réservées pour la
conversion de six cent soixante-treize millions huit cent trois mille neuf cent vingt-six (673.803.926) obligations conver-
tibles subordonnées rachetables à coupon zéro; le conseil d'administration de la Société est dûment autorisé à décider
de la classe d'actions devant être émise au moment de la conversion des obligations convertibles subordonnées rache-
tables à coupon zéro; et constat et approbation du rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément
à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la "Loi") en ce qui concerne
le prix, le cas échéant, auquel les actions peuvent être émises, ces émissions étant faites sans réserver de droits de
souscription préférentiels aux actionnaires existants. 3. Modification conséquente de l'article 5 des statuts en créant un
nouvel article 5.2.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé d'autoriser le conseil d'administration de la Société d'émettre un maximum de six cent soixante-treize

millions huit cent trois mille neuf cent vingt-six (673.803.926) obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon
zéro ayant les mêmes termes et conditions que les obligations convertibles rachetables émises dans le passé par la Société.

Actions ordinaires A:
- Pour 318.164.479
- Contre
- Abstention

41948

Actions préférentielles sans droit de vote B1:
- Pour 263.807.426
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote B2:
- Pour 3.619.497
- Contre
- Abstention

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'approuver la création d'un capital social autorisé de la Société de six millions sept cent trente-huit mille

trente-neuf Euros et vingt-six cents (€6.738.039,26) consistant en six cent soixante-treize millions huit cent trois mille
neuf cent vingt-six (673.803.926) actions ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01), lesquelles sont
réservées pour la conversion de six cent soixante-treize millions huit cent trois mille neuf cent vingt-six (673.803.926)
obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro, et d'autoriser le conseil d'administration de la Société
à décider de la classe d'actions devant être émise au moment de la conversion des obligations convertibles subordonnées
rachetables à coupon zéro.

En relation avec la création du capital social autorisé de la Société qui précède, l'assemblée a constaté et approuvé un

rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3(5) de la Loi relative au prix, le cas
échéant, auquel les actions pourraient être émises dans la mesure où ces émissions étaient faites sans réserver de droits
de souscription préférentiels aux actionnaires existants.

Il est décidé que ce rapport est conforme audit article 32-3(5).
Actions ordinaires A:
- Pour 318.164.479
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote B1:
- Pour 263.807.426
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote B2:
- Pour 3.619.497
- Contre
- Abstention

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société en créant

un nouvel article 5.2 qui aura la teneur suivante:

Art. 5.2. Le capital autorisé mais non émis est fixé à six millions sept cent trente-huit mille trente-neuf Euros et vingt-

six  cents  (€6.738.039,26)  consistant  en  six  cent  soixante-treize  millions  huit  cent  trois  mille  neuf  cent  vingt-six
(673.803.926) actions ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (€0,01) par action, lesquelles seront réservées pour
la conversion de six cent soixante-treize millions huit cent trois mille neuf cent vingt-six (673.803.926) obligations con-
vertibles subordonnées rachetables à coupon zéro. Le conseil d'administration aura le droit, au moment de l'émission
d'actions dans les limites du capital social autorisé, de décider si les actions devant être émises seront des actions ordinaires
A, des actions privilégiées sans droit de vote B1 ou des actions privilégiées sans droit de vote B2.

Toute action autorisée mais non émise expirera cinq (5) ans après la publication dans le Mémorial de l'acte notarié

prenant acte de la résolution des actionnaires portant sur le capital autorisé.

Afin  d'éviter  tout  doute,  les  actionnaires  renoncent  expressément  à  tout  droit  de  souscription  préférentiel  qu'ils

pourraient avoir en relation avec les émissions d'actions prévues dans les limites du capital autorisé.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions devant être souscrites en espèces seront offertes aux action-

naires sur une base préemptive au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription peut être
exercé pendant une période déterminée par le conseil d'administration, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à
compter de la date de la période de souscription, laquelle sera notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscription
peut être cédé pendant la période de souscription, et aucune restriction ne pourra être imposée sur cette cession autre
que les restrictions applicables aux actions qui bénéficient de ce droit.

Sous réserve des paragraphes précédents, le conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) dûment désigné(s) par le

conseil peut de temps à autre émettre des actions dans les limites de la totalité des actions autorisées aux dates et selon

41949

les termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le conseil ou son(ses) délégué(s) pourra(ont) déterminer à sa
(leur) discrétion.

Dans l'hypothèse d'un capital autorisé additionnel et/ou d'un renouvellement subséquent du capital autorisé, les dé-

tenteurs d'actions pourront bénéficier de droits de préemption en relation avec les actions à émettre, à moins que
l'assemblée générale des actionnaires ait renoncé à ces droits de préemption.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera enregistrée dans un acte notarié, à la demande

du conseil d'administration ou son(ses) délégué(s) sur présentation des documents établissant les souscriptions et les
paiements."

Actions ordinaires A:
- Pour 318.164.479
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote B1:
- Pour 263.807.426
- Contre
- Abstention
Actions préférentielles sans droit de vote B2:
- Pour 3.619.497
- Contre
- Abstention
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Coûts et Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à € 1.300,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties compa-
rantes, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: K. Panichi, V. Dadda, S. Amino, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 07 avril 2009. Relation: EAC/2009/4077. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009047826/272/270.
(090056843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

Berenberg Fund-of-Funds, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Verwaltungsreglement des Berenberg Fund-of-Funds, in Kraft getreten am 28. Februar 2009 wurde

beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg im April 2009.

Berenberg Lux Invest S.A.
Harald Wörister / Hermann Laub

Référence de publication: 2009047022/1368/13.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2009, réf. LSO-DD00149. - Reçu 72,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090049605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2009.

41950

Global Funds Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 37.359.

EXTRAIT

Il résulte des minutes de la réunion du conseil d'administration du 5 mars 2009 que Monsieur Koichi Matsumoto de

résidence professionnelle au Bâtiment A, 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange a été nommé avec effet immédiat en
tant qu'administrateur délégué de la société en charge de sa gestion journalière pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009047024/260/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03423. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090055248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

Silcart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 104.777.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés pour servir aux fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche Moutrier.

Référence de publication: 2009047815/272/10.
(090056779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

Nordea 1 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 31.442.

As part of a continued review of the product range, the Board of Directors of Nordea 1, SICAV (the "Company")

would like to inform the shareholders of the Company of its decision to terminate the Sub-fund "Nordea 1 - Sterling
Bond Fund" as per April 30, 2009 in accordance with chapter "Dissolution and Merger" of the Prospectus, considering
that the Sub-Fund is no longer economically viable due to its low assets under management, and that it is in the best
interest of the shareholders to close the Sub-fund.

Any amount not claimed by any Shareholder will be deposited at the close of the liquidation with the Custodian Bank,

Nordea Bank S.A. at 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within a period of 9
months after the decision to liquidate the Sub-fund, any outstanding amount will be deposited in escrow with the Caisse
de Consignation in Luxembourg.

Luxembourg, April 24, 2009.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2009048633/755/17.

ISS Facility Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 21.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009046379/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06868. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

41951

Sterling Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.775.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés pour servir aux fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche Moutrier.

Référence de publication: 2009047821/272/10.
(090056802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

PG Silver A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 145.179.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés pour servir aux fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche Moutrier.

Référence de publication: 2009047823/272/10.
(090056829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

AI Silver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.776.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés pour servir aux fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2009.

Blanche Moutrier.

Référence de publication: 2009047827/272/10.
(090056849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

European Investments Associates (E.I.A.) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 62.165.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale

<i>des actionnaires tenue extraordinairement en date du 16 février 2009

1. M. Sinan SAR a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. M. Cornelius Martin BECHTEL a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

4. M. Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Luxembourg, le 31 mars 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES (E.I.A.) S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009046337/29/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02366. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

41952


Document Outline

AI Silver S.A.

AI Silver S.A.

Allianz Global Strategy Defensive

Allianz Global Strategy Dynamic

Amhurst Corporation

Bayside International S.A.

Berenberg Fund-of-Funds

Bluestar International S.A.

Calypso Sicav

Capstar Holding S.A.

CEGEDEL société anonyme (Compagnie Grand-Ducale d'Electricité du Luxembourg)

Celfloor

Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L.

Destiny Invest S.A.

Eowyn S.A.

European Investments Associates (E.I.A.) S.A.

Firad S.A.

Galux S.A.H.

Generali Hedge Funds Sicav

Global Funds Management S.A.

Immo Inter Finance S.A.

ISS Facility Services S.A.

JamaicaLux S.A.

Karlix S.A.

Legg Mason Managed Solutions SICAV

Lhjrwing Dench S.A., SPF

Nextam Partners

Nordea 1 SICAV

Nucifera

Old Town

Parts Immobilière S.A.

PEH Quintessenz Sicav

PEH Trust Sicav

PG Silver A S.A.

PG Silver A S.A.

PG Silver B S.A.

Polifontaine S.A.

Sabarel S.A.

Shivling Holding S.A.

Silcart S.A.

Silcart S.A.

Siltarc S.A.

Spoleto S.A.

Sterling Holdings S.A.

Sterling Holdings S.A.

SWIP Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

SWIP (Luxembourg) S.à r.l.

Tenaris S.A.

Transfin S.A.

Velafi Holding S.A.

Winning Funds

WM Fund

Woodlander Project S.A.