logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 857

22 avril 2009

SOMMAIRE

74 C 122 A S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41095

A2CS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41096

AC Multiservices (Luxembourg) S.à r.l.  . .

41093

Aerolink International Sàrl . . . . . . . . . . . . . .

41122

Aggmore Europe 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

41133

AIRCO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41093

AIRCO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41092

Atrix Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

41100

Brinkman Trans Holland S.à r.l.  . . . . . . . . .

41130

CalEast Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41124

Centaur Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41120

Cetex Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41096

Challenger Global Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . .

41090

De Agostini Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41096

Delphi Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

41093

Dexia Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41130

Eiffel Properties Luxembourg S.à r.l. . . . . .

41122

Espalita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41132

Expotrans S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41094

Expotrans S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41094

Filipeservice S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41113

Fita Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

41095

FKI Luspartwo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41119

GCAT-L U X S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41135

Gemina Fiduciary Services S.A.  . . . . . . . . .

41099

Gisela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41093

GRB S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41132

HVB Banque Luxembourg Société Anony-

me  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41091

Iberint Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41133

Icare S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41134

Julia & Claudia Holding Company  . . . . . . .

41098

Keane, Piper & Associates S.A.  . . . . . . . . . .

41094

Kefren S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41131

Kirken Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41136

La Felicita S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41092

Lingerie Caprice S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41092

Marianne's Holding Company  . . . . . . . . . . .

41097

M.E.C. ImmoLux s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41092

MJ Collections S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41096

New Europe Property Holdings (Luxem-

bourg) 2005 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41098

NREP Transactions Holding 6 Junior S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41098

Nut Holding Company S.A.  . . . . . . . . . . . . .

41091

OI-Clothing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41094

Opera Masters SCA SICAR  . . . . . . . . . . . . .

41090

Panikom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41135

Pegaso Finance S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41134

Pramerica Real Estate Investors (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41090

Rex Bois Corporation  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41095

Roy Grandchildren Holding Company . . . .

41099

SVF Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41097

T-I Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41091

Tishman Speyer Caffamacherreihe Hol-

dings S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41134

Tishman Speyer Caffamacherreihe Hol-

dings S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41114

Tishman Speyer Caffamacherreihe S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41097

Tishman Speyer Caffamacherreihe S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41119

Tishman Speyer Valentinskamp L.P. S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41099

TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l.  . . .

41090

TS Nautilus Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

41123

TS Tour Esplanade Holdings II (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41116

Via Download, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41131

Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41091

Xender Eurolink Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

41136

Zach & Rubensun Group S.A.  . . . . . . . . . . .

41117

41089

Challenger Global Fonds, Fonds Commun de Placement.

R.C.S. Luxembourg B 29.905.

<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des

<i>Challenger Global Two Fonds

<i>(Anteilklasse A: WKN 974 566 ISIN LU0115167180)

<i>Challenger Global New Markets Fonds

<i>(Anteilklasse A: WKN 974 569 ISIN LU0115167859)

M.M.Warburg-LuxInvest S.A., die Verwaltungsgesellschaft des Challenger Global Fonds, gibt bekannt, dass für die oben

genannten Teilfonds, welche zum 31. Oktober 2008 aufgelöst wurden, das Auflösungsverfahren abgeschlossen ist. Die
Liquidationserlöse wurden vollständig an die berechtigten Anteilinhaber ausbezahlt.

Luxemburg, im April 2009.

M.M.Warburg-LuxInvest S.A.

Référence de publication: 2009047733/2112/14.

Pramerica Real Estate Investors (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 28.214.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 574 du 17 mars 2009, page 27551, de l'extrait

des résolutions prises par les actionnaires de la société le 25 juillet 2008:

au lieu de: «PricewaterhouseCoopers S.à r.l., (...) a été nommée réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice

social prenant fin le 31 décembre 2007.»,

lire: «PricewaterhouseCoopers S.à r.l., (...) a été nommée réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice social

prenant fin le 31 décembre 2006.»

Référence de publication: 2009047605/7959/13.

TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 117.194.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54861 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045493/211/12.
(090052334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Opera Masters SCA SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 115.895.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit les deux publications, dans le Mémorial C n° 150 du 23 janvier 2009, page 7155, et

dans le Mémorial C n° 216 du 31 janvier 2009, page 10328, de la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 9 février
2009:

- au lieu de: «Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la

société OPERA MASTERS SCA, SICAR qui se réunira le 9 février 2008 à 9.00 heures (...)»,

- lire: «Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société

OPERA MASTERS SCA, SICAR qui se réunira le 9 février 2009 à 9.00 heures (...)».

Référence de publication: 2009047502/6341/15.

41090

HVB Banque Luxembourg Société Anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 9.989.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 19 mars 2009.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045184/202/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2009, réf. LSO-DC03649. - Reçu 140,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090052036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 56.908.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 6 avril 2009.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045190/202/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00668. - Reçu 102,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Nut Holding Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 100.532.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour NUT HOLDING COMPANY S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009045110/565/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01241. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

T-I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 3, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 106.007.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54841 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009044237/211/12.
(090050949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

41091

M.E.C. ImmoLux s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 128.352.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 07 Avril 2009.

Fiduciaire COFIGEST S.A R.L.
Isabelle PHILIPIN
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN

Référence de publication: 2009044837/2631/15.
Enregistré à Diekirch, le 2 avril 2009, réf. DSO-DD00011. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(090051784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

Lingerie Caprice S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 36, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 106.537.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 30 mars 2009.

Martine WEINANDY
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045416/238/12.
(090052097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

La Felicita S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9521 Wiltz, 68, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 121.246.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wltz, le 19 mars 2009.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009045418/2724/13.
(090052109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

AIRCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7465 Nommern, 43, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 15.485.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2009.

Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2009045415/7747/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08475. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

41092

AIRCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7465 Nommern, 43, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 15.485.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2009.

Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2009045411/7747/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08479. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090052022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Delphi Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 123.200.000,00.

Siège social: L-4940 Bascharage, 1, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 99.207.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009045428/4475/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02362. - Reçu 109,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

AC Multiservices (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3509 Dudelange, 12-14, rue Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 137.199.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 03 avril 2009.

Frank MOLITOR
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045502/223/12.
(090052369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Gisela, Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 85.774.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 avril 2009.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009045508/206/13.
(090052490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

41093

Expotrans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 73.996.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EXPOTRANS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009045200/6341/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01076. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090051987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

OI-Clothing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.717.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54794 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045514/211/12.
(090052499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Keane, Piper &amp; Associates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 29.934.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009045277/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01903. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Expotrans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 73.996.

Les comptes annuels au 31 juillet 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EXPOTRANS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009045196/6341/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01071. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

41094

74 C 122 A S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 111.718.

Le siège social de la société 74 C 122 A S.A., RCS Luxembourg B 111.718 (L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre

Brasseur), a été dénoncé avec effet au 3 mars 2009.

Monsieur Lionel Guibert a démissionné de son poste d'administrateur, d'administrateur délégué et de Président du

conseil d'administration de la société 74 C 122 A S.A., RCS Luxembourg B 111.718, avec effet au 3 mars 2009.

La société Fiduciaire Principale SA, représentée par Monsieur Lionel Guibert, a démissionnée de son poste d'admi-

nistrateur de la société 74 C 122 A S.A., RCS Luxembourg B 111.718, avec effet au 3 mars 2009.

La société Imacorp, Fiduciaire d'Organisation SA, représentée par Monsieur Jean-Louis RICHARD, a démissionnée de

son poste de commissaire aux comptes de la société 74 C 122 A S.A., RCS Luxembourg B 111.718, avec effet au 3 mars
2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2009.

FELTEN &amp; ASSOCIES
<i>L'agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2009040017/320/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02467. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Rex Bois Corporation, Société Anonyme.

Siège social: L-9972 Lieler, 26, Hauptrooss.

R.C.S. Luxembourg B 106.836.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale du conseil de direction du 12 mars 2009

Démission de M. Charles Briffoz en qualité d'administrateur de la société.
Nomination de Mme Josiane von den Hoff en qualité d'administrateur.
Place du Martyr, 8, 4800 Verviers, Belgique.
Transfert du siège social de la succursale Hauptrooss, 26, L-9972 Lieler.

Fait en triple exemplaires à Lieler.

Josiane von den Hoff.

Référence de publication: 2009041076/801249/15.
Enregistré à Diekirch, le 25 mars 2009, réf. DSO-DC00243. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090047080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2009.

Fita Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 262.400,00.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 118.274.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession en date du 17 mars 2009 que les 1937 parts sociales détenues par la société TML-Invest

S.àr.l. sont cédées à Mr. Heiner KAMPS, domicilié à 4, Potsdamer Platz, 10785 Berlin, Allemagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Fita Investments S.àr.l.
Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2009044177/1459/17.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2009, réf. LSO-DD00008. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090050925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

41095

A2CS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5550 Remich, 20, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 132.479.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54947 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045492/211/12.
(090052329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Cetex Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. MJ Collections S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 44.919.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire au siège social le 5 novembre 2008

<i>5 

<i>e

<i> résolution

L'Assemblée Générale, accepte la démission avec effet au 15 octobre 2008 de la fonction de commissaire de la société

HRT Révision S.A. ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet au 15 octobre 2008 à la fonction de commissaire Monsieur Romain

THILLENS demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg et de ratifier l'exécution de son mandat
durant les exercices se clôturant au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006. Son mandat est valable jusqu'à l'Assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Cetex Luxembourg S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009043995/565/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2009, réf. LSO-DC07654. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090050813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

De Agostini Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 111.253.

Mr Pierre Thielen, administrateur et président de la société DE AGOSTINI INVEST S.A., a changé d'adresse. Sa nouvelle

adresse est: 5-11, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 mars 2009, après avoir pris acte de la démission de Messieurs

Marco Sterzi, Roberto Saviane et Julian Trunkfield de leurs mandats d'administrateurs, a nommé en tant que nouvel
administrateur:

- Monsieur Emile De Demo, avec adresse professionnelle au 9-11 Grand Rue, L-1661 Luxembourg.
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour De Agostini Invest S.A.
Pierre Thielen
<i>Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009044031/7663/21.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD00822. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090050931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

41096

Tishman Speyer Caffamacherreihe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.234.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54860 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045491/211/12.
(090052324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Marianne's Holding Company, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 100.238.

EXTRAIT

Le conseil d'administration, dans ses résolutions circulaires du 2 avril 2009 a décidé de transférer avec effet au 1 

er

février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui
sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs B de la société, à savoir Madame Michelle

DELFOSSE et Monsieur Laurent HEILIGER, est également modifiée avec effet au 1 

er

 février 2009 et sera à partir de cette

date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 avril 2009.

<i>Pour MARIANNE'S HOLDING COMPANY
Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2009045471/833/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01786. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

SVF Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 121.557.

<i>Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale des actionnaires du 2 mars 2009

En date du 2 mars 2009, l'assemblée générale a pris acte de la démission avec effet au 1 

er

 janvier 2009 de Monsieur

Alain Heinz de son mandat d'administrateur de catégorie B.

A cette même date, l'assemblée générale a décidé de nommer administrateur de catégorie B avec effet au 1 

er

 janvier

2009  Monsieur  Alain  Peigneux,  administrateur  de  sociétés,  avec  adresse  professionnelle  à  L-1511  Luxembourg,  121,
avenue de la Faïencerie.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2008,

qui se tiendra en 2009.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009045469/6341/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01833. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

41097

NREP Transactions Holding 6 Junior S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 134.150.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2009.

Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045504/9127/12.
(090052370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Julia &amp; Claudia Holding Company, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 100.237.

EXTRAIT

Le conseil d'administration, dans ses résolutions circulaires du 2 avril 2009 a décidé de transférer avec effet au 1 

er

février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui
sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs B de la société, à savoir Madame Michelle

DELFOSSE et Monsieur Laurent HEILIGER, est également modifiée avec effet au 1 

er

 février 2009 et sera à partir de cette

date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 avril 2009.

<i>Pour JULIA &amp; CLAUDIA HOLDING COMPANY
Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2009045468/833/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01789. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

New Europe Property Holdings (Luxembourg) 2005 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 112.548.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 janvier 2009

Troisième résolution
L'Associé unique accepte la démission de Monsieur Alain Heinz en tant que gérant de la société avec effet au 2 février

2009.

L'Associé unique décide de nommer Monsieur Emmanuel Mougeolle en tant que gérant de la société, résident pro-

fessionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, avec effet au 2 février 2009 pour une durée
indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009045459/6341/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01842. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

41098

Tishman Speyer Valentinskamp L.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 113.347.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54855 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045496/211/12.
(090052341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Roy Grandchildren Holding Company, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 100.222.

EXTRAIT

Le conseil d'administration, dans ses résolutions circulaires du 2 avril 2009 a décidé de transférer avec effet au 1 

er

février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera
désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs B de la société, à savoir Madame Michelle

DELFOSSE et Monsieur Laurent HEILIGER, est également modifiée avec effet au 1 

er

 février 2009 et sera à partir de cette

date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 avril 2009.

<i>Pour ROY GRANDCHILDREN HOLDING COMPANY
Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2009045466/833/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01790. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Gemina Fiduciary Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 67.668.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue en date du 3 avril 2009, a décidé que:
Madame Giuseppina CORSI, Maître Alex SCHMITT et Madame Josiane WAGNER-WEILER sont confirmés dans leurs

mandats d'administrateur de la société pour une année.

KPMG Audit est renommée Commissaire aux comptes de la société pour une année.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin aussitôt après la tenue de l'Assemblée

Générale de l'exercice 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme
GEMINA FIDUCIARY SERVICES S.A.
Signature

Référence de publication: 2009045439/9116/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01727. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

41099

Atrix Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.567.

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

für die grenzüberschreitende Verschmelzung der
Atrix Luxembourg S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée mit Sitz in L-2086 Luxembourg, 412F,

route d'Esch, noch nicht eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg ("Atrix S.à r.l.")

und
Atrix  Laboratories  GmbH,  eine  deutsche  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  mit  Sitz  in  Hessenring  119-121,

D-61348 Bad Homburg v. d. Höhe, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg unter HRB 6885
("Atrix GmbH", im Folgenden gemeinsam mit Atrix S.à r.l. als "Verschmelzende Gesellschaften" oder "Parteien" bezeich-
net).

Atrix GmbH hält sämtliche zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1) der Atrix S.à r.l. und ist somit alleinige Gesellschafterin dieser Gesellschaft. Sämtliche Geschäftsanteile der
Atrix S.à r.l. sind voll eingezahlt. Atrix GmbH beabsichtigt nunmehr, ihr gesamtes Vermögen (Aktiva und Passiva) im Wege
der Auflösung ohne Abwicklung durch grenzüberschreitende Verschmelzung auf die Atrix S.à r.l. zu übertragen.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt:

<i>1. Vermögensübertragung und Verschmelzungsdatum

1.1 Die Verschmelzenden Gesellschaften sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die erwägen, gemäß den Vors-

chriften des Abschnittes XIV des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner
aktuellen Fassung (das "LSC"), unter Berücksichtigung der Maßgaben der Richtlinie 2005/56/EG des europäischen Parla-
ments  und  des  Rates  vom  26.  Oktober  2005  über  die  Verschmelzung  von  Kapitalgesellschaften  aus  verschiedenen
Mitgliedstaaten  (die  "Richtlinie")  und  gemäß  §  122a  Abs.  1  i.V.m.  §  2  Nr.  1  des  deutschen  Umwandlungsgesetztes
("UmwG"), zu verschmelzen.

1.2 Mit Wirksamkeit der Verschmelzung ist Atrix GmbH aufgelöst und überträgt ihr gesamtes Vermögen (Aktiva und

Passiva) als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung gemäß § 122a Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr.
1 UmwG und der Artikel 257, 274 des LSC auf Atrix S.à r.l. (die "Verschmelzung").

1.3 Diese Verschmelzung soll am Tage der Veröffentlichung des Beschlusses der Gesellschafterin der Atrix S.à r.l.,

durch den die Verschmelzung beschlossen wird, im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations wirksam werden
("Verschmelzungsdatum"). Die Übernahme des Vermögens der Atrix GmbH durch die Atrix S.à r.l. erfolgt aus buchhal-
terischer Sicht und für die Rechnungslegung ab dem 1. Januar 2009, 0:00 Uhr ("Verschmelzungsstichtag"). Vom Versch-
melzungsstichtag  an  gelten  alle  Handlungen  und  Geschäfte  der  Atrix  GmbH  aus  buchhalterischer  Sicht  und  für  die
Rechnungslegung als für Rechnung der Atrix S.à r.l. vorgenommen.

1.4 Der Verschmelzung werden der Jahresabschluss der Atrix GmbH zum 31. Dezember 2008, der von der Gesell-

schafterin der Atrix GmbH am 8. April 2009 festgestellt wurde, und die Zwischenkonten vom 20 Maerz 2009 der Atrix
S.à r.l., die vom einem Geschäftsführer der Atrix S.à r.l. am 26 März 2009 angenommen wurden, zugrunde gelegt.

<i>2. Gewährung von Geschäftsanteilen, Barabfindungsangebot

2.1 Die alleinige Gesellschafterin der Atrix GmbH ist die QLT USA, Inc. Mit Wirksamkeit der Verschmelzung gehen

sämtliche von der QLT USA, Inc. in der Atrix GmbH gehaltenen Geschäftsanteile unter. Als Ausgleich erhält die QLT
USA, Inc. sämtliche Geschäftsanteile in der Atrix S.à r.l. nach Maßgabe der Ziffer 2.2 dieses Verschmelzungsplans.

2.2 Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden sämtliche zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile in

der Atrix S.à r.l. mit einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR 1) von Atrix GmbH auf QLT USA, Inc. übertragen
(die "Übertragenen Anteile"). Die Kosten der Übertragung trägt die QLT USA, Inc.

2.3 Das Nominalkapital von Atrix S.à r.l. wird zur Durchführung der Verschmelzung nicht erhöht (§ 122a Abs. 1 i.V.m.

§ 54 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 UmwG). Die Übertragenen Geschäftsanteile haben in jeder Hinsicht die selben Rechte; die Satzung
der Atrix S.à r.l., festgesetzt durch Gründungsakt vom 20 März 2009 des Notars Maître Jean-Joseph Wagner mit Amtssitz
in Sanem, Luxemburg, welcher noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde, wird
nicht geändert. Die Übertragenen Geschäftsanteile gewähren QLT USA, Inc. vom Beginn des laufenden Geschäftsjahres
der Atrix S.à r.l. an das Recht an der Beteiligung am Gewinn der Atrix S.à r.l.

2.4 Ein Barabfindungsangebot gemäß § 122i Abs. 1 UmwG wird nicht unterbreitet, da sämtliche Gesellschafter der

Atrix GmbH dem Verschmelzungsplan zugestimmt haben. Eine Ausgleichszahlung (soulte) i.S.d. Artikel 259 des LSC wird
nicht gezahlt.

41100

<i>3. Sonderrechte und Sondervorteile

3.1 Es werden keine Rechte i. S. v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG für mit Sonderrechten ausgestattete Gesellschafter

oder für Inhaber von anderen Wertpapieren als Gesellschaftsanteilen gewährt, und es sind auch keine Maßnahmen im
Sinne der vorgenannten Vorschrift für solche Personen vorgesehen. Atrix S.à r.l. hat im Zeitpunkt der Verschmelzung
keine Geschäftsanteile mit Sonderrechten, Schuldverschreibungen, (Wandel-)Anleihen oder sonstige Wertpapiere, die
keine Geschäftsanteile sind, ausgegeben.

3.2 Besondere Vorteile i. S. v. § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und/oder Artikel 261 (2) (g) des LSC für Mitglieder der

Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorganen und für Sachverständige, die den Verschmelzungsplan prüfen,
werden von keiner der beiden Gesellschaften gewährt.

3.3 Die Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften haben das Recht für einen Zeitraum von einem Monat,

beginnend ab der Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplanes im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations die
unter Artikel 267 (1) a), b), c), d), e) LSC aufgeführten Dokumente an den Geschäftssitzen der Verschmelzenden Ge-
sellschaften einzusehen. Eine Kopie dieser Dokumente wird jedem Gesellschafter auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

<i>4. Folgen der Verschmelzung für die Beschäftigung (Arbeitnehmer und ihre Vertretungen)

4.1 Sowohl Atrix GmbH als auch Atrix S.à r.l. haben keine Arbeitnehmer.
4.2 Betriebsänderungen sind infolge der Verschmelzung derzeit nicht geplant.
4.3 Die beteiligten Gesellschaften haben weder einen Betriebsrat noch einen mitbestimmten Aufsichtsrat.

<i>5. Satzung der übernehmenden Gesellschaft

Die gültige Satzung der Atrix S.ä r.l. ist dieser Urkunde als Anlage 1 beigefügt.

<i>6. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens

Die Verschmelzung erfolgt handelsbilanziell zu Zeitwerten (§ 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG).

<i>7. Zustimmungserfordernisse

Dieser Verschmelzungsplan bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Atrix S.à r.l. sowie der Ge-

sellschafterversammlung der Atrix GmbH.

<i>8. Kosten

Externe Kosten, die im Rahmen dieses Verschmelzungsplans bei der Atrix GmbH anfallen, insbesondere Kosten der

Erteilung einer Vorabbescheinigung, der Anmeldung und Eintragung im zuständigen Handelsregister sowie Kosten für die
Herbeiführung  des  Verschmelzungsbeschlusses  oder  sonstiger  erforderlicher  Beschlüsse  im  Zusammenhang  mit  der
Verschmelzung, werden von Atrix S.à r.l. getragen.

<i>9. Schlussbestimmungen

9.1 Dieser Verschmelzungsplan unterliegt luxemburgischem Recht, soweit nicht deutsches Recht gemäß der Richtlinie

Anwendung findet oder luxemburgisches Recht auf das deutsche Recht hinsichtlich der grenzüberschreitenden Versch-
melzung verweist.

9.2 Im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Verschmelzungsplan oder über seine Gültigkeit,

ist - soweit gesetzlich zulässig - Luxemburg ausschließlicher Gerichtsstand.

9.3 Änderungen oder Ergänzungen dieses Verschmelzungsplans oder seiner Anlagen bedürfen der Schriftform soweit

nicht die notarielle Form zu beachten ist. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

9.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar

sein oder werden, oder im Falle einer Vertragslücke, bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans
wirksam. Die Parteien dieses Verschmelzungsplans verpflichten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-
mungen oder die Lücke durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die soweit als möglich den Intentionen der Parteien
oder dem, was die Intention der Parteien nach diesem Verschmelzungsplans hätte sein können, entsprechen, wenn sie
die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder die Lücke berücksichtigt hätten.

9.5 Der deutsche Wortlaut dieser Urkunde ist rechtlich maßgebend. Eine englische Übersetzung dieser Urkunde wurde

lediglich zu Informationszwecken beigefügt.

ANLAGE 1: SATZUNG DER ATRIX S.À R.L.

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen der derzeitigen Inhaberin der Anteile und/oder jeder anderen Person, die

künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma "Atrix
Luxembourg S.à r.l." (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

41101

Art. 3. Zweck
3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus

Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.2 Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-

gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in

welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. In-

nerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-

papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes

beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

4.3 Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch

einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung

von Geschäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beste-

hend  aus  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Geschäftsanteilen  mit  einem  Nominalwert  von  einem  Euro  (EUR  1)  pro
Geschäftsanteil. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der
Gesellschafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags
erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Geschäftsanteile
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig

(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3 Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

6.4 Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend

den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-

gekauften  oder  zurückgenommenen  Geschäftsanteile  werden  sofort  gelöscht  und  das  Stammkapital  entsprechend
herabgesetzt.

6.6 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

41102

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis
7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-

schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft per Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mit-

teilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen
8.1 Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-

schafterverzeichnis  erbracht  werden.  Auf  Ersuchen  und  auf  Kosten  eines  Gesellschafters  werden  Zertifikate  dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.

8.3 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter

Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich des Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles

in  privatschriftlicher  oder  notarieller  Form  dokumentiert  werden,  und  eine  solche  Übertragung  wird  gegenüber  der
Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesell-
schafterverzeichnis eintragen kann.

8.5 Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Ü-bertragung zustimmen

und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung
9.1 Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-

terversammlung  aus.  In  einem  solchen  Fall,  soweit  anwendbar  und  wo  der  Begriff  "alleiniger  Gesellschafter"  nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
"Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den "alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.

9.3  Die  Gesellschafterversammlung  hat  die  ihr  durch  Gesetz  oder  durch  diesen  Gesellschaftsvertrag  ausdrücklich

verliehenen Befugnisse.

9.4 Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,

statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung
10.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit, je nach Lage des Falles, durch den Geschäftsführerrat, den/die

satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-

sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort, wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zei-
traums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

41103

10.3 Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit

der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass

sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss
11.1 In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-

denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3 Quorum und Stimmabgabe
11.3.1 Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2 Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-

schafterbeschlüsse bei  der  ersten  Abstimmung  wirksam  gefasst,  wenn sie  von  Gesellschaftern angenommen  werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,

Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5 Ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch

ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches ermöglicht, dass dieser Gesellschafter identifiziert werden kann
und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und sich effektiv an der
Versammlung beteiligen können, gilt für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit als anwesend.

11.6 Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden

müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag

durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen
13.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie

von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2 Der/die alleinige Gesellschafter/in, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm/ihr gefassten

Beschlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats
14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein

müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat"
als Verweis auf den "alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

14.2  Der  Geschäftsführerrat  verfügt  über  die  weitestgehenden  Befugnisse,  alle  Handlungen  vorzunehmen,  die  zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

41104

14.3 Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts

können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Beschluss des Geschäfts-
führerrats festgesetzt.

14.4 Die Gesellschaft kann auch durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde spezielle Vollmachten an jede Person

erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten

des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit
16.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit

festlegt.

16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen

werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.

16.3 Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats
17.1 Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner

Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2 Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung

anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einvers-
tändnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunika-
tionsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch
ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden
sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann nicht
erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schrift-
lichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats
18.1 Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner/ihrer

Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

18.2 Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder

an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

18.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder

vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

18.4 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch

ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und
dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung teil-
nehmen können, gilt für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit als anwesend. Eine durch solche Kommuni-
kationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft gilt als abgehalten.

18.6 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in

einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

41105

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats
19.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung

des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die alleinige

Unterschrift jedes beliebigen Mitglieds des Geschäftsführerrats oder durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsfüh-
rers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen
eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden
ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts
gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit
der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - unabhängige(r) Buchprüfer
21.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder

mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2 Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und

ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung

abberufen werden.

21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte

der Gesellschaft.

21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu
und das Abhalten von Sitzungen des Geschäftsführerrats sollen anwendbar sein.

21.7 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr.  Das  Geschäftsjahr  der  Gesellschaft  beginnt  am  ersten  Januar  jeden  Jahres  und  endet  am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne
23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt

werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen wird die Gesellschafterversammlung beschließen, wie der verbleibende Rest

des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden
soll.

Art. 24. Zwischendividenden. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden

zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind,
(ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Ge-
schäftsjahres,  für  welches  der  Jahresabschluss  genehmigt  wurde,  realisiert  worden  sind,  einschließlich  vorgetragener
Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener

41106

Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind,
und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem/ihrem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass
die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung des/der Liquidators/en bestimmt.

H. Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-

burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

English translation as follows:

JOINT MERGER PLAN

for the cross-border merger of
Atrix Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered address at 412F, route

d'Esch, L-2086 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("Atrix S.à r.l.")

and
Atrix Laboratories GmbH, a German Gesellschaft mit beschränkter Haftung, having its registered address at Hessenring

119-121, D-61348 Bad Homburg v. d. Höhe, registered with the trade register of the local court Bad Homburg under
number HRB 6885 ("Atrix GmbH", hereinafter together with Atrix S.à r.l. referred to as "Merging Companies" or "Par-
ties").

Atrix GmbH holds all twelve thousand five hundred (12,500) shares, all having a par value of one Euro (EUR 1) each,

in Atrix S.à r.l. and therefore is the sole shareholder of this company. All shares of Atrix S.à r.l. have been entirely paid
in. Henceforth, Atrix GmbH contemplates to transfer its entire assets (assets and obligations) by way of dissolution
without liquidation through cross-border merger to Atrix S.à r.l..

Now therefore the Parties agree as follows:

<i>1. Transfer of assets and date of the merger

1.1 The Merging Companies are limited liability companies who contemplate to merge according to the provisions of

chapter XIV of the Luxembourg law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "LSC"), in
accordance with the legal requirements of the directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26
October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (the "Directive"), and according to § 122a para. 1
in  connection  with  §  2  no.  1  of  the  German  law  regulating  the  transformation  of  companies  (Umwandlungsgesetz,
"UmwG").

1.2 Upon effectiveness of the merger, Atrix GmbH is dissoluted and transfers its entire assets (asstes and liabilities)

in  its  entirety  with  all  its  rights  and  obligations  under  dissolution  without  liquidation  according  to  §  122a  para.  1  in
connection with § 2 no. 1 UmwG and articles 257, 274 of the LSC to Atrix S.à r.l. (the "Merger").

1.3 This Merger shall be effective as of the publication of the resolution of the shareholder of Atrix S.à r.l., which

approves the Merger, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Date of the Merger"). The transfer of
the assets of Atrix GmbH to Atrix S.à r.l. shall have effect for accounting and reporting purposes as of 1 January 2009,
0:00 am ("Effective Date"). With the beginning of the Effective Date, the acts and transactions of Atrix GmbH shall be
deemed concluded and executed for accounting and reporting purposes for the account of Atrix S.à r.l.

1.4 The merger shall be based on the accounts of Atrix GmbH on 31 December 2008, which have been approved by

the shareholder of Atrix GmbH on 8 April 2009, and on the interim accounts of Atrix S.à r.l, which have been approved
by a manager of Atrix S.à r.l. on 26 March 2009.

<i>2. Issue of shares, compensation offer

2.1 The sole shareholder of Atrix GmbH is QLT USA, Inc. Upon effectiveness of the merger all shares held by QLT

USA, Inc. in Atrix GmbH shall be cancelled. As as compensation QLT USA, Inc. shall receive all shares in Atrix S.à r.l. in
accordance with Section 2.2 of this Merger Plan.

2.2 Upon effectiveness of the merger, all twelve thousand five hundred (12,500) shares in Atrix S.à r.l., having a par

value of one Euro (EUR 1) each, held by Atrix GmbH will be transferred to QLT USA, Inc. (the "Transferred Shares").
QLT USA, Inc. shall bear the costs of such transfer.

2.3 For the execution of the merger, the registered capital of Atrix S.à r.l. will not be increased. The Transferred Shares

have the same rights in every respect and the articles of association of Atrix S.à r.l., established through notarial deed of
constitution on 20 March 2009 of the notary Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, Luxembourg, which has has
not yet been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, will not be amended. The Transferred

41107

Shares grant to QLT USA, Inc. as of the beginning of Atrix S.à r.l.'s current business year the right of participation in the
benefit of Atrix S.à r.l.

2.4 A compensation offer according to § 122i para. 1 UmwG will not be submitted since all the shareholders of Atrix

GmbH have agreed upon the merger plan. A compensation payment (soulte) as defined in article 259 of the LSC will not
be paid.

<i>3. Special rights and advantages

3.1 No rights as defined in § 122c para. 2 no. 7 UmwG are granted to shareholders having special rights or to holder

of securities other than company's shares and no measures are planned with regard to this provision for such persons.
Atrix S.à r.l. did not issue on the effective Date of the Merger any shares granting special rights, bonds of debt, (convertible)
notes or any other securities that are not shares.

3.2 None of the companies grant special advantages as defined in § 122c para. 2 no. 8 UmwG and/or article 261 (2)

(g) of the LSC to members of the administrative, management, supervisory, or controlling bodies and to experts who
analyse the merger plan.

3.3 The shareholders of the Merging Companies have within the period of one month beginning with the publication

of this merger plan in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations the right to review the documents listed
under articles 267 (1) a), b), c), d), e) of the LSC on the registered addresses of the companies. A copy of these documents
will be provided upon request to each shareholder.

<i>4. Consequences of the merger for the employment (employees and their representations)

4.1 Atrix GmbH as well as Atrix S.à r.l. do not have employees.
4.2 No changes of the companies' businesses are scheduled due to the merger at present.
4.3 The involved companies neither dispose of work counsels nor of a supervisory board subject to employees par-

ticipation.

<i>5. Articles of association of the acquiring company

The valid articles of association of Atrix S.à r.l. are attached to this deed as Annex 1.

<i>6. Information concerning the valuation of the assets and liabilities

For financial statements, the merger is carried out for the current value (§ 122c para. 2 no. 11 UmwG).

<i>7. Approval requirements

This merger plan has to be approved by the shareholders' meeting of Atrix S.à r.l. as well as the shareholders' meeting

of Atrix GmbH.

<i>8. Costs

External costs of Atrix GmbH, which occur in connection with the merger plan, in particular costs regarding the release

of a pre-merger certificate, the application and registration in the competent commercial register as well as costs for the
arrangement of the resolution on the merger or any other required resolutions in connection with the merger will be
borne by Atrix S.à r.l.

<i>9. Final provisions

9.1 This merger plan is subject to Luxembourg laws unless German laws apply pursuant to the Directive or Luxembourg

laws refer to German laws with respect to the cross-border merger.

9.2 In case of disputes resulting from or in connection with this merger plan or regarding its validity, the sole place of

jurisdiction shall be - as far as admissible by law - Luxembourg.

9.3 Modifications of and amendments to this merger plan or to its appendixes require written form unless the form

of notarization is required. This shall also apply to any waiver with respect to this requirement of written form.

9.4 Should single provisions of this merger plan be or become entirely or partially invalid or unenforceable or in the

event of a gap, the other provisions of this merger plan remain effective. The Parties to this merger plan shall be obliged
to replace the invalid or unenforceable provisions and to fill the gap by those provisions which correspond as closely as
possible to the intention of the Parties or what would have been the intention of the Parties according to this merger
plan, if they had considered the invalidity, unenforceability or the gap.

9.5 The German wording of this deed shall be legally relevant. An English translation of this deed has been added for

information purposes only.

ANNEX 1: ARTICLES OF ASSOCIATION OF ATRIX S.À R.L.

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owner of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Atrix Luxembourg S.à r.l." (the
"Company").

41108

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose
3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting

of twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of 1 euro (EUR 1) each. Under the terms and conditions
provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

41109

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the
shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders rep-
resenting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders
9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of

holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the

municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

41110

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced injudicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone

or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and removal of managers and term of the office
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.

16.3  Any  manager  shall  hold  office  until  its/his/her  successor  is  elected.  Any  manager  may  also  be  re-elected  for

successive terms.

41111

Art. 17. Convening meetings of the board of managers
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at

a meeting of the board of managers.

18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting

of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced injudicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole

signature of any member of the board of managers or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or
by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or
by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the
power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and
the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s)
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

41112

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 23. Profits
23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the

remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment

of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds
are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year
for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves
available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements
of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the
board of managers that the first two conditions haven been satisfied.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

Per procuratio
Signatures

Référence de publication: 2009047032/250/766.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2009, réf. LSO-DD04708. - Reçu 68,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

Filipeservice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8095 Bertrange, 23, Cité Henri Dunant.

R.C.S. Luxembourg B 141.881.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le dix-huit mars.
Pardevant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch,

41113

Ont comparu:

1. Monsieur Giulio ZANASI, commerçant, né à Modena (Italie) le 1 

er

 juin 1964, matricule n° 1964 06 01 798, demeurant

à I-41100 Modena (Italie), 33, Viale Paolo Gaddl;

2. Monsieur Rui Manuel OLIVEIRA FILIPE, ouvrier, né à Figueira da Foz (Portugal) le 19 décembre 1965, demeurant à

L-5371 Schuttrange, 12, an der Uecht,

Lesquels comparants ont prié le notaire d'acter que:
Le dix-sept septembre deux mille huit fut constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire, la société anonyme

FILIPESERVICE S.A., avec siège social à L-8095 Bertrange, 23, Cité Henri Dunant dont les statuts furent publiés au Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2499 du 13 octobre 2008, numéro RSC Luxembourg,
B141881,

La société "FILIPESERVICE S.A." a actuellement un capital social trente et un mille (31 000) euros, représenté par trois

cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent (100) euros chacune, entièrement libérées.

Les comparants sont propriétaires de la totalité des actions de la société "FILIPESERVICE S.A.".
Par la présente les comparants en tant qu'actionnaires prononcent la dissolution anticipée de la société "FILIPESERVICE

S.A." avec effet immédiat.

Les comparants déclarent qu'ils ont pleine connaissance des statuts de la société et qu'ils connaissent parfaitement la

situation financière de la société.

Les comparants, agissant en leur qualité de liquidateurs de la prédite société déclarent que l'activité de la société a

cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que les actionnaires s'engagent expressément à
prendre à leur charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à
ce jour avant tout payement à leur personne; partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Les actionnaires donnent décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à

ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans auprès de Monsieur Rui

Manuel OLIVEIRA FILIPE, prénommé.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société "FILIPESERVICE S.A.".

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Zanasi, Oliveira Filipe, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2009. Relation: DIE/2009/2922. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Ries.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations.

Diekirch, le 26 mars 2009.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2009044652/234/44.
(090051738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.233.

In the year two thousand and nine, on the tenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

Tishman  Speyer  ESOF  Holdings  (Luxembourg)  S.à  r.l.,  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité

limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 113.349,

here represented by Ms Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue

of a proxy established on May 30th, 2008. The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities. Such appearing party, through
its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à r.l. (the "Company"),

a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, number 121.233, having its registered

41114

office  at  1B,  Heienhaff,  L-1736  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  incorporated  pursuant  to  a  deed  of  the
undersigned Notary, on October 23rd, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2349,
dated December 16th, 2006, and which bylaws have been lastly amended by extraordinary general meeting held in front
of the undersigned notary on January 25th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 653 dated April 19th, 2007.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg to 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of registered office, the 1st paragraph of article 5 of the Company's articles of

association is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Luxembourg. "

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six hundred Euro (€ 600.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary who

understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded
in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Tishman Speyer ESOF Holdings (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité régie par les lois luxembourgeoises,

ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 113.349,

ici représenté par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 mai 2008. Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par
le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en
même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à r.l. (la "Société"), une société

a responsabilité limitée régie par les lois luxembourgeoises, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg section B, sous le numéro 121.233 et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, constituée
par un acte du notaire instrumentaire reçu en date du 23 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, n° 2349, en date du 16 décembre 2006. et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par une
assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire instrumentant le 25 janvier 2007, publiée au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 653 du 19 avril 2007.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 34-38,

avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social ci-dessus, le 1 

er

 paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour

avoir désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier paragraphe). Le siège social de la Société est établi à Luxembourg."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents Euro (€ 600,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

41115

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 mars 2009. Relation: LAC/2009/9816. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009045212/211/84.
(090052316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.050.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 119.859.

In the year two thousand and nine, on the tenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

Tour Esplanade (Paris) L.P., a limited partnership established under the laws of England, having its principal place of

business at St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom, represented by its general partner
TS  Tour  Esplanade  (GP)  L.L.C.,  a  limited  liability  company  incorporated  and  existing  under  the  laws  of  the  State  of
Delaware (United States of America), having its registered office at National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover, DE 19904, County of Kent, Delaware, United States of America

here represented by Ms Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue

of a proxy established on May 30th, 2008. The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

existing in Luxembourg under the name of TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg) S.à r.l. (the "Company"), having
its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Re-
gister section B under number 119.859, incorporated by a deed of the undersigned notary of August 25th, 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2129, of November 15th, 2006, and which bylaws have been
last amended by a deed of the undersigned notary of September 4th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n° 2181 of November 22nd, 2006.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg to 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of registered office, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of

association is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Luxembourg. "

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six hundred Euro (€ 600.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarized deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

41116

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Tour Esplanade (Paris) L.P., un limited partnership régi par les lois de l'Angleterre, ayant son lieu principal d'activité à

St Catherine's House, 14 Kingsway, Londres WC2B 6LH, Royaume-Uni, représenté par son general partner TS Tour
Esplanade (GP) L.L.C., une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique),
ayant son siège social à National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, County of
Kent, Delaware, Etats-Unis d'Amérique.

ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 mai 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietuf par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg), S.à r.l. (la "Société"), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro
119.859, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 25 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2129 du 15 novembre 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
par acte du notaire soussigné en date du 4 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2181 du 22 novembre 2006.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 34-38,

avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié

pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier paragraphe). Le siège social de la Société est établi à Luxembourg."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents Euro (€ 600,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 mars 2009. Relation: LAC/2009/9820. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations

Luxembourg, le 23 mars 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009045218/211/87.
(090052268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Zach &amp; Rubensun Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 140.787.

L'an deux mille neuf, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Zach &amp; Rubensun Group

S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges

41117

d'Huart, de résidence à Pétange, en date du 25 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2097, du 29 août 2008,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.787,
L'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée ouverte à 14.15 heures et est présidée par Monsieur Gontran

STIERNON, conseiller économique, demeurant à B-1380 Lasne (Belgique), 1, Clos Trou du Renard, qui assume également
les fonctions de secrétaire.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane RIOULT, administrateur de sociétés, demeurant à F-44300

Nantes (France), 3, rue du Docteur Roux.

Le Bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:
1) Extension de l'objet social et modification de l'article 2 afférent des statuts par adjonction d'un alinéa nouveau entre

les alinéas 2 et 3 actuels, comme suit:

Art. 2. (alinéa nouveau). La société a également pour objet la vente en gros de matériels et équipements dans le

domaine du bâtiment."

2) Acceptation de la démission du commissaire aux comptes la société "Expert Us sprl".
3) Nomination en qualité de nouveau commissaire aux comptes, la société "MONEYLIFT SA".
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'étendre l'objet social et de modifier l'article 2 afférent des statuts par adjonction d'un alinéa

nouveau entre les alinéas 2 et 3 actuels, comme suit:

Art. 2. (alinéa nouveau). La société a également pour objet la vente en gros de matériels et équipements dans le

domaine du bâtiment."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes la société "Expert Us sprl", ayant son siège social

à B-1070 Bruxelles (Belgique), 11B, boulevard Paepsem, et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L'assemblée nomme en qualité de commissaire aux comptes pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2014: la société "MONEYLIFT S.A.", ayant son siège social à L-1463 Luxembourg, 29, rue du
Fort Elisabeth, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 96.010.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.45 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.050,- €.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Stiernon, Rioult, M.Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 mars 2009. Relation: LAC/2009/11871. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

41118

Hesperange, le 6 avril 2009.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2009045214/241/62.
(090052313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

FKI Luspartwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 73.137.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54723 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045513/211/12.
(090052497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Tishman Speyer Caffamacherreihe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.329.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.234.

In the year two thousand and nine, on the tenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

incorporated and existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 121.233,

here represented by Ms Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue

of a proxy established on May 30th, 2008. The said proxy, signed une varietur" by the person appearing and the under-
signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of Tishman Speyer Caffamacherreihe S.à r.l. (the "Company"), a private

limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  incorporated  and  existing  under  the  laws  of  Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, number 121.234, having its registered office
at 1B, Heienhaff, L-1736 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
Notary, on October 23rd, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2349, dated
December 16th, 2006, and which bylaws have been lastly amended by an extraordinary general meeting held in front of
the undersigned notary on January 25th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
653 dated April 19th, 2007.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg to 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of registered office, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of

association is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Luxembourg. "

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six hundred Euro (€ 600.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

41119

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à r.l., une société à responsabilité régie par les lois luxembourgeoises,

ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 121.233,

ici représenté par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 mai 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de Tishman Speyer Caffamacherreihe S.à r.l. (la "Société") une société à respon-

sabilité limitée régie par les lois luxembourgeoises, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
section B, sous le numéro 121.234 et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, constituée par un
acte du notaire instrumentaire reçu constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 octobre 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2349 en date du 16 décembre 2006, et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois par une assemblée générale tenue devant le notaire instrumentaire le 25 janvier
2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 653 du 19 avril 2007.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 34-38,

avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié

pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier paragraphe). Le siège social de la Société est établi à Luxembourg."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents Euros (€ 600,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 mars 2009. Relation: LAC/2009/9817. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009045208/211/84.
(090052320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Centaur Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 130.884.600,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 116.538.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 23 mai 2008 entre Monkwood Luxco S.à r.l., Guido Zuchi, Russell

Dale Owens, Jesús Fernandez Moràn et Isodoro Diez Caveda, les parts sociales de la Société, entre ces associés seulement
sont réparties comme suit:

41120

Guido Zucchi, né le 19 septembre 1962, à Pavia, en Italie, domicilié C Albacete 00022, Bajo B, 28223 Los Angeles

(Pozuelo de Alarco), Madrid, en Espagne, détient:

692 parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie D1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie E1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie F1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie G1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie H1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie I1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
Russell Dale Owens, né le 13 février 1959 en Californie, Etats-Unis, domicilié 3207 W Ball Road 10, CA92804-3769

Anaheim en Californie, Etats-Unis, détient:

407 parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
327 parts sociales de catégorie D1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
327 parts sociales de catégorie E1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
327 parts sociales de catégorie F1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
327 parts sociales de catégorie G1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
327 parts sociales de catégorie H1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
327 parts sociales de catégorie I1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.-
Jesús Fernadez Moran, né le 02 janvier 1966 à Cartagena en Espagne, domicilié C/Encinar 135, Bajo Las Matas, 28290

Las Rozas de Madrid, à Madrid, en Espagne, détient:

484 parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
389 parts sociales de catégorie D1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
389 parts sociales de catégorie E1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
389 parts sociales de catégorie F1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
389 parts sociales de catégorie G1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
389 parts sociales de catégorie H1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
389 parts sociales de catégorie I1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
Isidoro Diez Caveda, né le 06 décembre 1971 à Cadiz, en Espagne, domicilié C/ San Luis Gonzaga 8, 28229 Villanueva

del Pardillo à Madrid, en Espagne, détient:

692 parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie D1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie E1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie F1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie G1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie H1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
556 parts sociales de catégorie I1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
Monkwood Luxco S.à r.l. enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro

B117.178 et dont le siège social se situe 46A Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg, détient:

986 parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
793 parts sociales de catégorie D1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
793 parts sociales de catégorie E1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
793 parts sociales de catégorie F1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
793 parts sociales de catégorie G1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
793 parts sociales de catégorie H1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
793 parts sociales de catégorie I1 d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Centaur Luxco S.à r.l.
Frank Welman / Signature
<i>Gérant A

Référence de publication: 2009044811/683/62.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2009, réf. LSO-DC07831. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

41121

Aerolink International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.438.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendneun, den zweiten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung AVITEC, S.à r.l., Handelsregisternummer B 96.356, mit Sitz in L-1413 Lu-

xemburg, 1, place Dargent, vertreten durch seine Geschäftsführerin, die Aktiengesellschaft SOMATEC S.A., Handelre-
gisternummer  B  93.940,  mit  Sitz  in  L-1413  Luxemburg,  1,  place  Dargent,  sie  wiederum  vertreten  durch  ihren
Administrateur-délégué, Herrn Pierre THOLL, Ingénieur industriel, wohnhaft in L-7214 Bereldange, 29, rue Bellevue,
welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann.

Die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, erklärt:
1) Dass die Gesellschaft AEROLINK INTERNATIONAL S.à r.l., mit Sitz in L-1930 Luxemburg, 68, avenue de la Liberté,

eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Nummer B 132.438, gegründet wurde gemäss
Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 6. September 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C vom 8. November 2007, Nummer 2532.

2) Dass das Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500,-) hat und eingeteilt ist in fünfhundert (500) Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

3) Dass sie der alleinige Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist.
4) Dass sie, als einziger Gesellschafter ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2008

auflösen zu wollen.

5) Dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft AEROLINK INTERNATIONAL S.à r.l.

besitzt;

6) Dass sie den Geschäftsführern Entlastung erteilt für die Ausübung ihrer Mandate;
7) Dass sie alle verbleibenden Aktiva und Passiva der vorgenannten Gesellschaft AEROLINK INTERNATIONAL S.à

r.l. übernommen hat und somit frei darüber verfügen kann, und dass sie hiermit die Auflösung dieser Gesellschaft bes-
chliesst,  die  damit  definitiv  abgeschlossen  ist,  unter  Vorbehalt  der  Übernahme  aller  eventuellen  Verpflichtungen  der
Gesellschaft durch die Unterzeichnete.

Somit ist deren Liquidation mit Wirkung zum 31. Dezember 2008 beendet.
Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in L-1413 Lu-

xemburg, 1, place Dargent, aufbewahrt bleiben werden.

Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft AEROLINK INTERNATIONAL S.à r.l.,

vorgenannt, mit Wirkung zum 31. Dezember 2008 festgestellt.

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Pierre Tholl, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 03 mars 2009. LAC / 2009 / 8043. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 17. März 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009044647/202/46.
(090051699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

Eiffel Properties Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.418.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

41122

Luxembourg.

<i>Pour Eiffel Properties Luxembourg S.à r.l.
Stéphane HEPINEUZE
<i>Gérant

Référence de publication: 2009044711/1084/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01350. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

TS Nautilus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.692.

In the year two thousand and nine, on the tenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

TS Nautilus L.P., a limited partnership organized under the laws of England, having its registered office at St. Catherine's

House, 14 Kingsway, London WC2 6LH, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and
Wales under number LP11653, represented by its general partner TS Nautilus (GP), L.L.C., a limited liability company
incorporated under the laws of Delaware (United States of America), with its registered office at National Registered
Agents Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, County of Kent, Delaware, but with principal place of
business at 45 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111, United States of America,

here represented by Ms Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue

of a proxy established on May 30th, 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

established in Luxembourg under the name of TS Nautilus Holdings S.à r.l. ( the "Company"), having its registered office
at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under
number 120.692, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on October 2nd, 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2274, on December 6th, 2006, which bylaws have been last
amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 27th, 2006 and published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 434, dated of March 22nd, 2007.

II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg to 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Pursuant to the above transfer of registered office, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of

association is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. first ( paragraph). The registered office of the Company is established in Luxembourg. "

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six hundred Euro (€ 600,-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary who

understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded
in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarized deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

41123

A comparu:

TS Nautilus L.P., un limited partnership de droit anglais, ayant son siège social à St. Catherine's House, 14 Kingsway,

London WC2 6LH, Royaume-Uni, enregistré auprès du Registrar of Company for England and Wales sous le numéro LP
11653, représenté par son general partner, TS Nautilus (GP), L.L.C., une société régie par les lois du Delaware (Etats-
Unis d'Amérique), ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of
Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, et son lieu d'activité principal au 45 Rockefeller
Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 mai 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de TS Nautilus Holdings S.à r.l. (la "Société"), une société a responsabilité limitée

régie par les lois luxembourgeoises,, ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 120.692, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 2 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2274, du 6 décembre 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 27
décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 434, du 22 mars 2007.

II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 34-38,

avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

III. Suite au transfert du siège social ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié

pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier paragraphe). Le siège social de la Société est établi à Luxembourg."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents Euro (€ 600,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 mars 2009. Relation: LAC/2009/9821. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009045216/211/88.
(090052276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

CalEast Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 333.175,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.711.

In the year two thousand and nine, on the sixth of March.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

CalEast Europe L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Scotland, having its registered office at 66

Hanover Street, Edinburgh, EH2 1HH, Scotland and registered with the United Kingdom Companies House under number
SL005675 and acting through LaSalle European Advisers LLC as its general partner,

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue Zénon

Bernard, Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy established on February 2009.

41124

The said proxy, initialled "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

existing in Luxembourg under the name of "CalEast Holdings" (the "Company") with registered office at 41, Avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.711,
incorporated by virtue of a deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated March 6 

th

 , 2006 and

published in the Memorial C number 1009 of May 23 

rd

 , 2006.

II. The articles of association of the Company were modified several times and for the last time by virtue of a deed of

Me Jean-Joseph Wagner, notary prenamed, dated March 21 

st

 , 2007 and published in the Memorial C number 1236 of

June 22 

nd

 , 2007.

III. The Company's share capital is fixed at one hundred sixty-eight thousand seven hundred twenty-five Euro (EUR

168,725.-) represented by six thousand seven hundred forty-nine (6,749) shares with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each, all of which are fully paid-up.

IV. The sole shareholder resolves to convert all of its six thousand seven hundred forty-nine (6,749) existing shares

into Series 1 Shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

V. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of one hundred sixty-four

thousand four hundred fifty Euro (EUR 164,450.-) to raise it from its present amount of one hundred sixty-eight thousand
seven hundred twenty-five Euro (EUR 168,725.-) to three hundred thirty-three thousand one hundred seventy-five Euro
(EUR 333,175.-) by creation and issue of respectively two hundred thirty-nine (239) Series 1 Shares to be paid up together
with a share premium in the total amount of five hundred twenty-five Euro and sixty-seven Euro cents (EUR 525.67), six
thousand three hundred twelve (6,312) Series 2 Shares to be paid up together with a share premium in the total amount
of four hundred eighty-seven Euro and seventy-three Euro cents (EUR 487.73) and twenty-seven (27) Series 3 Shares to
be paid up together with a share premium in the total amount of two Euro and eighteen Euro cents (EUR 2.18), being at
total of six thousand five hundred seventy-eight (6,578) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each.

<i>Subscription - Payment

CalEast Europe, LP., prenamed, declared to subscribe for:
- all the two hundred thirty-nine (239) new Series 1 Shares, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)

each, and fully pay them up in the nominal amount of five thousand nine hundred seventy-five Euro (EUR 5,975.-) together
with a share premium in the total amount of five hundred twenty-five Euro and sixty-seven Euro cents (EUR 525.67)
which will remain attached to the Series 1 Shares, for a total contribution of six thousand five hundred Euro and sixty-
seven Euro cents (EUR 6,500.67), by contribution in kind consisting in the conversion of.

* a receivable in the amount of thirteen Euro and nineteen Euro cents (EUR 13.19) held by CalEast Europe, L.P. towards

the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, L.P. and the Company on July
11, 2008 whereby CalEast Europe, L.P. lent to the Company an amount of thirteen Euro and nineteen Euro cents (EUR
13.19),

* a receivable in the amount of forty-five Euro and two Euro cents (EUR 45.02) held by CalEast Europe, L.P. towards

the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, L.P. and the Company on July
11, 2008 whereby CalEast Europe, L.P. lent to the Company an amount of forty-five Euro and two Euro cents (EUR
45.02),

* a receivable in the amount of six Euro and twenty-one Euro cents (EUR 6.21) held by CalEast Europe, LP. towards

the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. and the Company on July
11, 2008 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of six Euro and twenty-one Euro cents (EUR
6.21),

* a receivable in the amount of ten Euro and three Euro cents (EUR 10.03) held by CalEast Europe, LP. towards the

Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. and the Company on August
1, 2008 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of ten Euro and three Euro cents (EUR 10.03),

* a receivable in the amount of fifty Euro (EUR 50.-) held by CalEast Europe, LP. towards the Company by virtue of

an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. and the Company on August 4, 2008 whereby CalEast
Europe, LP. lent to the Company an amount of fifty Euro (EUR 50.-),

* a receivable in the amount of twenty-five Euro (EUR 25.-) held by CalEast Europe, LP. towards the Company by

virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. and the Company on December 19, 2008
whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of twenty-five Euro (EUR 25.-),

* a receivable in the amount of six thousand three hundred fifty-one Euro and twenty-two Euro cents (EUR 6,351.22)

held by CalEast Europe, LP. towards the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast
Europe, LP. and the Company on February 9, 2009 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of six
thousand three hundred fifty-one Euro and twenty-two Euro cents (EUR 6,351.22);

41125

- all the six thousand three hundred twelve (6,312) Series 2 Shares, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR

25.-) each, and fully pay them up in the nominal amount of one hundred fifty-seven thousand eight hundred Euro (EUR
157,800.-) together with a share premium in the total amount of four hundred eighty-seven Euro and seventy-three Euro
cents (EUR 48773) which will remain attached to the Series 2 Shares, for a total contribution of one hundred fifty-eight
thousand two hundred eighty-seven Euro and seventy-three Euro cents (EUR 158,287.73), by contribution in kind con-
sisting of:

* a receivable in the amount of thirty-two Euro and sixty-one Euro cents (EUR 32.61) held by CalEast Europe, LP.

towards the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. and the Company
on July 11, 2008 whereby CalEast Europe, LP, lent to the Company an amount of thirty-two Euro and sixty-one Euro
cents (EUR 32.61),

* a receivable in the amount of thirteen thousand three hundred eighty Euro and thirty-four Euro cents (EUR 13,380.34)

held by CalEast Europe, LP. towards the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast
Europe, LP. and the Company on July 11, 2008 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of thirteen
thousand three hundred eighty Euro and thirty-four Euro cents (EUR 13,380.34),

* a receivable in the amount of one hundred sixty-three Euro and seventy Euro cents (EUR 163.70) held by CalEast

Europe, LP. towards the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. and
the Company on August 28, 2008 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of one hundred sixty-
three Euro and seventy Euro cents (EUR 163.70),

* a receivable in the amount of six thousand three hundred four Euro and ninety-seven Euro cents (EUR 6,304.97)

held by CalEast Europe, LP. towards the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast
Europe, LP. and the Company on October 22, 2008 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of six
thousand three hundred four Euro and ninety-seven Euro cents (EUR 6,304.97),

* a receivable in the amount of twelve thousand seven hundred fifty-seven Euro and fifty Euro cents (EUR 12,757.50)

held by CalEast Europe, LP. towards the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast
Europe, LP. and the Company on October 22, 2008 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of
twelve thousand seven hundred fifty-seven Euro and fifty Euro cents (EUR 12,757.50),

* a receivable in the amount of eight hundred eleven Euro and fifteen Euro cents (EUR 811.15) held by CalEast Europe,

LP. towards the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. and the
Company on November 20, 2008 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of eight hundred eleven
Euro and fifteen Euro cents (EUR 811.15),

* a receivable in the amount of twelve thousand eighty-one Euro (EUR 12,081.-) held by CalEast Europe, LP. towards

the Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. And the Company on
December 22, 2008 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of twelve thousand eighty-one Euro
(EUR 12,081.-),

* a receivable in the amount of one hundred twelve thousand seven hundred fifty-six Euro and forty-six Euro cents

(EUR 112,756.46) held by CalEast Europe, LP. towards the Company by virtue of an interest free loan agreement entered
into by CalEast Europe, LP. and the Company on February 9, 2009 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an
amount of one hundred twelve thousand seven hundred fifty-six Euro and forty-six Euro cents (EUR 112,756.46);

- all the twenty-seven (27) Series 3 Shares, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pay

it up in the nominal amount of six hundred seventy-five Euro (EUR 675.-) together with a share premium in the total
amount of two Euro and eighteen Euro cents (EUR 2,18), which will remain attached to the Series 3 Shares, for a total
contribution of six hundred seventy-seven Euro and eighteen Euro cents (EUR 677.18), by contribution in kind consisting
of:

* a receivable in the amount of two Euro and eighteen Euro cents (EUR 2.18) held by CalEast Europe, LP. towards the

Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. and the Company on July 11,
2008 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of two Euro and eighteen Euro cents (EUR 2.18);

* a receivable in the amount of six hundred seventy-five Euro (EUR 675.-) held by CalEast Europe, LP. towards the

Company by virtue of an interest free loan agreement entered into by CalEast Europe, LP. and the Company on February
9, 2009 whereby CalEast Europe, LP. lent to the Company an amount of six hundred seventy-five Euro (EUR 675.-).

The evidence of the existence and value of such receivables has been given to the Company by a copy of the above-

mentioned interest free loan agreements, which copies initialled "ne varietur" by the person appearing and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Managers' intervention

Thereupon intervened the managers of the company, duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, pren-

amed, who require the notary to act as follows: to acknowledge having been previously informed of the extent of their
responsibility, legally engaged as managers of the company by reason of the contributions in kind described above, ex-
pressly agree with the description of these contributions, with their valuation, and confirm the validity of the subscriptions
and payments.

41126

VI. Pursuant to the above share capital increase, article 5, first paragraph, of the Company's articles of association is

amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. The Company's share capital is set at three hundred thirty-three thousand one hundred seventy-five Euro

(EUR 333,175.-) represented by six thousand nine hundred eighty-eight (6,988) Series 1 Shares, six thousand three hun-
dred twelve (6,312) Series 2 Shares, and twenty-seven (27) Series 3 Shares, being a total of thirteen thousand three
hundred twenty-seven (13,327) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present shareholder's resolutions are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six mars.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

CalEast Europe, L.P., un limited partnership constitué et existant en vertu des lois écossaises, enregistré auprès du

registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro SL005675, ayant son siège social au 66 Hanover Street, Edinbourg,
EH2 1HH, Ecosse, agissant par son general partner LaSalle European Advisers LLC,

ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5,

rue Zénon Bernard, Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée en février 2009.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

"CalEast Holdings" (la "Société"), ayant son siège social au 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.711, constituée en vertu d'un
acte de Me Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, daté du 6 mars 2006 et publié au Mémorial C numéro
1009 du 23 mai 2006.

II. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois en vertu d'un acte de Me Jean-Joseph

Wagner, notaire prénommé, daté du 21 mars 2007 et publié au Mémorial C numéro 1236 du 22 juin 2007.

III. Le capital social de la Société est fixé à cent soixante-huit mille sept cent vingt-cinq Euro (EUR 168.725,-) divisé en

six mille sept cent quarante-neuf (6.749) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

IV. L'associé unique décide de convertir toutes ses six mille sept cent quarante-neuf (6.749) parts sociales existantes

en parts sociales de Série 1 d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

V. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent soixante-quatre mille

quatre cent cinquante Euro (EUR 164.450,-) pour le porter de son montant actuel de cent soixante-huit mille sept cent
vingt-cinq Euro (EUR 168.725,-) à trois cent trente-trois mille cent soixante-quinze Euro (EUR 333.175,-) par la création
et l'émission de deux cent trente-neuf (239) parts sociales de Série 1 à libérer avec une prime d'émission d'un montant
total de cinq cent vingt-cinq Euro et soixante-sept centimes (EUR 525,67), six mille trois cent douze (6.312) parts sociales
de Série 2 à libérer avec une prime d'émission d'un montant total de quatre cent quatre-vingt-sept Euro et soixante-treize
centimes (EUR 487,73), et vingt-sept (27) parts sociales de Série 3 à libérer avec une prime d'émission d'un montant total
de deux Euro et dix-huit centimes (EUR 2,18), représentant un total de six mille cinq cent soixante-dix-huit (6,578)
nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

CalEast Europe, L.P. susnommé, déclare souscrire:
- Toutes les deux cent trente-neuf (239) nouvelles parts sociales de Série 1 d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro

(EUR 25,-) chacune, et les libérer intégralement en valeur nominale pour un montant de cinq mille neuf cent soixante-
quinze Euro (EUR 5.975,-) avec une prime d'émission d'un montant total de cinq cent vingt-cinq Euro et soixante-sept

41127

centimes (EUR 525,67) qui restera liée aux parts sociales de Série 1, pour un montant total de six mille cinq cent Euro
et soixante-sept centimes (EUR 6,500.67) par apport en nature consistant en la conversion:

* d'une créance d'un montant de treize Euro et dix-neuf centimes (EUR 13,19) détenue par CalEast Europe, L.P. envers

la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 11 juillet 2008, par
lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de treize Euro et dix-neuf centimes (EUR 13,19),

* d'une créance d'un montant de quarante-cinq Euro et deux centimes (EUR 45,02) détenue par CalEast Europe, L.P.

envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 11 juillet 2008,
par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de quarante-cinq Euro et deux centimes (EUR 45,02),

* d'une créance d'un montant de six Euro et vingt-et-un centimes (EUR 6,21) détenue par CalEast Europe, L.P. envers

la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 11 juillet 2008, par
lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de six Euro et vingt-et-un centimes (EUR 6,21),

* d'une créance d'un montant de dix Euro et trois centimes (EUR 10,03) détenue par CalEast Europe, L.P. envers la

Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 1 

er

 août 2008, par

lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de dix Euro et trois centimes (EUR 10,03),

* d'une créance d'un montant de cinquante Euro (EUR 50,-) détenue par CalEast Europe, L.P. envers la Société en

vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 4 août 2008, par lequel CalEast
Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de cinquante Euro (EUR 50,-),

* d'une créance d'un montant de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) détenue par CalEast Europe, L.P. envers la Société en

vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 19 décembre 2008, par lequel
CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de vingt-cinq Euro (EUR 25,-),

* d'une créance d'un montant de six mille trois cent cinquante et un Euro et vingt-deux centimes (EUR 6.351,22)

détenue par CalEast Europe, L.P. envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe,
L.P. et la Société le 9 février 2009, par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de six mille trois cent
cinquante et un Euro et vingt-deux centimes (EUR 6.351,22);

- toutes les six mille trois cent douze (6.312) nouvelles parts sociales de Série 2 d'une valeur nominale de vingt-cinq

Euro (EUR 25,-) chacune, et les libérer intégralement en valeur nominale pour un montant de cent cinquante-sept mille
huit cents Euro (EUR 157.800,-) avec une prime d'émission d'un montant total de quatre cent quatre-vingt-sept Euro et
soixante-treize centimes (EUR 487,73) qui restera liée aux parts sociales de Série 2, pour un montant total de cent
cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-sept Euro et soixante-treize centimes (EUR 158.287,73) par apport en nature
consistant en la conversion:

* d'une créance d'un montant de trente-deux Euro et soixante-et-un centimes (EUR 32,61) détenue par CalEast Europe,

L.P. envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 11 juillet
2008, par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de trente-deux Euro et soixante-et-un centimes (EUR
32,61),

* d'une créance d'un montant de treize mille trois cent quatre-vingts Euro et trente-quatre centimes (EUR 13.380,34)

détenue par CalEast Europe, L.P. envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe,
L.P. et la Société le 11 juillet 2008, par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de treize mille trois cent
quatre-vingts Euro et trente-quatre centimes (EUR 13.380,34),

* d'une créance d'un montant de cent soixante-trois Euro et soixante-dix centimes (EUR 163,70) détenue par CalEast

Europe, L.P. envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le
28 août 2008, par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de cent soixante-trois Euro et soixante-dix
centimes (EUR 163,70),

* d'une créance d'un montant de six mille trois cent quatre Euro et quatre-vingt-dix-sept centimes (EUR 6.304,97)

détenue par CalEast Europe, L.P. envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe,
L.P. et la Société le 22 octobre 2008, par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de six mille trois cent
quatre Euro et quatre-vingt-dix-sept centimes (EUR 6.304,97),

* d'une créance d'un montant de douze mille sept cent cinquante-sept Euro et cinquante centimes (EUR 12.757,50)

détenue par CalEast Europe, L.P. envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe,
L.P. et la Société le 22 octobre 2008, par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de douze mille sept
cent cinquante-sept Euro et cinquante centimes (EUR 12.757,50),

* d'une créance d'un montant de huit cent onze Euro et quinze centimes (EUR 811,15) détenue par CalEast Europe,

L.P. envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 20 novembre
2008, par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de huit cent onze Euro et quinze centimes (EUR
811,15),

* d'une créance d'un montant de douze mille quatre-vingt-un Euro (EUR 12.081,-) détenue par CalEast Europe, L.P.

envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 22 décembre
2008, par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de douze mille quatre-vingt-un Euro (EUR 12.081,-),

*  d'une  créance  d'un  montant  de  cent  douze  mille  sept  cent  cinquante-six  Euro  et  quarante-six  centimes  (EUR

112.756,46) détenue par CalEast Europe, L.P. envers la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par

41128

CalEast Europe, L.P. et la Société le 9 février 2009, par lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de cent
douze mille sept cent cinquante-six Euro et quarante-six centimes (EUR 112.756,46);

- toutes les vingt-sept (27) nouvelles parts sociales de Série 3 d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-)

chacune, et les libérer intégralement en valeur nominale pour un montant de six cent soixante-quinze Euro (EUR 675,-)
avec une prime d'émission d'un montant total de deux Euro et dix-huit centimes (EUR 2,18) qui restera liée aux parts
sociales de Série 3, pour un montant total de six cent soixante-dix-sept Euro et dix-huit centimes (EUR 677,18) par apport
en nature consistant en la conversion:

* d'une créance d'un montant de deux Euro et dix-huit centimes (EUR 2,18) détenue par CalEast Europe, L.P. envers

la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P, et la Société le 11 juillet 2008, par
lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de deux Euro et dix-huit centimes (EUR 2,18),

* d'une créance d'un montant de six cent soixante-quinze Euro (EUR 675,-) détenue par CalEast Europe, L.P. envers

la Société en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt conclu par CalEast Europe, L.P. et la Société le 9 février 2009, par
lequel CalEast Europe, L.P. a prêté à la Société la somme de six cent soixante-quinze Euro (EUR 675,-).

La justification de l'existence et du montant des dites créances a été rapportée à la Société par la production d'une

copie des contrats de prêt sans intérêts susmentionnés, lesquelles copies après avoir été paraphées "ne varietur" par le
mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrée en
même temps.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, susnommée,

qui prient le notaire d'acter que: Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité,
légalement engagés en leur qualité de gérants de la Société en raison des apports en nature décrits ci-dessus, ils consentent
expressément à la description des apports en nature, sur leur évaluation et confirment la validité des souscriptions et des
libérations.

VI. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5, premier paragraphe, des statuts de la Société est modifié pour

avoir désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de trois cent trente-trois mille cent soixante-quinze Euro

(EUR 333.175,-) représenté par six mille neuf cent quatre-vingt-huit (6.988) parts sociales de Série 1, six mille trois cent
douze (6.312) parts sociales de Série 2, et vingt-sept (27) parts sociales de Série 3, représentant un total de treize mille
trois cent vingt-sept (13,327) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-). Le notaire
soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le

présent acte,

Signé: Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 mars 2009. Relation: EAC/2009/2841. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 mars 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009045804/219/291.

(090052906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.

41129

Brinkman Trans Holland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg B 129.978.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts intervenue le 19 décembre 2008 que la société AST HOLDING B.V. a cédé

la totalité de ses parts (125) à la société GLOBAL LOGISTIC GROUP HOLDING B.V. ayant son siège social à NL-7825GC
EMMEN, Curiestraat, 2.

Luxembourg, le 27 mars 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009045449/535/17.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2009, réf. LSO-DD00328. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090052008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Dexia Global, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.727.

L'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 20 mars 2009 a décidé:
- de noter la démission de Monsieur Hugo LASAT de son mandat d'administrateur avec effet au 31 janvier 2009,
- de ratifier la cooptation avec effet au 6 février 2009, de Monsieur Jean-Yves MALDAGUE, Président du Comité de

Direction et administrateur, Dexia Asset Management Luxembourg, 136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

- de renouveler les mandats en date du 20 mars 2009 de:
Monsieur Naïm ABOU JAOUDE, Global Head of Alternative Investment Management, 40, rue Washington, F-75408

Paris Cédex 08,

Monsieur Luc HERNOUX, Senior Vice President, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L -

2953 Luxembourg,

Monsieur Benoît HOLZEM, Managing Director, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L - 2953

Luxembourg,

Monsieur Jean-Yves MALDAGUE, Président du Comité de Direction et administrateur, Dexia Asset Management

Luxembourg, route d'Arlon, 136, L-1150 Luxembourg,

en  leur  qualité  d'administrateurs  pour  une  période  d'un  an  prenant  fin  lors  de  la  prochaine  Assemblée  Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2010,

- de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RCS B-65477, en qualité de Réviseur d'En-

treprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 23 mars 2009.

<i>Pour DEXIA GLOBAL
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009044790/1126/33.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2009, réf. LSO-DC07398. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

41130

Via Download, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 122.662.

<i>Contrat de cession de parts sociales

Entre les soussignés:
Monsieur Bernard LEIBOVICI-MONTAGNER, employé privé, né le 10 février 1961 à Clermont-Ferrand F-63000,

résidant 17 bis, rue des Bosquets, F-54300 Lunéville.

Agissant en sa qualité d'associé de la société VIA DOWNLOAD S.A.R.L., société à responsabilité limitée, ayant son

siège au 38 Avenue du X septembre, L -2550 LUXEMBOURG, GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, société au capital
de trente mille (30.000,00) euro, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B - 122.662, propriétaire de quarante neuf (49) parts sociales de la société VIA DOWNLOAD S.A.R.L.

désignée ci-après par "le cédant"
d'une part,
et
Monsieur Gérard FOURNIER, gérant, né le 25 janvier 1959 à Marseille F-13000 et demeurant au 2A bd des Dardanelles,

F-13007 MARSEILLE

désigné ci-après par "le cessionnaire"
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Art. 1 

er

 .  Monsieur Bernard LEIBOVICI-MONTAGNER cède par la présente quarante neuf (49) parts sociales libérées

à concurrence de 100%, de la société VIA DOWNLOAD S.A.R.L. à Monsieur Gérard FOURNIER qui accepte la présente
cession pour un montant total de quinze mille (15.000,00) euros, augmentés des frais de virement et de change. Le
paiement desdits parts sociales devant intervenir par virement bancaire sur le compte S.N.V.B. Lunéville de Monsieur
Bernard LEIBOVICI-MONTAGNER au plus tard le samedi 22 décembre 2007, sous peine de pénalités et d'intérêts de
retard à raison de 15% (QUINZE POUR CENT) par an.

Art. 2. Monsieur Bernard LEIBOVICI-MONTAGNER déclare et garantit qu'il est propriétaire des parts sociales cédées,

lesquelles sont libres de tout gage, privilège ou droit au profit d'un tiers; leur cession à Monsieur Gérard FOURNIER,
conformément aux termes de la présente convention, ne viole ou n'enfreint aucune restriction ou convention au profit
desquelles les parts sociales seraient grevées. Le transfert sera effectif dès la signature des présentes et le cessionnaire
disposera du droit de pleine propriété des parts sociales cédées ainsi que les obligations et droits ultérieurs tel que le
droit aux dividendes, à compter de la date de signature de la présente convention.

Art. 3. Tout impôt, obligation ou autre charge imposée en vertu du présent contrat sera à charge de l'Acquéreur.

Art. 4. Cette convention est soumise au droit luxembourgeois. Tout différend relatif à la présente convention est

soumis à la compétence exclusive de cours et tribunaux de Luxembourg.

Le présent contrat est établi en TROIS originaux et chaque partie en apposant sa signature, reconnaît en avoir reçu

un exemplaire.

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Signatures
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire

Référence de publication: 2009044316/1383/45.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00763. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090050936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

Kefren S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 52.039.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 mars 2009.

<i>Résolutions:

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30.06.2009 comme suit:

41131

<i>Commissaire aux comptes:

Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
KEFREN S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009044151/24/20.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00697. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090050988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

Espalita S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 90.779.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 février 2009 au siège de la

société que:

<i>Première résolution

L'Assemblée générale des actionnaires décide d'accepter la démission de Marie-Josiane ETEME et Anne HERTZOG

de leur fonction d'administrateur.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée des actionnaires décide de nommer comme administrateurs les personnes suivantes:
- Monsieur Engin DOYDUK, juriste, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31, Grand'rue;
- Monsieur Aloyse LEMMER, retraité, demeurant à L-8845 STEINFORT, 9, cité Mont Rose.
En conformité avec l'article 52 de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915, les administrateurs nommés

Engin DOYDUK et Aloyse LEMMER achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent, Marie-Josiane ETEME et Anne HER-
TZOG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009044122/1109/26.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08286. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090050748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

GRB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.458.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 25 mars 2009

1. Le siège social de la Société est transféré du 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412 F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

2. Il est pris acte du changement de siège social des sociétés:
- DMC Sàrl, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F route d'Esch,

L-2086 Luxembourg

- EFFIGI Sàrl, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F route d'Esch,

L-2086 Luxembourg

- LOUV Sàrl, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F route d'Esch,

L-2086 Luxembourg

3. Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la

Société, désormais situé au 12 rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

41132

Luxembourg, le 25 mars 2009.

Certifié conforme,
GRB S.A.
DMC S.à r.l. / EFFIGI S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
Représentée par S. BOULHAIS / Représentée par J.R BARTOLINI
<i>Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2009044723/795/28.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD00888. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090051832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.

Iberint Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 27.857.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 17 novembre 2008

- Le siège social de la Société est transféré au 412F, route d'Esch à Luxembourg (L-2086) à compter de ce jour.

- Il est pris acte de la modification, à compter de ce jour, de l'adresse professionnelle des Administrateurs suivants de

la Société comme suit:

*  Madame  Laurence  MOSTADE,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  au  412F,  route  d'Esch,  L-2086

Luxembourg,

* Madame Natalia VENTURINI, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg,

* Monsieur Thierry SIMONIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg.

- Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la

Société, ayant son siège social désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à Luxembourg (L-1882).

Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2008.

Certifié sincère et conforme
IBERINT HOLDING S.A.
T. SIMONIN / L. MOSTADE
<i>Administrateur / Administrateur Présidente du Conseil d'administration

Référence de publication: 2009045181/795/26.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01600. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Aggmore Europe 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.973.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 31 mars 2009 à 13.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de Sonia AJEDIGUE, avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en

tant que Administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2.  La  nomination  de  Kemal  AKYEL,  né  à  Beringen,  Belgique,  le  2  juin  1977,  avec  l'adresse  professionnelle  au  47,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Administrateur de la société est acceptée à la date de la réunion, celle-
ci terminant le mandat de son prédécesseur.

41133

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2009.

<i>Pour Aggmore Europe 2 S.A.
Mr. Matthijs BOGERS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009045441/1084/20.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01353. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Icare S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 54.948.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 23 mars 2009

1. M. Cornelius Martin BECHTEL a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'admi-

nistration.

2. M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

3. M. Gérard BIRCHEN a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 26 mars 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ICARE S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009045404/29/22.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01104. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.233.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54859 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009045490/211/12.
(090052319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Pegaso Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.008.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13 mars 2009

L'assemblée générale prend acte de la démission du commissaire aux comptes Alter Audit S.à.r.l. 69, Rue de la Semois

L-2533 Luxembourg, en date du 26 janvier 2009.

Les mandats des gérants venant à échéance, l'assemblée décide de les élire pour la période expirant à l'assemblée

générale statuant sur l'exercice 2009 comme suit:

41134

<i>Conseil d'administration:

MM Christophe Velle, employé privé, né le 28 octobre 1974 à Thionville (France), demeurant professionnellement

19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, gérant et président;

Sandro Capuzzo, employé privé, né le 14 décembre 1958 à Trieste (Italie), demeurant professionnellement 19-21

Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, gérant

Mme Gabrielle Mingarelli, employée privée, né le 15 mai 1959 à Villerupt (France), demeurant professionnellement

19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, gérante

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009044131/24/28.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00640. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090050910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

Panikom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 98.294.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mars 2009 que, le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance, ont été renommés:

a) <i>administrateurs

- Monsieur Jean PIRROTTE, directeur d'assurances e.r. avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont

- Monsieur Pierre SCHMIT, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont.

b) <i>commissaire aux comptes

- Monsieur Lou HUBY, directeur honoraire de la C.E. e.r. avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2015.

Luxembourg, le 18 mars 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2009045451/535/26.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2009, réf. LSO-DD00320. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090052020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

GCAT-L U X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 93.672.

<i>Procès-Verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 16/01/2009

Est présent:
L'ensemble du capital est représenté par:

La société OCTA S.A., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

L'associé unique présent se reconnaît dûment convoqué. Constatant que l'entièreté des parts représentatives du capital

est présentée, l'Assemblée est apte à prendre toute décision.

41135

Le Point à l'ordre du jour est le suivant:
1. Démission du gérant technique
La décision prise est la suivante:
1. L'Assemblée accepte la démission en tant que gérant technique pour tout ce qui concerne l'activité d'assistance

technique dans le bâtiment exercée par la société GCAT-LUX S.à.r.l.:

Monsieur Thierry GIRARD, résidant à F-78630 ORGEVAL, 98, rue de Maule
Né à Forcalquier (France), le 30 novembre 1957
Cette décision sort son effet à la date du 31/03/2009.

Fait à Wiltz.

Certifié conforme
Signature

Référence de publication: 2009045486/825/26.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04579. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090052102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.

Xender Eurolink Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 66.886.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 février 2009

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30 juin 2009 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

I.C. DOM-COM Sàrl, 69, rue du Semois L-2533 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
XENDER EUROLINK HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures

Référence de publication: 2009044166/24/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2009, réf. LSO-DC03921. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090051072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

Kirken Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 78.537.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 mars 2009 que:
1. La démission de la société «BF Consulting Sàrl» de son poste de Commissaire est acceptée.
2. Est nommée, en remplacement du Commissaire démissionnaire, la société «Réviconsult S.àr.l. », société à respon-

sabilité limitée, ayant son siège social au 16 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de
l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009044176/6312/19.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00535. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090050933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

41136


Document Outline

74 C 122 A S.A.

A2CS S.A.

AC Multiservices (Luxembourg) S.à r.l.

Aerolink International Sàrl

Aggmore Europe 2 S.A.

AIRCO

AIRCO

Atrix Luxembourg S.à r.l.

Brinkman Trans Holland S.à r.l.

CalEast Holdings

Centaur Luxco S.à r.l.

Cetex Luxembourg S.A.

Challenger Global Fonds

De Agostini Invest S.A.

Delphi Holdings Luxembourg S.à r.l.

Dexia Global

Eiffel Properties Luxembourg S.à r.l.

Espalita S.A.

Expotrans S.A.

Expotrans S.A.

Filipeservice S.A.

Fita Investments S.à r.l.

FKI Luspartwo S.à r.l.

GCAT-L U X S.à r.l.

Gemina Fiduciary Services S.A.

Gisela

GRB S.A.

HVB Banque Luxembourg Société Anonyme

Iberint Holding S.A.

Icare S.A.

Julia &amp; Claudia Holding Company

Keane, Piper &amp; Associates S.A.

Kefren S.A.

Kirken Investments S.A.

La Felicita S.à r.l.

Lingerie Caprice S.àr.l.

Marianne's Holding Company

M.E.C. ImmoLux s.àr.l.

MJ Collections S.A.

New Europe Property Holdings (Luxembourg) 2005 S.à r.l.

NREP Transactions Holding 6 Junior S.à r.l.

Nut Holding Company S.A.

OI-Clothing S.A.

Opera Masters SCA SICAR

Panikom S.A.

Pegaso Finance S.àr.l.

Pramerica Real Estate Investors (Luxembourg) S.A.

Rex Bois Corporation

Roy Grandchildren Holding Company

SVF Participations S.A.

T-I Holdings S.à r.l.

Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à.r.l.

Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à.r.l.

Tishman Speyer Caffamacherreihe S.à.r.l.

Tishman Speyer Caffamacherreihe S.à.r.l.

Tishman Speyer Valentinskamp L.P. S.à r.l.

TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l.

TS Nautilus Holdings S.à r.l.

TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg) S.à r.l.

Via Download, S.à r.l.

Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.

Xender Eurolink Holding S.A.

Zach &amp; Rubensun Group S.A.