This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 852
21 avril 2009
SOMMAIRE
Accelya Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
40859
AC Restaurants et Hôtels S.A. . . . . . . . . . .
40853
APN CF (No. 1) SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . .
40852
Artvalue.Com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40857
ASM Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40893
Ateliers Kräizbierg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40850
AZ Electronic Materials Holdings Sàrl . . .
40861
Bache Global Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40863
CFI Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40855
CFI Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40854
C&M Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
40886
Cofide International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
40850
Compagnie de Construction - CDC Société
à responsabilité limitée & Cie . . . . . . . . . .
40857
Cosma International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
40860
Credit Suisse Bellain Finance (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40889
Credit Suisse Calmar Investments (Lu-
xembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40887
Crommelco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40862
Crop Mark S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40853
Déco Plâtre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40852
Düsseldorf-Airport Hotel Investment S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40884
EAVF Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40858
EAVF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40858
EAVF WGS SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40858
Eurofinim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40857
Fair Sponsors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40853
Flash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40857
Gera-Home S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40856
GSCF Recklinghausen S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
40872
Hoctofin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40853
Impax Solargen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40891
INVESCO European Hotel Real Estate II
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40881
JCP gérances et exploitations, s.à r.l. . . . . .
40851
JP Commercial II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
40854
JP Commercial II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
40855
Katla Management Services . . . . . . . . . . . . .
40886
Lid Lift Industrial Development S.A. . . . . .
40850
LNR Arman S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40862
LuxCo 94 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40889
LuxCo 95 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40887
LuxCo Germany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40857
M.D. International Cargo S.A. . . . . . . . . . . .
40860
Mermos Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
40859
Millenium Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
40854
Millenium Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
40854
Moritzco Ltd S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40860
Nacofi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40851
NDX Market S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40882
Opéra Finance International S.A. . . . . . . . .
40851
PB Holding Company, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
40856
Pravert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40855
Satine International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
40850
SECURINVEST (Luxembourg) S.à r.l. . . .
40894
Steiner, d'Argonne, Brown S.A. . . . . . . . . .
40896
Steiner, d'Argonne, Brown S.A. . . . . . . . . .
40896
Steiner, d'Argonne, Brown S.A. . . . . . . . . .
40896
Techno Weld S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40861
Thomas Cook Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . .
40856
Timberland Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
40873
Transfinancière Européenne S.A. . . . . . . . .
40855
Transfinancière Européenne S.A. . . . . . . . .
40856
Traxys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40863
Traxys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40863
TS Nautilus Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
40852
TS Nautilus (Liebknechtstrasse) S.à.r.l. . .
40891
TS Tour Esplanade Holdings II (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40852
Variolabel Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40881
Wedco One (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . .
40851
WP Roaming IV S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40859
40849
Cofide International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 65.604.
<i>Extrait du Conseil d'administrationi>
<i>de la Société tenue par voie circulaire le 27 février 2009i>
<i>Résolutioni>
Le Conseil d'administration a décidé de transférer le siège de la Société de 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
à 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, à faire date du 1
er
mars 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2009.
COFIDE INTERNATIONAL S.A.
Pierluigi FERRERO / Monica PORFILIO
Référence de publication: 2009039919/1883/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06462. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090045440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.
Satine International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 108.561.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54525 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009044244/211/12.
(090050994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
Ateliers Kräizbierg, Société Coopérative.
Siège social: L-3598 Dudelange, route de Zoufftgen.
R.C.S. Luxembourg B 21.238.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnivoie, le 2 avril 2009.
Tom METZLER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009044232/222/12.
(090050712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
Lid Lift Industrial Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 66.700.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009044221/242/12.
(090050890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
40850
Wedco One (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 145.187.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 31 mars 2009.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009045083/239/12.
(090052162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Opéra Finance International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 103.397.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2009.
Gérard LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009045088/220/12.
(090052214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
JCP gérances et exploitations, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8212 Mamer, 33, rue du Baerendall.
R.C.S. Luxembourg B 93.436.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045093/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06659. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Nacofi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 63.468.
Constituée par-devant Me Frank MOLITOR, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxem-
bourg) et maintenant à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 4 mars 1998, acte publié au Mémorial
C n° 402 du 4 juin 1998, modifiée pour la dernière fois par acte sous seing-privé, en date du 16 novembre 2001,
acte publié au Mémorial C no 766 du 21 mai 2002.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NACOFI S.A.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009044807/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01141. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
40851
APN CF (No. 1) SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 138.306.
<i>Extrait des résolutions écrites des administrateursi>
<i>de la société APN CF (No. 1) SICAV-FIS prises à Luxembourg le 4 août 2008i>
Monsieur John Freemantle, demeurant au 97, Oak Street, Beaumaris, VIC 3193 Australia, a été nommé par cooptation
avec effet immédiat administrateur de la société APN CF (No. 1) SICAV-FIS en remplacement de Monsieur Charles
Raymond, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour APN CF (No. 1) SICAV-FIS
i>Signature
Référence de publication: 2009044903/9396/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2009, réf. LSO-DC08093. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 119.859.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54863 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009045102/211/12.
(090052270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
TS Nautilus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 120.692.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54864 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009045104/211/12.
(090052280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Déco Plâtre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3934 Mondercange, 14, Op Blach.
R.C.S. Luxembourg B 69.352.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045094/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06662. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
40852
Fair Sponsors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 134.872.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009045076/5770/12.
(090052049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
AC Restaurants et Hôtels S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.
R.C.S. Luxembourg B 46.422.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2009.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009045077/5770/12.
(090052114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Crop Mark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincaré.
R.C.S. Luxembourg B 55.619.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045099/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06719. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Hoctofin S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 54.554.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Suite à une assemblée générale extraordinaire enregistrée à Luxembourg, actes civils le 23 mars 2009, LAC/2009/11006
et reçue par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 13 mars 2009, acte n°
129, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société "HOCTOFIN S.A.", qui cessera d'exister.
L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, bld du
Prince Henri, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Jacques DELVAUX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009045193/208/18.
(090052147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
40853
JP Commercial II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 114.262.
Die Gesellschaft wurde am 10. Februar 2006 gegründet gemäβ Urkunde vom Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit
Amtssitz in Luxemburg, Groβherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt,
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg Nr. 931 vom 12. Mai 2006.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007, wurde am Handels- und Gesellschafstregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung um luxemburgischen Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
JP Commercial II S.à r.l.
Unterschriften
Référence de publication: 2009045314/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01623. - Reçu 54,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090052203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Millenium Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 87.300.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045304/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02244. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
CFI Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 99.356.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045300/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02243. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Millenium Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 87.300.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045308/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02245. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
40854
CFI Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 99.356.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045298/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02242. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090052213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Transfinancière Européenne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 87.299.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045293/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02237. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Pravert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R.C.S. Luxembourg B 41.791.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009045311/6053/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02140. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
JP Commercial II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 114.262.
Die Gesellschaft wurde am 10. Februar 2006 gegründet gemäβ Urkunde vom Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit
Amtssitz in Luxemburg, Groβherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt,
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg Nr. 931 vom 12. Mai 2006.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006, wurde am Handels- und Gesellschafstregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung um luxemburgischen Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
JP Commercial II S.à r.l.
Unterschriften
Référence de publication: 2009045317/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01620. - Reçu 44,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
40855
Transfinancière Européenne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 87.299.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045292/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02236. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090052218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Gera-Home S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5310 Contern, 4, rue de Moutfort.
R.C.S. Luxembourg B 126.207.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009045290/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02224. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Thomas Cook Belgium, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-4011 Esch-sur-Alzette, 113, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 69.653.
Le bilan au 31 octobre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045150/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08556. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
PB Holding Company, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.512.
Constituée par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en
date du 24 mars 2006, acte publié au Mémorial C n
o
1211 du 22 juin 2006 et modifiée pour la dernière fois par-
devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 10 octobre
2006, acte publié au Mémorial C n
o
2388 du 22 décembre 2006.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PB Holding Company S.à r.l.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2009045322/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01684. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
40856
LuxCo Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 72.683.
Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045151/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2009, réf. LSO-DD00296. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Compagnie de Construction - CDC Société à responsabilité limitée & Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 16.861.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045148/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2009, réf. LSO-DD00295. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Eurofinim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 67.434.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009045360/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02165. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Artvalue.Com, Société Anonyme,
(anc. Flash S.A.).
Siège social: L-7213 Bereldange, 8, am Becheler.
R.C.S. Luxembourg B 54.750.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2009.
<i>Pour la société
i>PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
i>Signature
Référence de publication: 2009045400/592/18.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02098. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
40857
EAVF Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 119.844.
EXTRAIT
En date du 4 décembre 2008, le conseil de gérance de EAVF Holding II S.à r.l. (la "Société") a décidé de transférer le
siège social de la Société du 7, rue de la Chapelle, L-1325, Luxembourg, au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EAVF Holding II S.à r.l.
i>Signature
<i>Avocati>
Référence de publication: 2009044196/267/18.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08928. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090050859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
EAVF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.742.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.851.
EXTRAIT
En date du 4 décembre 2008, le conseil de gérance de EAVF S.à r.l. (la "Société") a décidé de transférer le siège social
de la Société du 7, rue de la Chapelle, L-1325, Luxembourg, au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331,
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EAVF S.à r.l.
i>Signature
<i>Avocati>
Référence de publication: 2009044197/267/18.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08927. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090050848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
EAVF WGS SCS, Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 68.517,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.015.
EXTRAIT
En date du 4 décembre 2008, le Gérant Commandité de EAVF WGS SCS (la "Société") a décidé de transférer le siège
social de la Société du 7, rue de la Chapelle, L-1325, Luxembourg au 21, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331,
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EAVF WGS SCS
i>Signature
<i>Avocati>
Référence de publication: 2009044198/267/18.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08926. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090050842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
40858
Accelya Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.600,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 123.755.
EXTRAIT
En date du 4 décembre 2008, le conseil de gérance de EAVF Finance S.à r.l. (la "Société") a décidé de transférer le
siège social de la Société du 7, rue de la Chapelle, L-1325, Luxembourg, au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EAVF Finance S.à r.l.
i>Signature
<i>Avocati>
Référence de publication: 2009044199/6762/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06221. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
Mermos Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 54.950.
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 9 janvier, 2009i>
Au Conseil d'Administration de Mermos Investments S.A. ("la société"), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du Carré Bonn, 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 2-8 Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat.
Luxembourg, le 10 Février 2009.
Luxembourg Corporation Company S.A.,
<i>Administrateur délégué
i>By Doeke van der Molen
<i>Permanent Représentativei>
Référence de publication: 2009044200/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00486. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090050759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
WP Roaming IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.750.800,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 109.441.
EXTRAIT
Résultant des résolutions du Conseil de Gérance prises par voie circulaire en date du 27 novembre 2008, les modifi-
cations suivantes ont été décidées:
- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle
adresse 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.
- modification de l'adresse de Mr. Richard Brekelmans, Manager B, de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763
Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.
Richard Brekelmans.
Référence de publication: 2009044201/751/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04548. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090050632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
40859
Moritzco Ltd S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 17.373.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI
ème
chambre, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu le Juge-commissaire, le liquidateur et le représentant du Ministère Public, a déclaré
closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société MORITZCO LTD S.A., avec siège social à L-1724
LUXEMBOURG, 11, boulevard de fait inconnue à cette adresse.
Les frais ont été mis à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Elisabeth ALVES
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2009044189/2675/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2009, réf. LSO-DC04054. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
M.D. International Cargo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R.C.S. Luxembourg B 63.401.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI
ème
chambre, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu le Juge-commissaire, le liquidateur et le représentant du Ministère Public, a déclaré
closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société M.D. INTERNATIONAL CARGO S.A.., avec siège
social à L-1725 LUXEMBOURG, 28, rue Henri VII, de fait inconnue à cette adresse.
Les frais ont été mis à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Elisabeth ALVES
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2009044190/2675/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2009, réf. LSO-DC04057. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
Cosma International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 91.893.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour COSMA INTERNATIONAL S.A.
i>FIDALUX S.A.
<i>Le domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2009045106/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01968. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
40860
AZ Electronic Materials Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.248.125,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 102.143.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 10 mars 2009 à Luxembourg que:
- la démission de Monsieur Robert Easton de ses fonctions de gérant de la Société a été acceptée avec effet au 30 mars
2009;
- la nomination de Monsieur Franck Falezan, né le 3 mai 1971 à Dreux en France, demeurant au 48 Cadogan Square
à Londres SW1X 0JW, Royaume Uni, en tant que nouveau gérant de la Société a été acceptée avec effet au 30 mars 2009
et ce pour une durée indéterminée.
Suite à ces décisions, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
Thomas von Krannichfeldt
Werner Interthal
Robert Rosner
Jean-François Félix
Zeina Bain
Franck Falezan
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars, 2009.
<i>Pour AZ Eléctronic Materials Holdings S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009044733/5776/29.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01347. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Techno Weld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 133A, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 113.866.
<i>Décisions collectives des associési>
<i>pour la constatation de cession de parts socialesi>
Les Associés de la société à responsabilité limitée Techno Weld SARL, réunis en date du 9 janvier 2009 au siège social,
portent à la connaissance des tiers que suite à une convention de cession de parts sociales du 9 janvier 2009, signée sous
seing privé par le cédant et le cessionnaire et acceptée par la gérance au nom de la société, le capital social de la société
TECHNO WELD SARL ayant son siège social à L-4940 Bascharage, 133A, avenue du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 113.866, est désormais réparti comme
suit:
Monsieur Cosimo Fergola, né le 24.10.1960 à Barletta (italie), demeurant à
F-54810 Longlaville (France), 14, rue du 19 mars 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 parts sociales
Monsieur Joaquim Da Costa Antunes, né le 11.11.1962 à Braga (Portugal), demeurant à
F-57580 Remilly (France), 5, place St Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Bascharage, le 9 janvier 2009.
<i>Les Associés
i>Cosimo Fergola / Joaquim Da Costa Antunes
Référence de publication: 2009042864/9323/25.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06190. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090044149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2009.
40861
Crommelco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 102.941.
<i>Extrait de l'Assemblée générale extraordinairei>
L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur et Administrateur-délégué avec effet 1
er
avril 2009
Monsieur Erik Crommelynck, commerçant, demeurant à B-9050 Gentbrugge, Jean Jaurèslaan 14, né le 7 septembre
1968 à Saint-Amandsberg (B),
L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur avec effet 1
er
avril 2009
Monsieur Yves Piens, commerçant, demeurant à B-1050 Bruxelles, 83/b23, boulevard Général Jacques, né le 14 mai
1952 à Bruges (B),
L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur avec effet 1
er
avril 2009
Monsieur Ashwin Jacobs, commerçant, demeurant à NL-4501 JH Oostburg Walstraat 22, né le 18 juillet 1971 à Oost-
burg (Pays-Bas),
L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur avec effet 1
er
avril 2009
Madame Els Van den Hende, sans état, demeurant à B-9050 Gentbrugge, Jean Jaurèslaan 14, née le 24 janvier 1972 à
Saint-Amandsberg (B),
L'Assemblée a décidée de nommer comme Administrateur et Administrateur-délégué avec effet 1
er
avril 2009
Madame Audrey Fouré commerçante, née le 19 août 1977 à Saint-Ouen (Fr) domicilié administrativement 29 avenue
Monterey L-2163 Luxembourg
L'Assemblée a décidée de nommer comme Administrateur et Administrateur-délégué avec effet 1
er
avril 2009
Monsieur Bruno Fouré commerçant, né le 14 Décembre 1955 à Poissy (Fr) domicilié administrativement 29 avenue
monterey L-2163 Luxembourg
Fait à Luxembourg le 1
er
avril 2009.
Mr Claessens A. pp..
Référence de publication: 2009044173/3288/29.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01262. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090050971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
LNR Arman S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 86.291.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 26 janvier 2009i>
En date du 26 janvier 2009, l'actionnaire unique a décidé comme suit:
- d'accepter les démissions de:
* Madame Elena Morrisova de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;
* Monsieur Jacques de Patoul de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;
- d'accepter les nominations de:
* Monsieur Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
* Monsieur Paul Lefering, né le 20 Octobre 1972 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indé-
terminée.
Luxembourg, le 19 mars 2009.
Pour extrait analytique conforme
Jan Willem Overheul
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009044071/9168/25.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2009, réf. LSO-DC07700. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090050664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
40862
Bache Global Series, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 129.297.
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre hat mit Wirkung vom 28. Mai 2008 die Herren Marc Bailey,
Berufsanschrift: 9, Devonshire Square, GB - EC2M 4HP London, Andreas Jockel, Berufsanschrift 4, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg und Hugh Trenchard, Berufsanschrift: 9, Devonshire Square, GB - EC2M 4HP London zu Verwal-
tungsratsmitgliedern bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2009 gewählt.
Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre hat Herrn Hans-Willem R. Baron van Tuyll van Serroskerken
mit Wirkung vom 10. September 2008 zum Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Ablauf der ordentlichen Generalver-
sammlung im Jahre 2009 gewählt.
Die Herren Alex Ladouceur, Berufsanschrift: 1, New York Plaza, USA - NY 10292 New York, Ronald Ivans, Beruf-
sanschrift: 1, New York Plaza, USA - 10292 New York und Michael John Coomber, Berufsanschrift: 9, Devonshire Square,
GB - EC2M 4HP London sind mit Wirkung vom 28. Mai 2008 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
Herr Andreas Jockel, Berufsanschrift: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg und Herr Marc Bailey, Berufsanschrift:
9, Devonshire Square, GB - EC2M 4HP London wurden mit Wirkung vom 9. Oktober 2007 als delegierte Geschäftsführer
(Administrateurs Délégués) bestellt. Herr Andreas Schmidt-von Rhein, Berufsanschrift: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Lu-
xemburg wurde mit Wirkung vom 14. April 2008 als Beauftragter der täglichen Geschäftsführung (Délégué à la gestion
journalière) bestellt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, im März 2009.
Bache Global Series
Unterschriften
Référence de publication: 2009045429/1999/28.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08957. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Traxys S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Traxys).
Siège social: L-8080 Bertrange, 3, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 90.829.
In the year two thousand and nine, on the seveneenth day of February,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
There appeared
T-I Holdings S.à r.L, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Lu-
xembourg and registered at the Luxembourg commercial register under number R.C.S. Luxembourg B 106 007, being
the sole shareholder of Traxys ., société anonyme, (hereinafter referred to as the "Company"), with registered office at
3, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés
of Luxembourg under number B 90.829. The Company was incorporated by deed of Me Frank Baden, notary residing in
Luxembourg, on 31
st
December 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial")
on 26 February 2003, number 206. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by a
deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 16 January 2007 and published in the Mémorial dated
30 April 2007, number 749.
represented by Me Karl Pardaens, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy given
under private seal.
The appearing party declared and requested the notary to state that:
1. The entire issued share capital represented by two million two hundred seventy-three thousand seventy-six
(2,273,076) shares of class C is held by the sole shareholder, it being noted that the Company holds two hundred thousand
(200,000) shares of class A, and two hundred thousand (200,000) shares of class B.
2. The sole shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this
extraordinary decision of the sole shareholder and the decisions can be validly taken on all items of the agenda.
3. The items on which resolutions are to be passed are as follows, it being understood that all the items of the agenda
are interrelated and shall form one single resolution:
40863
A) To transform the Company by converting its form from a société anonyme into a société à responsabilité limitée
while acknowledging and approving the report by the Board of Directors on the net asset value of the Company.
B) To reclassify the two hundred thousand (200,000) shares of class A, two hundred thousand (200,000) shares of
class B and two million two hundred seventy-three thousand seventy-six (2,273,076) shares of class C of a nominal value
of twenty five US dollars (USD 25) into two million six hundred seventy-three thousand seventy-six (2,673,076) shares
(parts sociales) with a nominal value of twenty-five US dollars (USD 25) each.
C) To amend and restate the articles of incorporation of the Company in order to in particular adapt them to the
new form of the Company, substantially in the form as set out in the proxy, the proxy holder being expressly authorised
and empowered to make, and agree to, such changes and amendments as deemed appropriate.
D) To appoint as new managers of the board of managers of the Company for an undetermined period of time with
such signature powers as set forth in the restated articles as follows:
- Rodney COHEN, director, born on November 5, 1965 in Livingston, USA, with professional address at 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Ross R. BHAPPU, director, born on April 14, 1960 in Socorro, USA, with professional address at 16
th
Street, Suite
200, Denver, CO 80202, USA;
- Alan DOCTER, director, born on November 24, 1943 in Chicago, USA, with professional address at 205 Worth
Avenue, Palm Beach, FL 33480, USA;
- George DORSEY, director, born on January 1, 1950 in Baltimore, USA, with professional address at 457 Cider Mill
Road, Cornwall, VT 05753, USA;
- Eric GRIBETZ, director, born on February 13, 1974 in New York, USA, with professional address at 99 River Road,
Cos Cob, CT 06787, USA;
- Mark KRISTOFF, director, born on November 10, 1961 in Easton, USA, with professional address at 825 Third
Avenue, New York, NY 10022, USA;
- Alec MACHIELS, director, born on August 9, 1972 in Wilrijk, Belgium, with professional address at 99 River Road,
Cos Cob, CT 06787, USA;
- Stanley de JONGH OSBORNE, director, born on November 7, 1970 in Palo Alto, USA, with professional address
at 320 Park Avenue, New York, NY 10022, USA;
- Dan STENCEL, director, born on June 16, 1970 in Point Pleasant, USA, with professional address at 99 River Road,
Cos Cob, CT 06787, USA; and
- Richard WEINBERG, director, born on September 2, 1959 in Brooklyn, USA, with professional address at 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Henry MANNIX, born on 1 February 1979 in Hartford, Connecticut, USA, with professional address at 320 Park
Avenue, New York, NY 10022, USA.
E) To confirm that two million two hundred seventy-three thousand seventy-six (2,273,076) shares (parts sociales) in
issue of the Company are held by T-I Holdings S.àr.l., a société à responsabilité limitée under Luxembourg law with
registered office at 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg and registered with the commercial register under number
RCS Luxembourg B 106.007 and four hundred thousand (400,000) shares (parts sociales) are held in treasury by the
Company).
The above being approved the Meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved that all the items of the agenda shall constitute one single resolution.
It is resolved to transform the Company by converting its form from a société anonyme into a société à responsabilité
limitée.
The sole shareholder acknowledged and approved the report by the board of directors of the Company in relation
with the net asset value of the Company the conclusion of which reads as follows:
"In view of the above the Board of Directors confirms that nothing has come to its attention which would lead it to
believe that the net assets of the Company are not at least equal to the number and value of the shares to be issued by
the Company upon its transformation into a société à responsabilité limitée and the reclassification of its 200,000 shares
of class A, 200,000 shares of class B and 2,273,076 shares of class C into two million six hundred seventy-three thousand
seventy-six (2,673,076) shares of a société à responsabilité limitée (parts sociales) with a nominal value of twenty-five US
dollars (USD 25) each, being in the aggregate USD 66,826,900-, together with a share premium in an amount of USD
2,783,244."
The sole shareholder resolved to reclassify the two hundred thousand (200,000) shares of class A, two hundred
thousand (200,000) shares of class B and two million two hundred seventy-three thousand seventy-six (2,273,076) shares
of class C of a nominal value of twenty five US dollars (USD 25) into two million six hundred seventy-three thousand
seventy-six (2,673,076) shares (parts sociales) with a nominal value of twenty-five US dollars (USD 25) each.
40864
The sole shareholder then resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company as set out
hereafter, in order to adapt them to the new form of the Company as set forth below.
ARTICLES OF INCORPORATION
Art. 1. Establishment, Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Tra-
xys S.à r.l." (the "Company") is formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The
Company will be governed by these articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") and the relevant legislation.
Art. 2. Registered office.
2.1 The Company has its registered office in the City of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of
its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.
2.2 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
2.3 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
2.4 In the event that the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social deve-
lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers.
Art. 3. Duration. The Company is established for an undetermined period. The Company may be dissolved at any time
by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 4. Object, Purpose. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in
other, either Luxembourg or foreign, companies and the management, control and development of such participating
interests.
The Company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The Company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving
from these patents or complementary thereto.
To the maximum extent permitted by Luxembourg law, the Company may borrow and grant assistance (by way of
loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to companies or other entities in which the Company has a direct
or indirect interest or which forms part of the group to which the Company belongs including, for the avoidance of doubt,
the direct or indirect shareholders of the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or
immovable, commercial or industrial operation directly or indirectly linked to the above object or to any similar or related
objects, which it deems useful in the achievement and development of its purpose.
Art. 5. Share Capital. The issued share capital of the Company is set at sixty-six million eight hundred and twenty-six
thousand nine hundred United States dollars (USD 66,826,900) represented by two million six hundred and seventy-three
thousand seventy-six (2,673,076) shares, each with a nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25) each
and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting adopted in the manner
requiredfor amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 6. Transfer of shares.
6.1 Shares are freely transferable among members.
6.2 Except if otherwise provided by law, any share transfer to non-members is subject to the consent of the majority
of members representing at least seventy five percent of the Company's issued share capital.
Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or several managers who need not be members.
7.2 They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
7.3 In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate
in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
40865
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
7.4 The board of managers shall meet upon call by any manager. Notice of any meeting shall be given by letter, cable,
telegram, telephone, facsimile transmission, telex or e-mail advice to each manager wherever practical five business days
before the meeting, except in the case of an emergency, in which event a twelve hours notice shall be sufficient. The
convening notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or email of each manager. Separate notice
shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by
resolution of the board of managers.
7.5 A duly called meeting of the board of managers shall be duly quorated if at least a majority of the managers are
present or represented, provided that at least two of the managers shall be participating in such meeting from Luxembourg.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation).
7.6 The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any
manager.
Art. 8. Powers of the board, Binding signatures.
8.1 Vis-a-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive
powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations
relative to the Company.
8.2 The Company will be bound by the joint signature of any two of the managers or by the sole signature of any
person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the manager or the board of managers
(in the case of a board of managers).
Art. 9. Liability of managers. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Art. 10. Decision by members.
10.1 Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he
owns and may validly participate in written resolutions and act at any meeting of members through a special proxy.
10.2 Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as set out herein or to the extent
mandatory as prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held
including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing members
taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another; the participation in a meeting by
these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of
the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the
Company.
10.3 Meetings shall be called by the board of managers by convening notice addressed by registered mail to members
to their address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of
the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior
notice.
10.4 In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses
inscribed in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of
the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
10.5 However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the
members (ii) representing at least three quarters of the issued share capital.
10.6 In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on
first Tuesday of the month of March of each year at 11.00 am of each year. If such day is not a business day, the meeting
shall be held on the immediately following business day.
Art. 11. Accounting Year, Auditor.
11.1 The accounting year begins on 1
st
December of each year and ends on 30
th
November of the following year.
11.2 Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the board of managers.
11.3 The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.
40866
Art. 12. Distributions.
12.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
12.2 The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the board
of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be dis-
tributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward
and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established
by law.
12.3 The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
12.4 The share premium account (if any) may be distributed to the members upon decision of a general meeting of
members. The general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.
Art. 13. Liquidation of the Company. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or
several liquidators who may be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members
who will specify their powers and remunerations.
Art. 14. Sole Shareholder. If and as long as one member holds all the Shares of the Company, the Company shall exist
as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies; in
this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 15. Applicable law. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the
relevant legislation.
The sole shareholder noted that the persons referred to below have been members of the board of directors of the
Company prior to its transformation into a société à responsabilité limitée.
The sole shareholder resolved to confirm the appointment of and to reappoint as managers to the board of managers
of the Company the following persons for an unlimited time:
- Rodney COHEN, director, born on November 5, 1965 in Livingston, USA, with professional address at 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Ross R. BHAPPU, director, born on April 14, 1960 in Socorro, USA, with professional address at 16
th
Street, Suite
200, Denver, CO 80202, USA;
- Alan DOCTER, director, born on November 24, 1943 in Chicago, USA, with professional address at 205 Worth
Avenue, Palm Beach, FL 33480, USA;
- George DORSEY, director, born on January 1, 1950 in Baltimore, USA, with professional address at 457 Cider Mill
Road, Cornwall, VT 05753, USA;
- Eric GRIBETZ, director, born on February 13, 1974 in New York, USA, with professional address at 99 River Road,
Cos Cob, CT 06787, USA;
- Mark KRISTOFF, director, born on November 10, 1961 in Easton, USA, with professional address at 825 Third
Avenue, New York, NY 10022, USA;
- Alec MACHIELS, director, born on August 9, 1972 in Wilrijk, Belgium, with professional address at 99 River Road,
Cos Cob, CT 06787, USA;
- Stanley de JONGH OSBORNE, director, born on November 7, 1970 in Palo Alto, USA, with professional address
at 320 Park Avenue, New York, NY 10022, USA;
- Dan STENCEL, director, born on June 16, 1970 in Point Pleasant, USA, with professional address at 99 River Road,
Cos Cob, CT 06787, USA; and
- Richard WEINBERG, director, born on September 2, 1959 in Brooklyn, USA, with professional address at 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Henry MANNIX III, born on 1 February 1979 in Hartford, Connecticut, USA, with professional address at 320 Park
Avenue, New York, NY 10022, USA.
The sole shareholder confirms that two million two hundred seventy-three thousand seventy-six (2,273,076) shares
(parts sociales) in issue of the Company are held by T-I Holdings S.àr.l., a société à responsabilité limitée under Luxem-
bourg law with registered office at 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg and registered with the commercial register
under number RCS Luxembourg B 106.007 and four hundred thousand (400,000) shares (parts sociales) are held in
treasury by the Company.
There being nothing further on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at one thousand three hundred Euro.
40867
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, the
minutes of the Meeting are drafted in English followed by a French translation. In the event of a conflict between the
French and the English version, the English version shall prevail.
This deed is made in Luxembourg on the day beforementioned.
Upon reading the minutes of the Meeting, the appearing party and the notary signed this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le dix-septième jour du mois de février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu
T-I Holdings S.àr.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxem-
bourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106 007, étant l'associé
unique de Traxys (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 3, rue Pietzer, L-8080 Bertrange, Grand
Duché de Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
90.829. La Société a été constituée le 31 décembre 2002 par acte de Me Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 206 du 26 février 2003. Les statuts
de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 16 février 2007 suivant acte reçu du notaire Joseph Elvinger,
publié au Mémorial numéro 749 du 30 avril 2007,
représentée par Me Karl Pardaens, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée sous seing privé.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. La totalité du capital social émis représentée par deux millions deux cent soixante-treize mille soixante seize
(2.273.076) actions de classe C est détenue par l'actionnaire unique, étant noté que la Société détient deux cent mille
(200.000) actions de classe A et deux cent mille (200.000) actions de classe B.
2. L'actionnaire unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les actions sont représentées
à cette décision extraordinaire de l'actionnaire unique de sorte que toutes les décisions peuvent être valablement prises
sur tous les points de l'ordre du jour.
3. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants, étant entendu que tous les points à
l'ordre du jour sont interdépendants et ne forment qu'une seule résolution:
A) Transformer la Société en modifiant sa forme d'une société anonyme en société à responsabilité limitée tout en
confirmant et en approuvant le rapport du Conseil d'Administration sur la valeur d'actif net de la Société.
B) Reclassifier les deux cent mille (200.000) actions de classe A, deux cent mille (200.000) actions de classe B et deux
millions deux cent soixante-treize mille soixante-seize mille (2.273.076) actions de classe C d'une valeur nominale de
vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 25) en deux millions six cent soixante-treize mille soixante-seize mille
(2.673.076) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 25).
C) Modifier et faire une refonte complète des statuts de la Société afin de, en particulier, les adapter à la nouvelle
forme de la Société, substantiellement en la forme telle qu'elle est incluse dans la procuration, le mandataire étant ex-
pressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord aux changements et modifications qui
lui sembleront appropriées.
D) Nommer en tant que nouveaux gérants du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée ayant les
pouvoirs de signature tels que rédigés dans les statuts modifié:
- Rodney COHEN, administrateur, né le 5 novembre 1965 à Livingstone, USA, ayant son adresse professionnelle à 99
River Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Ross R. BHAPPU, administrateur, né le 14 avril 1960 à Socorro, USA, ayant son adresse professionnelle à 16
th
Street,
Suite 200, Denver, CO 80202, USA;
- Alan DOCTER, administrateur, né le 24 novembre 1943 à Chicago, USA, ayant son adresse professionnelle à 205
Worth Avenue, Palm Beach, FL 33480, USA;
- George DORSEY, administrateur, né le 1
er
janvier 1950 à Baltimore, USA, ayant son adresse professionnelle à 457
Cider Mill Road, Cornwall, VT 05753, USA;
- Eric GRIBETZ, administrateur, né le 13 février 1974 à New York, USA, ayant son adresse professionnelle à 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Mark KRISTOFF, administrateur, né le 10 novembre 1961 à Easton, USA, ayant son adresse professionnelle à 825
Third Avenue, New York, NY 10022, USA;
- Alec MACHIELS, administrateur, né le 9 août 1972 à Wilrijk, Belgique, ayant son adresse professionnelle à 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Stanley de JONGH OSBORNE, administrateur, né le 7 novembre 1970 à Palo Alto, USA, ayant son adresse profes-
sionnelle à 320 Park Avenue, New York, NY 10022, USA;
40868
- Dan STENCEL, administrateur, né le 16 juin 1970 à Point Pleasant, USA, ayant son adresse professionnelle à 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Richard WEINBERG, administrateur, né le 2 septembre 1959 à Brooklyn, USA, ayant son adresse professionnelle à
99 River Road, Cos Cob, CT 06787, USA; et
- Henry MANNIX, né le 1
er
février 1979 à Hartford, Connecticut, USA, ayant son adresse professionnelle à 320 Park
Avenue, New York, NY 10022, USA.
E) Confirmer que les deux millions deux cent soixante-treize mille soixante-seize (2.273.076) parts sociales émises de
la Société sont détenues par T-I Holdings S.à r.L, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège
social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
R.C.S. B 106.007, et quatre cent mille (400.000) parts sociales sont détenues en trésorerie par la Société.
Ce qui précède ayant été approuvé, l'Assemblée, à l'unanimité, a adopté la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé que tous les points à l'ordre du jour constituent une résolution unique.
Il est décidé de transformer la Société en modifiant sa forme d'une société anonyme en société à responsabilité limitée.
L'associé unique décide de confirmer et d'approuver le rapport du conseil d'administration de la Société en relation
avec la valeur nette d'inventaire de la Société dont la conclusion est la suivante:
"Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Administration confirme que rien n'est venu à son attention qui l'amènerait à
croire que les avoirs de la Société ne sont pas au moins égaux au nombre et à la valeur des parts sociales à émettre par
la Société lors de sa transformation en société à responsabilité limitée et reclassification de ses 200.000 actions de classe
A, 200.000 actions de classe B et 2.273.076 actions de classe C en deux millions six cent soixante-treize mille soixante-
seize (2.673.076) parts sociales d'une société à responsabilité limitée d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-
Unis (USD 25) chacune, représentant une totalité de USD 66.826.900-, ensemble avec une prime d'émission d'un montant
de USD 2.783.244."
L'associé unique a décidé de reclassifier les deux cent mille (200.000) actions de classe A, deux cent mille (200.000)
actions de classe B et deux millions deux cent soixante-treize mille soixante-seize (2.273.076) actions de classe B d'une
valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (USD 25) chacune en deux millions six cent soixante-treize mille
soixante seize (2.673.076) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (USD 25) chacune.
L'associé unique a ensuite décidé de modifier et de procéder à la refonte des statuts de la Société tel que prévu ci-
après en vue de les adapter à la nouvelle forme de la Société tel que prévu ci-après.
Art. 1
er
. Etablissement, Dénomination. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la
suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Traxys S.àr.l. " (la "Société"). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute
autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des as-
sociés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
2.2. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du conseil de gérance.
2.3. La Société peut établir des bureaux et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
2.4. Au cas où le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège
avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement
à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auront aucun effet
sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société luxem-
bourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par
décision des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.
Art. 4. Objet, But. La Société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et par toute autre manière
des titres transférables, ainsi que les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir et gérer tous brevets, et toutes marques et autres licences y relatives ainsi que
tous droits découlant de ces brevets ou qui sont complémentaires.
Dans la mesure maximale permise en droit luxembourgeois, la Société peut emprunter et prêter assistance (par des
prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à toute société ou autres entité dans laquelle la Société a un intérêt direct
ou indirect ou qui fait partie du groupe auquel la Société appartient, en ce compris, afin d'éviter tout doute, les associés
directes ou indirectes de la Société.
40869
La Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction immo-
bilière ou mobilière qui peut lui paraître utile dans la réalisation de son objet.
D'une manière générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle et de supervision ainsi qu'effectuer toute
opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle, pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l'objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe, que la Société estime utile à la réalisation et au
développement de son objet.
Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à soixante six millions huit cent vingt-six mille neuf
cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (66.826.900 USD) représenté par deux millions six cent soixante-treize mille
soixante-seize (2.673.076) parts sociales avec un pair comptable de vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
25) chacune et bénéficiant des droits et obligations tels que prévus dans les présents Statuts.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise
pour la modification des présents Statuts.
Art. 6. Transfert de parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont librement transférables entre associés.
6.2. Sauf exception prévu par la loi, toute cession de parts sociales à des non-associés est soumise à l'accord préalable
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social émis.
Art. 7. Conseil de Gérance.
7.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non.
7.2. Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés par une décision à la majorité simple, qui
détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur mandat est également révocable avec ou sans motifs (ad
nutum) à tout moment.
7.3. Dans le cas d'une pluralité de gérants, les gérants forment un conseil de gérance. Chaque gérant peut participer
aux réunions du conseil de gérance par voie de conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication
similaires permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de communiquer entre eux. Une
réunion peut également être tenue moyennant conférence téléphonique uniquement. La participation à, ou la tenue de,
ces réunions par ces moyens équivaut à une participation en personne à ce type de réunion. Tout Gérant peut être
représenté à une réunion du conseil de gérance par un autre gérant sans limitation quant au nombre de procurations
qu'un gérant peut accepter et voter.
7.4 Le conseil de gérance se réunira sur convocation de tout gérant. Un avis écrit de toute réuni on du conseil de
gérance doit être donné par lettre, câble, télégramme, téléphone, télécopie, télex ou email à chaque gérant, à chaque fois
que cela est faisable, cinq jours avant la date de la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas un délai de douze heures sera
suffisant. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble,
télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.
7.5 Une réunion du conseil de gérance valablement convoquée aura atteint le quorum si au moins une majorité des
gérants sont présents ou représentés, à conditition qu'au deux gérants participent à cette réunion à partir du Luxembourg.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation).
7.6 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par
voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions
des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis
sous la signature individuelle de chaque gérant.
Art. 8. Pouvoirs du Conseil, Pouvoir de signature.
8.1 Vis-à-vis des tiers, le gérant ou chaque gérant (dans le cas d'un conseil de gérance) a les pouvoirs les plus étendus
pour agir pour le compte de la Société en toute circonstance et faire, autoriser et approuver tous les actes et opérations
concernant la Société.
8.2 La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants (présents ou représentés) ou par la signature
individuelle de toute(s) personne(s) ayant reçu délégation de ce pouvoir de signature par le gérant ou par le conseil de
gérance (dans le cas d'un conseil de gérance).
Art. 9. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes
de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.
40870
Art. 10. Décisions des Associés.
10.1 Chaque Associé pourra prendre part aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu'il détient et peut valablement participer à des résolutions écrites et agir à toute assemblée des associés par
une procuration spéciale.
10.2 Les décisions des associées sont prises par écrit sous les conditions de forme et de majorité telles que prévues
par les présentes ou par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales (dans les limites prévues par la loi) ou lors
d'assemblées tenues y compris (dans les limites prévues par la loi) par voie de conférence téléphonique, video conférence
ou autres moyens de communication permettant à touts les associés prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les
autres et de communiquer ensemble, la participation à une assemblée par ces moyens étant équivalente à une participation
en personne à ces assemblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution
circulaire valablement prise (le cas échéant) représente l'entier été des associés de la Société.
10.3 Les assemblées sont convoquées par le conseil de gérance par une convocation par lettre recommandée adressée
aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date
d'une telle assemblée. Si l'entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans
convocation préalable.
10.4 Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse
inscrite dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des conditions de majorité, à la date y précisée). Des résolutions écrites peuvent
être passées à l'unanimité à tout moment sans convocation préalable.
10.5 Cependant, des décisions concernant les modifications des statuts seront prises par (i) une majorité des associés
(ii) représentant au moins trois-quarts du capital social émis. 10.6. Lorsque, et aussi longtemps que la Société compte
plus de 25 associés la tenue d'une assemblée générale annuelle des associés sera tenue le premier mardi du mois de mars
de chaque année. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.
Art. 11. Comptes annuels, Commissaire aux comptes.
11.1 L'année comptable de la Société commence le 1
er
décembre de chaque année et se terminera le 30 novembre
de l'année suivante.
11.2 Chaque année à la fin de l'année comptable, les comptes annuels sont dressés par le conseil de gérance.
11.3 Les comptes annuels seront à la disposition des associés au siège de la Société.
Art. 12. Distributions.
12.1 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
12.2 Les associés peuvent décider de distribuer des dividendes intermédiaires, en fonction de la situation des comptes
de la société préparés par le conseil de gérance, montrant des fonds suffisants pour la distribution, étant entendu que le
montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du
bénéfice reporté et des réserves distribuâmes et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale,
en conformité avec la loi.
12.3 Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
12.4 Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des
associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 13. Liquidation de la Société. En cas de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rému-
nérations
Art. 14. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales, la société est une
société unipersonnette au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 15. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
L'associé unique prend note de ce que les personnes mentionnées ci-après étaient membres du conseil d'administration
de la Société avant sa transformation en société à responsabilité limitée.
L'associé unique a décidé de confirmer la nomination et la renomination des personnes suivantes en tant que gérants
au conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:
- Rodney COHEN, administrateur, né le 5 novembre 1965 à Livingstone, USA, ayant son adresse professionnelle à 99
River Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Ross R. BHAPPU, administrateur, né le 14 avril 1960 à Socorro, USA, ayant son adresse professionnelle à 16
th
Street,
Suite 200, Denver, CO 80202, USA;
40871
- Alan DOCTER, administrateur, né le 24 novembre 1943 à Chicago, USA, ayant son adresse professionnelle à 205
Worth Avenue, Palm Beach, FL 33480, USA;
- George DORSEY, administrateur, né le 1
er
janvier 1950 à Baltimore, USA, ayant son adresse professionnelle à 457
Cider Mill Road, Cornwall, VT 05753, USA;
- Eric GRIBETZ, administrateur, né le 13 février 1974 à New York, USA, ayant son adresse professionnelle à 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Mark KRISTOFF, administrateur, né le 10 novembre 1961 à Easton, USA, ayant son adresse professionnelle à 825
Third Avenue, New York, NY 10022, USA;
- Alec MACHIELS, administrateur, né le 9 août 1972 à Wilrijk, Belgique, ayant son adresse professionnelle à 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Stanley de JONGH OSBORNE, administrateur, né le 7 novembre 1970 à Palo Alto, USA, ayant son adresse profes-
sionnelle à 320 Park Avenue, New York, NY 10022, USA;
- Dan STENCEL, administrateur, né le 16 juin 1970 à Point Pleasant, USA, ayant son adresse professionnelle à 99 River
Road, Cos Cob, CT 06787, USA;
- Richard WEINBERG, administrateur, né le 2 septembre 1959 à Brooklyn, USA, ayant son adresse professionnelle à
99 River Road, Cos Cob, CT 06787, USA; et
- Henry MANNIX III, né le 1
er
février 1979 à Hartford, Connecticut, USA, ayant son adresse professionnelle à 320
Park Avenue, New York, NY 10022, USA.
L'associé unique confirme que toutes les deux millions deux cent soixante-treize mille soixante-seize (2.276.076) parts
sociales émises de la Société sont détenues par T-I Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,
ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg et enregistrée au registre de commerce sous le numéro
R.C.S. B 106.007 et quatre cent mille (400.000) parts sociales sont détenues en trésorerie par la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée fut clôturée.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés
à mille deux cents Euro.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le procès-verbal
de l'Assemblée est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la
version française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Après lecture faite, la partie comparante et le notaire ont signé le présent acte,
Signé: K.PARDAENS, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 février 2009. Relation: LAC/2009/6386. Reçu: soixante quinze euros (75 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009045594/211/512.
(090052900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
GSCF Recklinghausen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 133.251.
EXTRAIT
L'actionnaire unique de la société décide conformément aux statuts de la société:
De la nomination de Jeremy Vickerstaff, résidant 22 Mielstrachen, Niederanven, Luxembourg L-6942 en qualité d'ad-
ministrateur de la société pour une durée illimitée et avec effet au 10 février 2009;
Que par conséquent, par suite des démissions de Neil Varnham et Timothy Horrocks le conseil de gérance sera
désormais composé des trois (3) membres suivants:
- Jeremy Vickerstaff
- Erwan le Berre
- John Sutherland
40872
Que tout directeur et/ou secrétaire générale et/ou agent administratif et/ou conseiller juridique de la société a pouvoir
au besoin de concourir à tous actes complémentaires et de signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette
décision avec effet au 10 février 2009, ou toute date ultérieure déterminée par la législation locale.
Luxembourg, le 26 mars 2009.
GSCF Recklinghausen S.àr.l.
Signature
Référence de publication: 2009045388/8648/25.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02461. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Timberland Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1316 Luxembourg, 20B, rue des Carrières.
R.C.S. Luxembourg B 145.557.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundneun, am dreißigsten März.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Thomas Krämer, mit beruflicher Anschrift 20B, rue des Carrières, L-1316 Luxemburg, geboren am 12. Februar
1974 in Duisburg, Deutschland, ordnungsgemäß vertreten durch Frau Verena Zimmermann, Rechtsanwältin, mit beru-
flicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 26. März 2009 in Luxemburg erteilten
Vollmacht.
Nachdem die Vollmacht durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet worden
ist, soll diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.
Solch erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société anonyme aufzunehmen, welche
sie gründen möchte und deren Satzung folgendermaßen lauten soll:
A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz
Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Aktien und/oder jeder anderen Person, die
künftig Aktionär sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société anonyme unter der Firma "Timberland Capital S.A." (die
"Gesellschaft").
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen
Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine
Änderung dieser Satzung erforderlich ist.
Art. 3. Zweck.
3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus
Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
3.2 Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-
gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Verwaltungsratsmitglieds oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder
eines Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches
sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewäh-
ren; und
- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in
welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.
3.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. In-
nerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:
- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-
papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;
40873
- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland beteiligen; und
- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes
beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats
verlegt werden.
4.3 Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in jede andere Gemeinde des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.
4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch
einen Beschluss des Verwaltungsrats errichtet werden.
B. Aktienkapital - Aktien - Aktienverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Aktien
Art. 5. Aktienkapital.
5.1 Ausgegebenes Aktienkapital
5.1.1 Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) bestehend aus
einunddreißigtausend (31.000) Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Aktie.
5.1.2 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss
der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser
Satzung erforderlich ist.
5.1.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden Aktionären/dem bestehen-
den Aktionär zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden solche Aktien den Aktionären im
Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Aktienkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwal-
tungsrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Aktienbezugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser
Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an die Aktionäre/den Aktionär ge-
sendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung ankündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen
kann jedoch die Hauptversammlung der Aktionäre, welche einberufen wurde, um (i) entweder über eine Erhöhung des
Aktienkapitals der Gesellschaft (ii) oder über die dem Verwaltungsrat zu erteilende Ermächtigung, das ausgegebene Ak-
tienkapital der Gesellschaft zu erhöhen, zu bestimmen, das bevorzugte Aktienbezugsrecht der bestehenden Aktionäre/
des bestehenden Aktionärs begrenzen oder aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun. Ein solcher
Beschluss muss in der Weise gefasst werden wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.
5.1.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Aktienkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Haupt-
versammlung herabgesetzt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung
erforderlich ist.
Art. 6. Aktien.
6.1 Das Aktienkapital der Gesellschaft ist in Aktien mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
6.3 Das Recht eines Aktionärs auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl der
von ihm im Aktienkapital der Gesellschaft gehaltenen Aktien.
6.4 Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend
den alleinigen Aktionär, falls anwendbar, oder jeden anderen Aktionär soll die Gesellschaft nicht aufgelöst werden.
6.5 Soweit gesetzlich vorgesehen und unter den gesetzlichen Bedingungen kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien
zurückkaufen oder zurücknehmen.
6.6 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien und können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.
6.7 Bruchteilsaktien sollen auf einer anteilsmäßigen Basis dieselben Rechte gewähren wie ganze Aktien, wobei aufgrund
von Aktien nur dann Stimmrechte ausgeübt werden können, wenn die Anzahl der Bruchteilsaktien in eine oder mehrere
Aktien zusammengefasst werden können. Falls Bruchteilsaktien bestehen, welche nicht zu einer Aktie zusammengefasst
werden können, können aufgrund solcher Bruchteilsaktien keine Stimmrechte ausgeübt werden.
Art. 7. Aktienverzeichnis.
7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Aktionär ein-
gesehen werden kann. Dieses Aktienverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder
eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Aktionär gehaltenen Aktien, die Angabe der auf diese Aktien
geleisteten Zahlungen, jede Übertragung von Aktien und deren Datum gemäß Artikel 8.4 dieser Satzung sowie jedes über
Aktien gewährte Sicherungsrecht.
7.2 Jeder Aktionär wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mitteilen.
Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Aktionärs berufen.
40874
Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Aktien.
8.1 Der Beweis des Eigentums an Aktien kann aufgrund der Eintragung eines Aktionärs im Aktienverzeichnis erbracht
werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Aktionärs werden Zertifikate dieser Eintragungen je nach Lage des Falles
vom Präsidenten des Verwaltungsrats, von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom alleinigen Geschäfts-
führer herausgegeben und unterzeichnet.
8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Wenn eine Aktie mehreren Personen gehört, müssen
sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer der Aktie angesehen
werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einer im Eigentum mehrerer Personen stehenden
Aktie verbundene Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet worden ist.
8.3 Die Aktien sind unbeschadet gesetzlicher Bestimmungen frei übertragbar.
8.4 Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten entweder durch die Eintragung einer
vom Zedenten und vom Zessionar oder von deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung
ins Aktienverzeichnis oder durch Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung, gemäß derer jedes beliebige Verwaltungsratsmitglied die Übertragung in das Aktienverzeichnis eintragen
kann, wirksam.
8.5 Die Gesellschaft kann durch jedes einzelne ihrer Verwaltungsratsmitglieder auch einer solchen Übertragung zus-
timmen und diese ins Aktienverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
9.1 Die Aktionäre üben ihre kollektiven Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
9.2 Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre
aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Aktionär" nicht ausdrücklich in dieser Satzung
erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die "Hauptversammlung der Aktionäre" als Verweis auf den
"alleinigen Aktionär" gelesen werden.
9.3 Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen
Befugnisse.
Art. 10. Ladung der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Verwaltungsrat oder den/
die satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.
10.2 Auf schriftliches, die Tagesordnung enthaltendes und an den Verwaltungsrat oder den/die satzungsmäßigen Buch-
prüfer gerichtetes Ersuchen eines oder mehrerer Aktionäre, die zusammen zumindest 10 Prozent (10%) des ausgegebenen
Aktienkapitals repräsentieren, muss die Hauptversammlung der Aktionäre je nach Lage des Falles vom Verwaltungsrat
oder von dem/den satzungsmäßigen Buchprüfer(n), falls vorhanden, einberufen werden, um innerhalb eines Zeitraums
von einem (1) Monat ab Zugang des Ersuchens an dem Ort und zu der Zeit wie sie sich aus der Ladung zur Versammlung
ergeben abgehalten zu werden.
10.3 Eine Jahreshauptversammlung der Aktionäre muss in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Ge-
sellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie er sich aus der Ladung ergibt am dritten Montag des Monats Mai um
10.00 Uhr abgehalten werden. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre
am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Je nach Lage des Falles muss der Verwaltungsrat oder der/die satzungsmäßige
(n) Buchprüfer die Jahreshauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Abs-
chluss der Gesellschaftskonten einberufen.
10.4 Die Ladung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die
Uhrzeit der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung
anberaumten Datum an jeden Aktionär abzusenden.
10.5 Einer oder mehrere Aktionäre, die insgesamt mindestens zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals
der Gesellschaft repräsentieren, können ersuchen, dass ein Punkt oder mehrere Punkte der Tagesordnung jeder belie-
bigen Hauptversammlung der Aktionäre zugefügt wird/werden. Dieses Ersuchen muss mindestens fünf (5) Tage vor dem
für die Versammlung anberaumten Datum per Einschreiben an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft gesendet werden.
10.6 Wenn an einer Hauptversammlung der Aktionäre alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Hauptversammlung der Aktionäre ohne
vorherige Ladung abgehalten werden.
Art. 11. Abhalten von Hauptversammlungen der Aktionäre.
11.1 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem
Präsidenten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Hauptversammlung der Aktionäre
40875
ernannt wird und welche weder Aktionäre noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen. Der Rat der Versammlung
soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den
Regeln über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.
11.2 In jeder Hauptversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3 Quorum
Für das wirksame Handeln und die wirksame Beschlussfassung der Hauptversammlung der Aktionäre ist kein Quorum
erforderlich, sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt.
11.4 Abstimmung
11.4.1 Jede Aktie gewährt unbeschadet gesetzlicher Vorschriften eine (1) Stimme.
11.4.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in einer
ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen
gefasst unabhängig von dem vertretenen Anteil am Kapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksich-
tigt.
11.5 Ein Aktionär kann an jeder beliebigen Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person,
Aktionär oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch
jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer solchen
Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.
11.6 Es wird vermutet, dass ein Aktionär, der an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz,
Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Aktionär
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören
und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend
ist.
11.7 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch ein unterzeichnetes Stimm-
formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Aktionäre können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionär ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den vorges-
chlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Gesellschaft
wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Hauptversammlung der Aktionäre, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.
11.8 Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen,
damit sie an Hauptversammlungen der Aktionäre teilnehmen können.
Art. 12. Änderung der Satzung. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann diese Satzung durch einen Beschluss der
Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden, welcher bei der ersten Abstimmung mit einer Zweidrittelmehrheit
der gültig abgegebenen Stimmen in einer solchen Versammlung gefasst wird, an der zumindest die Hälfte des ausgegebenen
Aktienkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist. Bei der zweiten Abstimmung wird der Beschluss ungeachtet
des an der Versammlung anwesenden oder vertretenen Kapitalanteils mit einer Zweidrittelmehrheit der in der Ver-
sammlung gültig abgegebenen Stimmen gefasst. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.
Art. 13. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann der Verwal-
tungsrat jede bereits begonnene Hauptversammlung der Aktionäre einschließlich jeder zu einer Satzungsänderung
einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre auf vier (4) Wochen vertagen. Der Verwaltungsrat muss eine bereits
begonnene Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder von mehreren Aktionären beantragt
wird, welche insgesamt mindestens zwanzig Prozent (20%) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft repräsen-
tieren. Durch eine solche Vertagung einer bereits begonnenen Hauptversammlung der Aktionäre wird jeder in dieser
Versammlung bereits getroffene Beschluss wieder aufgehoben.
Art. 14. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
14.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie
von jedem Aktionär, der das ersucht, unterzeichnet wird.
14.2 Der alleinige Aktionär, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse
aufnehmen und unterzeichnen.
14.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen
oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Verwaltungsratspräsidenten, durch zwei beliebige Verwaltungsratsmitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
40876
D. Geschäftsführung
Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates.
15.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, dessen Mitglieder nicht Aktionäre der Gesellschaft
sein müssen.
15.2 Wenn in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat,
kann die Gesellschaft durch einen alleinigen Geschäftsführer verwaltet werden bis zu der Hauptversammlung der Aktio-
näre, die der Erkenntnis der Gesellschaft nachfolgt, dass es mehrere Aktionäre gibt. In einem solchen Fall, soweit
anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in
dieser Satzung genannter Verweis auf den "Verwaltungsrat" als Verweis auf den "alleinigen Geschäftsführer" gelesen wer-
den.
15.3 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung
des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung der
Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Handlungen.
15.4 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten
Fassung können die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Ta-
gesgeschäfts einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Personen, ob sie Aktionäre sind oder nicht,
allein oder gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung and ihre Befugnisse werden durch Verwal-
tungsratsbeschluss festgesetzt.
15.5 Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede
Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.
Art. 16 Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
16.1 Der Verwaltungsrat setzt sich unbeschadet des Artikels 15.2 dieser Satzung aus mindestens einem oder mehreren
Mitgliedern zusammen.
16.2 Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Verwaltungsratspräsidenten wählen. Er kann auch einen Sekretär
ernennen, der weder Aktionär noch Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.
Art. 17. Wahl und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern und Amtszeit.
17.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, welche deren Bezahlung
und Amtszeit festlegt.
17.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied gewählt wird, muss diese eine natürliche Person als
dauernden Vertreter benennen, welche diese Rolle im Namen und für Rechnung der juristischen Person ausübt. Die
betreffende juristische Person kann nur dann ihren dauernden Vertreter abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen
Nachfolger ernennt. Eine natürliche Person kann der dauernde Vertreter nur eines (1) Verwaltungsratsmitglieds sein und
kann nicht gleichzeitig auch das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds innehaben.
17.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Hauptversammlung der Aktionäre
abberufen werden.
17.4 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds kann nicht länger als sechs (6) Jahre betragen, und jedes Verwal-
tungsratsmitglied muss sein Amt weiter ausüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann
auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.
Art. 18. Verhinderung eines Verwaltungsratsmitglieds.
18.1 Wenn das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wegen Todes, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Ausscheidens oder
aus einem anderem Grund unbesetzt ist, kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder vorü-
bergehend besetzt werden, und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, in welcher die Aktionäre, wenn
dies für geeignet erachtet wird, über eine dauerhafte Besetzung bestimmen.
18.2 Wenn im Falle von mehreren Aktionären die Gesamtanzahl der Verwaltungsratsmitglieder unter drei (3) oder
unter eine sich eventuell aus dieser Satzung ergebende höhere Mindestzahl fällt, so muss diese freie Stelle unverzüglich
entweder durch die Hauptversammlung der Aktionäre oder vorübergehend durch die verbleibenden Verwaltungsrats-
mitglieder besetzt werden, und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, welche über die dauerhafte
Besetzung bestimmt.
18.3 Wenn die Verhinderung im Amt des alleinigen Geschäftsführers entsteht, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Hauptversammlung besetzt werden.
Art. 19. Ladung zu Verwaltungsratssitzungen.
19.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner Mit-
glieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
19.2 Die Verwaltungsratsmitglieder müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anbe-
raumten Datum zu jeder Verwaltungsratssitzung per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunika-
tionsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in der Ladung
zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einverständnisses jedes
40877
Verwaltungsratsmitglieds per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, wobei eine
Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch ist eine Ladung zu
Verwaltungsratssitzungen nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden sollen wie in einem
vorausgehenden Beschluss des Verwaltungsrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann nicht erforderlich sein, wenn alle
Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß dieser
Satzung.
Art. 20. Verlauf von Verwaltungsratssitzungen.
20.1 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrats geleitet. In seiner Abwesenheit
kann der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als vorübergehenden Präsidenten ernennen.
20.2 Quorum
Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an
der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
20.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Verwaltungsratssitzung anwesenden oder vertretenen
Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.
20.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Verwal-
tungsratsmitglied schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel bevollmäch-
tigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einen
oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
20.5 Es wird vermutet, dass ein Verwaltungsratsmitglied, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz
oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden
kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung
teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird vermutet, dass eine
durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde.
20.6 Der Verwaltungsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer
ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Verwaltungsratsmitglieder auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert
und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch
jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unters-
chriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das Fassen
der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.
20.7 Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Verwaltungsratsmitglied, das an einer Transaktion,
die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches
mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und
seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende Verwaltungsrats-
mitglied kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die
nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss vor Fassen jedweden Beschlusses betreffend einen Tagesordnungspunkt
über einen solchen Interessenskonflikt informiert werden. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat und
dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt ein
vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Interes-
senskonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden.
Art. 21. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen.
21.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident soll ein Protokoll über jede Ver-
waltungsratssitzung aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.
21.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
21.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden
sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Verwaltungsratspräsidenten,
von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 22. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die alleinige
Unterschrift jedes beliebigen Verwaltungsratsmitglieds oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Un-
terschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat oder
den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. In den Grenzen des Tagesgeschäfts wird die Gesellschaft gegenüber
Dritten durch die Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen diese Befugnis in Verbindung mit dem Tages-
geschäft der Gesellschaft gemäß den Regeln dieser Übertragung allein oder gemeinschaftlich handelnd übertragen wurde.
40878
E. Aufsicht
Art. 23. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
23.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt,
welche Aktionäre sind oder nicht.
23.2 Die Hauptversammlung der Aktionäre soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen
und ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen, welche nicht mehr als sechs (6) Jahre betragen darf. Ein ehemaliger oder
derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Hauptversammlung der Aktionäre wieder ernannt werden.
23.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktio-
näre abberufen werden.
23.4 Im Falle einer Verringerung der Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer durch Versterben oder auf andere Weise
um mehr als die Hälfte muss der Verwaltungsrat die Hauptversammlung der Aktionäre unverzüglich einberufen, um die
freigewordene(n) Stelle(n) zu besetzen.
23.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte
der Gesellschaft.
23.6 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten
der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.
23.7 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher
aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Aktionär noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in dieser Satzung genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Verwaltungs-
ratssitzungen anwendbar sein.
23.8 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt
wird/werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 25. Gewinne.
25.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.
25.2 Die durch einen Aktionär an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage
zugeführt werden, wenn der einlegende Aktionär dieser Zuführung zustimmt.
25.3 Im Falle einer Herabsetzung des Aktienkapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis he-
rabgesetzt werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals nicht übersteigt.
25.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Verwaltungsrat wird die Hauptversammlung
der Aktionäre beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und dieser Satzung verwendet werden soll.
Art. 26. Zwischendividenden - Emissionsagio.
26.1 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden zahlen.
26.2 Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Aktionärsbeschluss oder Beschluss des Verwaltungsrats unter
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Aktienkapitals und die gesetzliche Rücklage
frei an den/die Aktionär(e) ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 27. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt
werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.
H. Anwendbares Recht
Art. 28. Anwendbares Recht. Die Satzung und ihre Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht. Alle
in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.
40879
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2009.
2) Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll in 2010 abgehalten werden.
3) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zeichnenden Aktionäre haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:
Herr Thomas Krämer, vorbenannt, zahlte einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) gegen Zeichnung von
einunddreißigtausend (31.000) Aktien.
Alle Aktien sind ganz in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) von
jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, dass er das Vorliegen der in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in der abgeänderten Fassung genannten Voraussetzungen geprüft hat, und erklärt ausdrücklich,
dass sie alle erfüllt sind.
<i>Auslageni>
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang
mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.
<i>Hauptversammlung der Aktionärei>
Die Gründungsaktionäre, welche das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft repräsentieren und die sich selbst als
ordnungsgemäß geladen erachten, haben sofort eine Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten. Nachdem die Haupt-
versammlung der Aktionäre zunächst überprüft hat, ordnungsgemäß konstituiert zu sein, hat sie einstimmig folgende
Beschlüsse gefasst.
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf zwei (2) festgesetzt und die Zahl der satzungsmäßigen Buchprüfer
auf einen (1).
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt:
(a) Herr Thomas Krämer, mit beruflicher Anschrift 20B, rue des Carrières, L-1316 Luxemburg, geboren am 12. Februar
1974 in Duisburg, Deutschland; und
(b) Herr Dirk Köster, mit beruflicher Anschrift 20B, rue des Carrières, L-1316 Luxemburg, geboren am 18. März 1962
in Duisburg, Deutschland.
3. Die folgende Person wird als satzungsmäßiger Buchprüfer der Gesellschaft ernannt:
Herr Matthias Brinkmann, Steuerberater, mit beruflicher Anschrift Konrad-Adenauer-Platz 5, D-47803 Krefeld, Deuts-
chland, geboren am 14. Mai 1967 in Moers, Deutschland.
4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder soll an dem Zeitpunkt enden, an dem die Hauptversammlung der Ak-
tionäre/der alleinige Aktionär, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für
das Geschäftsjahr 2014 bestimmt, oder an jedem anderen, von der Hauptversammlung der Aktionäre/vom alleinigen
Aktionär, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.
Die Amtszeit des satzungsmäßigen Buchprüfers soll an dem Zeitpunkt enden, an dem die Hauptversammlung der
Aktionäre/der alleinige Aktionär, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft
für das Geschäftsjahr 2009 bestimmt, oder an jedem anderen, von der Hauptversammlung der Aktionäre/vom alleinigen
Aktionär, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.
5. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 20B, rue des Carrières, L-1316 Luxemburg.
Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten
Tag aufgenommen.
Nachdem das Dokument dem/den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat/haben der
Bevollmächtigte/die Bevollmächtigten diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Signé: V. Zimmermann et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 1
er
avril 2009. Relation: LAC/2009/12668. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
40880
Luxembourg, le 6 avril 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009045376/5770/436.
(090051994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Variolabel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.805.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft die am 20. Februar 2009i>
<i>um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz abgehalten wurdei>
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass Herr Christoph Ledergerber zum 20. Februar 2009 als Mitglied des Verwal-
tungsrats zurückgetreten ist.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Frau Annemarie Arens, Head of Sales and Relationship Management, RBC Dexia
Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, als neues Mitglied des Verwaltungsrats bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung zu ernennen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, die Ernennung der Herren Dominic Gaillard und Anders Malcolm als neue Ver-
waltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu bestätigen.
<i>Für Variolabel SICAV
i>Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2009045436/1126/25.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00621. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
INVESCO European Hotel Real Estate II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.600.
In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,
There appeared, Me Cintia Martins Costa, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, as proxyholder of
Invesco European Hotel Real Estate Fund, a société d'investissement à capital variable, having its registered office at 25C,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under
number B 116.664, acting as sole shareholder of Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l. (the "Company") a société
à responsabilité limitée, having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B142.600, incorporated by a deed of the undersi-
gned notary on 21
st
October 2008 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial")
dated 10
th
November 2008, number 2734.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all five hundred (500) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken
on all items of the agenda.
2. The item on which resolutions are to be passed is as follows: Amendment of the third paragraph of article 7 of the
Articles so as to read as follows:
"In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Meetings of the board of managers
shall be held at the registered office or such other place in Luxembourg as the board of managers may from time to time
determine. Resolutions are taken by majority vote of the managers present or represented at the meeting. Any manager
may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication
allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another provided
that where a conference call or video conference is used as a means of communication, it must be initiated and chaired
from Luxembourg."
40881
The decision taken by the sole member is as follows:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to amend the third paragraph of article 7 of the Articles as set out in the agenda.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day beforementioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundneun, am sechsundzwanzigsten Tage des Monats März.
Vor dem Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
erschien Me Cintia Martins Costa, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, als Bevollmächtigte der Invesco
European Hotel Real Estate Fund, eine société d'investissement à capital variable, mit Gesellschaftssitz in 25C, boulevard
Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg unter Nummer B
116.664 als alleiniger Gesellschafter der Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l., eine société à responsabilité limitée,
mit Gesellschaftssitz in 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés
in Luxembourg unter Nummer B 142.600, gegründet durch Urkunde des amtierenden Notars am 21. Oktober 2008,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial"), Nummer 2734 am 10. November
2008.
Die Bevollmächtigte erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der alleinige Gesellschafter hält alle fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile Gesellschaft, so dass rechtsgültig über
alle Punkte der Tagesordnung entschieden werden kann.
2. Der Punkt, über welchen Beschluss gefasst werden soll, ist der folgende:
Änderung von Artikel 7, Absatz drei der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
"Im Falle von mehreren Geschäftsführern, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführersitzung wird im Ge-
sellschaftssitz oder durch Beschluss der Geschäftsführung an einem anderen Ort in Luxemburg abgehalten. Entscheidun-
gen werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Jeder Geschäftsführer kann
an den Geschäftsführungssitzungen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikations-
mitteln, die es ihm ermöglichen mit anderen zu kommunizieren, teilnehmen, vorausgesetzt, dass die Sitzung welche mittels
einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten wird, von Luxemburg aus geleitet und initiiert
wird."
<i>Einziger Beschlussi>
Es wird beschlossen Artikel 7, Absatz drei der Satzung, wie in der Tagesordnung beschrieben, zu ändern.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg an dem zu Beginn des Dokumentes aufgeführten Tag.
Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelegt wurde, wurde das vorliegende Protokoll von dieser
zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: C. MARTINS COSTA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
avril 2009. Relation: LAC/2009/12631. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Hinterlegung beim Gesellschafts und Handelsregister.
Luxemburg, den 7. April 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009045604/242/73.
(090052658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
NDX Market S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 115.425.
In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth of March.
Before Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
40882
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme")
"GOLDEN GROUP S.A.", (the "Company"), with registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscribed
in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 115425, incorporated pursuant to a
deed of Me Henri HELLINCKX, then notary residing in Mersch, on the 7
th
of March 2006, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1167 of the 15
th
of June 2006.
The meeting is presided by Ms. Monique GOERES, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster, 3,
route de Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Christian DOSTERT, private employee,
professionally residing in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the
following:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Change of the name of the Company into "NDX Market S.A." and subsequent amendment of Article 1 of the bylaws.
2. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Resolutioni>
The meeting decides to change the name of the Company into "NDX Market S.A." and to amend subsequently Article
1 of the bylaws, in order to give it the following wording:
" Art. 1. There exists a public limited company ("société anonyme") under the name of "NDX Market S.A.", governed
by the relevant legal dispositions as well as by the present articles of association."
There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt-cinq mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GOLDEN GROUP S.A.", (la
"Société"), avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 115425, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors
notaire de résidence à Mersch, en date du 7 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1167 du 15 juin 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
40883
La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT,
employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement du nom de la Société en "NDX Market S.A." et modification subséquente de l'article 1 des statuts.
2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la Société en "NDX Market S.A." et de modifier subséquemment
l'article 1 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "NDX Market S.A.", régie par les dispositions
légales y afférentes, ainsi que par les présents statuts."
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président ajourne l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de huit cents euros.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des
comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connu du notaire par leur nom, prénom, état civil et domicile, lesdits
comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: GOERES - DOSTERT - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2009. Relation GRE/2009/1231. Reçu soixante quinze euros 75 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): BENTNER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Junglinster, le 7 avril 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009045902/231/101.
(090053004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
Düsseldorf-Airport Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.685.
In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,
There appeared, Me Cintia Martins Costa, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, as proxyholder of
Invesco European Hotel Real Estate S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 25C, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B
119.686, acting as sole shareholder of Düsseldorf-Airport Hotel Investment S.à r.l. (the "Company") a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Registre de
40884
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B119.685, incorporated by a deed of the undersigned notary,
then residing in Mersch, on 20
th
September 2006 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial") dated 14
th
November 2006, number 2118. The articles of incorporation of the Company (the "Articles")
have been amended for the last time by a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 20 February
2007, published in the Mémorial on 7 July 2007, number 1912.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all two hundred and twenty four thousand (224,000) shares in issue in the Company, so
that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The item on which resolutions are to be passed is as follows:
Amendment of the third paragraph of article 7 of the Articles so as to read as follows:
"In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Meetings of the board of managers
shall be held at the registered office or such other place in Luxembourg as the board of managers may from time to time
determine. Resolutions are taken by majority vote of the managers present or represented at the meeting. Any manager
may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication
allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another provided
that where a conference call or video conference is used as a means of communication, it must be initiated and chaired
from Luxembourg."
The decision taken by the sole member is as follows:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to amend and restate the third paragraph of article 7 of the Articles as set out in the agenda.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day beforementioned
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundneun, am sechsundzwanzigsten Tage des Monats März.
Vor dem Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
erschien Me Cintia Martins Costa, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, als Bevollmächtigte der Invesco
European Hotel Real Estate S.àr.l., eine société à responsabilité limitée, mit Gesellschaftssitz in 25C, boulevard Royal,
L-2449 Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg unter Nummer B 119.686 als
alleiniger Gesellschafter der Düsseldorf-Airport Hotel Investment S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, mit Ge-
sellschaftssitz in 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg unter Nummer B 119685, gegründet durch Urkunde des unterzeichnenden Notars, mit dem damaligen
Amtssitz in Mersch, am 20. September 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das
"Mémorial"), Nummer 2118 am 14. November 2006. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt durch Urkunde des
Notars Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 20. Februar 2007 geändert, die im Mémorial Nummer 1912
am 7 Juli 2007 veröffentlicht wurde.
Die Bevollmächtigte erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der alleinige Gesellschafter hält alle zweihundervierundzwanzigtausend (224.000) Gesellschaftsanteile Gesellschaft,
so dass rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung entschieden werden kann.
2. Der Punkt, über welchen Beschluss gefasst werden soll, ist der folgende: Änderung von Artikel 7, Absatz drei der
Satzung der Gesellschaft wie folgt:
"Im Falle von mehreren Geschäftsführern, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführersitzung wird im Ge-
sellschaftssitz oder durch Beschluss der Geschäftsführung an einem anderen Ort in Luxemburg abgehalten. Entscheidun-
gen werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Jeder Geschäftsführer kann
an den Geschäftsführungssitzungen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikations-
mitteln, die es ihm ermöglichen mit anderen zu kommunizieren, teilnehmen, vorausgesetzt, dass die Sitzung welche mittels
einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten wird, von Luxemburg aus geleitet und initiiert
wird."
<i>Einziger Beschlussi>
Es wird beschlossen Artikel 7, Absatz drei der Satzung, wie in der Tagesordnung beschrieben, zu ändern.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
40885
Worüber Urkunde, ausgestellt in Luxemburg, an dem zu Beginn des Dokumentes aufgeführten Tag.
Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelegt wurde, wurde das vorliegende Protokoll von dieser
zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: C. MARTINS COSTA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
avril 2009. Relation: LAC/2009/12629. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.
Luxemburg, den 7. April 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009045605/242/77.
(090052667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
C&M Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi,
(anc. Katla Management Services).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 141.888.
L'an deux mil neuf, le treize mars.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Marc-André LEFEBVRE, employé privé, né à Rocourt (Belgique) le 30 août 1976, demeurant à B-4141 Lou-
veigne (Belgique), 33, Clos Yves Robert,
ici représenté par Monsieur Laurent HITER, employé privé, demeurant professionnellement à Clémency, en vertu
d'une procuration sous seing privé donnée le 10 mars 2009.
Laquelle procuration, après avoir été signée "Ne Varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant
restera annexée aux présentes, pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- suite à une cession de parts sous seing privé intervenue le 12 février 2009,
il a été cédé:
par Tharr Inc., une société ayant son siège social au Suite 13, First Floor, Oliaji trade centre, Francis Rachel Street,
Victoria, Mahe, République des Seychelles enregistrée sous le numéro 047422, à Monsieur Marc-André LEFEBVRE, prén-
ommé, MILLE (1.000) parts sociales de la société à responsabilité - limitée KATLA MANAGEMENT SERVICES.
Ladite cession de parts, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
- en conséquence de ce qui précède, Monsieur Marc-André LEFEBVRE, prénommé, est le seul associé de la société à
responsabilité limitée "KATLA MANAGEMENT SERVICES", ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 534, rue de
Neudorf, constituée suivant acte du notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederanven, en date du 26 août 2008,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2519 du 15 octobre 2008;
Après avoir exposé ce qui précède, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de donner son agrément en ce qui concerne la cession de parts mentionnée ci-avant.
L'associé unique décide également de retirer la version anglaise des statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société en "C&M MANAGEMENT S.à r.l.".
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 1 des statuts pour lui donner
désormais la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination "C&M MANAGEMENT
S. à r.l." (la "Société") , régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en
particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi"), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre
1992 sur les sociétés à responsabilité limitée."
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
40886
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique décide de supprimer les différentes catégories de gérants.
En conséquence, l'associé unique décide de modifier les articles 7 (alinéa premier), 8 (alinéa premier) et 9 (huitième
alinéa) des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:
" Art. 7. Gérance (premier alinéa). La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait
nommé, les gérants formeront un conseil de gérance."
" Art. 8. Représentation (premier alinéa). Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société.
Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la seule signature du gérant technique ou par la signature
conjointe de deux gérants administratifs"
" Art. 9. Procédure (huitième alinéa). Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment
le quorum."
<i>Sixième résolutioni>
L'associé unique décide de révoquer tous les gérants avec effet immédiat et décide de leur donner décharge pour
l'exercice de leur mandat.
<i>Septième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer pour une durée indéterminée à la fonction de gérant:
<i>Gérant Technique:i>
Monsieur Marc-André LEFEBVRE, employé privé, né à Rocourt (Belgique) le 30 août 1976, demeurant à B-4141 Lou-
veigne (Belgique), 33, Clos Yves Robert.
<i>Gérants administratifs:i>
a) Monsieur Raf Corneef Monique VAN LEUVEN, employé privé, né à Hoogstraten (B) le 6 novembre 1974, demeurant
à 54, An Der Deckt, L-9841 Wahlhausen;
b) Monsieur André LEFEBVRE, expert-comptable, né à Seraing (B) le 21 mars 1950, demeurant professionnellement
à L-9501 Wiltz, BP 6;
c) Madame Céline DELVENNE, employée privée, née à Liège (B) le 16 juillet 1978, demeurant à B-4141 Louveigne
(Belgique), 33, Clos Yves Robert.
Monsieur Marc-André LEFEBVRE, prénommé, en sa qualité de gérant technique de la société, déclare accepter ladite
cession de parts au nom et pour compte de la société et dispenser le cédant de la faire notifier à la société, le tout
conformément à l'article 1690 du Code Civil.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200.-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte, il a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: L. HITER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 mars 2009. Relation: LAC/2009/10128. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. Schneider.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009045901/220/86.
(090053039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
Credit Suisse Calmar Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LuxCo 95 S.à r.l.).
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 143.900.
In the year two thousand and nine, on the seventeenth of March,
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg,
40887
There appeared:
1. Credit Suisse Bellain Finance (Luxembourg) S.à r.l. (formerly LuxCo 94 S.à r.l.), a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 143901 and whose registered office is at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg and
2. Credit Suisse Alzette Holdings (Luxembourg) S.à r.l. (formerly LuxCo 93 S.à r.l.), a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 143709 and whose registered office is at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg,
Both acting here represented by Jan BÖING, attorney-at-law, having his professional address in Luxembourg, by virtue
of proxies given under private seal.
Said proxies after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed are the sole shareholders of "LuxCo 95 S.à r.l.", a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 143900, incorporated by a deed of Maître Gérard LECUIT, notary
residing in Luxembourg, dated December 24, 2008, published in the Mémorial C number 210 of January 30, 2009 and
whose bylaws have been modified by a deed of the undersigned notary dated March 17,2009 (the "Company").
Which appearing parties, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Change of the Company's name from "LuxCo 95 S.a r.l." to "Credit Suisse Calmar Investments (Luxembourg) S.à
r.l."
2. Subsequent amendment of Article 2 of the Company's articles of association as follows:
" Art. 2. The denomination of the Company is "Credit Suisse Calmar Investments (Luxembourg) S.à r.l."."
II. That the shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of the Company resolved to change the name of the Company from "LuxCo 95 S.à r.l." to "Credit
Suisse Calmar Investments (Luxembourg) S.à r.l."
<i>Second resolutioni>
The general meeting of the Company resolved to subsequently amend Article 2 of the articles of association of the
Company to read as follows:
" Art. 2. The denomination of the Company is "Credit Suisse Calmar Investments (Luxembourg) S.à r.l."."
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by first and surname, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille neuf, le dix sept mars,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1. Credit Suisse Bellain Finance (Luxembourg) S.à r.l. (ci-avant LuxCo 94 S.à r.l.), une société à responsabilité limitée
constituée selon le droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 143901, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg,
2. Credit Suisse Alzette Holdings (Luxembourg) S.à r.l. (ci-avant LuxCo 93 S.à r.l.), une société à responsabilité limitée
constituée selon le droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 143709, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg,
ici toutes les deux représentées par Me Jan Böing, Rechtsanwalt, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu de procurations lui conférées sous seing privé.
Lesquelles procurations seront signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire soussigné et
resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
40888
Les comparants sont les uniques associés de "LuxCo 95 S.à r.l." une société à responsabilité limitée ayant son siège
social au 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 143900, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 24 décembre 2008, publié au Mémorial C numéro 210 du 30 janvier 2009 et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 mars 2009 (la "Société").
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination de la Société de "LuxCo 95 S.à r.l." en "Credit Suisse Calmar Investments (Lu-
xembourg) S.à r.l.".
2. Modification subséquente de l'Article 2 des statuts de la Société comme suit:
" Art. 2. La dénomination de la société est "Credit Suisse Calmar Investments (Luxembourg) S.à r.l."."
II. Que les associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de changer la dénomination de la Société de "LuxCo 95 S.à r.l." en "Credit Suisse Calmar
Investments (Luxembourg) S.à r.l.".
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique a décidé de modifier par conséquent l'Article 2 des statuts de la Société comme suit:
" Art. 2. La dénomination de la Société est "Credit Suisse Calmar Investments (Luxembourg) S.à r.l."."
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état
et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Böing, Frieders.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 mars 2009. Relation: LAC / 2009 / 10843. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Paul FRIEDERS.
Référence de publication: 2009045904/212/95.
(090052924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
Credit Suisse Bellain Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LuxCo 94 S.à r.l.).
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 143.901.
In the year two thousand and nine, on the seventeenth of March,
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.
There appeared
Credit Suisse Alzette Holdings (Luxembourg) S.à r.l. (formerly LuxCo 93 S.à r.l.), a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 143 709 and whose registered office is at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg,
acting here represented by Jan BÖING, attorney-at-law, having his professional address in Luxembourg, by virtue of
proxy given under private seal.
Said proxy after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed is the sole shareholder of "LuxCo 94 S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
40889
and Companies' Register under number B 143901, incorporated by a deed of the Maître Gérard LECUIT, notary residing
in Luxembourg, dated December 24, 2008 published in the Mémorial C number 192 of January 28, 2009 and whose bylaws
have been modified by a deed of the undersigned notary dated March 17, 2009 (the "Company").
Which appearing person, acting in the above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up the
following resolutions taken by the sole shareholder:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the name of the Company from "LuxCo 94 S.à r.l." to "Credit Suisse Bellain
Finance (Luxembourg) S.à r.l."
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to subsequently amend Article 2 of the articles of association of the Company to read
as follows:
" Art. 2. The denomination of the Company is "Credit Suisse Bellain Finance (Luxembourg) S.à r.l."."
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by first and surname, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille neuf, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu
Credit Suisse Alzette Holdings (Luxembourg) S.à r.l. (ci-avant LuxCo 93 S.à r.l.), une société à responsabilité limitée
constituée selon le droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 143 709, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
ici représentée par Me Jan Böing, Rechtsanwalt, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation lui conférée sous seing privé.
Laquelle procuration sera signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire soussigné et restera
annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'associé unique de "LuxCo 94 S.à r.l." une société à responsabilité limitée ayant son siège social au
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 143 901, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 24 décembre 2008, publié au Mémorial C numéro 192 du 28 janvier 2009 et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 mars 2009 (la "Société").
Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes prises par
l'associé unique:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique a décidé de changer la dénomination de la Société de "LuxCo 94 S.à r.l." en "Crédit Suisse Bellain
Finance (Luxembourg) S.à r.l.".
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique a décidé de modifier par conséquent l'article 2 des statuts de la Société comme suit:
" Art. 2. La dénomination de la Société est "Credit Suisse Bellain Finance (Luxembourg) S.à r.l."."
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état
et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Böing, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mars 2009. Relation: LAC/2009/10842. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
40890
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2009.
Paul FRIEDERS.
Référence de publication: 2009045903/212/75.
(090052931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
Impax Solargen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 140.155.
EXTRAIT
Il ressort des résolutions de l'associé unique tenues par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette, en date du 11 février 2009, que le capital de la société Impax Solar Investments S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.154, a été augmenté
par son associé unique, Impax New Energy Investors L.P., une société en commandite simple (limited partnership) de
droit anglais, ayant son siège social au Pegasus House, 37-43 Sackville Street, London W1S 3EH, Royaume-Uni, enregistrée
auprès du Registrar of Companies pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro LP 10697, entre autres, par
l'apport en nature de deux cent vingt-quatre (224) parts sociales représentant huit virgule dix-sept pour cent (8,17%) du
capital social de la Société, à leur valeur nominale totale de cent dix-sept mille six cents Euros (€ 117.600,-).
Suite à cet apport, les deux mille sept cent quarante (2.740) parts sociales de la Société sont détenues comme il suit:
- deux mille quatre cent soixante-six (2.466) parts sociales sont détenues par Impax New Energy Investors S.C.A., une
société en commandite par actions, constituée et établie sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 121 avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 110.337, et
- deux cent soixante-quatorze (274) parts sociales sont détenues par Impax Solar Investments S.à r.l., prénommée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2009.
Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center – Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2009045437/4170/33.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02027. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
TS Nautilus (Liebknechtstrasse) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.328.200,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.561.
In the year two thousand and nine, on the tenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appears:
TS Nautilus Holdings, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the Luxembourg laws, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under number 120.692,
here represented by Ms. Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue
of a proxy established on May 30
th
, 2008.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
40891
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established in Luxembourg under the name of TS Nautilus (Liebknechtstrasse) S.à r.l. (the "Company") having its registered
office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B,
under number 121.561, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on October 23
rd
, 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December 21
st
, 2006, number 2384, and which bylaws have
been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of December 28
th
, 2006 and published in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 486 dated of March 29
th
, 2007.
II. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 1B Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg to 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
III. Pursuant to the above transfer of registered office, the1
st
paragraph of article 5 of the Company's articles of
association is amended and shall henceforth read as follows:
" Art. 5. first paragraph. The registered office of the Company is established in Luxembourg."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six hundred Euro (€ 600.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarized deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le dix mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TS Nautilus Holdings, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante en vertu des lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrit au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 120.692,
ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 mai 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de TS Nautilus (Liebknechtstrasse) S.à r.l. (la "Société"), une société a responsabilité
limitée régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrit au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 121.561, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 23 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 21
décembre 2006, numéro 2384, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 28
décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 29 mars 2007, numéro 486.
II. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 34-38
Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
III. Suite au transfert du siège social ci-dessus, le 1
er
paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour
avoir désormais la teneur suivante:
" Art. 5. premier paragraphe. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents Euro (€ 600.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
40892
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 mars 2009. Relation: LAC/2009/9828. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck SCHNEIDER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations.
Luxembourg, le 19 mars 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009045758/211/83.
(090053058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
ASM Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 119.379.
In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of March,
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Apex Silver Mines Limited, an exempted company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, and
registered with the Registrar of Companies - Cayman Islands, under number 64989,
represented by Maître Marie-Claude FRANK, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
March 24, 2009.
Said proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed is the sole shareholder of "ASM Services S.à r.l.", having its registered office in 13-15, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under number B 119379,
incorporated on August 29, 2006 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C of November 7, 2006,
number 2077 (the "Company").
Which appearing person, acting in its above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up as
follows:
That the sole shareholder has taken the following resolution:
<i>Resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend Article 7 of the Company's articles of association, so as to add a second
paragraph (the first paragraph remaining unchanged) as follows:
" Art. 7.
(...)
Any funds paid in as premium upon or without issuance of shares are allocated to a special premium reserve, except
for those allocated to the legal reserve. The special premium reserve is at the free disposal of the sole participant or, as
the case may be, the general meeting of participants and the board of managers for equity re-payments, dividends and
any other distributions (including of liquidation proceeds) pursuant to the provisions of articles 9, 12 and 13 below."
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by first and surname, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille neuf, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
40893
Apex Silver Mines Limited, une société exempte constituée sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à
Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, et immatriculée auprès
du Registre des Sociétés - Iles Cayman, sous le numéro 64989,
représentée par Maître Marie-Claude FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le 24 mars 2009.
Laquelle procuration sera signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, et restera
annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'associé unique de "ASM Services S.à r.l.", ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119379,
constituée le 29 août 2006, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C du 7 novembre 2006,
numéro 2077 (la "Société").
Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que l'associé unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associé unique a décidé de modifier l'article 7 des statuts de la Société de manière à ajouter un second paragraphe
(le premier demeurant inchangé) comme suit:
" Art. 7.
(...)
Les fonds versés au titre de prime lors de ou sans émission de parts sociales sont alloués à une réserve de prime
spéciale, à l'exception de ceux alloués à la réserve légale. La réserve de prime spéciale est à la libre disposition de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés et du conseil de gérance aux fins de remboursement
d'apports, de versement de dividendes et de toutes autres distributions (y compris du boni de liquidation) en vertu des
dispositions des articles 9, 12 et 13 ci-dessous."
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état
et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-Cl. Frank, Frieders.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 mars 2009. Relation: LAC/2009/11812. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2009.
Paul FRIEDERS.
Référence de publication: 2009045789/212/79.
(090052909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.
SECURINVEST (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 62, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 136.519.
L'an deux mille neuf, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu
Monsieur Frank K. LÖHRIG, juriste, demeurant au 3, rue du Château Fiat, F-67500 Haguenau, France,
Le comparant déclare être l'unique associé de la société à responsabilité limitée SECURINVEST (LUXEMBOURG) S.à
r.l., ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 62, Val Sainte Croix, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 136.519, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 11 février 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 734 du 26 mars
2008, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
I. L'associé unique détient toutes les parts sociales émises de la Société, de sorte que les résolutions peuvent être
valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
II. Les points sur lesquels les résolutions doivent être prises sont les suivants:
40894
1 - Cession par Monsieur Frank K.LÖHRIG de 499 parts sociales de la société SECURINVEST (Luxembourg) S. à r.l.
à Monsieur Jacek B. MAKOWSKI.
2.- Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par CINQ
CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.
Les parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Jacek B. MAKOWSKI, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2- Monsieur Frank K. LÖHRIG, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
TOTAL: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales."
Le comparant a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolution cession de parts socialesi>
Monsieur Frank K. LÖHRIG, prénommé, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie
de fait et de droit QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (499) parts sociales de la dite société SECURINVEST
(Luxembourg) S.à r.l., à Monsieur Jacek B. MAKOWSKI, conseiller, demeurant au 3, rue du Château Fiat, F-67500 Ha-
guenau, France,
ici présent et ce acceptant, pour le prix de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-).
Le prix de cession a été payé avant les formalités des présentes, ce dont le cédant accorde bonne et valable quittance.
Ensuite Monsieur Frank K. LÖHRIG, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la dite société SECURIN-
VEST (LUXEMBOURG) S.à r.l., déclare par son représentant accepter au nom et pour compte de la société, la cession
de parts sociales ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux disposi-
tions de l'article 1690 du code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le nouvel associé rejoint l'assemblée générale et les résolutions sont prises à l'unanimité des deux associés.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par
CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.
Les parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Jacek B. MAKOWSKI, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2- Monsieur Frank K. LÖHRIG, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
TOTAL: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales."
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge de la cessionnaire qui s'oblige expressément
à leur acquittement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. K. LÖHRIG, J. B. MAKOWSKI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 mars 2009. Relation: LAC/2009/11510. Reçu soixante-quinze euros (75
€).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.
40895
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009044624/242/72.
(090051872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Steiner, d'Argonne, Brown S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7213 Bereldange, 8, am Becheler.
R.C.S. Luxembourg B 54.763.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2009.
<i>Pour la société
i>PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
i>Signature
Référence de publication: 2009045406/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02111. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090052227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Steiner, d'Argonne, Brown S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7213 Bereldange, 8, am Becheler.
R.C.S. Luxembourg B 54.763.
Le bilan au 31/12/2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2009.
<i>Pour la société
i>PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
i>Signature
Référence de publication: 2009045392/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02103. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Steiner, d'Argonne, Brown S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7213 Bereldange, 8, am Becheler.
R.C.S. Luxembourg B 54.763.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2009.
<i>Pour la société
i>PKF Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
i>Signature
Référence de publication: 2009045364/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02109. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
40896
Accelya Investment S.à r.l.
AC Restaurants et Hôtels S.A.
APN CF (No. 1) SICAV-FIS
Artvalue.Com
ASM Services S.à r.l.
Ateliers Kräizbierg
AZ Electronic Materials Holdings Sàrl
Bache Global Series
CFI Sàrl
CFI Sàrl
C&M Management S.à r.l.
Cofide International S.A.
Compagnie de Construction - CDC Société à responsabilité limitée & Cie
Cosma International S.A.
Credit Suisse Bellain Finance (Luxembourg) S.à r.l.
Credit Suisse Calmar Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Crommelco S.A.
Crop Mark S.à r.l.
Déco Plâtre S.à r.l.
Düsseldorf-Airport Hotel Investment S.à r.l.
EAVF Holding II S.à r.l.
EAVF S.à r.l.
EAVF WGS SCS
Eurofinim S.A.
Fair Sponsors S.à r.l.
Flash S.A.
Gera-Home S.à r.l.
GSCF Recklinghausen S.à r.l.
Hoctofin S.A.
Impax Solargen S.à r.l.
INVESCO European Hotel Real Estate II S.à r.l.
JCP gérances et exploitations, s.à r.l.
JP Commercial II S.à r.l.
JP Commercial II S.à r.l.
Katla Management Services
Lid Lift Industrial Development S.A.
LNR Arman S.à r.l.
LuxCo 94 S.à r.l.
LuxCo 95 S.à r.l.
LuxCo Germany S.à r.l.
M.D. International Cargo S.A.
Mermos Investments S.A.
Millenium Financière S.A.
Millenium Financière S.A.
Moritzco Ltd S.A.
Nacofi S.A.
NDX Market S.A.
Opéra Finance International S.A.
PB Holding Company, S.à r.l.
Pravert S.A.
Satine International S.A.
SECURINVEST (Luxembourg) S.à r.l.
Steiner, d'Argonne, Brown S.A.
Steiner, d'Argonne, Brown S.A.
Steiner, d'Argonne, Brown S.A.
Techno Weld S.à r.l.
Thomas Cook Belgium
Timberland Capital S.A.
Transfinancière Européenne S.A.
Transfinancière Européenne S.A.
Traxys
Traxys S.à r.l.
TS Nautilus Holdings S.à r.l.
TS Nautilus (Liebknechtstrasse) S.à.r.l.
TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg) S.à r.l.
Variolabel Sicav
Wedco One (Luxembourg) S.à r.l.
WP Roaming IV S. à r.l.