This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 849
21 avril 2009
SOMMAIRE
ABF European Holdings & Co SNC . . . . . .
40707
Acheria International Group s.à r.l. . . . . . .
40748
Alcuilux Desox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40749
Arabella I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40713
Arc en Ciel Immobilier S.A. . . . . . . . . . . . . .
40712
Atrix Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
40718
Axento S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40717
Ball Investment Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
40716
BGV III Bielefeld S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40706
Bio-Seef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40716
Bugs S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40708
Catering Enterprises International Holding
Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40706
Cirio Del Monte Internationale S.A. . . . . .
40713
CMJ Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40714
Conafex Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40713
Dimac Systems S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40742
Distriwood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40717
DNA Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40738
DNA Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40736
Eubro Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40710
Eurocofin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40710
Fair Bianca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40745
Fiduciaire COFIGEST s.àr.l. . . . . . . . . . . . . .
40717
Fikonmynta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40710
Futura Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40742
Gabriella Luxembourg Holdings Sàrl . . . . .
40708
GAP-Xchange Partners, L.L.C. and Com-
pany, SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40715
GAP-Xchange Partners, L.L.C., SCA . . . . .
40714
Gigipi Mode S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40751
Groupe Olidef S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40747
HSH Investment Management S.A. . . . . . .
40709
Innoco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40745
Integrated Core Strategies (Europe) S. à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40709
Kudelski Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
40713
Lusciniole S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40738
Manufacture d'Orgues Luxembourgeoise
Westenfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40708
Marshall Monteagle Holdings . . . . . . . . . . . .
40715
Merrill Lynch Luxembourg Investments
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40709
MLAnna Real Estate 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
40707
MLAnna Real Estate 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
40706
Morgane Investissements . . . . . . . . . . . . . . .
40715
NG Luxembourg 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
40745
Nidial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40707
Passion´Elle s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40712
PBG Investment (Luxembourg) S.àr.l. . . .
40710
Peter's Soups and Juices . . . . . . . . . . . . . . . .
40730
R&A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40736
REA Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40712
Red & Black S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40752
ReFlow Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40712
Rolo Operation Project S.A. . . . . . . . . . . . .
40711
Services Touristiques S.A. . . . . . . . . . . . . . .
40717
Signum Holdings 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
40711
SSCP Coatings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40715
SSCP Coatings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40714
Timberland Capital Management KG . . . .
40732
Tobago Investment Holding S.A. . . . . . . . .
40707
Tower 6 Bis S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40709
Ugic SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40708
United Investors Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40716
VHCL Deux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40716
VHCL UN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40711
Wald Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40711
Zambia Copper Investments (Luxem-
bourg) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40714
Zidcom Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
40706
40705
BGV III Bielefeld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 142.710.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009036525/242/12.
(090040869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.
MLAnna Real Estate 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.650.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009043957/242/13.
(090050043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.
Zidcom Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 102.430.
Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24.03.2009.
Fidiciaire DI FINO & Associés S.àr.l.
Signature
Référence de publication: 2009043422/4507/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC05831. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090045000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
Catering Enterprises International Holding Limited, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 33.740.
Le bilan de la Société, arrêté au 31 décembre 2007, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 24 mars 2009.
Signature
Un mandataire
Référence de publication: 2009042584/1035/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2009, réf. LSO-DC08360. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090048207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2009.
40706
ABF European Holdings & Co SNC, Société en nom collectif.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 96.924.
<i>Extrait des résolutions écrites date du 27 mars 2009i>
Les associés ont décidé:
- De renommer Paul Egerton-Vernon, John Boothman, François Brouxel, Georges Gudenburg et Peter Russell à la
fonction de gérant pour une durée déterminée jusqu'à la prochaine assemblée générale en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009043421/5564/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2009, réf. LSO-DD00232. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090049331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2009.
Nidial S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 89.414.
Par la présente, le domiciliataire dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège de la société NIDIAL S.A.,
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés, section B 89.414.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2009.
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2009042288/2948/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC03257. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090043375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2009.
MLAnna Real Estate 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.646.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009043961/242/13.
(090050102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.
Tobago Investment Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 88.545.
Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009042354/536/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC02950. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090043198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2009.
40707
Manufacture d'Orgues Luxembourgeoise Westenfelder, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7440 Lintgen, 75, rue de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 6.896.
Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2007.
Signature.
Référence de publication: 2009042356/800096/12.
Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2007, réf. DSO-CF00298. - Reçu 91,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070082025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.
Bugs S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 99.929.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2009.
<i>Pour la société
i>Paul DECKER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009039821/206/13.
(090045690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.
Ugic SA, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 76.605.
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu entre la société EP Services SA, ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 18-20
rue Michel Rodange et la société UGIC S.A. a été dénoncé avec effet au 16 mars 2009 par l'Agent domiciliataire.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2009044194/1334/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08887. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
Gabriella Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 8.895.600,00.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 94.964.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009040018/631/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2009, réf. LSO-DC03533. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090040790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.
40708
HSH Investment Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 122.688.
Die Bilanz am 31.12.07 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2009039955/37/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08115. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090045737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2009.
Merrill Lynch Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.502.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009043965/242/13.
(090050156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.
Integrated Core Strategies (Europe) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.569.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Doeke van der Molen
<i>Géranti>
Référence de publication: 2009044364/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00492. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090050773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
Tower 6 Bis S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 145.339.
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mars 2009 acte n°110 pardevant
Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Jacques DELVAUX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009044226/208/15.
(090051000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
40709
Eubro Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée.
R.C.S. Luxembourg B 99.256.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2009044678/1029/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2009, réf. LSO-DC04596. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
PBG Investment (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.500.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 89.428.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044408/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2009, réf. LSO-DC08185. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090050718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
Eurocofin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 122.988.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 avril 2009.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2009044693/1051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD00868. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Fikonmynta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 90.924.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009044689/631/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08604. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
40710
Signum Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard K. Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 119.057.
Le Bilan au 31 août 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2009044379/1463/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00795. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090050703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
Rolo Operation Project S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 118.539.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06/04/09.
Signature.
Référence de publication: 2009044706/5878/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD00851. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Wald Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 97.804.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 avril 2009.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2009044696/1051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD00862. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
VHCL UN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois.
R.C.S. Luxembourg B 131.740.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 régulièrement approuvés, le rapport de gestion du conseil d'administration,
le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2009044686/7989/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01338. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
40711
Passion´Elle s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8552 Oberpallen, 2, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.246.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 07 Avril 2009.
Fiduciaire COFIGEST S.A R.L.
Isabelle PHILIPIN
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN
Référence de publication: 2009044835/2631/15.
Enregistré à Diekirch, le 13 mars 2009, réf. DSO-DC00099. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(090051778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Arc en Ciel Immobilier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 103.180.
Rapports et comptes annuels pour l'exercice clôture au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2009044909/322/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD00898. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
REA Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 128.430.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044953/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00523. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
ReFlow Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.238.
Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044941/801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01364. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
40712
Cirio Del Monte Internationale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 41.468.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044957/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00533. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Kudelski Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 85.284.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044958/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00538. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Conafex Holdings, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 17.789.
Le bilan au 30 septembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009044952/631/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00449. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Arabella I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 131.565.
Die Adresse des Teilhabers Universal-Investment-Luxembourg S.A. hat sich geändert in 18-20, Parc d'Activité Syrdall,
5365 Munsbach, Luxembourg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 31. März 2009.
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Evelyn Löhnertz / Anja Sonnen
Référence de publication: 2009044951/1779/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00427. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
40713
GAP-Xchange Partners, L.L.C., SCA, Société en Commandite par Actions (en liquidation).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 68.396.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044961/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00553. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
SSCP Coatings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 56.587.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 101.097.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044960/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00541. - Reçu 114,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Zambia Copper Investments (Luxembourg) Ltd, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 13.057.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009044947/631/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2009, réf. LSO-DD00188. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
CMJ Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 111.733.
Rapport et comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009044972/322/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01333. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
40714
GAP-Xchange Partners, L.L.C. and Company, SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 68.397.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044963/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00549. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
SSCP Coatings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 56.587.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 101.097.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044959/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00545. - Reçu 50,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Marshall Monteagle Holdings, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 19.600.
Le bilan au 30 septembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009044950/631/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00452. - Reçu 58,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Morgane Investissements, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 66.314.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2009.
Monsieur Patrick ROCHAS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2009044981/636/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD01106. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
40715
United Investors Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 129.617.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Signatures.
Référence de publication: 2009044688/1176/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01351. - Reçu 60,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Ball Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 90.415.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044956/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00528. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Bio-Seef, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 116.279.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 avril 2009.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Référence de publication: 2009044699/1051/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2009, réf. LSO-DD00860. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
VHCL Deux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois.
R.C.S. Luxembourg B 131.753.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 régulièrement approuvés, le rapport de gestion du conseil d'administration,
le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2009044687/7989/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01345. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
40716
Distriwood S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 92, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 83.959.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2009.
Signature.
Référence de publication: 2009044990/5332/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06294. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090051682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Axento S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 121.993.
Le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2009044979/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2009, réf. LSO-DC08357. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Services Touristiques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 60.949.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2009.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signatures
Référence de publication: 2009044975/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2009, réf. LSO-DC08335. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Fiduciaire COFIGEST s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8552 Oberpallen, 8, Platinereï.
R.C.S. Luxembourg B 94.959.
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 07 Avril 2009.
Fiduciaire COFIGEST S.A R.L.
Isabelle PHILIPIN
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN
Référence de publication: 2009044844/2631/15.
Enregistré à Diekirch, le 24 mars 2009, réf. DSO-DC00228. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(090051797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
40717
Atrix Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 145.567.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twentieth day of March.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
It appeared:
"Atrix Laboratories GmbH", a Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and existing under the laws of
Germany, having its registered address at Hessenring 119-121, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, registered with the trade
register of the local court Bad Homburg, Germany, under number HRB 6885;
duly represented by Mrs. Christina GROSCHE, having her professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17 March 2009.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité
limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owner of the shares and/or anyone who may be a shareholder
in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Atrix Luxembourg S.à r.l." (the
"Company").
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.
Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
3.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds
a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,
the Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
40718
B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares
Art. 5. Share capital. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), consisting
of twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each. Under the terms and
conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by
him/her/it in the Company's share capital.
6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed
shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.6 The Company's shares are in registered form.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.
7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-
holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the
shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.
8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company's corporate bodies.
9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".
9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
40719
9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of
holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the
municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.
10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly
passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.
11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
11.6 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.
40720
D. Management
Art. 14 Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".
14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).
14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone
or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a
chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.
Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-
holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.
16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph.
17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours
at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers.
18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting
of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.
18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.
40721
18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
Art. 19 Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the
board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.
Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole
signature of any member of the board of managers or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or
by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or
by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the
power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and
the limits of such delegation.
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors shall appoint them and
shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.
21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the
law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 22 Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on
thirty-first December of the same year.
Art. 23. Profits.
23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the
remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.
Art. 24. Interim dividends. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment
of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds
40722
are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year
for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves
available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements
of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the
board of managers that the first two conditions haven been satisfied.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
H. Governing law
Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31
December 2009.
2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscriber has subscribed the shares to be issued as follows:
"Atrix Laboratories GmbH", aforementioned, paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) in subscription
for twelve thousand five hundred (12,500) shares.
Total: Twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) paid for twelve thousand five hundred (12,500) shares.
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be two thousand euro.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The number of members of the board of managers is fixed at two (2).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:
a) Mr Sean Moriarty, born on 20 May 1964 in California U.S.A., having his professional address in 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, and
b) Mr Alexander Lussow, born on 23 April 1962 in Kansas U.S.A., having his professional address in 887 Great Northern
Way, Suite 101, Vancouver, BC V5T 4T5 Canada.
The term of the office of the members of the board of managers shall end on the date when the general meeting of
shareholders/sole shareholder shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2009 or
at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder may determine.
4. The address of the Company's registered office is set at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed, together with
the notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundneun, den zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, Zivilrechtsnotar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum
Luxemburg.
Ist erschienen:
40723
"Atrix Laboratories GmbH", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß dem deutschen Recht gegründete und
existent, mit eingetragenem Sitz in Hessenring 119-121, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Bad Homburg unter Registernummer HRB 6885,
ordnungsgemäß vertreten durch Frau Christina GROSCHE, mit beruflicher Adresse in Luxemburg-Stadt, Großher-
zogtum Luxemburg, kraft einer am 17. März 2009.
Nachdem die Vollmachten durch die Bevollmächtigte und den unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet
worden sind, sollen diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.
Solch erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée aufzu-
nehmen, welche sie gründen möchte und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:
A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz
Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen der derzeitigen Inhaberin der Anteile und/oder jeder anderen Person, die
künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma "Atrix
Luxembourg S.à r.l." (die "Gesellschaft").
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen
Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 3. Zweck.
3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus
Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
3.2 Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-
gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und
- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in
welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.
3.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. In-
nerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:
- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-
papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;
- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland beteiligen; und
- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes
beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
4.3 Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch
einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.
B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung
von Geschäftsanteilen
Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) beste-
hend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro
Geschäftsanteil. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der
40724
Gesellschafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags
erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig
(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.
6.3 Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl
der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.
6.4 Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend
den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.
6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-
gekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend
herabgesetzt.
6.6 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.
Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-
schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.
7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft per Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mit-
teilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.
Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1 Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-
schafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.
8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-
sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.
8.3 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter
Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich des Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.
8.4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles
in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesell-
schafterverzeichnis eintragen kann.
8.5 Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen und
diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Do-
kument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.
C. Gesellschafterversammlung
Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1 Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-
terversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
"Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den "alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.
40725
9.3 Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich
verliehenen Befugnisse.
9.4 Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,
statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.
Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit, je nach Lage des Falles, durch den Geschäftsführerrat, den/die
satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.
10.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-
sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort, wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.
10.3 Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit
der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.
10.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.
Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1 In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-
denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.
11.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3 Quorum und Stimmabgabe
11.3.1 Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2 Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-
schafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.
11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,
Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.
11.5 Ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches ermöglicht, dass dieser Gesellschafter identifiziert werden kann
und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und sich effektiv an der
Versammlung beteiligen können, gilt für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit als anwesend.
11.6 Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden
müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.
Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag
durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.
Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie
von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.
13.2 Der/die alleinige Gesellschafter/in, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm/ihr gefassten
Beschlüsse aufnehmen und unterzeichnen.
40726
13.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen
oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein
müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat"
als Verweis auf den "alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.
14.2 Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.
14.3 Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts
können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Beschluss des Geschäfts-
führerrats festgesetzt.
14.4 Die Gesellschaft kann auch durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde spezielle Vollmachten an jede Person
erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.
Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten
des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.
Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit
festlegt.
16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen
werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.
16.3 Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer
kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.
Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1 Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner
Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
17.2 Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung
anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.
Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1 Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner/ihrer
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen.
18.2 Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
18.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder
vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.
40727
18.4 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein
anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
18.5 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und
dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung teil-
nehmen können, gilt für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit als anwesend. Eine durch solche Kommuni-
kationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft gilt als abgehalten.
18.6 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in
einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.
Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung
des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.
19.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden
sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die alleinige
Unterschrift jedes beliebigen Mitglieds des Geschäftsführerrats oder durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsfüh-
rers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen
eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden
ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts
gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit
der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.
E. Aufsicht
Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder
mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.
21.2 Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und
ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.
21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung
abberufen werden.
21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte
der Gesellschaft.
21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten
der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.
21.6 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher
aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu
und das Abhalten von Sitzungen des Geschäftsführerrats sollen anwendbar sein.
21.7 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jeden Jahres und endet am ein-
unddreißigsten Dezember desselben Jahres.
40728
Art. 23. Gewinne.
23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.
23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage
zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.
23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt
werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.
23.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen wird die Gesellschafterversammlung beschließen, wie der verbleibende Rest
des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden
soll.
Art. 24. Zwischendividenden. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden
zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind,
(ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Ge-
schäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener
Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener
Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind,
und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem/ihrem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass
die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung des/der Liquidators/en bestimmt.
H. Anwendbares Recht
Art. 26 Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-
burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2009.
2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zeichnende Gesellschafterin hat die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
"Atrix Laboratories GmbH", vorbenannt, zahlte zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gegen Zeichnung von
zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen.
Gesamt: zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezahlt für zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile.
Alle Geschäftsanteile sind vollständig in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500,-) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Auslageni>
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang
mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf zwei tausend geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, betrachtet sich als ordnungsgemäß
einberufen und hat unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft in einer außerordentlichen Hauptversammlung fol-
gende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf zwei (2) festgesetzt.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:
a) Sean Moriarty, geboren am 20. Mai 1964 in Kalifornien, U.S.A., der seine Geschäftsadresse in 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, hat und
b) Alexander Lussow, geboren am 23. April 1962 in Kansas U.S.A., der seine Geschäftsadresse in 887 Great Northern
Way, Suite 101, Vancouver, BC V5T 4T5 Kanada, hat.
40729
Die Amtszeit der Mitglieder des Geschäftsführerrats soll zu dem Zeitpunkt enden, an dem die Gesellschafterver-
sammlung/der alleinige Gesellschafter, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2009 bestimmt, oder an jedem anderen, von der Gesellschafterversammlung/vom alleinigen
Gesellschafter, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.
4. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-
schienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschie-
nenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung
vorrangig sein.
Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten
Tag aufgenommen.
Nachdem das Dokument dem/den Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevoll-
mächtigte diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: C. GROSCHE, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 25. März 2009. Relation: EAC/2009/3408. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,-
EUR).
<i>Der Einnehmeri>
(gezeichnet): SANTIONI.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Ge-
sellschaften und Vereinigungen.
Beles, den 31. März 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009045391/239/679.
(090052111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Peter's Soups and Juices, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 145.577.
STATUTS
L'an deux mille neuf,
Le vingt-sept mars,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
Monsieur Pierre APPOCHER, gérant de sociétés, né à Briey (France), le 30 décembre 1975, demeurant à F-54560
Audun-Le-Roman, 19, rue de Serrouville,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'il déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étranger, l'exploitation d'un établissement
de restauration rapide avec un bar à soupes ainsi qu'un bar à jus de fruits et légumes avec débit de boissons alcooliques
et non-alcooliques.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. La société prend la dénomination de "Peter's Soups and Juices", société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Les cent vingt-cinq (125) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Pierre APPOCHER, prénommé.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé reconnaît.
40730
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille neuf.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,00).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Pierre APPOCHER, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Appocher, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1
er
avril 2009. Relation LAC / 2009 / 12651. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
40731
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 avril 2009.
Emile SCHLESSER.
Référence de publication: 2009045331/227/85.
(090052204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Timberland Capital Management KG, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1316 Luxembourg, 20B, rue des Carrières.
R.C.S. Luxembourg B 145.558.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundneun, am dreißigsten März.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1. Der Komplementär, Timberland Capital S.A., eine gemäß dem Luxemburgischen Recht gegründete und existierende
Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 20B, rue Carrières, L-1316 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburgischen
Handels- und Gesellschaftsregister, ordnungsgemäß vertreten durch Frau Verena Zimmermann, Rechtsanwältin, mit be-
ruflicher Anschrift in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 26. März 2009 in Luxemburg erteilten
Vollmacht;
2. Der Kommanditist, Herr Thomas Krämer, mit beruflicher Anschrift in 20B, rue des Carrières, L-1316 Luxemburg,
geboren am 12. Februar 1974 in Duisburg, Deutschland, ordnungsgemäß vertreten durch Frau Verena Zimmermann,
Rechtsanwältin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 26. März 2009 in
Luxemburg erteilten Vollmacht.
Nachdem die Vollmachten durch die Bevollmächtigte und die unterzeichnende Notarin "ne varietur" unterzeichnet
worden sind, sollen diese an diese Urkunde angeheftet werden, um mit derselben registriert zu werden.
Die erschienenen Parteien haben die Notarin ersucht, die Gründungsurkunde einer Kommanditgesellschaft aufzuneh-
men, welche sie gründen möchten und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:
A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz
Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die
künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer Kommanditgesellschaft unter der Firma "Timberland
Capital Management KG".
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen
Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 3. Zweck.
3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus
Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Gesellschaften im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
3.2 Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit gewähren für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten
jeder Gesellschaft, in welcher sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welcher
sie auf andere Weise investiert hat oder welche derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von
Verbindlichkeiten des Komplementärs oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder einer Gesellschaft,
in welcher sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welcher sie auf andere Weise
investiert hat oder welche derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft; und
- jede Gesellschaft, in welcher sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welcher
sie auf andere Weise investiert hat oder welche derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, Finanz-
mittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.
3.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. In-
nerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:
- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-
papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;
- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jeder Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg oder im
Ausland beteiligen; und
40732
- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jeder
beliebigen Luxemburger oder ausländischen Gesellschaft handeln.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Komplementärs
verlegt werden.
4.3 Er kann durch Beschluss des Komplementärs in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch
einen Beschluss des Komplementärs errichtet werden.
B. Stammkapital - Anteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung
von Geschäftsanteilen
Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt eintausend und ein Euro (EUR 1.001), bestehend aus
eintausend (1.000) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil und einem (1) Komplementär-
santeil mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1).
Jeder Anteil gewährt eine Stimme bezüglich der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 6. Änderung des Stammkapitals. Das Stammkapital kann jederzeit von dem Komplementär geändert werden.
Art. 7. Anteile. Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Anteil an. Sollte das Eigentum an einem Anteil
aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesem Anteil geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten
ernennen, um die aus dem Anteil resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten.
Art. 8. Gesellschafterverzeichnis.
8.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, das durch jeden Gesell-
schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Anteile, jede Übertragung von Anteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die Gesellschaft oder
das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem Gesellschaftsver-
trag sowie jedes über Anteile gewährte Sicherungsrecht.
8.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung
mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.
Art. 9. Übertragung der Anteile.
9.1 Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Übertragung an einen Nicht-Gesellschafter kann
nur mit Einwilligung aller Gesellschafter erfolgen. Die Übertragung der Anteile führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
9.2 In Übereinstimmung mit Artikel 1690 des Code Civil ist die Abtretung gegenüber der Gesellschaft wirksam, wenn
sie der Gesellschaft mitgeteilt wurde oder von ihr angenommen wurde.
Art. 10. Haftung. Jeder Anteil gibt Recht auf einen anteiligen Betrag des Gewinns und des Gesellschaftsvermögens
sofern nicht anders in der Gesellschafterversammlung einstimmig beschlossen.
Die Komplementäre haften unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für die Gesellschaftsverpflichtungen.
Die Kommanditisten haften für die Schulden und Verluste der Gesellschaft bis zur Höhe des von ihnen eingebrachten
Gesellschaftskapitals beschränkt.
C. Gesellschafterversammlung
Art. 11 Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
11.1 Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
11.2 Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich
verliehenen Befugnisse.
11.3 Gemeinschaftliche Entscheidungen können auch auf dem Schriftwege erfolgen, wenn alle Gesellschafter zustim-
men.
Art. 12. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
12.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Komplementär oder durch
Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, ein-
berufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.
12.2 Einmal im Jahr sollen sich die Gesellschafter treffen oder einen schriftlichen Beschluss fassen, dessen Tagesordnung
die Annahme der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Berichts des Komplementärs, die Entscheidung
über die Verwendung des Nettogewinns und die Entlastung des Komplementärs enthält.
40733
Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der
Gesellschaftskonten einberufen werden.
12.3 Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit
der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.
12.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.
Art. 13. Abhalten von Gesellschafterversammlungen.
13.1 In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden, der aus einem Vorsitzenden,
einem Sekretär und einem Prüfer besteht, die alle durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden und welche
weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll insbesondere
sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln über Ladung,
Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.
13.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
13.3 Quorum und Stimmabgabe
13.3.1 Jeder Anteil gewährt eine (1) Stimme.
13.3.2 Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-
schafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.
13.4 Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,
die entweder ein Gesellschafter oder ein Nicht-Gesellschafter sein kann, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf
dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schrift-
lich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer solchen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann
mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.
13.5 Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Vi-
deokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesellschafter
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören
und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend
ist.
13.6 Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-
formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.
Art. 14. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag
durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.
Art. 15. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
15.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie
von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.
15.2 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet oder welche
einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufge-
nommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen je nach
Lage des Falles durch den Komplementär unterzeichnet werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
40734
Art. 17. Gewinne. Der Komplementär bereitet die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Bericht des
Komplementärs, vor. Die Kommanditisten können am Gesellschaftssitz Einsicht in den Bilanzen und Dokumente der
Gesellschaft nehmen. Sie können sich von einem Sachverständigen begleiten lassen.
D. Geschäftsführung
Art. 18. Die Gesellschaft wird ausschließlich durch den Komplementär, Timberland Capital S.A. verwaltet. Gegenüber
Dritten ist der Komplementär befugt, im Namen der Gesellschaft im weitesten Sinn zu handeln und Verwaltungs- sowie
Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche dem Zweck der Gesellschaft dienen. Der Komplementär vertritt die Ge-
sellschaft rechtsgültig durch seine alleinige Unterschrift.
Kommanditisten sollen auf keinen Fall die Geschäfte der Gesellschaft führen. Jedoch gilt dieser Verbot nicht für
Äußerungen, Ratschläge, Aufsichtshandlungen und Ermächtigungen die gegenüber dem Komplementär bezüglich Tätig-
keiten gemacht werden, die dessen Entscheidungsbereich überschreiten.
E. Auflösung und Liquidation
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren. Fassen
die Gesellschafter keine Entscheidung in dieser Hinsicht, so ist der Komplementär Dritten gegenüber als Liquidator
anzusehen.
F. Anwendbares Recht
Art. 20. Für sämtliche in dieser Satzung nicht geregelte Punkte gelten das Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetze in der jeweils gültigen Fassung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am 31. Dezember 2009.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Die Erschienenen haben die Anteile wie folgt zu zeichnen:
<i>Kommanditist:i>
1) Herr Krämer, vorgenannt,
zahlte eintausend Euro (EUR 1.000) für eintausend (1.000) Anteile
<i>Komplementär:i>
2) Timberland Capital S.A., vorgenannt,
zahlte einen Euro (EUR 1) für ein (1) Komplementäranteil
Insgesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eintausend und ein (1.001) Anteile
Alle Anteile wurden einbezahlt, sodass die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von eintausend
und einem Euro (EUR 1.001) verfügt, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Auslageni>
Die gesamten Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer
Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden sollen,
werden auf eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Alsdann haben sich die Gesellschafter, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Generalversammlung zusammengefunden und haben einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Die Gesellschafter beschließen, den Sitz der Gesellschaft in 20B, rue des Carrières, L-1316 Luxemburg, festzulegen.
<i>Worüber Urkundei>
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem
amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.
Signé: V. Zimmermann et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 1
er
avril 2009. Relation : LAC/2009/12670. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
40735
Luxembourg, le 6 avril 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009045378/5770/213.
(090052000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
DNA Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 105.147.
Par la présente a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions d'administrateur au sein de votre société
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 mars 2009.
LDF DIRECTOR I LTD
Signature
Référence de publication: 2009045396/4507/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2009, réf. LSO-DD00332. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090052390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
R&A S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 132, rue de Muehlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 145.560.
STATUTS
L'an deux mille neuf, le vingt-six mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1) Monsieur Romain THEIS, chauffeur, demeurant à L-1631 Luxembourg, au 65, rue Glesener;
2) Monsieur Acacio FERREIRA RODRIGUES, salarié, demeurant à L-1521 Luxembourg, au 95, rue Adolphe Fischer.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "R&A S. à r.l.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de café-brasserie avec débit de boissons alcooliques et
non-alcooliques, ainsi que la petite restauration.
En outre, elle aura pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La société pourra
acquérir, développer, recevoir et donner en licence des brevets, marques et autres droits de propriété industrielle.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie
de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle
dispose d'un intérêt direct ou indirect.
La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur
et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.
En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières
et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation et
le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
40736
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitement et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des disposition légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende
intérimaire.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux disposition légales.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finit le 31 décembre 2009.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Romain THEIS, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts sociales;
2) Monsieur Acacio FERREIRA RODRIGUES, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts sociales;
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts sociales.
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la société est établi à L-2168 Luxembourg, 132, rue de Muehlenbach.
2) Est nommé gérant administratif:
Monsieur Romain THEIS, chauffeur, demeurant à L-1631 Luxembourg, au 65, rue Glesener.
Est nommé gérant technique:
Monsieur Acacio FERREIRA RODRIGUES, salarié, demeurant à L-1521 Luxembourg, au 95, rue Adolphe Fischer.
La société sera engagée par la signature du gérant technique pour tous les actes de gestion quotidienne et jusqu'à un
montant de cinq cents euros (EUR 500,-). La signature conjointe des gérant technique et gérant administratif sera requise
au-delà de cinq cents euros (EUR 500,-).
DONT ACTE, fait est passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Theis, A. Ferreira Rodrigues et M. Schaeffer.
40737
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 30 mars 2009. Relation: LAC/2009/12098. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2009.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2009045379/5770/94.
(090052012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
DNA Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 105.147.
Par la présente, la soussignée, LDF DIRECTOR II GROUP LTD, a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses
fonctions d'administrateur au sien de votre société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 mars 2009.
LDF DIRECTOR II GROUP LTD
Signature
Référence de publication: 2009045393/4507/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2009, réf. LSO-DD00333. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090052394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Lusciniole S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 145.563.
STATUTS
L'an deux mille neuf, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
la société «IHL-Seupar S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg,
ici représentée par:
Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 20 mars 2009.
La procuration signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «Lusciniole S.A.».
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
40738
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou
indirectes, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions ordinaires
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital autorisé est fixé à trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR) qui sera représenté par trente et un mille
(31.000) actions, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents
statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans
les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec
ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-
vertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables, en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra
se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.
La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.
<i>Usufruit et Nu-propriétéi>
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée
soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire».
Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont les suivants:
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extra-ordinaires, sauf pour l'assemblée se prononçant sur la
mise en liquidation de la société,
- droit aux dividendes.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par
le droit commun pour autant qu'ils n'aient pas été expressément réservés ci-avant à l'usufruitier et en particulier le droit
au produit de la liquidation de la société.
La titularité de l'usufruit et de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l'usufruitier de la mention «usufruit»,
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention «nue-propriété».
Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et
- par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-
tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
40739
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
40740
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2009.
2.- La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2010.
<i>Souscription et Libérationi>
Les trois cent dix (310) actions sont souscrites par la société «IHL-Seupar S.A.», prénommée.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à mille cinq cents euros.
<i>Décision de l'actionnaire uniquei>
Et aussitôt l'actionnaire, représentant l'intégralité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1) Monsieur Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki, République Démocratique du Congo, employé privé,
demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
2) Monsieur Guillaume Scroccaro, né le 9 septembre 1977 à Thionville, employé privé, demeurant professionnellement
au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
3) Madame Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant profes-
sionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Monsieur Alain Geurts, prénommé, est nommé Président du Conseil d'Administration.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Marc BESCH, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. MIGNON, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1
er
avril 2009. Relation: EAC/2009/3706. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): BOIÇA.
40741
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Belvaux, le 6 avril 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009045385/239/197.
(090052035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Dimac Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 97.113.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2009045287/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD02096. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090052166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Futura Kirchberg, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 145.590.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundneun, den ersten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
SUBLIMO Stiftung unter dem Recht des Fürstentums Liechtenstein, mit Sitz in FL-9490 Vaduz, Äulestrasse 5,
hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in L-2740 Luxemburg, 3, rue Nicolas Welter,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 24. März 2009.
Welche Vollmacht nach gehöriger „ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
welcher Komparent den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche er hiermit grün-
det, zu beurkunden wie folgt:
Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung "FUTURA KIRCHBERG" wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geei-
gnet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit
nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches
unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien und der Erwerb
von Beteiligungen unter irgendwelche Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften welche im Bereich der
Immobilienverwaltung tätig sind sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme
von allen anderen Anlageformen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben. Die Gesellschaft hat ebenso
40742
zum Zweck die Beteiligung und den Beteiligungshandel an anderen Gesellschaften. Sie kann alle Arten von Wertpapieren
und Rechten insbesondere Patente und sonstige Nutzungsrechte erwerben, dieselben verwalten und verwerten. Die
Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben, welche mittelbar oder unmittelbar mit Ihrem Ge-
sellschaftszweck zusammenhängen.
Titel II - Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundert tausend Euro (500.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000)
Aktien von jeweils fünfhundert Euro (500,- EUR).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesell-
schaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die société anonyme à
Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat ("directoire et conseil de surveillance") und die Einmannaktiengesell-
schaft („société anonyme unipersonnelle"). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter"
bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher
Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Titel III - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-
schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter
oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt,
kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter ("ad-
ministrateur unique") bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem
Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft
erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen durch die Einzelunterschrift eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes
rechtmäßig verpflichtet.
Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.
Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen
und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft
vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
40743
Titel V - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag des Monats Juni um 10.30 Uhr,
am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden
Befugnisse aus.
Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abs-
chreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen
und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrie-
ben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder
mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2010 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, erklärt die Komparentin, die Gesamtheit des Gesellschafts-
kapitals, das heißt eintausend (1.000) Aktien, zu zeichnen und voll und ganz einzuzahlen, so dass ab sofort der Gesellschaft
ein Kapital von fünfhundert tausend Euro (500.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich
nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein 1900,- EUR zu deren Zahlung die Gründer
sich persönlich verpflichten.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Alsdann hat der vorgenannte Komparent, welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingesellschafter folgende
Beschlüsse gefasst:
1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
a) Herr Romain BONTEMPS, réviseur d'entreprises, berufsansässig in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.
b) Herr Ronald WEBER, réviseur d'entreprises, berufsansässig in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.
c) Herr Carlo REDING, réviseur d'entreprises, berufsansässig in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.
3.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PKF ABAX AUDIT, mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 142.867, wird zum Kommissar
ernannt.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2014.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
40744
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,
dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M.MAYER, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 avril 2009. Relation: LAC/2009/13164. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.
Luxemburg, den 6. April 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2009045313/206/149.
(090052326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Innoco S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. Fair Bianca S.A.).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 69.135.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour INNOCO S.A.
i>FIDALUX S.A.
<i>Le domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2009045141/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2009, réf. LSO-DD01957. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
NG Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 158.000,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 120.899.
In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of March.
Before Me Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
NG Luxembourg Holdings Limited, a company governed by the laws of England, having its registered office at 1-3
Strand, London WC2N 5EH, United Kingdom and registered under number 5284989,
hereby represented by Mrs Senay GUREL, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 16 March 2009, (the "Sole Shareholder").
The said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Sole Shareholder is the sole sha-
reholder of NG Luxembourg 3 S.à r.l., a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) governed by
the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365, Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 120.899,
incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
dated 12 October 2006, published on 28 November 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2221 (the "Company"). The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed dated 25
February 2009 of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement
of Me Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder represented as above mentioned has recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
40745
<i>Agenda:i>
1 To amend the starting date and the ending date of the Company's financial year and to amend article 21 of the articles
of incorporation of the Company, so that said article shall read as follows:
"The Company's financial year begins on the eighteenth day of March of each year and ends on the seventeenth day
of March of the following year."
2 To resolve that the current financial year which began on 5 November 2008 shall end on 17 March 2009.
3 Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the starting date and the ending date of the Company's financial year and
resolved to consequently amend article 21 of the articles of incorporation of the Company, so that said article shall read
as follows:
"The Company's financial year begins on the eighteenth day of March of each year and ends on the seventeenth day
of March of the following year."
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved that the current financial year which began on 5 November 2008 shall end on 17 March
2009.
<i>Costsi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of the present deed amount to one thousand one hundred Euro (1,100.- EUR).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le seize mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel restera
dépositaire du présent acte.
A comparu:
NG Luxembourg Holdings Limited, une société de droit anglais, ayant son siège social au 1-3 Strand, London WC2N
5EH, Royaume-Uni et enregistrée sous le numéro 5284989,
représentée aux fins des présentes par Madame Senay GUREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration donnée le 16 mars 2009 ("l'Associé Unique").
La prédite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée
aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
L' Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé Unique est le seul associé de NG Luxembourg
3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au, 9, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365, Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 120.899, constituée suivant acte reçu par Me Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 12 octobre 2006, publié le 28 novembre 2006 au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2221 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), agissant
en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date
du 25 février 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à inter-
venir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Modification de la date d'ouverture et de la date de clôture de l'année sociale de la Société et modification de l'article
21 des statuts de la Société, de sorte que ledit article soit lu comme suit:
"L'année sociale de la Société commence le dix-huitième jour du mois de mars de chaque année et finit le dix-septième
jour du mois de mars de l'année suivante."
40746
2 Décision de clôturer l'année sociale en cours, commencée le 5 novembre 2008, au 17 mars 2009.
3 Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier la date d'ouverture et la date de clôture de l'année sociale de la Société et, par
conséquent, de modifier l'article 21 des statuts de la Société, de sorte que ledit article soit lu comme suit:
"L'année sociale de la Société commence le dix-huitième jour du mois de mars de chaque année et finit le dix-septième
jour du mois de mars de l'année suivante."
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de clôturer l'année sociale en cours, commencée le 5 novembre 2008, au 17 mars 2009.
<i>Coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte
sont estimés à environ mille cent Euros (1.100,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. GUREL, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 20 mars 2009. Relation: LAC/2009/10803. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009045136/220/107.
(090052249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2009.
Groupe Olidef S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7622 Larochette, 14A, rue Osterbour.
R.C.S. Luxembourg B 132.914.
L'an deux mille neuf, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Olivier DEFOORT, indépendant, né à Draguignan (France), le 20 décembre 1979 demeurant à L-7622 La-
rochette, 14a, rue Osterbour,
ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Larochette, le 22 mars 2009.
La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'actionnaire unique de GROUPE OLIDEF S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-9909
Troisvierges, 17a, rue de Bellain, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B, numéro 132.914, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 octobre 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 2689 du 22 novembre 2007 (ci-après la "Société").
Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, a requis le notaire sous-
signé de prendre acte de ses résolutions comme suit:
<i>Première résolution:i>
L'actionnaire unique décide de transférer le siège social de la Société de L-9909 Troisvierges, 17a, rue de Bellain vers
L-7622 Larochette, 14a, rue Osterbour.
40747
<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la résolution qui précède, l'actionnaire unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de
la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
" Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Larochette."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2009. LAC/2009/11652. Reçu soixante quinze euros €75,-.
<i>Le Receveuri>
(signé): SANDT.
- POUR EXPÉDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 3 avril 2009.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2009044623/7241/38.
(090051790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Acheria International Group s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 124.111.
L'an deux mil neuf, le douze mars.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Nicolas Zastavni, ingénieur informaticien, domicilié et résidant à B-1325 Chaumont-Gistoux, Chemin du
Beter, 5
ici représenté par Monsieur Christophe Fender, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 Janvier 2009.
laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, représenté comme ci-avant, agissant en sa qualité d'associé unique, représentant l'intégralité du
capital social de la société à responsabilité limitée "ACHERIA INTERNATIONAL GROUP S.à r.l." avec siège social à
L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo,
constituée suivant acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 23 janvier
2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 565 du 7 avril 2007.
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 124.111,
Lequel associé unique, représentant l'intégralité du capital, a requis le notaire d'acter la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L'associé unique a décidé de transférer le siège social vers L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères et en conséquence
le premier alinéa de l'article 2 (1
er
alinéa) aura la teneur suivante:
" Art. 2. (1
er
alinéa). Le siège social de la société est établi dans la Commune de Hesperange."
<i>Frais.i>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement à 800.- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C.FENDER, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mars 2009. Relation: LAC/2009/10426. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
40748
Luxembourg, le 30 mars 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2009044627/206/39.
(090051889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Alcuilux Desox S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang.
R.C.S. Luxembourg B 143.064.
Im Jahre zweitausend und neun, am sechsundzwanzigsten März,
vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,
Ist erschienen:
Die Aktiengesellschaft Luxemburgischen Rechts Gottschol Alcuilux S.A., mit Gesellschaftssitz in L-9779 Eselborn, 18,
Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter
Nummer B92809,
hier vertreten durch Frau Mevlüde-Aysun TOKBAG, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, gemäß Voll-
macht vom 24. März 2009,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, von der Bevollmächtigten und dem amtierenden
Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert
zu werden.
Die Aktiengesellschaft Alcuilux Desox S.A. wurde gegründet durch Urkunde von Notar Jean SECKLER, vorgenannt,
am 11. November 2008, veröffentlicht im Amtsblatt "Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C" Nummer 2931
vom 9. Dezember 2008.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Mevlüde Aysun TOKBAG, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in L-2320
Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Die Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Fräulein Mandy FLORIJAN, Sekretärin,beruflich wohnhaft in L-2320 Lu-
xemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Fräulein Nathalie HOULLE, Avocat, beruflich wohnhaft in L-2320 Luxem-
burg, 69, boulevard de la Pétrusse.
Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes
zu beurkunden:
A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 8.969.000.- (acht Millionen neunhundertneunundsech-
zigtausend Euro) von seinem jetzigen Betrag von EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 310 (dreihun-
dertzehn) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100.- (einhundert Euro) auf den Betrag von EUR 9.000.000,- (neun
Millionen Euro), eingeteilt in 90000 (neunzigtausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro)
durch Sacheinlage bestehend aus sämtlichen betriebsnotwendigen Aktiva und Passiva der Desoxidation Aluminium Ab-
teilung der Gottschol Alcuilux S.A., eine Gesellschaft Luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-9779 Eselborn,
18, Op der Sang, ZI. Eselborn-Lentzweiler, und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B92809,
einschließlich sämtlichen Anteilen der Gottschol Alucom Aluminium - Produktions GmbH, eine Gesellschaft Deutschen
Rechts, mit Gesellschaftssitz in Ennepetal und eingetragen im Handelsregister von Hagen unter HRB 6328, worin Gott-
schol Alcuilux S.A. 100% der Anteile hält („Desox Abteilung").
2) Ausgabe von insgesamt 89.690 (neunundachtzigtausendsechshundertneunzig) neuen Aktien zu einem Nennwert von
je EUR 100,- (einhundert Euro), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten verbunden sind wie die bereits existie-
renden Aktien.
3) Zeichnung und Einzahlung der insgesamt 89.690 (neunundachtzigtausendsechshundertneunzig) zusätzlichen Aktien
mit einem Nennwert zu jeweils EUR 100,- (einhundert Euro), zusätzlich eines Aktienaufschlages in Höhe von EUR 99,19
(neunundneunzig Euro und neunzehn Cent) je Aktie, und zwar wie folgt durch durch Sacheinlage durch Gottschol Alcuilux
S.A. und bestehend aus sämtlichen betriebsnotwendigen Aktiva und Passiva der Desox Abteilung, einschließlich sämtlichen
Anteilen der Alucom GmbH, worin Gottschol Alcuilux S.A. 100% der Anteile hält.
4) Änderung von Artikel 5 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft um der Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen mit
folgendem neuen Wortlaut:
" Art. 5. Satz 1. „Das Gesellschaftskapital beträgt KUR 9.000.000.- (neun Millionen Euro), aufgeteilt in 90.000 (neun-
zigtausend) Aktien mit einem Nennwert von EUR 100.- (einhundert Euro)."
5) Vollmachterteilung an Herrn Ralph Gottschol das Gesellschafterregister der Gesellschaft in Folge der Kapitalerhö-
hung zu ändern.
6) Verschiedenes.
40749
B) Dass der vertretene Alleingesellschafter alle von den 310 ausgegebenen Aktien der Gesellschaft hält.
C) Dass die Vollmacht des vertretenen Gesellschafters, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem
unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen wird, um mit derselben einregistriert zu
werden.
D) Dass diese Versammlung ordnungsgemäß einberufen ist, das erforderliche Quorum erreicht wurde und dass
rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte gefasst werden können.
Alsdann hat die außerordentliche Generalversammlung des Alleingesellschafters folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 8.969.000,- (acht
Millionen neunhundertneunundsechzigtausend Euro) von seinem jetzigen Betrag von EUR 31.000,- (einunddreißig tausend
Euro) eingeteilt in 310 (dreihundertzehn) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), auf den Betrag
von EUR 9.000.000,- (neun Millionen Euro), eingeteilt in 90.000 (neunzigtausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR
100,- (einhundert Euro) durch Sacheinlage bestehend aus sämtlichen betriebsnotwendigen Aktiva und Passiva der Desox
Abteilung der Gottschol Alcuilux S.A., eine Aktiengesellschaft Luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-9779
Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxem-
burg unter Nummer B92809, einschließlich sämtlichen Anteilen der Gottschol Alucom Aluminium - Produktions
GmbH,eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-58256 Ennepetal-Has-
perbach, Hagener Strasse 274, und eingetragen im Handelsregister von Hagen unter HRB 6328, worin Gottschol Alcuilux
S.A. 100% der Anteile hält.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt die Ausgabe von insgesamt 89.690 (neunundachtzigtausendsechshundertneunzig)
neuen Aktien zu einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten
verbunden sind wie die bereits existierenden Aktien.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Es erscheint nunmehr Frau Mevlüde-Aysun TOKBAG, vorgenannt, als Bevollmächtigte der Gottschol Alcuilux S.A.,
vorbezeichnet,
aufgrund der Vollmachtserteilung innerhalb der Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder der Gottschol Alcuilux S.A. vom
24. März 2009, und zeichnet vollständig die insgesamt 89.690 (neunundachtzigtausendsechshundertneunzig) neu ausge-
gebenen Aktien mit einem Nennwert zu jeweils EUR 100.- (einhundert Euro), zusätzlich eines Aktienaufschlages in Höhe
von EUR 99,19 (neunundneunzig Euro und neunzehn Cent) je Aktie, und zahlt diese neuen Aktien vollständig durch
Sacheinlage ein, und zwar wie folgt durch Zeichnung und Einzahlung der 89.690 (neunundachtzigtausendsechshundert-
neunzig) zusätzlichen Aktien mit einem Nennwert zu jeweils EUR 100,- (einhundert Euro) durch Sacheinlage durch
Gottschol Alcuilux S.A. und bestehend aus sämtlichen betriebsnotwendigen Aktiva und Passiva der Desox Abteilung,
einschließlich sämtlichen Anteilen der Gottschol Alucom Aluminium - Produktions GmbH, eine Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung Deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-58256 Ennepetal-Hasperbach, Hagener Strasse 274, und
eingetragen im Handelsregister von Hagen unter HRB 6328, worin Gottschol Alcuilux S.A. 100% der Anteile hält.
Die vorgenannte Sacheinlage begreift folgende der Gottschol Alcuilux S.A. gehörende Immobilie:
<i>Bezeichnungi>
Ein Industriegelände mit den sich darauf befindenden Gebäuchlichkeiten gelegen in Eselborn, 18, Op der Sang, einge-
tragen im Kataster der Gemeinde Clerf, Sektion B von Eselborn, Ort genannt "auf der Sang", unter der Nummer 14/3261,
als "bâtiment industriel ou artisanal", mit einer Grösse von 03 Hektar 27 Ar 18 Centiar.
<i>Eigentumsnachweisi>
Die vorbezeichnete Immobilie gehört der Aktiengesellschaft Gottschol Alcuilux S.A. (ehemals ALCUILUX S.A.), um
dieselbe erworben zu haben wie folgt:
- teils auf Grund einer Kaufurkunde aufgenommen durch den damals in Clerf residierenden Notar Marc DELVAUX
am 19. September 1961, überschrieben im Hypothekenamte in Diekirch am 16. Oktober 1961, Band 151, Nummer 35;
- teils auf Grund einer Kaufurkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Marc DELVAUX am 2. Mai 1975,
überschrieben im Hypothekenamte in Diekirch am 19. Juni 1975, Band 409, Nummer 198;
- teils auf Grund einer Kaufurkunde aufgenommen durch den damals in Luxemburg residierenden Notar André
SCHWACHTGEN am 28. Februar 1983, überschrieben im Hypothekenamte in Diekirch am 8. März 1983, Band 589,
Nummer 131;
- teils auf Grund einer administrativen Kaufurkunde aufgenommen am 15. Juli 1983, überschrieben im Hypothekenamte
in Diekirch am 14. September 1983, Band 600, Nummer 37.
Der Gesamtwert der Sacheinlage wird auf EUR 17.865.231,80 (siebzehn Millionen achthundertfünfundsechzigtau-
sendzweihunderteinunddreissig Euro und achtzig Cents) abgeschätzt.
40750
Ein Sacheinlagebericht wurde am 25. März 2009 durch Interaudit S.à r.L, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la Faïencerie, erstellt, worin sämt-
liche eingebrachten Aktiva und Passiva sowie Anteile bezeichnet und bewertet wurden. Der Sacheinlagebericht kommt
zu folgendem Schluss:
„Auf der Grundlage unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Wert der Sacheinlage mindestens dem
Nennwert der 89690 neu auszugebenden Aktien zum Nennwert von EUR 100 je Aktie, also ein Gegenwert von EUR
8.969.000, sowie zuzüglich dem Ausgabeagio in Höhe von EUR 8.896.231,80, also insgesamt EUR 17.865.231,80, ents-
pricht."
Nachdem der Bericht durch die Komparenten und den Notar „ne varietur" unterzeichnet worden ist, bleibt er an
dieser Urkunde anliegend, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden eingereicht zu werden.
Eine zwischen der Gottschol Alcuilux S.A. und der Gesellschaft am 25. März 2009 mit rückwirkender Wirkung zum
01. Januar 2009 geschlossene und unterzeichnete Sacheinlagevereinbarung bestimmt, dass der Gesellschaft sämtliche hier
in Rede befindliche Aktiva und Passiva sowie Anteile übertragen werden.
Nachdem die Sacheinlagevereinbarung durch die Komparenten und den unterzeichnenden Notar „ne varietur" un-
terzeichnet worden ist, bleibt sie an dieser Urkunde anliegend, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden eingereicht
zu werden.
Daraufhin wird beschlossen, die erwähnte Zeichnung und Einzahlung anzunehmen und 89.690 (neunundachtzigtau-
sendsechshundertneunzig) vollständig bezahlte zusätzliche Aktien mit einem Nennwert zu jeweils EUR 100.- (einhundert
Euro) an Gottschol Alcuilux S.A. auszugeben und zuzuteilen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt Artikel 5 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um die beschlossene
Erhöhung des Gesellschaftskapitals wiederzuspiegeln. Artikel 5 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu
gefasst:
" Art. 5. (Satz 1). Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 9.000.000,- (neun Millionen Euro), aufgeteilt in 90.000 (neun-
zigtausend) Aktien mit einem Nennwert von EUR 100,- (einhundert Euro)."
<i>Vierter Beschlussi>
Herr Ralph GOTTSCHOL wird hiermit ermächtigt, das Gesellschafterregister der Gesellschaft in Folge der Kapitale-
rhöhung zu ändern.
<i>Abschlussi>
Nach Erledigung der Tagesordnung, schließt die Vorsitzende die Versammlung.
<i>Kosteni>
Die Kosten. die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von sechstau-
sendeinhundert Euro abgeschätzt.
Hierüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesen haben die Erschienenen zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unters-
chrieben.
Signé: TOKBAG - FLORIJAN - HOULLE - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2009. Relation GRE/2009/1250. Reçu soixante quinze euros 75 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Junglinster, le 6 avril 2009.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2009044637/231/152.
(090051456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Gigipi Mode S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4972 Dippach, 32, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 73.248.
DISSOLUTION
L'an deux mille neuf, le vingt-sept février.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
A comparu
Madame Antonietta PIETRANGELO, sans état, demeurant à L-4972 Dippach, 32, rue de Luxembourg.
40751
Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire:
Que la société dénommée GIGIPI MODE S.à r.l., avec siège social à L-4972 Dippach, 32, rue de Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.248,
ci-après nommée la "Société",
a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, le 27 décembre
1999, publié au Mémorial C numéro 140 le 12 février 2000, modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné le
4 mai 2004, publié au Mémorial C numéro 730 le 15 juillet 2004.
Que le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par cent (100) parts
sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées.
Que la comparante déclare être seule associée de la Société.
L'activité de la Société ayant cessé, elle déclare expressément vouloir procéder à sa dissolution.
Que l'associée se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité elle requiert le notaire instrumentant
d'acter qu'elle déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation
est dûment approvisionné; en outre elle déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus
et non payés à l'heure actuelle, elle assume irrévocablement et solidairement l'obligation de payer tout ce passif éventuel;
qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;
Que l'actif restant éventuel est attribué à l'associée unique;
Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société;
Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et
demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Antonietta Pietrangelo, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 03 mars 2009. LAC/2009/8039. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis Sandt.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 17 mars 2009.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2009044648/202/43.
(090051696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2009.
Red & Black S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 135.250.
Je, soussignée,
TRUSTAUDIT S.à.R.L.
Dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 73125,
démissionne, par la présente, du mandat de commissaire aux Comptes de la société anonyme:
RED & BLACK S.A.
ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistré au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 135250
Date effective: le 27 février 2009
Fait à Luxembourg, le 27 février 2009.
TRUSTAUDIT S.à.R.L.
Signature
Référence de publication: 2009044018/1022/21.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2009, réf. LSO-DC07937. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090051032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
40752
ABF European Holdings & Co SNC
Acheria International Group s.à r.l.
Alcuilux Desox S.A.
Arabella I S.à r.l.
Arc en Ciel Immobilier S.A.
Atrix Luxembourg S.à r.l.
Axento S.A.
Ball Investment Holdings S.à r.l.
BGV III Bielefeld S.à r.l.
Bio-Seef
Bugs S.A.
Catering Enterprises International Holding Limited
Cirio Del Monte Internationale S.A.
CMJ Holdings S.A.
Conafex Holdings
Dimac Systems S.à r.l.
Distriwood S.A.
DNA Investments S.A.
DNA Investments S.A.
Eubro Holding S.A.
Eurocofin S.A.
Fair Bianca S.A.
Fiduciaire COFIGEST s.àr.l.
Fikonmynta S.à r.l.
Futura Kirchberg
Gabriella Luxembourg Holdings Sàrl
GAP-Xchange Partners, L.L.C. and Company, SCA
GAP-Xchange Partners, L.L.C., SCA
Gigipi Mode S.à r.l.
Groupe Olidef S.A.
HSH Investment Management S.A.
Innoco S.A.
Integrated Core Strategies (Europe) S. à r.l.
Kudelski Luxembourg S.à r.l.
Lusciniole S.A.
Manufacture d'Orgues Luxembourgeoise Westenfelder
Marshall Monteagle Holdings
Merrill Lynch Luxembourg Investments S.à r.l.
MLAnna Real Estate 2 S.à r.l.
MLAnna Real Estate 6 S.à r.l.
Morgane Investissements
NG Luxembourg 3 S.à r.l.
Nidial S.A.
Passion´Elle s.à r.l.
PBG Investment (Luxembourg) S.àr.l.
Peter's Soups and Juices
R&A S.à r.l.
REA Lux 2 S.à r.l.
Red & Black S.A.
ReFlow Fund
Rolo Operation Project S.A.
Services Touristiques S.A.
Signum Holdings 1 S.à r.l.
SSCP Coatings
SSCP Coatings
Timberland Capital Management KG
Tobago Investment Holding S.A.
Tower 6 Bis S. à r. l.
Ugic SA
United Investors Sicav
VHCL Deux S.A.
VHCL UN S.A.
Wald Holding S.A.
Zambia Copper Investments (Luxembourg) Ltd
Zidcom Investments S.A.