logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 653

26 mars 2009

SOMMAIRE

Aardvark Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

31344

Absolute Miracle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31318

Bateman Oil & Gas Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31299

Bateman Technologies Luxembourg S. à r.

l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31300

BBEIF LH Sub 09 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31302

Carta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31312

Cirius S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31298

Diminu'tif s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31315

Duplitape S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31344

Eduma Marketing & Education S.A. . . . . . .

31314

Entreprise de Construction G. THOMAS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31311

Eusid Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31344

Eusid S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31344

Fachmaart Robert Steinhäuser  . . . . . . . . . .

31302

Fachmart Robert Steinhäuser  . . . . . . . . . . .

31302

Footprint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31301

Globo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31310

Groupe Compétence S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

31310

Groupe Compétence S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

31315

Guardian Automotive-E S.A.  . . . . . . . . . . . .

31299

Haybom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31318

Hydratec SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31311

IFA Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31332

Immo Creation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31311

International Oil Products S.A.  . . . . . . . . . .

31315

International Oil Products S.A.  . . . . . . . . . .

31312

International Oil Products S.A.  . . . . . . . . . .

31313

International Oil Products S.A.  . . . . . . . . . .

31313

International Oil Products S.A.  . . . . . . . . . .

31314

International Oil Products S.A.  . . . . . . . . . .

31313

International Oil Products S.A.  . . . . . . . . . .

31313

Intertrade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31298

Lady-Shop Chaussures S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

31311

Latitude Luxembourg S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

31300

Locatrans S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31315

Magnisense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31340

New Market S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31316

Oeste International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

31316

P.F. Logistic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31339

P.F. Logistic A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31316

P.F. Logistic B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31322

P.F. Logistic BZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31320

P.F. Offices  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31333

P.F. Offices A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31323

P.F. Retail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31336

P.F. Retail A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31328

P.F. Retail BZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31327

Presidential B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31325

Presidential BZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31334

Rentaltech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31300

SPI Equity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31314

Telecom Italia Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31314

Tower 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31338

VDC Beta Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31301

Verdandi Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

31312

Wintec Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31312

X-Com Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31330

31297

Intertrade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 106.709.

L'an deux mille neuf, le dix-sept février.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INTERTRADE S.A." ayant

son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 106.709, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de
résidence à Mersch, en date du 7 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 709 du
18 juillet 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social du 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg au 9, rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof.
2. Modification afférente de l'article 1 

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social du 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg au 9, rue des Trois

Cantons, L-8399 Windhof de sorte que le deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 Art. 1 

er

 . 2 

ème

 alinéa.  Le siège social est établi à Windhof, dans la commune de Koerich."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 février 2009. Relation: LAC/2009/6491. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mars 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009031848/242/46.
(090036119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

Cirius S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 133.717.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 août 2008

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 août 2008 que:
- Le siège social est transféré à partir du 15 août 2008 au 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

31298

- Suite à la démission de Monsieur Patrick Rodrigues, Madame Marie-Anne Bos, née le 07 mai 1977 et demeurant

professionnellement au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald - Luxembourg est nommée administrateur jusqu'à la pro-
chaine assemblée générale qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 14 août 2008.

Christophe Fender / Luc Sunnen.

Référence de publication: 2009032427/1321/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01260. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Bateman Oil &amp; Gas Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.438,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 106.362.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 02 février 2009

<i>Première résolution

L'Associé unique prend note de la démission de Monsieur Alain HEINZ de son poste de gérant B de la Société avec

effet au 2 février 2009.

<i>Deuxième résolution

L'Associé unique nomme Monsieur Eddy DOME, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie L-1511

Luxembourg, au poste de gérant B de la Société avec effet au 02 février 2009 pour une période indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009032508/6341/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00574. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Guardian Automotive-E S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaaschberg.

R.C.S. Luxembourg B 39.475.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société du 16 avril 2003

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 16 avril 2003 au siège de la société, Zone Industrielle

Potaaschberg, L-6776 Grevenmacher, que le Conseil d'Administration de la société a décidé de nommer Albert Franck
en tant que nouvel Administrateur Délégué à la gestion journalière, dont l'adresse professionnelle se situe Zone Indus-
trielle Potaaschberg, L-6776 Grevenmacher, Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société du 19 décembre 2007

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 19 décembre 2007 au siège de la société, Zone

Industrielle Potaaschberg - L-6776 Grevenmacher, que le Conseil d'Administration de la société a décidé de retirer James
D. Moore, Administrateur du Conseil d'Administration et Administrateur Délégué à la gestion journalière et de nommer
Luc Theis en tant que nouvel Administrateur du Conseil d'Administration, dont l'adresse professionnelle se situe Zone
Industrielle Potaaschberg, L-6776 Grevenmacher, Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société du 18 avril 2008

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 18 avril 2008 au siège de la société, Zone Industrielle

Potaaschberg - L-6776 Grevenmacher, que le Conseil d'Administration de la société a décidé de nommer Gabor Harakaly
en tant que nouvel Administrateur du Conseil d'Administration jusqu'au 31 novembre 2011, dont l'adresse professionnelle
se situe Zone Industrielle Potaaschberg, L-6776 Grevenmacher, Luxembourg, et de retirer David B. Jaffe, Administrateur
du Conseil d'Administration.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

31299

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009032504/3123/31.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01960. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Latitude Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 143.333.

EXTRAIT

Lors de la réunion du conseil de gérance tenue en date du 26 novembre 2008, les gérants ont décidé de nommer

Mademoiselle Kristel Segers au poste de président du conseil de gérance avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christophe Gammal
<i>Gérant

Référence de publication: 2009032507/6762/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00523. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Bateman Technologies Luxembourg S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.155.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 02 février 2009

<i>Première résolution

L'Associé unique prend note de la démission de Monsieur Alain HEINZ de son poste de gérant de la Société avec effet

au 2 février 2009.

<i>Deuxième résolution

L'Associé unique nomme Monsieur Eddy DOME, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie L-1511

Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec effet au 02 février 2009 pour une période indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009032510/6341/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00571. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Rentaltech S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 118.892.

Le siège social de la Société a été dénoncé le 06 mars 2009 avec effet immédiat par l'Etude Chevalier &amp; Sciales.

31300

Luxembourg, le 06 mars 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009032432/6407/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2009, réf. LSO-DC02161. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Footprint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 107.906.

EXTRAIT

Lors de sa réunion du 2 mars 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1 

er

 février 2009,

le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais
au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle de deux des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri

GRISIUS et Madame Michelle DELFOSSE, est également modifiée avec effet au 1 

er

 février 2009 et sera à partir de cette

date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mars 2009.

<i>Pour FOOTPRINT S.A., Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2009032437/833/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2009, réf. LSO-DC01393. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

VDC Beta Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 98.854.

EXTRAIT

Le conseil d'administration, dans ses résolutions du 16 février 2009 a décidé de transférer avec effet au 1 

er

 février

2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera
désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B de la société, à savoir Monsieur

Laurent HEILIGER et de Madame Michelle DELFOSSE est également modifiée avec effet au 1 

er

 février 2009 et sera à

partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 février 2009.

<i>Pour VDC BETA LUX, Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2009032439/833/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2009, réf. LSO-DC01395. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

31301

Fachmaart Robert Steinhäuser, Société Anonyme,

(anc. Fachmart Robert Steinhäuser).

Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 29.444.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54236 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009032946/211/13.
(090036858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

BBEIF LH Sub 09 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 145.004.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the sixth day of February.
Before Us Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

BBEIF Luxembourg Holdings S.à r.l. with registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg registered

at the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 129.159, here represented by Mr Max
MAYER, employee, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on February 6th, 2009.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration.

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the "Company"), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

The Company is initially composed of one single shareholder, hereinafter "the Shareholder", subscriber of all the shares.

The Company may however at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders,
notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The Corporation's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase
or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of "BBEIF LH Sub 09 S.à r.l.".

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

31302

Chapter II.- Capital, Shares.

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 500 (five hundred) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and Reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder

or by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 18 of these
Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company
and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders re-
presenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the

death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III.- Manager(s).

Art. 10. Manager(s), Board of managers. The Company is managed by the sole manager or a Board of Managers

composed of at least two Managers.

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting.

Art. 11. Powers of the manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provided the terms of this Art. shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the individual signature of the sole manager or the joint signature

of any two members of the Board of Managers."

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management of the

Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager's / agent's responsibilities and remu-
neration  (if  any),  the  duration  of  the period of  representation  and any other relevant conditions  of  his agency.  It  is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 13. Meetings of the board of managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its members.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
Quorum: The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present

or represented by proxies. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority. In case of a

31303

conflict of interest as defined in article 15 below, the quorum requirement shall apply without taking into account the
affected Manager or Managers.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having
participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 14. Liability - Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported
to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV.- Shareholder(s).

Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay of
fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, alternatively by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders' meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, including fax or PDF, as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Managers, which is final, circumstances of "force majeure" so require.

Art. 17. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company

represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object of

the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

31304

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject

by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V.- Financial year, Distribution of profits.

Art. 19. Financial year. The Company's accounting year starts on 1st January and ends on 31st December of each year.

Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established

and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory
reserve.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remu-
neration.

Chapter VII.- Applicable law.

Art. 24. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st

December 2009.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as

follows:

BBEIF Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of EUR 12,500.- is at the disposal of the Company, as

has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at EUR 1,750.-.

31305

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint BBEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l. having its registered office actually at L-2721 Luxembourg, 4,

rue Alphonse Weicker (RCS Luxembourg N° B 129.159) for an undetermined period as sole manager of the company.

2. Fix the address of the Company at L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le sixième jour du mois de février.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

BBEIF Luxembourg Holdings S.à r.l. avec siège social à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.159, représentée par Monsieur Max MAYER,
employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 6 février 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après "la Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "la Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après "les Statuts).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit,

toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirecte-
ment en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et
sociétés dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement,
permanent ou temporaire, du porte-feuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une
société de participations financières conformément aux lois applicables.

La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,

mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination "BBEIF LH Sub 09 S.à r.l.".

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Chapitre II.- Capital, Parts sociales.

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer

31306

le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et Diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en

une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et

dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la sus-

pension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Chapitre III.- Gérant(s).

Art. 10. Gérants, Conseil de gérance. La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé d'au moins deux

gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement "Gérants de catégorie A" et "Gérants de catégorie B".

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou
des associés.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir

au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément
à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature individuelle de gérant unique ou par la signature

conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs

gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la
durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion
journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de finance-
ment et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 13. Réunions du conseil de gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le

président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Quorum: le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses

membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité
simple. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant. En cas de conflit d'intérêt tel que défini à
l'article  15  ci-dessous,  les  exigences  de  quorum  doivent  s'appliquer  sans  prendre  en  considération  le  ou  les  gérants
concernés..

31307

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans

l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour

lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations
telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Gérant ou
mandataire pourrait prétendre.

Art. 15. Conflit d'intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Chapitre IV.- Associé(s).

Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs

qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d'entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, inclus par télécopieur ou par PDF un mandataire,

lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque

fois  que  se  produiront  des  circonstances  de  force  majeure  qui  seront  appréciées  souverainement  par  le  Conseil  de
Gérance.

31308

Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente

l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformément

à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition.

Art. 19. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont

établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas,

des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve

du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pourcents (5%) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII.- Loi applicable.

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2009.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire le capital comme suit:

BBEIF Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

31309

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cent Euros est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.750,- EUR.

<i>Décision de l'associé unique

L'associé unique décide de:
1. nommer BBEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l. ayant son siège social actuellement à L-2721 Luxembourg, 4,

rue Alphonse Weicker (RCS Luxembourg N° B 129.159) aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée.

2. Fixer l'adresse du siège social à L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5511. Reçu € 75,- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033066/206/432.
(090037201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Groupe Compétence S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 78.819.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009032789/4906/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07033. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Globo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 124.631.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04/03/09.

Signature.

Référence de publication: 2009032847/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00842. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

31310

Hydratec SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 39.177.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009032786/2738/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2009, réf. LSO-DC01583. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090036641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Immo Creation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 136.831.

<i>Extrait des décisions prises lors du conseil d'administration tenu en date du 24 novembre 2008

<i>Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Les administrateurs B de la Société, Christophe DAVEZAC et Géraldine SCHMIT ont également transféré leur adresse

professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009032754/6341/18.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00586. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Lady-Shop Chaussures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 27.386.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 3 mars 2009.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2009032950/201/12.
(090036920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Entreprise de Construction G. THOMAS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 12.334.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 3 mars 2009.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2009032951/201/12.
(090037012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

31311

Wintec Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 134.304.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 4 mars 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009032963/239/12.
(090036409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Carta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 82.155.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 mai 2008

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Serge KRANCENBLUM, administrateur
de catégorie A. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 15 mai 2008.

Pour copie conforme
CARTA S.A.
N. THIRION / Serge KRANCENBLUM
<i>Administrateur Catégorie B / Administrateur Catégorie A

Référence de publication: 2009032488/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC00922. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Verdandi Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 130.803.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société

L'associé unique
approuve le rapport du commissaire à la liquidation
prononce la clôture de la liquidation et constate que le Société a définitivement cessé d'exister au 20 février 2009,
décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du 20

février 2009 chez SGG Corporate Services S.A., 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Verdandi Management S.à r.l., en liquidation volontaire
Signature

Référence de publication: 2009032455/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07727. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

International Oil Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

Le bilan et l'annexe légale au 30 juin 1996, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

31312

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6/03/09.

Référence de publication: 2009032779/1004/12.
Enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2009, réf. DSO-DA00246. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090036570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

International Oil Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

Le bilan et l'annexe légale au 30 juin 2000, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6/03/09.

Référence de publication: 2009032778/1004/12.
Enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2009, réf. DSO-DA00250. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(090036587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

International Oil Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

Le bilan et l'annexe légale au 30 juin 1997, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6/03/09.

Référence de publication: 2009032780/1004/12.
Enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2009, réf. DSO-DA00247. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090036575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

International Oil Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

Le bilan et l'annexe légale au 30 juin 1995, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6/03/09.

Référence de publication: 2009032782/1004/12.
Enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2009, réf. DSO-DA00245. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090036565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

International Oil Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

Le bilan et l'annexe légale au 30 juin 2006, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6/03/09.

Référence de publication: 2009032773/1004/12.
Enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2009, réf. DSO-DA00256. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090036611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

31313

International Oil Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

Le bilan et l'annexe légale au 30 juin 2005, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6/03/09.

Référence de publication: 2009032772/1004/12.
Enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2009, réf. DSO-DA00255. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(090036606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Eduma Marketing &amp; Education S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7620 Larochette, 12A, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 92.077.

En date du 28 janvier 2009, l'Assemblée Generale a décidé à l'unanimité:
- De dispenser, De kroon, Vincent Antonio Jozef, demeurant à L-9184 Schrondweiler, 32, Rue principale, comme

Administrateur

- De nommer, Idsinga, Catharina Theresia Vlaria, demeurant à NL-1251 AC Laren, 45, Tafelberg, comme Administra-

teur à 2015

Larochette, 28 janvier 2009.

<i>Le Conseil d’Administration
Steven Gijsen
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2009032705/757/18.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03758. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Telecom Italia Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 76.448.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration qui a été tenue le 25 février 2009

Il résulte du verbale du Conseil d'Administration de Telecom Italia Finance qui a été tenue au siège social à Luxembourg

le 25 février 2009 que:

Le Conseil d'Administration a pris acte des démissions de M. Riccardo Varetto et a nommé en tant qu'Administrateur

M. Riccardo Taranto, né à Genova (Italie) le 11 mars 1958 et domicilié à Milano, piazza degli Affari 2.

M. Taranto restera en charge jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009.

<i>Telecom Italia Finance, Société Anonyme
Adriano TRAPLETTI
<i>Managing Director

Référence de publication: 2009032690/1813/18.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01261. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

SPI Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 96.524.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

31314

Belvaux, le 4 mars 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009032964/239/12.
(090036399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Locatrans S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 53, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 59.239.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 3 mars 2009.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2009032949/201/12.
(090036924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

International Oil Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

Le bilan et l'annexe légale au 30 juin 2003, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6/03/09.

Référence de publication: 2009032770/1004/12.
Enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2009, réf. DSO-DA00253. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090036598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Groupe Compétence S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 78.819.

Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009032788/4906/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07032. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Diminu'tif s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 20, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 98.782.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 05/03/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009032915/3220/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00036. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

31315

Oeste International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 81.283.

Constituée par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du

28 février 2001, acte publié au Mémorial C no 915 du 24 octobre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour OESTE INTERNATIONAL S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009032939/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01319. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090036740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

New Market S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 136.093.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 décembre 2008 au siège social:

Il a été décidé de nommer Madame Natacha STEURMANN à la fonction de Président du Conseil d'Administration

Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009032703/322/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01169. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

P.F. Logistic A, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.948.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

P.F. LOGISTIC, a limited liability company having its registered office in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins,

registered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 122.947

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on February 2 

nd

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of P.F. LOGISTIC A, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 13 

th

 , 2006,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 247 of February 24 

th

 , 2007, registered at

the Companies and Trade of Luxembourg section B. 122.948.

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

31316

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started October 1 

st

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

P.F. LOGISTIC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer 122.947

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen P.F. LOGISTIC A mit Sitz in L-1313 Luxemburg,
2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. Dezember 2006 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 247 vom 24. Februar 2007

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 122.948
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 1. Oktober 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

31317

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5529. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033130/206/81.
(090037343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Absolute Miracle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 101.152.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 31 décembre 2008

Il résulte dudit procès-verbal:
1. Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur l'assemblée approuve les comptes de la liquidation

et donne décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions, au liquidateur la société BENOY KARTHEISER MA-
NAGEMENT SARL ayant son siège à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société, ainsi qu'au commissaire-
vérificateur la société FBKAUDIT SARL ayant son siège à Luxembourg.

2. Tous les documents et les livres de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au

45-47, route d'Arlon, à L-1140 Luxembourg.

3. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société ABSOLUTE MIRACLE SA a définitive-

ment cessé d'exister.

Luxembourg, le 31 décembre 2008.

<i>Pour la société
FBK
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT
45-47, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009032757/510/27.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02723. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Haybom, Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 132.873.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

The private liability company PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED having its registered office at 146, Wickhams Cay

1, Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies),

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 6 

th

 , 2009.

31318

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of HAYBOM, having its registered office in L-1313 Lu-
xembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on October 18 

th

 , 2007,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2696 of November 23 

rd

 , 2007, registered

at the Companies and Trade of Luxembourg section B.132.873

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started October 18 

th

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED, mit Sitz in 146, Wickhams Cay 1,

Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies)

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 6. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen HAYBOM mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 2a, rue
des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. Oktober 2007 gegründet wurde,
veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2696 vom 23. November 2007

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 132.873
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

31319

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 18. Oktober 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,-EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet,

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2009. Relation: LAC/2009/6109. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033132/206/81.

(090037357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

P.F. Logistic BZ, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 134.826.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.

Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

PRESIDENTIAL HOLDINGS FERDINAND BZ, a limited liability company having its registered office in L-1313 Lu-

xembourg, 2a, rue des Capucins, registered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 134.702

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on February 2 

nd

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of P.F. LOGISTIC BZ, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 11 

th

 , 2007,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 236 of January 29 

th

 , 2008, registered at the

Companies and Trade of Luxembourg section B. 134.826.

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

31320

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started December 11 

th

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

PRESIDENTIAL HOLDINGS FERDINAND BZ, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxem-

bourg, 2a, rue des Capucins, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer
134.702

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009. Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschie-

nenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen P.F. LOGISTIC BZ mit Sitz in L-1313 Luxemburg,
2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 11. Dezember 2007 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 236 vom 29. Januar 2008

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 134.826
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 11. Dezember 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

31321

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet,

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5532. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033134/206/81.
(090037381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

P.F. Logistic B, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.949.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

P.F. LOGISTIC, a limited liability company having its registered office in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins,

registered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 122.947

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 2 

nd

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of P.F. LOGISTIC B, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 13 

th

 , 2006,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 249 of February 26 

th

 , 2007, registered at

the Companies and Trade of Luxembourg section B. 122.949.

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started October 1 

st

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

31322

The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

P.F. LOGISTIC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer 122.947

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen P.F. LOGISTIC B mit Sitz in L-1313 Luxemburg,
2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. Dezember 2006 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 249 vom 26. Februar 2007

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 122.949
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 1. Oktober 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5530. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2 März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033135/206/81.
(090037395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

P.F. Offices A, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.930.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

31323

There appeared the following:

P.F. OFFICES, a limited liability company having its registered office in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins,

registered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 123.149

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 2 

nd

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of P.F. OFFICES A, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 13 

th

 , 2006,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 246 of February 24 

th

 , 2007, registered at

the Companies and Trade of Luxembourg section B. 122.930

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started October 1 

st

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

P.F. OFFICES, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins, ein-

getragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer 123.149

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen P.F. OFFICES A mit Sitz in L-1313 Luxemburg,
2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. Dezember 2006 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 246 vom 24. Februar 2009

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 122.930
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

31324

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 1. Oktober 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5534. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033137/206/81.

(090037404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Presidential B, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.920.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.

Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

PRESIDENTIAL A, a limited liability company having its registered office in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins,

registered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 122.938

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on February 9 

th

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of PRESIDENTIAL B, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 14 

th

 , 2006,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 258 of February 27 

th

 , 2007, registered at

the Companies and Trade of Luxembourg section B. 122.920

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

31325

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

Art. 11. (1st paragraph). Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started October 1 

st

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

PRESIDENTIAL A, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer 122.938

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen PRESIDENTIAL B mit Sitz in L-1313 Luxemburg,
2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 14. Dezember 2006 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 258 vom 27. Februar 2007

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 122.920
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 1. Oktober 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

31326

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5540. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033139/206/81.
(090037415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

P.F. Retail BZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 134.706.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

P.F. RETAIL HOLDINGS BZ, a limited liability company having its registered office in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des

Capucins, registered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 134.693

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 9 

th

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of P.F. RETAIL BZ, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 11 

th

 , 2007,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 185 of January 23 

rd

 , 2008, registered at the

Companies and Trade of Luxembourg section B. 134.706

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started December 11 

th

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

31327

The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

P.F. RETAIL HOLDINGS BZ, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des

Capucins, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer 134.693

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen P.F. RETAIL BZ mit Sitz in L-1313 Luxemburg,
2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 11. Dezember 2007 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 185 vom 23. Januar 2008

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 134.706
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 11. Dezember 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5539. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033144/206/81.
(090037418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

P.F. Retail A, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.945.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

31328

There appeared the following:

P.F. RETAIL, a limited liability company having its registered office in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins, re-

gistered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 122.944

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 9 

th

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of P.F. RETAIL A, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 13 

th

 , 2006,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 247 of February 24 

th

 , 2007, registered at

the Companies and Trade of Luxembourg section B. 122.945

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started October 1 

st

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

P.F. RETAIL, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins, einge-

tragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer 122.944

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen P.F. RETAIL A mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 2a,
rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. Dezember 2006 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 247 vom 24. Februar 2009

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 122.945
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

31329

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 1. Oktober 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet,

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5537. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033148/206/81.
(090037432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

X-Com Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 74.468.

In the year two thousand and nine, the sixteenth day of February.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of X-Com Holding S.A. a Luxembourg

public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange,
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 74.468 (the Company).
The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg) on 16 February 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C n° 405
on 7 June 2000. The articles of association of the Company (the Articles) have been modified several times and for the
last time on 21 December 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C n° 573 on 18 March
2006.

The Meeting is opened at 11.30 a.m. chaired by Lars SWENNINGSON, corporate secretary, professionally residing

in Leudelange (the Chairman). The Chairman appoints Mr Jean-Michel SCHMIT, attorney at law, with professional address
at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The Meeting elects Candida
GILLESPIE, legal assistant, professionally residing in Leudelange as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chair-
man, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on

an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of
the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders of the Company represented at the Meeting, after having been signed ne varietur

by the proxyholder and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record:
I. that it appears from the attendance list that all of the 40,000 (forty thousand) shares having each a nominal value of

EUR 100.00 (one hundred Euro), representing the entire subscribed share capital of the Company of EUR 4,000,000.00
(four million Euro) are present or duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly

31330

deliberate on all the items on the agenda hereinafter reproduced, the shareholders represented at the Meeting having
agreed to meet after examination of the agenda.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Decision to transfer the registered seat of the Company from its current address to 15, rue Léon Laval, L-3372

Leudelange with effect as of 26th June 2007;

3. Subsequent change of the 1st paragraph of article 2 of the Articles; and
4. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives,

according to article 13 paragraph 1st of the Company's Articles, the convening notices, the shareholders represented at
the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has
been made available to them in advance of the Meeting.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to transfer effective as of 26th June 2007 to 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange.

<i>Third resolution

In respect of the above resolution, the Meeting resolves to amend subsequently the 1st paragraph of article 2 of the

Articles to reflect such change of registered office, which shall read henceforth as follows:

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Leudelange."
There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting at a.m..

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 1,000.-

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille neuf, le seize février.
Par-devant nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de X-Com Holding S.A. (la Société),

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 75, route de Longwy, L-8080
Bertrange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.468, constituée
le 16 févirer 2000 suivant un acte du notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C N°405 du 7 juin 2000. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois le 31 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°
1222 en date du 19 août 2002.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures et présidée par Monsieur Lars SWENNINGSON, corporate secretary, rési-

dant professionnellement à Leudelange (le Président) qui nomme comme secrétaire Mr Jean-Michel SCHMIT, avocat,
résidant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg (le Secrétaire). L'Assemblée nomme comme
scrutatrice Madame Candida GILLESPIE, legal assistant, résidant professionnellement à Leudelange (le Scrutateur). Le
Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau.

Les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par les représentants des actionnaires et les
membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les

représentants et le notaire restera annexées aux présentes pour être enregistré auprès des autorités d'enregistrement.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président requiert le notaire d'enregistrer ce qui suit:
I. Il apparaît sur la liste de présences établie et certifiée par les membres du Bureau que toutes les 40.000 (quarante

mille) actions, ayant une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, représentant l'entièreté du capital social
souscrit de la Société sont dûment représentées à l'Assemblée qui est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer
sur les points de l'agenda, ci-dessus reproduit, les actionnaires représentés à l'Assemblée ont décidé de se réunir après
examen de l'agenda.

31331

II. que l'agenda de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Décision de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange

avec effet rétroactif au 26 juin 2007;

3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des Statuts;
4. Divers.

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

malités  de  convocation,  les  actionnaires  se  considérant  comme  dûment  convoqués  et  déclarant  avoir  une  parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui a été rendu accessible avant l'Assemblée.

<i>Seconde résolution

L'Assemblée décide de transférer avec effet rétroactif au 26 juin 2007 vers 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier subséquemment le 1 

er

 alinéa de l'article 2

des Statuts pour refléter un tel changement de siège social de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Leudelange."

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.000,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes, en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: L. SWENNINGSSON, J-M. SCHMIT, C. GILLESPIE, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 février 2009. Relation: LAC/2009/6856. Reçu € 75,- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033112/206/116.
(090037248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

IFA Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 645.700,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 133.157.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale tenue en date du 22 décembre 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121, avenue

de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg et ce avec effet au 1 

er

 décembre 2008.

Les gérants de catégorie A de la société, Christophe DAVEZAC et Géraldine SCHMIT, ont également transféré leur

adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

31332

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009032756/6341/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00589. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

P.F. Offices, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 123.149.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

PRESIDENTIAL HOLDINGS FERDINAND III, a limited liability company having its registered office in L-1313 Luxem-

bourg, 2a, rue des Capucins, registered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 122.943

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 2 

nd

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of P.F. OFFICES, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 13 

th

 , 2006,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 276 of March 1 

st

 , 2007, registered at the

Companies and Trade of Luxembourg section B. 123.149

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started October 1 

st

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

31333

PRESIDENTIAL HOLDINGS FERDINAND III, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxem-

bourg, 2a, rue des Capucins, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer
122.943

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen P.F. OFFICES mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 2a,
rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. Dezember 2006 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 276 vom 1. März 2009

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 123.149
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 1. Oktober 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet,

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5533. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033133/206/82.
(090037363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Presidential BZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 134.697.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

The private liability company SHIHAN HOLDINGS Ltd. having its registered office at 146, Wickhams Cay 1, Road

Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 208951 Register of companies),

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 6 

th

 , 2009.

31334

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of PRESIDENTIAL BZ, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 11 

th

 , 2007,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 179 of January 23 

rd

 , 2008, registered at the

Companies and Trade of Luxembourg section B. 134.697

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started December 11 

th

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.

Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SHIHAN HOLDINGS Ltd, mit Sitz in 146, Wickhams Cay 1, Road Town,

Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 208951 Register of companies)

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 6. Februar 2009. Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschie-

nenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen PRESIDENTIAL BZ mit Sitz in L-1313 Luxemburg,
2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 11. Dezember 2007 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 179 vom 23. Januar 2008

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 134.697

Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

31335

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 11. Dezember 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,-EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5561. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033151/206/80.

(090037455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

P.F. Retail, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.944.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.

Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

PRESIDENTIAL HOLDINGS FERDINAND II, a limited liability company having its registered office in L-1313 Luxem-

bourg, 2a, rue des Capucins, registered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 122.942

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on February 9 

th

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability  Company established in  Luxembourg,  under the  name  of  P.F. RETAIL, having  its registered  office in  L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 13 

th

 , 2006,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 247 of February 24 

th

 , 2007, registered at

the Companies and Trade of Luxembourg section B. 122.944

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

31336

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started October 1 

st

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

PRESIDENTIAL HOLDINGS FERDINAND II, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxem-

bourg, 2a, rue des Capucins, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer
122.942

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen P.F. RETAIL mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 2a,
rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. Dezember 2006 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 247 vom 24. Februar 2009

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 122.944
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 1. Oktober 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,-EUR geschätzt.

31337

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5536. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033150/206/82.
(090037445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Tower 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 142.847.

RECTIFICATIF

L'an deux mil neuf, le trente janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société en commandite par actions de droit luxembourgeois "Equinox Two Sca", ayant son siège social 35 boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section
B et le numéro 129.986,

ici représentée par Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée en date du 14 octobre 2008, laquelle procuration est restée annexée à l'acte de constitution du 15 octobre 2008
dont question ci-après,

en sa qualité de seule et unique associée, détenant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois dénommée "TOWER 3 S.àr.l.", avec siège social à Luxembourg, 5, Place du Théâtre, inscrite au
R.C.S. Luxembourg B n° 142847, constituée par acte du notaire soussigné en date du 15 octobre 2008, publié au Mémorial
C n° 2812 du 21 novembre 2008.

Laquelle comparante demande au notaire instrumentaire d'acter que dans le susdit acte de constitution de la société

"TOWER 3 S.à r.l.", à la page 5, la 2 

ème

 disposition transitoire a été érronément indiqué comme suit:

"A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 11 des présents statuts, le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le Conseil de gérance, dressera l'inventaire et le compte de pertes et profits pour la première fois le dernier
mercredi du mois de juin 2009 à 10.00 heures"

alors qu'elle aurait du se lire comme suit:
"A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 11 des présents statuts, le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le Conseil de gérance, dressera l'inventaire et le compte de pertes et profits pour la première fois le dernier
mercredi du mois de juin 2010 à 10.00 heures"

La société comparante requière le notaire instrumentaire de faire les rectifications nécessaires partout ou cela s'im-

pose.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la société comparante, cette dernière a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: V. BARAVINI, J. DELVAUX
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 4 février 2009, LAC/2009/4382: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

31338

Luxembourg, le 27/02/09.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009034778/208/42.
(090039345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

P.F. Logistic, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.947.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

PRESIDENTIAL HOLDINGS FERDINAND I, a limited liability company having its registered office in L-1313 Luxem-

bourg, 2a, rue des Capucins, registered at the Companies and Trade of Luxembourg under section B number 122.941

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on February 2 

nd

 , 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited

Liability Company established in Luxembourg, under the name of P.F. LOGISTIC, having its registered office in L-1313
Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 13 

th

 , 2006,

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 247 of February 24 

th

 2007, registered at the

Companies and Trade of Luxembourg section B. 122.947.

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30 

th

 , to December

31 

st

 , and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as

follows:

Art. 10. The Company's financial year start on January 1 

st

 , of each year and ends on December 31 

st

 , of the same

year".

 Art. 11. (1 

st

 paragraph).  Each year, on December 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities

of the Company, as well as a profit and loss account."

<i>Transitory provision

The financial year which started October 1 

st

 , 2007 shall finish on December 31 

st

 , 2008.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.
Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

PRESIDENTIAL HOLDINGS FERDINAND I, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1313 Luxem-

bourg, 2a, rue des Capucins, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nummer
122.941

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 9. Februar 2009.

31339

Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen P.F. LOGISTIC mit Sitz in L-1313 Luxemburg,
2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. Dezember 2006 gegründet
wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 247 vom 24. Februar 2007

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 122.947
Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Einziger Beschluss

Die  alleinige  Anteilinhaberin  beschliesst  das  Abschlussdatum  des  Geschäftsjahren  vom  30.  September  auf  den  31.

Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

selben Jahres.

Art. 11. (1. Absatz). Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein

Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgestellt

<i>Übergangsbestimmung

Das Geschäftsjahr war am 1. Oktober 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst

worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung
zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  der  Urkunde  des  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und  Wohnort  bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5527. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033131/206/82.
(090037351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Magnisense, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 55.561,42.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 122.697.

In the year two thousand and nine, on the twentieth of February.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) MIRA CETI LTD, a limited liability company, organized and registered under the laws of the Island of Bermuda, with

registered office at Milner House, 18, Parliament Street, Hamilton HM12 Bermuda, registered at the Commercial Register
of Bermuda under the number 33589;

2) PROVESTIS SAS, a "société par actions simplifiée", registered under the laws of France, with registered office at 14,

rue Marignan, Paris, registered at the Commercial Register of Versailles under the number 479 041 824;

3) GERMEX Ltd, a company limited by shares, incorporated under the laws of Cayman Islands, with registered office

at 1, Windward, 2 

nd

 Floor, regatta Office Park, KY-Grand Cayman, registered at the Commercial Registrar of Companies

in Cayman Islands under the number CC 167 624;

31340

4) NORMAFIN S. à r.l., a limited liability company, incorporated under the laws of France, with registered office at 29,

rue des Gravilliers, F-75003 Paris, registered at the Commercial Register of Paris under the number 485 137 202;

5) Mr Jacques WENIG, residing in 24, Avenue de Suffren, F-75015 Paris;
6) Mr Michel FEDOROFF, residing in 74, Boulevard d'Italie, MC-98000 Monaco.
All here represented by Mr Keimpe REITSMA, private employee, with professional address at 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg, by virtue of a proxy given in the general meeting of January 21 

st

 , 2009 by all the shareholders

represented at that meeting which was registered by a deed of the undersigned notary under her registered number
134/2009 (LAC/2009/3292).

All the shareholders have been duly convened to the present meeting.
Said appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
- The appearing parties are shareholders of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

existing under the name of "Magnisense", R.C.S Luxembourg B 122.697, with registered office in Luxembourg, transferred
from the British Virgin Islands to Luxembourg, pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, then residing in Luxembourg-
Eich, dated December 11 

th

 , 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 186 of

February 15 

th

 , 2007.

- The Company's capital is set at forty-eight thousand four hundred and seventy euro (48,470.- EUR), represented by

sixty-five thousand five hundred (65,500) shares of a par value of zero point seventy-four euro (0,74 EUR) each.

- The agenda is worded as follows:
1. Increase of the capital of the company by an amount of seven thousand ninety-one point forty-two euro (7,091.42

EUR) so as to bring it from its present amount of forty-eight thousand four hundred and seventy euro (48,470.- EUR) to
fifty-five thousand five hundred sixty-one point forty-two euro (55,561.42 EUR) by the issue of nine thousand five hundred
eighty-three (9,583) new shares of a par value of seventy-four cent (0.74 EUR) each;

2. Subscription, intervention of the subscribers and issuance of nine thousand five hundred eighty-three (9,583) new

shares with a nominal value of seventy-four cent (0.74 EUR) each, by a contribution in cash;

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of

the share capital of the Company;

4. Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions:

<i>First resolution

Pursuant to an extraordinary general meeting held before the undersigned notary on January 21 

st

 , 2009 the share-

holders had proposed to increase the capital by an amount of maximum of nine thousand two hundred seventy-four euro
(9,274.- EUR).

Nevertheless the shareholders finally resolve to increase the capital by an amount of seven thousand ninety-one point

forty-two euro (7,091.42 EUR) so as to bring it from its present amount of forty-eight thousand four hundred and seventy
euro (48,470.- EUR) to fifty-five thousand five hundred sixty-one point forty-two euro (55,561.42 EUR) by the issue of
nine thousand five hundred eighty-three (9,583) new shares of a par value of seventy-four cent (0.74 EUR).

<i>Subscription and Payment

The new shares shall be subscribed as follows:

1) MIRA CETI LTD, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,833 shares;
2) PROVESTIS SAS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125 shares;
3) GERMEX Ltd, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417 shares;

4) Mr Jacques WENIG, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 shares;

5) Mr Michel FEDOROFF, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.583 shares

The whole being fully paid up by a contribution in cash so that the amount of seven thousand ninety-one point forty-

two euro (7,091.42 EUR) is at the free disposal of the Company.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary by producing a blocked funds certificate

issued on February 16 

th

 , 2009.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions and the contribution having been fully carried out, the shareholders

resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company to read as follows:

31341

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at fifty-five thousand five hundred sixty-one point forty-two

euro (55,561.42 EUR), represented by seventy-five thousand and eighty-three (75,083) shares of a par value of zero point
seventy-four euro (0.74 EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up in cash or in kind."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about one thousand two hundred euro (EUR
1,200).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le vingt février.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de residence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) MIRA CETI LTD, une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois des Iles de Bermude, établie et ayant

son siège social à Milner House, 18, Parliament Street, Hamilton HM12 Bermudes, inscrite au Registre Commercial des
Bermudes sous le numéro 33589;

2) PROVESTIS SAS, une société par actions simplifiée, constituée sous la loi française, établie et ayant son siège social

à 14, rue Marignan, Paris, inscrite au Registre de Commerce de Versailles sous le numéro 479 041 824,

3) GERMEX Ltd, une société par actions, constituée sous les lois des Iles Cayman, établie et ayant son siège social à

1, Windward, 2 

nd

 Floor, regatta Office Park, KY-Grand Cayman, inscrite au Registre de Commerce des Iles Caïmans

sous le numéro 167624;

4) NORMAFIN S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois françaises, établie et ayant son siège

social à 29, rue des Gravilliers, F-75003 Paris, inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le numéro 485 137 202;

5) Monsieur Jacques WENIG, demeurant à 24, Avenue de Suffren, F-75015 Paris;
6) Monsieur Michel FEDOROFF, deumeurant à 74, Boulevard d'Italie, MC-98000 Monaco.
Tous ici représentés par Monsieur Keimpe REITSMA, employé privé, demeurant professionnellement à 58, rue Charles

Martel, L-2134 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 21 janvier
2009 par tous les associés représentés lors de l'assemblée tenue par devant le notaire instrumentaire, acte numéro
134/2009 de son répertoire (LAC/2009/3292).

Tous les associés ont été valablement convoqués à la présente Assemblée.
Les parties comparantes, par l'organe de leur représentant, ont demandé au notaire d'acter comme suit:
- Les parties comparantes sont associées de la société à responsabilité limitée existante sous la dénomination "Magni-

sense", inscrite au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 122.697, établie et ayant son siège social à Luxembourg, transféré
des Iles Vierges Britanniques au Luxembourg, suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à
Luxembourg-Eich, date du 11 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 186
du 15 février 2007.

- Le capital social est fixé à quarante-huit mille euros et quatre cent soixante-dix euros (48.470.- EUR), représenté par

soixante-cinq mille cinq cents (65.500) parts sociales d'une valeur nominale de soixante-quatorze cents (0,74 EUR) cha-
cune.

- L'ordre du jour est établi comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de sept mille quatre-vingt-onze euros et quarante-deux

cents (7.091,42 EUR) afin de le porter de son montant actuel de quarante-huit mille quatre cent soixante-dix euros
(48.470.- EUR) à cinquante-cinq mille cinq cent soixante et un euros et quarante-deux cents (55.561,42 EUR) par le biais
de l'émission de neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois (9.583) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de soixante-
quatorze cents (0,74 EUR) chacune;

2. Souscription, intervention du souscripteur et émission des neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois (9.583) nouvelles

parts sociales d'une valeur nominale de soixante-quatorze cents (0,74 EUR) chacune, par un apport en numéraire;

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital de la

Société;

4. Divers.

31342

Les associés ont ensuite pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à une assemblée générale extraordinaire tenue par devant le notaire instrumentaire en date du 21

janvier 2009 les associés avaient proposé d'augmenter le capital d'un montant de maximum neuf mille deux cent soixante-
quatorze euros (9.274.- EUR).

Néanmoins les associés ont finalement décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept mille

quatre-vingt-onze euros et quarante-deux cents (7.091,42 EUR) afin de le porter de son montant actuel de quarante-huit
mille quatre cent soixante-dix euros (48.470.- EUR) à cinquante-cinq mille cinq cent soixante et un euros et quarante-
deux cents (55.561,42 EUR) par le biais de l'émission de neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois (9.583) nouvelles parts
sociales d'une valeur nominale de soixante-quatorze cents (0,74 EUR) chacune.

<i>Souscription et Paiement

Les nouvelles parts sociales sont souscrites comme suit:

1) MIRA CETI LTD, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,833 parts sociales;
2) PROVESTIS SAS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125 parts sociales;
3) GERMEX Ltd, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417 parts sociales;

4) Mr Jacques WENIG, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 parts sociales;

5) Mr Michel FEDOROFF, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,583 parts sociales

La totalité de l'augmentation de capital a été réalisé par apport en espèces de sorte que la somme de sept mille quatre-

vingt-onze euros et quarante-deux cents (7.091,42 EUR) est désormais à la libre disposition de la Société.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage

des fonds émis le 16 février 2009.

<i>Deuxième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent et l'apport ayant été pleinement effectué, l'Associé Unique a décidé de

modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille cinq cent soixante et un euros et quarante-deux cents (55.561,42

EUR), représenté par soixante-quinze mille quatre-vingt-trois (75.083) parts sociales d'une valeur nominale de zéro virgule
soixante-quatorze euros (0,74 EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces ou en
nature."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en

raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette augmentation de capital est évalué à environ mille deux
cents euros (1.200.- EUR).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Reitsma et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2009. LAC/2009/7856. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009034755/5770/172.
(090039159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

31343

Eusid Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Eusid S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 50.994.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/03/09.

Signature.

Référence de publication: 2009033658/768/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2009, réf. LSO-DC01688. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090037434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Aardvark Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 8.935.

Les comptes annuels consolidés au 30.09.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 mars 2009.

<i>Pour: AARDVARK INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009033652/1017/18.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01203. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090037451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Duplitape S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 13.613.

Constituée par acte sous seing privé sous la dénomination de WORLD COMPUTER CORPORATION en date du 25

octobre 1972, publié au Mémorial C no 208 du 29 décembre 1972, modifiée par acte de Me Tom METZLER, notaire
alors de résidence à Rédange maintenant à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 20 novembre 1975, publié au Mé-
morial  C  no  40  du  27  février  1976,  modifiée  par  acte  de  Me  Lucien  SCHUMAN,  notaire  alors  de  résidence  à
Luxembourg, en date du 31 juillet 1979, publié au Mémorial C no 252 du 30 octobre 1979, modifiée par acte de Me
Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange en date du 17 octobre 1986, publié
au Mémorial C no 358 du 27 décembre 1986, modifiée par acte de même notaire, en date du 12 septembre 2000,
publié au Mémorial C no 245 du 4 avril 2001.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2009.

<i>Pour DUPLITAPE S.A.
Interfiduciaire S.A.
Signature

Référence de publication: 2009033619/1261/23.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06140. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090037279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

31344


Document Outline

Aardvark Investments S.A.

Absolute Miracle S.A.

Bateman Oil &amp; Gas Luxembourg S.à r.l.

Bateman Technologies Luxembourg S. à r. l.

BBEIF LH Sub 09 S.à r.l.

Carta S.A.

Cirius S.A.

Diminu'tif s.à r.l.

Duplitape S.A.

Eduma Marketing &amp; Education S.A.

Entreprise de Construction G. THOMAS

Eusid Holding S.A.

Eusid S.A.

Fachmaart Robert Steinhäuser

Fachmart Robert Steinhäuser

Footprint S.A.

Globo S.A.

Groupe Compétence S.à r.l.

Groupe Compétence S.à r.l.

Guardian Automotive-E S.A.

Haybom

Hydratec SA

IFA Holding S.à r.l.

Immo Creation S.A.

International Oil Products S.A.

International Oil Products S.A.

International Oil Products S.A.

International Oil Products S.A.

International Oil Products S.A.

International Oil Products S.A.

International Oil Products S.A.

Intertrade S.A.

Lady-Shop Chaussures S.à r.l.

Latitude Luxembourg S.àr.l.

Locatrans S.à.r.l.

Magnisense

New Market S.A.

Oeste International S.A.

P.F. Logistic

P.F. Logistic A

P.F. Logistic B

P.F. Logistic BZ

P.F. Offices

P.F. Offices A

P.F. Retail

P.F. Retail A

P.F. Retail BZ

Presidential B

Presidential BZ

Rentaltech S.A.

SPI Equity S.A.

Telecom Italia Finance

Tower 3 S.à r.l.

VDC Beta Lux

Verdandi Management S.à r.l.

Wintec Lux S.à r.l.

X-Com Holding S.A.