logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 610

20 mars 2009

SOMMAIRE

2206 Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

29240

Accelior S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29243

Air Ghelamco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29280

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 1 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29263

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 2 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29271

Allianz Business Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29235

Assurgest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29252

Carmignac Portfolio Advisory Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29240

Centore Société Financière d'Investisse-

ments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29239

Cerep Ares GP S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29263

CEREP II Investment Ten S.à r.l.  . . . . . . . .

29263

CEREP Investment Parc de Seine S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29280

Cinquanteneuf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29235

Compagnie Financière de Castiglione  . . . .

29237

Compagnie Financière de Castiglione  . . . .

29238

Compagnie Financière Française S.A. . . . .

29238

CROWN PREMIUM Private Equity IV

S.C.S., SICAF-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29250

Dotcom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29242

Dresdner Vermögensplan 15  . . . . . . . . . . . .

29235

Dresdner Vermögensplan 25  . . . . . . . . . . . .

29235

Dresdner Vermögensplan 35  . . . . . . . . . . . .

29234

Dresdner Vermögensplan 65  . . . . . . . . . . . .

29234

Dresdner Vermögensplan 80  . . . . . . . . . . . .

29234

Europa Managed Assets  . . . . . . . . . . . . . . . .

29236

Finaris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29239

Fondation Jean Think. Fonds de Secours

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29248

HSBC Property Investment (French Offi-

ces)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29241

Immobinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29234

IPC - Portfolio Invest XIII  . . . . . . . . . . . . . . .

29238

Kentucky s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29238

LCF Edmond de Rothschild Conseil . . . . . .

29243

Les Productions du Cercle S.à r.l. . . . . . . . .

29239

LMA German Investments  . . . . . . . . . . . . . .

29242

LMB German Investments  . . . . . . . . . . . . . .

29239

LMC German Investments  . . . . . . . . . . . . . .

29242

LMD German Investments  . . . . . . . . . . . . . .

29241

LuxCo IIIC S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29254

MEAG Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

29237

MEAG Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

29237

Nordea Asset Allocation Fund  . . . . . . . . . .

29236

Observatoire Mondial Géostratégique S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29240

Participe 49, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29236

Patio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29240

Porta Westfalica S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

29279

Promvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29248

Quinlan Private Balaton Client Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29242

Renaco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29241

Renaco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29280

SCAP (Société de Courtage en Assurances

et Placements) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29245

Steel & Co. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29241

Sylso Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29236

Textil Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

29251

TLU International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

29243

Triangle Immobilière S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

29237

VTS Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29245

29233

Dresdner Vermögensplan 80, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Dresdner Vermögensplan 80 wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Januar 2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009016317/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00234. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090018456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Dresdner Vermögensplan 65, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Dresdner Vermögensplan 65 wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Januar 2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009016319/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00232. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Dresdner Vermögensplan 35, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Dresdner Vermögensplan 35 wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Januar 2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009016321/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00230. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Immobinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 39.718.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2008

MAS Management &amp; Accouting Services Sàrl, RC Luxembourg B 91.999, 6 Parc d'Activités Sydrall L-5365 Munsbach,

démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes.

Fiduciaire &amp; Expertises (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, est nommée

commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

Pour extrait sincère et conforme
Le bureau
Grotz Pierre / Frieden Corinne / Ries Laurent
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2009030493/1197/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05757. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

29234

Cinquanteneuf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 129.539.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2008

MAS Management &amp; Accouting Services Sàrl, RC Luxembourg B 91.999, 6 Parc d'Activités Sydrall L-5365 Munsbach,

démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes.

Fiduciaire &amp; Expertises (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, est nommée

commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

Pour extrait sincère et conforme
Le bureau
Grotz Pierre / Guccione Luca / Ries Laurent
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2009030494/1197/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05750. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090033665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Dresdner Vermögensplan 25, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Dresdner Vermögensplan 25 wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Januar 2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009016323/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00227. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Dresdner Vermögensplan 15, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Dresdner Vermögensplan 15 wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Januar 2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009016324/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00223. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Allianz Business Cash, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Allianz Business Cash wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Januar 2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009016326/755/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00222. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

29235

Europa Managed Assets, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion concernant le fonds commun de placement EUROPA MANAGED ASSETS a été déposé au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

EUROPA INVEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2009024667/250/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07738. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090031868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Nordea Asset Allocation Fund, Fonds Commun de Placement.

Les modifications au règlement de gestion du Fonds Commun de Placement Nordea Asset Allocation Fund ont été

déposées auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Nordea Investment Funds Company I S.A.
Lidia Palumbo / Andrea Martin

Référence de publication: 2009033865/3922/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05602. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090030776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2009.

Participe 49, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.178.

<i>Résolution l'associé unique en date du 14 janvier 2009

Le siège social est transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature / FBK

Référence de publication: 2009030488/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09023. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Sylso Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 42.244.

<i>Extrait de la résolution du gérant en date du 14 janvier 2009

Le siège social est transféré du 13, rue Bartholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature / FBK

Référence de publication: 2009030484/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10755. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

29236

MEAG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 127.482.

Le règlement de gestion MEAG OptiErtrag April 2009 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.02.2009.

Sandra Müller.

Référence de publication: 2009033867/9964/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07940. - Reçu 153,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090031412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

MEAG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 127.482.

Le règlement de gestion MEAG KlimaStrategie April 2009 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.02.2009.

Sandra Müller.

Référence de publication: 2009033868/9964/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07941. - Reçu 153,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Compagnie Financière de Castiglione, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 122.067.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 493 du 6 mars 2009, page 23620, de la mention

du dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés des comptes 2006 de la société Compagnie Financière de Castiglione:

au lieu de: «Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.»,

lire: «Les comptes consolidés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.»

Référence de publication: 2009034125/546/13.

Triangle Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.296.

<i>Résolution l'associé unique en date du 14 janvier 2009

Le siège social est transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature / FBK

Référence de publication: 2009030486/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09014. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

29237

Compagnie Financière de Castiglione, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 122.067.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 493 du 6 mars 2009, page 23618, de la mention

du dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés des comptes 2007 de la société Compagnie Financière de Castiglione:

au lieu de: «Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.»,

lire: «Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.»

Référence de publication: 2009034128/546/13.

IPC - Portfolio Invest XIII, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Verwaltungsreglement des IPC - Portfolio Invest XIII, in Kraft getreten am 5. Januar 2009, wurde beim

Handels- und Gesellchaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im März 2009.

IPConcept Fund Management S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009014147/1239/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06469. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090010887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Kentucky s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.078.

<i>Résolution du gérant en date du 14 janvier 2009

Le siège social est transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature / FBK

Référence de publication: 2009030489/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09012. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Compagnie Financière Française S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 45.245.

Le  bilan  au  31.12.2007  et  le  documents  y  annexés  ont  été  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/03/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031198/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07128. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29238

Centore Société Financière d'Investissements, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 105.028.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/02/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031204/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08419. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090034108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Finaris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 40.178.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009031202/636/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00118. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

LMB German Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 140.466.

Le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031206/833/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00165. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Les Productions du Cercle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 103.151.

<i>Résolution l'associé unique de la société en date du 14 janvier 2009

Le siège social est transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature / FBK

Référence de publication: 2009030487/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09020. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

29239

Patio, Société Civile.

Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.

R.C.S. Luxembourg E 2.185.

Il est constaté que la Commune de Bertrange a changé la dénomination de l'adresse de la société qui devient 3,

Grevelsbarrière L-8059 Bertrange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Signature
<i>La gérance

Référence de publication: 2009030490/5643/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06666. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090033977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Carmignac Portfolio Advisory Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 70.969.

Le bilan au 31 octobre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/03/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031199/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08278. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

2206 Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 106.266.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/03/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031197/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07125. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Observatoire Mondial Géostratégique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.544.

<i>Rapport de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 10 février 2009

Présent: M. Marc LAMBINET, administrateur délégué
Monsieur Marc Lambinet décide à ce jour:
de  transférer le  siège  social  de  la société OBSERVATOIRE  MONDIAL GEOSTRATEGIQUE  S.A. du  13,  rue Jean

Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030492/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06758. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

29240

HSBC Property Investment (French Offices), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 117.075.

Le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031208/833/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00177. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090034121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Renaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8085 Bertrange, 10A, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 60.839.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 02/03/2009.

<i>Pour RENACO S.à r.l.
p.p. J. REUTER

Référence de publication: 2009031193/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07914. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

LMD German Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 141.012.

Le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031209/833/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00168. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Steel &amp; Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 92, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 41.801.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/03/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031196/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07131. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29241

LMA German Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 135.712.

Le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031211/833/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00163. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090034124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

LMC German Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 140.584.

Le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009031212/833/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00136. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Quinlan Private Balaton Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 133.992.

En date du 16 janvier 2009, Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

a démissionné de son mandat de gérant de type B, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030506/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07133. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Dotcom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 74.628.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/03/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031200/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08276. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

29242

TLU International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 109.506.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2009

1. L'assemblée décide de pourvoir au remplacement du Commissaire aux comptes sortant en appelant la société

REVICONSULT Sàrl, ayant son siège social à 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148, Luxembourg. Le nouveau Commissaire aux
comptes est élu avec effet rétroactif au 17 décembre 2007 et pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale
qui se tiendra en l'an 2013.

Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2009.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2009030496/6312/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06882. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090033671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Accelior S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8366 Hagen, 3, rue Randlingen.

R.C.S. Luxembourg B 103.319.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 1 

<i>er

<i> juillet 2008

Monsieur Paul Jean Michel, Hillerest 51-57 Ladborke Grove Londres Royaume Uni, né le 25/09/1969 à Etterbeck,

démissionne de sa fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Le bureau
Sonia Livoir / Stéphanie Paché / Deschuytter Isabelle
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2009030495/1197/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU00936. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

LCF Edmond de Rothschild Conseil, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 59.956.

L'an deux mille neuf, le trente janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LCF Edmond de Rothschild

Conseil", ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, constituée suivant acte reçu par
Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 1997, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations C (le "Mémorial") numéro 561 du 13 octobre 1997. Les statuts de la société ont été modifiés
successivement et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 2003,
publié au Mémorial numéro 149 du 5 février 2004.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Luc GREGOIRE, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Esther MORITZ, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Muriel HOMBROISE, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

29243

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) actions, représentant l'intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Modification de l'article quatre des statuts quant à l'objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux sociétés dans lesquelles
la Société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d'un projet
dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêt, avance
ou garantie.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet."

2.- Suppression pure et simple de la valeur nominale des SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) actions existantes.
3.- Réduction du capital social à concurrence de TROIS CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 325.000,) pour le

ramener de son montant actuel de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (EUR 375.000,-) à celui de CIN-
QUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-) par remboursement du montant de TROIS CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS
(EUR 325.000,-) aux actionnaires dans la proportion de leur participation actuelle dans la société.

4.- Autorisation au Conseil d'Administration de faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution des résolutions à

prendre sub 2 et 3.

5.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts quant à l'objet social pour lui donner désormais la teneur

suivante:

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux sociétés dans lesquelles
la Société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d'un projet
dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêt, avance
ou garantie.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500)

actions existantes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de TROIS CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR

325.000,-) pour le ramener de son montant actuel de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (EUR 375.000,-)
à celui de CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-) par remboursement du montant de TROIS CENT VINGT-CINQ
MILLE EUROS (EUR 325.000,-) aux actionnaires dans la proportion de leur participation actuelle dans la société, sans
annulation d'actions.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs nécessaires au conseil d'administration de la Société pour procéder aux

écritures comptables qui s'imposent, à l'échange des SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) actions de l'ancienne valeur
nominale de CINQUANTE EUROS (EUR 50,-) chacune, contre le même nombre d'actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale et au remboursement aux actionnaires actuels, étant entendu que ledit remboursement ne peut avoir

29244

lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial C, conformément aux dispositions de l'article
69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
"Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-), représenté par SEPT MILLE CINQ CENTS

(7.500) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées. Toutes les actions sont nominatives."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de EUR 2.000.-

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. GREGOIRE, E. MORITZ, M. HOMBROISE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 février 2009. Relation: LAC/2009/3924. Reçu soixante-quinze euros (75€)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009033768/242/98.
(090038947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

VTS Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.136.

<i>Auszug des Beschlusses

<i>des Einzelgesellschafters vom 14. Januar 2009

Der Gesellschafter entscheidet, den Gesellschaftssitz mit sofortiger Wirkung von 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg

nach 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 14. Januar 2009.

<i>Für die Gesellschaft
VTS Consulting S.à r.l.
FOX DEPARTMENT
73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
Unterschrift

Référence de publication: 2009030483/510/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10183. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

SCAP (Société de Courtage en Assurances et Placements), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 144.906.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-huit février.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée de droit français "EURO'CAP ASSURANCES ET PLACEMENTS", établie et ayant

son siège social à F-57100 Thionville, 9, rue d'Angleterre (France), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du
Tribunal d'Instance de Thionville sous le numéro B 410 783 690,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Henri MELE, gérant de société, demeurant à F-57130 Jussy, 13, rue

de la Porte Sainte Catherine (France),

29245

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme

suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par les présentes.

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "SCAP (Société de Courtage en Assurances et
Placements)", (ci-après la "Société"), régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet principal toutes opérations de courtage d'assurances et de réassurances telles que

définies à l'article cent sept (107) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Elle peut s'associer
avec ou représenter des personnes physiques ou morales poursuivant le même objet; elle peut participer dans des sociétés
nationales ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe.

La Société peut en outre, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, et en assurer la gestion, le contrôle et la mise en valeur.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts et avances ou garanties.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

29246

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique,

la société "EURO'CAP ASSURANCES ET PLACEMENTS", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées
entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l'associée unique

Et aussitôt l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
2. Monsieur Henri MELE, gérant de société, né à Rodez (France), le 22 juillet 1965, demeurant à F-57130 Jussy, 13,

rue de la Porte Sainte Catherine, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le représentant de la partie comparante au fait qu'avant toute activité com-

merciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne
et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par ledit représentant.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, ès qualités qu'il agit, connu

du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MELE; J. SECKLER.

29247

Enregistré à Grevenmacher, le 25 février 2009. Relation GRE/2009/767. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur ff. (signé): HIRTT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 2 mars 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009030714/231/120.
(090034302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Promvest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 37.721.

Le bilan au 30 avril 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PROMVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009031192/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08921. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090034085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Fondation Jean Think. Fonds de Secours, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: Remerschen,

R.C.S. Luxembourg G 146.

BILAN AU 31/12/2006

Approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire

en date du 26 novembre 2007

Bilan au 31/12/2006

31-12-05

31-12-06 Compte

Actif:

Terrains et immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

752 347,58

752 347,58

201000

Titres (Héritage Jean Think)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

607 824,73

354 116,78

501000

DEXIA portefeuille sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 182 928,89 1 220 042,60

504000

ING portefeuille sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244 621,56

261 496,42

505000

FORTIS CC 30-009346-68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-142,95

73,05

511000

DEXIA CC 3-116/0167/000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 773,91

21 658,23

512010

B.I.L. Terme 3-116/0167/006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

367 632,73

407 162,23

512030

Perte de l'exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 170 986,45 3 016 896,89

Passif:

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 353 281,78 2 590 504,82

101000

Plus-value sur titres (Héritage Jean Think) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

569 797,87

0,00

102000

Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 467,77

19 239,98

411000

Fournisseurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

691,59

20 489,04

401000

Impôt foncier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

524,40

0,00

442000

Administration de l'Enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

443000

Bénéfice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237 223,04

386 663,05

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 170 986,45 3 016 896,89

Pertes &amp; Profits 2006

D

C

Compte

Immeuble:

Frais de Gestion Immeubles  . . . . . . . . . . .

2 756,16

601400

Entretien immeubles et réparations  . . . . .

79 479,25

601500

Impôt Foncier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1151,70

602000

Frais Centre Marisca  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 868,49

603000

29248

Assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

447,79

605000

Annonces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75,15

606000

Autres Frais en relation avec Immeubles . .

16,82

609000

92 795,36

D

C

Compte

Frais
administratifs:

Frais de bureau et informatique  . . . . . . . .

1 436,61

611000-6136

00

Frais de port et transport  . . . . . . . . . . . . .

16,00

612000-6135

00

Frais de télécommunication . . . . . . . . . . . .

600,96

613000

Frais de secrétariat  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 820,94

611000

Frais de route et de représentation  . . . . .

2 542,45

631000

Frais de maintenance de tombe . . . . . . . . .

285,00

615000-6330

00

Dons divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150,00

651000

8 851,96

Frais

financiers:

Intérêts passifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,54

641000

Frais financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5003,32

642000

Droits de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 597,42

642100

6 615,28

D

C

Compte

Produits
capitaux:

Intérêts actifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 416,11

711000-7111

00

Produits titres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 027,29

712000

75 443,40

D

C

Compte

Plus value
sur sicav:

Plus-value sur sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

392 328,31

712500

392 328,31

D

C

Compte

Loyers:

Garages, caravanes, Differdange  . . . . . . . .

25 742,00

701000

Station essence, rte de Soleuvre Differd. . .

10 492,50

703000

Centre Marisca, Mersch  . . . . . . . . . . . . . .

29 725,50

706000

Loyer hangar et terrain  . . . . . . . . . . . . . . .

2 943,94

707000

Cautions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250,00

708000

69153,94

108 262,60 536 925,65

Bénéfice de l'exercice avant dons  . . . . . . .

428 663,05

D

C

Compte

Dons:

Dons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

651000

Club Jeunes Remerschen Ph. Parreira  . . . .

15 000,00

Labaratoire Nationale de Santé  . . . . . . . . .

10 000,00

Frère Joseph - Projet Haîti  . . . . . . . . . . . .

5 000,00

Coopération humanitaire Luxembourg  . . .

2 000,00

Foyer de Jour "Museldrauwen"  . . . . . . . . .

2 000,00

Kannerland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000,00

Foyer de l'Enfance Rodange Lamadelaine . .

2 000,00

Dufaing Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . .

2 000,00

Initiative Kaerjeng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000,00

42 000,00

Bénéfice de l'exercice

386 663,05

150 262,60 536 925,65

29249

<i>Rapport du réviseur de caisse pour l'exercice 2006

Conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai vérifié aujourd'hui les livres, les comptes et le bilan de notre

Fondation.

J'ai constaté que les livres sont tenus d'une façon professionnelle, comme pour les exercices précédents. Le contrôle

a été effectué par sondages et n'a révélé aucune irrégularité.

Les avoirs en compte figurant au bilan correspondent exactement à ceux indiqués sur les extraits de compte bancaires.
Par conséquent, je propose à l'assemblée d'approuver le bilan et les comptes qui lui sont présentés, et aussi d'accorder

décharge au Président et au Sécrétaire-Comptable.

Rodange, le 10 novembre 2007.

Pierre AZZERI
<i>Le Réviseur

Référence de publication: 2009030658/7129/105.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00753. - Reçu 170,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090034769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS, Société en Commandite simple sous la forme

d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 137.939.

Im Jahr zweitausendacht, am dreißigsten April.

SIND ERSCHIENEN:

sämtliche Gesellschafter der CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS (die „Gesellschaft"), einer société

d'investissement à Capital Fixe in Form einer société en commandite simple.

Die  persönlich  anwesenden  Gesellschafter  oder  deren  bevollmächtigten  Vertreter  sowie  die  jeweilige  Anzahl  der

Gesellschaftsanteile gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Gesellschaftern oder deren
bevollmächtigten Vertretern unterzeichnet wurde.

Somit ist die Generalversammlung der Gesellschafter ordnungsgemäß gebildet und darf rechtmäßig über alle Punkte

der folgenden Tagesordnung entscheiden:

<i>Tagesordnung

1. Aufnahme von 6 Personen als Kommanditisten gemäß Aufnahmeliste Nr. 1 und der Ausgabe von 400 Kommandi-

tanteilen (davon 300 A-Anteile und 100 B-Anteile), jeweils ohne Nennwert, wie folgt:

- Friedrich Knott, Walchstadter Strasse 2, D-81377 München, Geburtsdatum: 8. Februar 1945, Geburtsort: Passau

(Deutschland), 150 Kommanditanteile der Klasse A

- Katharina Zeitler, Theodor-Storm-Strasse 32, D-93077 Bad Abbach, Geburtsdatum: 26. Mai 1983, Geburtsdatum:

München (Deutschland), 50 Kommanditanteile der Klasse A

- Georg Zeitler jun., Walchstadter Strasse 4, D-81377 München, Geburtdatum: 2. April 1982, Geburtsort: München

(Deutschland), 50 Kommanditanteile der Klasse A

- Maximilian Zeitler, Walchstadter Strasse 4, D-81377 München, Geburtsdatum: 6. Januar 1987, Geburtsort: München

(Deutschland), 50 Kommanditanteile der Klasse A

- SOLUTIO Partners GmbH &amp; Co. KG, Osterwaldstrasse 10, D-80805 München, Registernummer: 86132, HR Mün-

chen (Deutschland), 15 Kommanditanteile der Klasse B

- LGT Capital Partners Advisers AG, c/o LGT Capital Management AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Register-

nummer: FL-0002.008.524-2, HR Fürstentum Liechtenstein (Liechtenstein), 85 Kommanditanteile der Klasse B

2. Mit Tagespunkt 1 einhergehende Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 60.100,00 von seinem aktuellen Betrag

31.200,00 Euro auf 91,300,00 Euro.

3. Anschließende - aus Tagespunkt 1 und 2 resultierende - sprachliche Anpassung des Artikels 6 (b), Satz 1 der Ge-

sellschaftssatzung, welcher von nun an wie folgt lauten wird:

"Das Kapital der Gesellschaft beträgt einundneunzigtausenddreihundert Euro (91.300,00 Euro) und ist in einen (1)

Anteil,  der  durch  den  Komplementär  und  in  vierhundertfünfundfünfzig  (455)  Kommanditanteile  der  Klasse  A  und  in
einhundert (100) Kommanditanteile der Klasse B, jeweils ohne Nennwert, eingeteilt. Die Anteile wurden vollständig
eingezahlt."

Die Generalversammlung der Gesellschafter hat daraufhin einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

29250

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt,
400 Kommanditanteilen (davon 300 A-Anteile und 100 B-Anteile), jeweils ohne Nennwert, auszugeben und 6 Personen

als Kommanditisten gemäß Aufnahmeliste Nr. 1 wie folgt aufzunehmen:

- Friedrich Knott, Walchstadter Strasse 2, D-81377 München, Geburtsdatum: 8. Februar 1945, Geburtsort: Passau

(Deutschland), 150 Kommanditanteile der Klasse A

- Katharina Zeitler, Theodor-Storm-Strasse 32, D-93077 Bad Abbach, Geburtsdatum: 26. Mai 1983, Geburtsdatum:

München (Deutschland), 50 Kommanditanteile der Klasse A

- Georg Zeitler jun., Walchstadter Strasse 4, D-81377 München, Geburtdatum: 2. April 1982, Geburtsort: München

(Deutschland), 50 Kommanditanteile der Klasse A

- Maximilian Zeitler, Walchstadter Strasse 4, D-81377 München, Geburtsdatum: 6. Januar 1987, Geburtsort: München

(Deutschland), 50 Kommanditanteile der Klasse A

- SOLUTIO Partners GmbH &amp; Co. KG, Osterwaldstrasse 10, D-80805 München, Registernummer: 86132, HR Mün-

chen (Deutschland), 15 Kommanditanteile der Klasse B

- LGT Capital Partners Advisers AG, c/o LGT Capital Management AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Register-

nummer: FL-0002.008.524-2, HR Fürstentum Liechtenstein (Liechtenstein), 85 Kommanditanteile der Klasse B.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt,
infolge des Ersten Beschlusses, das Gesellschaftskapitals um EUR 60.100,00 von seinem aktuellen Betrag 31.200,00

Euro auf 91.300,00 Euro zu erhöhen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt,
infolge des Ersten und Zweiten Beschlusses Artikel 6 (b), Satz 1 der Gesellschaftssatzung anzupassen, welcher von nun

an wie folgt lauten wird:

"Das Kapital der Gesellschaft beträgt einundneunzigtausenddreihundert Euro (91.300,00 Euro) und ist in einen (1)

Anteil,  der  durch  den  Komplementär  und  in  vierhundertfünfundfünfzig  (455)  Kommanditanteile  der  Klasse  A  und  in
einhundert (100) Kommanditanteile der Klasse B, jeweils ohne Nennwert, eingeteilt. Die Anteile wurden vollständig
eingezahlt."

Unterzeichnet zum 30. April 2008 in Luxemburg durch die Gesellschafter gemäss Anwesenheitsliste.
Vollmachten werden nach Unterzeichnung und Paraphierung „ne varietur" dem vorliegenden Dokument als Anlage

beigefügt.

Signature
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009030663/250/76.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06891. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Textil Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 58.751.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 29 janvier 2009

Il résulte dudit procès-verbal:
la démission de Madame Gabrielle TRIERWEILER en tant qu'administrateur de la société;
la nomination de Monsieur Jeannot DIDERRICH, comme administrateur résidant professionnellement au 45-47, route

d'Arlon, L-1140 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale tenue en 2015;

le  renouvellement  des  mandats  de  Madame  Nathalie  CARBOTTI-PRIEUR  qui  change  son  patronyme  en  Nathalie

PRIEUR et qui demeure administrateur résidant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg ainsi
que de Monsieur Brunello DONATI, résidant professionnellement à 1, Riva Albertolli, CH-6901 Lugano, en tant que
administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2015;

la démission de Monsieur Lex BENOY en tant que commissaire aux comptes de la société;
la nomination de la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S. à r.l., 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg

en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale tenue en 2015;

29251

le transfert du siège social de la société du n° 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au n° 45-47, route d'Arlon, L-1140

Luxembourg.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

<i>Pour la société
FBK
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S. à r.l.
45-47, route d'Arlon
L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009030491/510/30.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03803. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090033855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Assurgest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 24-26, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 68.266.

L'an deux mille neuf, le trois février.

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ASSURGEST S.A. avec siège social à L-3490

Dudelange, 24-26, rue Jean Jaurès, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 68.266, constituée
suivant acte du notaire Jacques DELVAUX de Luxembourg du 13 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C, numéro 271 du 20 avril 1999, modifiée suivant acte du notaire Christine DOERNER de
Betembourg du 21 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 632 du
13 août 2001, modifiée suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C, numéro 21 du 9 janvier 2003.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Muriel LEHMANN, employée privée, demeurant à Hayange (France),

qui désigne comme secrétaire, Martine PRIM, employée privée, demeurant à Schifflange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Raymond LANG, courtier en assurances, demeurant à Luxembourg.

Le Président expose d'abord que

I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:

1. Refonte complète des statuts.

2. Révocation avec décharge des administrateurs respectivement administrateur-délégué.

3. Nomination d'un administrateur unique.

4. Révocation avec décharge du commissaire aux comptes.

5. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La Société n'ayant plus qu'un actionnaire, l'Assemblée procède à une refonte complète des statuts, qui auront désor-

mais la teneur suivante:

29252

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg

et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par
les présents statuts dénommée: ASSURGEST SA.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration respectivement de l'administrateur unique dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et
même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de travaux administratifs et de bureau de toute nature en relation avec le

secteur des assurances, l'activité de courtage en assurances par l'intermédiaire de personnes physiques agréées par les
autorités.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se ratta-

chant directement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros par actions, entièrement libérées, disposant
chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé, de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pourra être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Art. 7. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les

affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui
n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment
compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes

aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires

de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en

cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit, pour les actes relevant de
la gestion journalière, par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires

et prend les décisions par écrit.

29253

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Deuxième résolution

Elle révoque Yolande MORIS, employée de l'État, demeurant à L-5685 Dalheim, 5, Suebelwee et Gilbert MORIS,

demeurant à L-7727 Colmar-Berg, 19, rue Prince Henri de leur fonction d'administrateurs respectivement Raymond
LANG, employé privé, demeurant à L-5685 Dalheim, 5, Suebelwee de ses fonctions d'administrateur respectivement
administrateur-délégué.

Elle leur donne décharge quant à l'exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

Elle nomme aux fonctions d'administrateur unique:
Raymond LANG, courtier en assurances, né à Grevenmacher, le 20 juin 1959, demeurant à L-1870 Luxembourg, 199,

Kohlenberg.

Elle lui donne décharge pour l'exécution de son mandat.
Le mandat de l'administrateur unique ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera

sur les comptes de l'exercice social 2014.

<i>Quatrième résolution

Elle révoque PRISMA CONSULTING SARL avec siège social à L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass, inscrite au Registre

de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 101 674 de ses fonctions de commissaire aux comptes.

Elle lui donne décharge pour l'exécution de son mandat.

<i>Cinquième résolution

Elle nomme aux fonctions de commissaire aux comptes:
GEFCO SA Gestion financière &amp; Consulting à L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester, inscrite au Registre de Com-

merce de Luxembourg sous le numéro B 44.091.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera

sur les comptes de l'exercice social 2014.

Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Lehmann, Prim, Lang et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 12 février 2009. Relation: EAC/2009/1 555. Reçu soixante-quinze euros

75,-.

<i>Le Receveur (Signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Dudelange, le 16 février 2009.

Franck MOLITOR.

Référence de publication: 2009030678/223/132.
(090034676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

LuxCo IIIC S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 144.910.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of the month of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

29254

Wolflux II S.àr.l., being a "société à responsabilité limitée" with registered office at 29, avenue de la Porte-Neuve,

L-2227 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 143.829,

represented by Mr Pierre Stemper, private employee, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated

16 

th

 February, 2009 (such proxy to be registered together with the present deed).

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") Luxco INC S.àr.l. which is hereby established
as follows:

Art.  1.  Denomination.  A  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  with  the  name  "LuxCo  IIIC

S.àr.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is to hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, including, to the extent permitted by law, in any direct or indirect parent company, or other business entities,
acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise, of stock,
bonds, debentures, notes, convertible loan notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Company may hold interests in partnerships and carry out its business
through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may, in addition, engage in making, buying or investing in loans, deposits, securities, financial assets and/

or financial instruments of any type in or issued by Luxembourg or foreign companies or other enterprises.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible

notes) and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs or any entity as the Company may deem fit (including up stream or cross stream), take
any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500)

divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (€ 1.00) each. The capital of
the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent
(75%) of the Company's capital.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own shares.

Art. 7. Management of the company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for

29255

an undetermined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at
any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have
had knowledge of the agenda of the meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A (which may be
represented)).

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in

the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always an class A managers unless otherwise
resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by any one managers provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers
shall be signed by two managers, one of which being always an Class A Managers unless otherwise resolved by the board
of managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the

sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound  by  the  joint  signature  of  two  managers  one  of  which  shall  always  be  a  class  A  manager  (including  by  way  of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of
managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).

Art. 8. Liability managers, Indemnification.
8.1 The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they

are responsible for the performance of their duties.

8.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 8.3., every person who is, or has been, a manager or officer

of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against
all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

8.3 No indemnification shall be provided to any manager or officer:

29256

8.3.1 Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

8.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not

in the interest of the Company; or

8.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or

by the board of managers.

8.4The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

8.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 8 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 8.

Art. 9. Conflicts. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or
is a director, associate, officer, agent, adviser or employee of such other company or firm. Any manager or officer who
serves as a director, officer or employee or otherwise of any company or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 10. Shareholder meetings. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy. Decisions
by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by law in writing (to the extent permitted
by law) or at meetings held including (to the extent permitted by law) meetings held by way of conference call, video
conference or other means of communication allowing shareholders taking part in the meeting to hear one another and
to communicate with one another, the participation in a meeting by these means being equivalent to a participation in
person at such meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution
(as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is present or represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital. Decisions to change of nationality of the Company are to be taken by
shareholders representing 100% of the issued share capital.

Art. 11. Accounting year. The accounting year begins on the 1 

st

 January of each year and ends on the 31st December

of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

December, 2009.

Art. 12. Financial statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.

29257

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist  as  a  single  shareholder  company,  pursuant  to  article  179  (2)  of  the  law  of  10 

th

  August,  1915  on  commercial

companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

Subscriber

Number of shares subscribed

Payment

Wolflux II S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

€ 12,500.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

€ 12,500.-

Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500) has been shown

to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,900.-.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
2. The following persons are named managers of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company:

Name

Address

Title

Date of birth

City and country
of birth

Pierre Stemper

29, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg

Private employee

th

 December,

1970

Poissy (France)

Justin Bateman

667 Madison Ave 19 

th

 Fl,

NY 10065, New York USA

Investment
director

23 

rd

 December

1973

Tunbridge Wells
(England)

Josephine Pallet

40 Portman Square London
W1H 6DA

Investment
director

10 

th

 June, 1974

York (England)

Andrew Newington 40 Portman Square London

W1H6DA

Investment
director

18 

th

 January 1968 New York (USA)

Christelle Rétif

29, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg

Private employee

13 

th

 December,

1973

Saint-Germain-en-
Laye (France)

Naïm Gjonaj

29, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg

Private employee

th

 October, 1973 Liège (Belgium)

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31 

st

 December, 2009.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le seizième jour du mois de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

29258

A comparu:

Wolflux II S.àr.l., une société à responsabilité limitée, avec siège au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.829,

représentée par Monsieur Pierre Stemper, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration du 16 février 2009 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte).

La partie comparante agissant ès-qualités a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société à responsabilité limitée LuxCo IIIC S.à r.l., qui est constituée par la présente:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "LuxCo IIIC S.à r.l." (la "Société"). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, y inclus, dans la mesure permis par la loi, dans toutes société-mère directe ou indirecte,
ou dans toute autre entreprise, acquérir par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente,
l'échange ou autrement, d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute
nature, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut détenir des
intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou
étrangères.

La Société peut aussi effectuer la prise, l'achat ou l'investissement dans des prêts, dépôts, valeurs mobilières, avoirs

financiers et/ou instruments financiers de tout type dans ou émis par des sociétés ou autres entités luxembourgeoises
ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations (y

compris de notes convertibles) et de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par le biais de prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou

autres) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y compris up stream ou cross stream),
prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement
et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures temporaires n'au-
raient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société
luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas
échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500) divisé en

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (€ 1,00) chacune. Le capital de la Société
peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des
présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions

contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
au moins soixante-quinze pourcent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut, dans la mesure est selon les termes permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales.

Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

29259

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de

classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de
l'assemblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou
représentés et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente

ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de
classe A (qui peut se faire représenter)).

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société

présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés
incluant au moins un gérant de classe A.

Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée

générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par
deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits
de ces résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un
des gérants à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies
ou extraits de telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf
en cas de décision contraire du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue. Les réso-
lutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature

d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe
de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans
tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de
signature auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de
gérants, par deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).

Art. 8. Responsabilité des gérants, Indemnisation.
8.1 Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la

Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

8.2 Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article 8.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant

ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute
responsabilité encourue et contre toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par lui en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant
ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots "demande",
"action", "plainte" ou "procédure" s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou cri-
minelles,  y  compris  le  cas  échéant  toute  procédure  d'appel)  actuelles  ou  prévisibles  et  les  mots  "responsabilité"  et
"dépenses" devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et dépens, jugements
et montants payés en règlement et autres responsabilités.

8.3 Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable:

29260

8.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de

pouvoir,  de  mauvaise  foi,  de  négligence  grave  ou  d'imprudence  dans  l'accomplissement  des  devoirs  découlant  de  sa
fonction;

8.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt

de la Société; ou

8.3.3 Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait

été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

8.4 Le droit à indemnisation prévu par la présente est distinct et n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou

responsable peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être
gérant ou responsable et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les
dispositions  du  présent  article  n'affecteront  aucun  droit  à  indemnisation  dont  pourrait  bénéficier  le  personnel  de  la
Société, y compris les gérants, ou responsable en vertu d'un contrat ou autre en vertu de la loi.

8.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande,

action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article 8, seront avancées par la Société avant
toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte
du gérant ou du responsable de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation
conformément au présent article 8.

Art. 9. Conflits. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou responsables de la Société est intéressé à un tel contrat ou
transaction, ou est administrateur, collaborateur, responsable, agent, consultant ou employé de cette autre société ou
entité. Tout gérant ou responsable qui exerce la fonction d'administrateur, gérant, dirigeant ou employé ou autre auprès
d'une société ou d'une entité avec laquelle la Société conclura un contrat ou entre autrement en relation d'affaires, ne
sera pas, en raison d'une telle affiliation avec telle autre société ou entité, empêché de délibérer et de voter ou agir sur
n'importe quelle matière en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.

Art. 10. Assemblées générales. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal

au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de
procuration spéciale. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la (aux) majorité(s) prévue(s) par la loi,
par écrit (dans la mesure permise par la loi) ou lors d'assemblées y compris (dans la mesure permise par la loi) les
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, visioconférence, ou autres moyens de communication permet-
tant à tous les associés prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble, la
participation  à  une  assemblée  par  ces  moyens  équivalant  à  une  présence  en  personne  à  une  telle  assemblée.  Toute
assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) re-
présentera l'ensemble des associés de la Société.

Les  assemblées  peuvent  être  convoquées  par  une  convocation  adressée  par  lettre  recommandée  aux  associés  à

l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle
assemblée. Si l'entièreté du capital social est présent ou représenté à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans
convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date proposée pour l'effectivité des
résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant
les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent
être passées à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si

elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considération de
la portion du capital représenté. Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x)
une  majorité  des  associés  (y)  représentant  au  moins  trois-quarts  du  capital  social  émis.  Les  décisions  concernant  le
changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

Art. 11. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
2009.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance,

établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

29261

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé

par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier  exercice  comptable  augmenté  des  bénéfices  reportés  et  des  réserves  distribuables  mais  diminué  des  pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules

mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Souscription et Payement

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Souscripteur

Nombre de parts sociales souscrites

Paiement

Wolflux II S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

€ 12.500,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

€ 12.500,-

Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents euros (€ 12.500) a été donnée au notaire

instrumentant.

<i>Dépenses, Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ EUR 1.900,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l'unique associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts

de la Société:

Nom

Adresse

Profession

Date de naissance Pays et lieu

de naissance

Pierre Stemper

29, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg

Employé privé

6 décembre 1970 Poissy (France)

Justin Bateman

667 Madison Ave 19 

th

 Fl,

NY 10065, New York, USA

Directeur
d'investissement

23 décembre 1973 Tunbridge Wells

(Angleterre)

Josephine Pallett

40 Portman Square, Londres
W1H 6DA

Directeur
d'investissement

10 juin 1974

York (Angleterre)

Andrew Newington 40 Portman Square, Londres

W1H6DA

Directeur
d'investissement

18 janvier 1968

New York (USA)

Christelle Rétif

29, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg

Employée privée

13 décembre 1973 Saint-Germain-en-

Laye (France)

Naïm Gjonaj

29, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg

Employé privé

8 octobre 1973

Liège (Belgique)

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

29262

Signé: P. STEMPER, H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 février 2009. Relation: LAC/2009/6483. Reçu soixante-quinze euros, EUR

75,00.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le dix-neuf février de l'an deux mille neuf.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009030715/242/460.
(090034357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

CEREP II Investment Ten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 126.036.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031106/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07996. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Cerep Ares GP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 113.154.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031107/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07998. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.349.

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1
Registered office: Berliner Straße 44
D-60311 Frankfurt am Main, Germany
Share capital: EUR 25,000
R.C.S. Frankfurt am Main : HRB 82417
(the Absorbing Company)
and
Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 1 S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: 46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Share capital: EUR 12,500
R.C.S. Luxembourg: B 124.351
(the Absorbed Company)

29263

MERGER PROPOSAL

Merger to be carried out by way of the absorption of the private limited liability company Allco Wind Energy (Lu-

xembourg) No. 1 S.à.r.l. by the German private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) DIF
Erneuerbare Energien GmbH 1.

The Board of Managers of Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 1 S.à.r.l. (the "Absorbed Company") and the Board

of Managers of DIF Erneuerbare Energien GmbH 1 (the "Absorbing Company" and together with the Absorbed Company,
the "Companies") have decided to draw up the following merger proposal in accordance with:

(i) Sections 122a et seq. of the German Transformation Act (hereinafter: "UmwG"),
(ii) Articles 261 and 278 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter:

"Luxembourg Law"),

(iii) Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council as of October 26, 2005 on cross-border

mergers of limited liability companies (hereinafter: "Merger Directive").

and to present the merger proposal to their respective general meeting of shareholders.

<i>Requirements under luxembourg and german law:

I. The Companies (Art. 5 lit. a) of the Merger Directive)

The Absorbing Company is a private limited liability company existing under German laws, with registered seat in

Frankfurt am Main, Germany, registered in the Commercial Register of the local court of Frankfurt am Main, under No.
HRB 82417. The Absorbing Company was incorporated pursuant to a notarial deed of the Notary Prof. Dr. Dieter Mayer,
residing in Munich, dated January 2, 2008. Its share capital is EUR 25,000 and is fully paid in. According to its Articles of
Association, the object of the Absorbing Company's business is the management of its own assets. The Absorbing Com-
pany is entitled to take over other companies and partnerships of the same or a similar kind. The Absorbing Company
is entitled to participate in such companies and partnerships, whether as a personally liable partner or otherwise, and
may establish branches under the same or another name in Germany and abroad. According to Section 122b (1) UmwG
in conjunction with Art. 4 (1a) of the Merger Directive a cross-border merger of a company with limited liability into
another company with limited liability is permitted so that the Absorbing Company may participate in a cross border
merger.

The Absorbed Company is a Luxembourg private limited liability company, incorporated and organized under the laws

of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg R.C.S. under number B 124.349, incorporated pursuant to a notarial deed
of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, of February 1, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations of April 20, 2007, number 663. Its articles of association have been amended several times and, for the
last time, pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, of June 6, 2008, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of August 26, 2008, number 2060. The share capital of the Absorbed
Company is EUR 12,500. The Absorbing Company is the owner of all 500 (five hundred) A shares with a nominal value
of twenty-five euros (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up, in the Absorbed Company, representing all the shares
of the share capital of the Absorbed Company in an amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500). The
Absorbed Company has not granted any special rights similar to those defined in Section 23 UmwG. Under the laws
applicable in Luxembourg, in particular article 257 of the Luxembourg Law a merger of a company with limited liability
into another company with limited liability is permitted. The Absorbed Company may therefore participate in a cross-
border merger in accordance with Section 122b (1) UmwG in conjunction with Art. 4 (1a) of the Merger Directive.

II. Merger

The Absorbed Company transfers all of its assets and liabilities including all rights and obligations, on being dissolved

without going into liquidation, to the Absorbing Company by way of a cross-border merger with an existing company
without granting of shares in the Absorbing Company (absorption) according to Section 122a UmwG and article 278 of
the Luxembourg Law, in particular, article 274 (1) a) of the Luxembourg Law and this Merger Proposal (the Merger).

This transfer includes all the assets and liabilities belonging to the Absorbed Company (known or unknown) as of the

date of the shareholders meeting, approving the Merger. Upon entry of the merger into the commercial register of the
Absorbing Company ("Legal Effective Date") all the assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company
ipso jure between the Companies and vis-à-vis third parties.

The Absorbed Company guarantees to the Absorbing Company that the claims transferred as a result of the Merger

are certain and exisiting but does not guarantee the solvency of their respective debtors.

The Absorbing Company shall pay, as of the Legal Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance

premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been transferred.

As of the Legal Effective Date the Absorbing Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the

Absorbed Company.

The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company

with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be subrogated,

29264

without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Company with respect to all assets and
against all debtors without any exception.

The Absorbing Company shall incur all debts and liabilities of any kind of the Absorbed Company. In particular, it shall

pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Absorbed Company.

All corporate documents of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company

for as long as prescribed by the competent jurisdiction.

The mandates of the members of the board of managers and of the statutory auditor(s) of the Absorbed Company (if

any) will be terminated on the Legal Effective Date. Full discharge will be given to the members of the board of managers
and to the statutory auditor(s) for the performance of their mandate.

III. New Shares (Art. 5 lit. b), c) and e) of the Merger Directive)

Since the Absorbing Company is the only shareholder of the Absorbed Company, there shall be no granting of shares

in the Absorbing Company or any other consideration in exchange for the transfer of the assets and liabilities pursuant
to Section 122c (3) UmwG. Therefore, any particular information pursuant to Section 122c (2) No. 2, 3 and 5 UmwG,
Art. 5 lit. b) c) and e) of the Merger Directive is not required.

IV. Shareholders' approval

The merger is subject to the approval of the shareholders of the Absorbing Company according to Sections 122g (1)

and 13 UmwG.

Further the merger is subject to the approval of the shareholders of the Absorbed Company according to article 263

of the Luxembourg Law. The board of managers of the Absorbed Company shall convene the shareholders to an ex-
traordinary general meeting of the shareholders to be held for the purpose of article 263 of the Luxembourg Law before
a Luxembourg notary as soon as practicable after one month has elapsed following the filing and publication of this Merger
Proposal in accordance with articles 9 and 262 of the Luxembourg Law, in order to approve the Merger in accordance
with this Merger Proposal.

The boards of managers of each of the Companies have approved the Merger of the Companies.

V. Compensation offer

A compensation offer pursuant to Section 122i UmwG is not required, since the Absorbing Company as the acquiring

company is a company under German law. Neither is a compensation offer pursuant to Sections 122a (2) and 29 (1)
UmwG required, since the Absorbing Company as the acquiring company holds all shares in the Absorbed Company as
the transferring company. As a matter of precaution the Absorbing Company in its capacity as sole shareholder of the
Absorbed Company will also waive any rights for a compensation offer in the shareholder's meeting to decide upon the
merger.

VI. Effective date of the Merger from an accounting point of view (Art. 5 lit. f) of the Merger Directive)

and date of the merging companies' accounts (Art. 5 lit. l) of the Merger Directive)

In relation to the Absorbing Company the takeover of the assets and liabilities of the Absorbed Company shall be

effective upon expiry of December 31, 2008 ("Effective Date"). As of January 1, 2009 all dealings and business transactions
of the Absorbed Company shall be deemed to be made for the account of the Absorbing Company (effective date pursuant
to Section 122c (2) No. 6 UmwG, Art. 5 lit. f) of the Merger Directive).

The Merger shall be based on the interim balance sheet of the Absorbed Company as of December 31, 2008 ("Closing

Balance Sheet"), which describes the evaluation of the assets and liabilities of the Absorbed Company as of December
31, 2008 (date of the Absorbed Company's accounts).

The date of the Absorbing Company's accounts is December 31, 2007. However, since there shall be no exchange of

shares or other consideration for the transfer of the assets and liabilities in the course of the merger, the accounts of
the Absorbing Company are not relevant to establish the conditions of the cross-border merger in the sense of Section
122c (2) No. 12 UmwG, Art. 5 lit. l) of the Merger Directive.

VII. Evaluation of assets and liabilities (Art. 5 lit. k) of the Merger Directive)

The transferred assets and liabilities shall be carried over at book values in the balance of the Absorbing Company

(Section 122c (2) No. 11 UmwG, Art. 5 lit. k) Merger Directive).

Since all shares of the transferring company are held by the Absorbing Company a merger audit or an audit report

will not be necessary (Sections 122f and 9 (2) UmwG; article 278 of the Luxembourg Law).

VIII. Special rights and special advantages (Art. 5 lit. g), h) of the Merger Directive)

The companies acknowledge that the Absorbed Company has not issued to any person any securities other than the

shares held by the Absorbing Company in the share capital of the Absorbed Company. No special rights concerning the
Companies exist and no special rights will be granted to any shareholder in connection with the merger pursuant to
Section 122c (2) No. 7 UmwG, Art. 5 lit. g) h) Merger Directive and article 261 (2) f) and g) of the Luxembourg Law.

29265

The Companies acknowledge that no special advantage or benefits will be granted to the managers of the Companies

or to any of the persons referred to in Section 122c (2) No. 8 UmwG and articles 261 (2) lit. g) of the Luxembourg Law.

IX. Repercussions on employment and employee participation (Art. 5 lit. d) and j) of the Merger Directive)

Neither the Absorbed Company nor the Absorbing Company has any employees. Therefore no particular information

can be given regarding the repercussions of the cross-border merger on employment (Section 122c (2) No. 4 UmwG).

Information on any issues of employee participation (Section 122c (2) No. 10 UmwG) are not required either, because

no employee participation rights exist or will have to be established at the Absorbed Company or the Absorbing Company,
either before or after the cross-border merger.

X. Cancellation of the shares and dissolution without liquidation of the Absorbed Company

As from the Legal Effective Date, the shares held by the Absorbing Company in the Absorbed Company will be cancelled

and the Absorbed Company will cease to exist.

XI. Additional provisions and Statutes of the Absorbing Company (Art. 5 lit. i) of the Merger Directive)

The cost of the merger will be incurred by the Absorbing Company. Regarding a potential real estate transfer tax

obligation the parties declare that the Absorbed Company does not own any real estate.

The statutes of the Absorbing Company shall remain unchanged after this merger and are attached to this deed as

Annex 1.

The Companies mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the merger in accordance

with the legal and statutory requirements of both companies.

The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the Merger as

well as the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.

The shareholders of each of the Companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered office

of the said companies, at least one month before the date of the general meeting of the shareholders called to decide on
the Merger: the merger plan, the merger report, the annual accounts and annual reports of the Companies for the last
three financial years, if any, and, if necessary, a recent accounting statement. A copy of the above mentioned documents
will be obtainable upon request.

If any provision in this Agreement is completely or partially invalid or if it subsequently looses its legal validity, this shall

not affect the validity of the remaining provisions. Instead of the invalid provision, to the extent legally permissible, such
a reasonable provision shall apply which comes as close as possible in economic terms to what the parties intended or
would have intended had they considered the invalidity of the provision. This applies mutatis mutandis if this Agreement
contains a gap; such gap shall be closed by a provision which corresponds to what the parties intended or would have
intended had they considered the gap herein.

Amendments of and supplements to this Agreement and this clause shall require written form in order to be valid,

unless a stricter, in particular notarial form is prescribed. Any oral agreements have not been made and would be invalid.

The present document has been drafted in Luxembourg on March 11, 2009, in original, in order (i) to be registered

with the Luxembourg Register of Commerce and Companies of the Absorbed Company and to be published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, (ii) to be registered with the German Commercial Register of the
Absorbing Company at least one month prior to the date of the general meeting of the shareholder(s) of each Companies
called to decide on the terms of the merger, in accordance with article 262 of the Luxembourg Law, Section 122d UmwG
and Art. 6 of the Merger Directive.

The present document has been drafted in English, followed by a German version.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1
Sitz: Berliner Straße 44
D-60311 Frankfurt am Main, Germany
Stammkapital: EUR 25.000,
Handelsregister Frankfurt am Main: HRB 82417
(nachstehend: übernehmende Gesellschaft)
und
Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 1 S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Sitz: 46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Stammkapital: EUR 12.500,
Handelsregister Luxemburg: B 124.349

29266

(nachstehend: übertragende Gesellschaft)

VERSCHMELZUNGSPLAN

Verschmelzung durch Aufnahme der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 1

S.à.r.l. in die deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung DIF Erneuerbare Energien GmbH 1.

Die Geschäftsführung der Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 1 S.à.r.l. (nachstehend: übernehmende Gesellschaft)

und die Geschäftsführung der DIF Erneuerbare Energien GmbH 1 (nachstehend: übertragende Gesellschaft, gemeinsam
mit der übernehmenden Gesellschaft als die Gesellschaften bezeichnet) haben entschieden, den folgenden Verschmel-
zungsplan gemäß

(i) §§ 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (nachstehend: UmwG),
(ii) Artikel 261 und 278 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden

Fassung (nachstehend: "Luxemburgisches Gesetz"),

(iii) der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von

Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (nachstehend: "Verschmelzungsrichtlinie")

durchzuführen und den Verschmelzungsplan ihren jeweiligen Gesellschafterversammlungen zu unterbreiten.

<i>Erfordernisse nach luxemburgischem und deutschem recht:

I. Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften (Art. 5 a) der Verschmelzungsrichtlinie)

Die übernehmende Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit

Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB
82417. Die übernehmende Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde des Notars Prof. Dr. Dieter Mayer, München,
vom 2. Januar 2008 errichtet. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,--. Es ist vollständig erbracht. Gemäß dem Gesell-
schaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft ist deren Unternehmensgegenstand die Verwaltung des eigenen Vermö-
gens. Die übernehmende Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen. Sie darf sich
an solchen Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin und kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma errichten. Gemäß § 122b Abs. 1 UmwG i. V. m. Art. 4 Abs. 1
lit a) der Verschmelzungsrichtlinie ist die grenzüberschreitende Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung auf eine andere Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig, so dass die übernehmende Gesellschaft Teilnehmer
einer grenzüberschreitenden Verschmelzung sein kann.

Die übertragende Gesellschaft ist eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, errichtet nach luxem-

burgischem Recht, mit Sitz in 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum von Luxemburg, einge-
tragen im Handelsregister von Luxemburg zu B 124.349, gegründet gemäß notarieller Urkunde des Maître Jean Seckler,
Notar, Junglinster, vom 1. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 20. April
2007, Nr. 663. Der Gesellschaftsvertrag ist mehrmals geändert worden, zuletzt gemäß Urkunde des Maître Henri Hel-
linckx, Notar in Luxemburg, vom 6. Juni 2008, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 26.
August 2008, Nr. 2060. Das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft beträgt EUR 12.500,--. Die übernehmende
Gesellschaft hält alle 500 (fünfhundert) Stammanteile der Klasse A mit einem Nennwert von EUR 25,-- (fünfundzwanzig
Euros) je Anteil am Stammkapital von insgesamt EUR 12.500,00 (zwölftausendfünfhundert Euro) an der übertragenden
Gesellschaft, die von ihr übernommen und vollständig eingezahlt worden sind. Bei der übertragenden Gesellschaft be-
stehen  keine  Sonderechte  entsprechend  §  23  UmwG.  Nach  dem  geltenden  innerstaatlichen  luxemburgischen  Recht,
insbesondere Art. 257 des Luxemburgischen Gesetzes, ist die Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
auf eine andere Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig. Die übertragende Gesellschaft kann daher gem. § 122b
Abs. 1 UmwG i. V. m. Art. 4 Abs. 1 lit. a) der Verschmelzungsrichtlinie auch an einer grenzüberschreitenden Verschmel-
zung teilnehmen.

II. Verschmelzung

Die übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung

ohne Abwicklung auf die übernehmende Gesellschaft im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung mit einer
bestehenden Gesellschaft ohne die Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft (Verschmelzung durch
Aufnahme) gemäß § 122a UmwG und Art. 278 des Luxemburgischen Gesetzes, insbesondere Art. 274 Abs. 1 lit. a) des
Luxemburgischen Gesetzes, sowie in Übereinstimmung mit diesem Verschmelzungsplan (Verschmelzung).

Die  Übertragung  beinhaltet  sämtliche  (bekannten  und  unbekannten)  Vermögenswerte  und  Verbindlichkeiten  der

übertragenden  Gesellschaft  zum  Zeitpunkt  der  dieser  Verschmelzung  zustimmenden  Gesellschafterversammlung.  Mit
Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft ("rechtlicher Verschmelzungss-
tichtag")  gehen  sämtliche  Aktiva  und  Passiva  auf  die  übernehmende  Gesellschaft  von  Rechts  wegen  im  Innen-  und
Außenverhältnis über.

Die  übertragende  Gesellschaft  garantiert  der  übernehmenden  Gesellschaft,  dass  die  aufgrund  der  Verschmelzung

übertragenen Forderungen bestehen, garantiert jedoch nicht die Zahlungsfähigkeit der jeweiligen Schuldner.

29267

Die übernehmende Gesellschaft übernimmt ab dem rechtlichen Verschmelzungsstichtag die Zahlung sämtlicher Steu-

ern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und Versicherungsprämien, die hinsichtlich des Eigentums der übertragenen Vermö-
genswerte fällig sind oder werden.

Ab  dem  rechtlichen  Verschmelzungsstichtag  erfüllt  die  übernehmende  Gesellschaft  sämtliche  Vereinbarungen  und

Verpflichtungen jeglicher Art, die von der übertragenden Gesellschaft eingegangen worden sind.

Die sich aus den Vermögenswerten der übertragenden Gesellschaft ergebenden Rechte und Ansprüche gehen auf die

übernehmende Gesellschaft mit sämtlichen dinglichen und schuldrechtlichen Sicherheiten über. Die übernehmende Ge-
sellschaft tritt somit ohne Forderungsübertragung in alle dinglichen und schuldrechtlichen Rechte aus sämtlichen Ver-
mögenswerten und im Verhältnis zu sämtlichen Schuldnern ohne Ausnahme ein.

Die übernehmende Gesellschaft übernimmt sämtliche Schulden und Verbindlichkeiten jeglicher Art der übertragenden

Gesellschaft. Insbesondere übernimmt sie die Zahlung von Kapital und Zinsen auf sämtliche Schulden und Verbindlich-
keiten jeglicher Art, die von der übertragendenGesellschaft eingegangen worden sind.

Sämtliche Unterlagen der übertragenden Gesellschaft sind am Sitz der übernehmenden Gesellschaft in Übereinstim-

mung mit den dort geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufzubewahren.

Die Mandate der Mitglieder der Geschäftsführung sowie etwaiger Abschlussprüfer der übertragenden Gesellschaft

werden zum rechtlichen Verschmelzungsstichtag beendet. Den Mitgliedern der Geschäftsführung sowie den Abschluss-
prüfern wird für die Erfüllung ihres Mandats jeweils vollständige Entlastung erteilt.

III. Neue Anteile (Art. 5 lit. b), c) und e) der Verschmelzungsrichtlinie)

Da die übernehmende Gesellschaft alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, erfolgt keine Gewäh-

rung von Geschäftsanteilen an der übernehmenden Gesellschaft oder sonstiger Gegenleistungen für die Übertragung des
Aktiv- und Passivvermögens gemäß § 122c Abs. 3 UmwG. Somit sind keine besonderen Angaben gemäß § 122c Abs. 2
Nr. 2, 3 und 5 UmwG, Art. 5 lit. b) c) und e) der Verschmelzungsrichtlinie erforderlich.

IV. Zustimmung der Gesellschafter

Die Verschmelzung unterliegt der Zustimmung der Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft gemäß §§ 122g

Abs. 1 und 13 UmwG.

Weiterhin unterliegt die Verschmelzung der Zustimmung der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gemäß

Art. 263 des Luxemburgischen Gesetzes. Die Geschäftsführung der übertragenden Gesellschaft wird für die Zwecke des
Art. 263 des Luxemburgischen Gesetzes so schnell wie möglich nach Ablauf eines Monats nach Anmeldung und Veröf-
fentlichung  des  vorliegenden  Verschmelzungsvorhabens  gemäß  Art.  9  und  262  des  Luxemburgischen  Gesetzes  eine
außerordentliche Gesellschafterversammlung vor einem luxemburgischen Notar zur Erteilung der Zustimmung zu der
Verschmelzung gemäß des vorliegenden Verschmelzungsvorhabens einberufen.

Die Geschäftsführungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften haben der Verschmelzung jeweils bereits

zugestimmt.

V. Abfindungsangebot

Ein Abfindungsangebot gemäß § 122i UmwG ist nicht erforderlich, da es sich bei der übernehmenden Gesellschaft (als

aufnehmendem Rechtsträger) um eine Gesellschaft nach deutschem Recht handelt. Ein Abfindungsangebot ist auch nicht
gemäß §§ 122a Abs. 2 und 29 Abs. 1 UmwG erforderlich, da sich sämtliche Geschäftsanteile der übertragenden Gesellschaft
(als übertragendem Rechtsträger) in der Hand der übernehmenden Gesellschaft (als aufnehmendem Rechtsträger) be-
finden. Die übernehmende Gesellschaft wird als Alleingesellschafter des übertragenden Gesellschafters in der über die
Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlung vorsorglich auf sämtliche Rechte auf ein Abfindungsangebot
verzichten.

VI. Verschmelzungsstichtag unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung (Art. 5 lit. f) der Verschmel-

zungsrichtlinie) und verwendete Bilanzstichtage (Art. 5 lit. l) der Verschmelzungsrichtlinie)

Mit Bezug auf die übernehmende Gesellschaft wird die Übernahme des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden

Gesellschaft mit Ablauf des 31. Dezember 2008 ("Verschmelzungsstichtag") wirksam. Ab dem 1. Januar 2009 gelten sämt-
liche  Handlungen  der  übertragenden  Gesellschaft  als  für  Rechnung  der  übernehmenden  Gesellschaft  vorgenommen
(Stichtag gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG, Art. 5 lit. f) der Verschmelzungsrichtlinie).

Der Verschmelzung wird eine Zwischenbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2008 (Schlussbilanz)

zu Grunde gelegt, aus der sich die Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft zum 31.
Dezember 2008 (Bilanzstichtag der übergehenden Gesellschaft) ergibt.

Der Bilanzstichtag der übernehmenden Gesellschaft ist der 31. Dezember 2007. Da jedoch im Verlauf der Verschmel-

zung weder ein Austausch von Anteilen stattfindet noch eine sonstige Gegenleistung für die Übertragung des Aktiv- und
Passivvermögens erfolgt, ist der Jahresabschluss der übernehmenden Gesellschaft zur Bestimmung der Verhältnisse der
grenzüberschreitenden Verschmelzung im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 12 UmwG, Art. 5 lit. l) der Verschmelzungsrichtlinie
nicht erforderlich.

29268

VII. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens (Art. 5 lit. k) der Verschmelzungsrichtlinie)

Das übertragene Aktiv- und Passivvermögen wird zu Buchwerten in der Bilanz der übernehmenden Gesellschaft wei-

tergeführt (§ 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG, Art. 5 lit. k) Verschmelzungsrichtlinie).

Da sich sämtliche Geschäftsanteile der übertragenden Gesellschaft in der Hand der übernehmenden Gesellschaft be-

finden, ist eine Verschmelzungsprüfung oder ein Prüfungsbericht nicht erforderlich (§§ 122f und 9 Abs. 2 UmwG; Art.
278 des Luxemburgischen Gesetzes).

VIII. Sonderrechte und besondere Vorteile (Art. 5 lit. g), h) der Verschmelzungsrichtlinie)

Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erklären, dass die übertragende Gesellschaft außer den von der

übernehmenden Gesellschaft an ihrem Stammkapital gehaltenen Geschäftsanteile keine Wertpapiere an andere Personen
ausgegeben hat. Es bestehen keine Sonderrechte betreffend die Gesellschaften und es werden den Gesellschaftern auch
keine Sonderrechte im Zusammenhang mit der Verschmelzung gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG, Art. 5 lit. g) h) der
Verschmelzungsrichtlinie und Art. 261 Abs. 2 lit. f) und g) des Luxemburgischen Gesetzes gewährt.

Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erklären, dass den Geschäftsführern oder sonstigen Personen

gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und Art. 261 Abs. 2 lit. g) des Luxemburgischen Gesetzes keine besonderen Vorteile
oder Leistungen gewährt werden.

IX. Auswirkung der Verschmelzung auf die Beschäftigung und die Arbeitnehmermitbestimmung (Art. 5

lit. d) und j) der Verschmelzungsrichtlinie)

Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft beschäftigt Arbeitnehmer. Aus diesem

Grund können keine Angaben zu den voraussichtlichen Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die
Beschäftigung (§ 122c Abs. 2 Nr. 4 UmwG) gemacht werden.

Auch Angaben zu mitbestimmungsrechtlichen Fragen (§ 122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG) entfallen, weil bei den an der

Verschmelzung beteiligten Gesellschaften weder vor noch nach der grenzüberschreitenden Verschmelzung Mitbestim-
mungsrechte oder ein der Mitbestimmung unterliegendes Gremium bestehen oder einzurichten sind.

X. Einziehung der Anteile und Auflösung ohne Abwicklung der übertragenden Gesellschaft

Mit Wirkung zum rechtlichen Verschmelzungsstichtag werden die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen

Anteile an der übertragenden Gesellschaft eingezogen und die Gesellschaft besteht nicht weiter fort.

XI. Zusätzliche Bestimmungen und Satzung der übernehmenden Gesellschaft (Art. 5 lit. i) der Ver-

schmelzungsrichtlinie)

Die Kosten der Verschmelzung werden von der übernehmenden Gesellschaft getragen. Bezüglich etwaiger Grunder-

werbsteuern erklären die Parteien, dass die übertragende Gesellschaft keinen Grundbesitz hat.

Der Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft besteht nach der Verschmelzung unverändert fort und ist

als Anhang 1 beigefügt.

Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften verpflichten sich gegenseitig zur Mitwirkung bei der Durchführung

der Verschmelzung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und rechtlichen Erfordernissen beider Gesellschaften.

Die übernehmende Gesellschaft verpflichtet sich, sämtliche notwendigen formalen Erfordernisse für die Durchführung

der Verschmelzung sowie die Übertragung des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft auf die über-
nehmende Gesellschaft zu erfüllen.

Die Gesellschafter der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften sind jeweils berechtigt, am Sitz der Gesell-

schaften  mindestens  einen  Monat  vor  der  über  die  Verschmelzung  beschließenden  Gesellschafterversammlung  die
folgenden Unterlagen einzusehen: die Bedingungen der Verschmelzung, den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht
der Gesellschaften in den letzten drei Geschäftsjahren sowie ggf. eine buchhalterische Übersicht neueren Datums. Eine
Kopie dieser Unterlagen ist auf Anfrage erhältlich.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit

später verlieren, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. Das gleiche
gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen Bestimmung
oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, wirtschaftlich dem
am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bei Abschluss dieses Vertrages
bedacht hätten.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie dieser Klausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform,

soweit nicht eine strengere, insbesondere die notarielle Form zu beachten ist. Mündliche Abmachungen sind nicht ge-
troffen und wären unwirksam.

Das vorliegende Dokument wurde am 11. März 2009 im Original in Luxemburg zum Zweck der (i) Eintragung im

Luxemburgischen Handelsregister der übertragenden Gesellschaft sowie zur Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations, (ii) zur Eintragung im deutschen Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft min-
destens einen Monat vor der über die Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlungen der an der Ver-

29269

schmelzung beteiligten Gesellschaften gemäß Art. 262 des Luxemburgischen Gesetzes, § 122d UmwG und Art. 6 der
Verschmelzungsrichtlinie erstellt.

Draft merger propoal is approved by:
Dem Entwurf des Verschmelzungsplan wird zugestimmt von:

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1
represented by / vertreten durch
Allard Ruijs
<i>Managing director / Geschäftsführer

Anhang 1

Gesellschaftsvertrag der

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1

Annex 1

Articles of

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1

§. 1. Firma der Gesellschaft.

Die Firma der Gesellschaft lautet:

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1

§. 1. Corporate name, Registered office.

The corporate name of the Company is:

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1

§. 2. Sitz der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

§. 2. Registered Office.

The Company has its registered office in Frankfurt am Main.

§. 3. Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr.

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das

Kalenderjahr.

§. 3. Duration, Business year.

(1) The Company is set up for uncertain time.

(2) The business year of the Company is the calendar year.

§. 4. Gegenstand des Unternehmens.

§. 4. Objects of the company.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die

Vermögensverwaltung, der Erwerb, das Halten

und die Veräußerung von Beteiligungen.
(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte

betreiben und Handlungen vornehmen,

die geeignet sind, dem Gesell-schaftszweck

unmittelbar oder mittelbar zu dienen.

(3) Die Gesellschaft darf andere Unternehmen

übernehmen, sie darf sich an Unternehmen beteiligen

und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin.

Die Gesell-schaft darf im In- und Ausland

Zweigniederlassungen unter gleicher

oder anderer Firma errichten.

(1) Objects of the Company are the administration

of property, the purchase, the holding and the sale of shares.

(2) The Company may do all business being in direct or

indirect coherence with the aforesaid objects.

(3) The Company may acquire interests in other

enterprises , may purchase or in-corporate enterprises

especially as a personal liable general partner. The Company

is entitled to set up branch offices in Germany or abroad

under the same or a similar name.

§. 5. Stammkapital.

§. 5. Share capital.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00

Euro (in Worten: fünfundzwanzig-tausend Euro).

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

The share capital of the Company amounts to Euro

25.000,00, in words Euro twentyfivethousand. The share

capital has been fully paid in.

§. 6. Geschäftsführung.

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere

Geschäftsführer, die von der

Gesellschafterversammlung

bestellt und abberufen werden.

(2) Die Geschäftsführer sind an Gesetz

und Gesellschaftsvertrag sowie die Beschlüsse

der Gesellschafterversammlung gebunden.
Sie haben die Gesellschaft mit der Sorgfalt

eines ordentlichen Kaufmanns zu führen.

§. 6. Managing directors.

(1) The Company has one or more managing directors who
are appointed and dismissed by the shareholders' assembly.
(2) The rights and duties of the managing directors arise from

the governing law and the resolutions of the share-holders'

assembly. They have to run the Company

in the ordinary course of business.

§. 7. Vertretung.

(1) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt

dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, so wird

die Gesellschaft durch zwei

§. 7. Power of attorney.

(1) If only one managing director is appointed, he acts

individually on behalf of the Company. If several managing

directors are appointed, either two managing directors or

one managing director jointly with a registered clerk

29270

Geschäftsführer gemeinsam

oder durch einen Geschäftsführer

in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

(2) Die Gesellschafterversammlung kann einem

oder mehreren Geschäftsführern Befreiung von

den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. Ebenso

kann einem oder mehreren Geschäftsführern

Einzelvertretungsbefugnis auch dann erteilt werden,

wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind.

("Prokurist") are entitled to act on behalf of the Company.

(2) The shareholders' assembly may release single managing

directors generally or for an individual case from

the restrictions of Sect. 181 of the German Civil Code, so

that they are authorized to act on behalf of the Company in

legal transactions with

themselves in person or with themselves as representatives

of a third party. The assembly may also assign individual

power of attorney to one,

several or all of the managing directors.

§. 8. Bekanntmachungen.

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen

nur im elektronischen Bundesanzeiger.

§. 8. Announcements of the corporation.

Announcements of the Company are published

in the Electronic Federal Gazette.

§. 9. Gründungskosten.

Die Gesellschaft trägt den ihr oder ihrem Gründer

sowohl bei der rechtlichen Gründung, als auch bei

der so genannten "wirtschaftlichen Neugründung"

entstehenden Gründungsaufwand (Rechtsanwalts-,

Notar- und Gerichtskosten und Bankgebühren)

bis zu insgesamt € 2.500,00.

§. 9. Expenses for formation.

The Company is liable for the expenses of the legal

and economic formation (lawyer's fees, notary´s fees, fees of
registration and banking fees) up to the aggregate amount of

€ 2.500,00.

§. 10. Wettbewerbsverbot.

Die Gesellschafter sind von jedwedem

Wettbewerbsverbot befreit und schulden hierfür

keine Vergütung.

§. 10. Release of the duties of non-competition.

The shareholders are released of the legal duty not

to compete with the Company. They owe no compensation.

§. 11. Salvatorische Klausel.

Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags

ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar

sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen

Bestimmungen hiervon unberührt. Das gleiche gilt,

falls sich herausstellt, dass der Gesellschaftsvertrag

eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen

Bestimmungen ist eine wirksame Bestimmung

zu vereinbaren, die dem von den Gesellschaftern

Gewollten am nächsten

kommt; gleiches gilt im Fall einer Lücke.

§. 11. Severability

If a provision of this Articles of Association should be or

become ineffective or impracticable, the remaining

provisions shall stay effective. The same applies to eventual

gaps of this Articles. All parties shall be bound to replace

the ineffective or impracticable provision by a such

an effective one, by which the economic purpose intended

with the ineffective or impracticable provision can

be reached as far as possible in a permitted way.

Référence de publication: 2009034122/2460/454.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04423. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090041748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2009.

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.351.

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1
Registered office: Berliner Straße 44
D-60311 Frankfurt am Main, Germany
Share capital: EUR 25,000
R.C.S. Frankfurt am Main : HRB 82417
(the Absorbing Company)
and
Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 2 S.à.r.l.

29271

Société à responsabilité limitée
Registered office: 46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Share capital: EUR 12,500
R.C.S. Luxembourg: B 124.351
(the Absorbed Company)

MERGER PROPOSAL

Merger to be carried out by way of the absorption of the private limited liability company Allco Wind Energy (Lu-

xembourg) No. 2 S.à.r.l. by the German private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) DIF
Erneuerbare Energien GmbH 1.

The Board of Managers of Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 2 S.à.r.l. (the "Absorbed Company") and the Board

of Managers of DIF Erneuerbare Energien GmbH 1 (the "Absorbing Company" and together with the Absorbed Company,
the "Companies") have decided to draw up the following merger proposal in accordance with:

(i) Sections 122a et seq. of the German Transformation Act (hereinafter: "UmwG"),
(ii) Articles 261 and 278 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter:

"Luxembourg Law"),

(iii) Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council as of October 26, 2005 on cross-border

mergers of limited liability companies (hereinafter: "Merger Directive").

and to present the merger proposal to their respective general meeting of shareholders.

<i>Requirements under luxembourg and german law:

I. The Companies (Art. 5 lit. a) of the Merger Directive)

The Absorbing Company is a private limited liability company existing under German laws, with registered seat in

Frankfurt am Main, Germany, registered in the Commercial Register of the local court of Frankfurt am Main, under No.
HRB 82417. The Absorbing Company was incorporated pursuant to a notarial deed of the Notary Prof. Dr. Dieter Mayer,
residing in Munich, dated January 2, 2008. Its share capital is EUR 25,000 and is fully paid in. According to its Articles of
Association, the object of the Absorbing Company's business is the management of its own assets. The Absorbing Com-
pany is entitled to take over other companies and partnerships of the same or a similar kind. The Absorbing Company
is entitled to participate in such companies and partnerships, whether as a personally liable partner or otherwise, and
may establish branches under the same or another name in Germany and abroad. According to Section 122b (1) UmwG
in conjunction with Art. 4 (1a) of the Merger Directive a cross-border merger of a company with limited liability into
another company with limited liability is permitted so that the Absorbing Company may participate in a cross border
merger.

The Absorbed Company is a Luxembourg private limited liability company, incorporated and organized under the laws

of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg R.C.S. under number B 124.351, incorporated pursuant to a notarial deed
of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, of February 1, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations of April 19, 2007, number 651. Its articles of association have been amended several times and, for the
last time, pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, of June 16, 2008, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of August 13, 2008, number 1974. The share capital of the Absorbed
Company is EUR 12,500. The Absorbing Company is the owner of all 500 (five hundred) A shares with a nominal value
of twenty-five euros (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up, in the Absorbed Company, representing all the shares
of the share capital of the Absorbed Company in an amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500). The
Absorbed Company has not granted any special rights similar to those defined in Section 23 UmwG. Under the laws
applicable in Luxembourg, in particular article 257 of the Luxembourg Law a merger of a company with limited liability
into another company with limited liability is permitted. The Absorbed Company may therefore participate in a cross-
border merger in accordance with Section 122b (1) UmwG in conjunction with Art. 4 (1a) of the Merger Directive.

II. Merger

The Absorbed Company transfers all of its assets and liabilities including all rights and obligations, on being dissolved

without going into liquidation, to the Absorbing Company by way of a cross-border merger with an existing company
without granting of shares in the Absorbing Company (absorption) according to Section 122a UmwG and article 278 of
the Luxembourg Law, in particular, article 274 (1) a) of the Luxembourg Law and this Merger Proposal (the Merger).

This transfer includes all the assets and liabilities belonging to the Absorbed Company (known or unknown) as of the

date of the shareholders meeting, approving the Merger. Upon entry of the merger into the commercial register of the
Absorbing Company ("Legal Effective Date") all the assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company
ipso jure between the Companies and vis-à-vis third parties.

29272

The Absorbed Company guarantees to the Absorbing Company that the claims transferred as a result of the Merger

are certain and existing but does not guarantee the solvency of their respective debtors.

The Absorbing Company shall pay, as of the Legal Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance

premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been transferred.

As of the Legal Effective Date the Absorbing Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the

Absorbed Company.

The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company

with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be subrogated,
without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Company with respect to all assets and
against all debtors without any exception.

The Absorbing Company shall incur all debts and liabilities of any kind of the Absorbed Company. In particular, it shall

pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Absorbed Company.

All corporate documents of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company

for as long as prescribed by the competent jurisdiction.

The mandates of the members of the board of managers and of the statutory auditor(s) of the Absorbed Company (if

any) will be terminated on the Legal Effective Date. Full discharge will be given to the members of the board of managers
and to the statutory auditor(s) for the performance of their mandate.

III. New Shares (Art. 5 lit. b), c) and e) of the Merger Directive)

Since the Absorbing Company is the only shareholder of the Absorbed Company, there shall be no granting of shares

in the Absorbing Company or any other consideration in exchange for the transfer of the assets and liabilities pursuant
to Section 122c (3) UmwG. Therefore, any particular information pursuant to Section 122c (2) No. 2, 3 and 5 UmwG,
Art. 5 lit. b) c) and e) of the Merger Directive is not required.

IV. Shareholders' approval

The merger is subject to the approval of the shareholders of the Absorbing Company according to Sections 122g (1)

and 13 UmwG.

Further the merger is subject to the approval of the shareholders of the Absorbed Company according to article 263

of the Luxembourg Law. The board of managers of the Absorbing Company shall convene the shareholders to an ex-
traordinary general meeting of the shareholders to be held for the purpose of article 263 of the Luxembourg Law before
a Luxembourg notary as soon as practicable after one month has elapsed following the filing and publication of this Merger
Proposal in accordance with articles 9 and 262 of the Luxembourg Law, in order to approve the Merger in accordance
with this Merger Proposal.

The board of managers of each of the Companies have approved the Merger of the Companies.

V. Compensation offer

A compensation offer pursuant to Section 122i UmwG is not required, since the Absorbing Company as the acquiring

company is a company under German law. Neither is a compensation offer pursuant to Sections 122a (2) and 29 (1)
UmwG required, since the Absorbing Company as the acquiring company holds all shares in the Absorbed Company as
the transferring company. As a matter of precaution the Absorbing Company in its capacity as sole shareholder of the
Absorbed Company will also waive any rights for a compensation offer in the shareholder's meeting to decide upon the
merger.

VI. Effective date of the Merger from an accounting point of view (Art. 5 lit. f) of the Merger Directive)

and Date of the merging companies` accounts (Art. 5 lit. l) of the Merger Directive)

In relation to the Absorbing Company the takeover of the assets and liabilities of the Absorbed Company shall be

effective upon expiry of December 31, 2008 ("Effective Date"). As of January 1, 2009 all dealings and business transactions
of the Absorbed Company shall be deemed to be made for the account of the Absorbing Company (effective date pursuant
to Section 122c (2) No. 6 UmwG, Art. 5 lit. f) of the Merger Directive).

The Merger shall be based on the interim balance sheet of the Absorbed Company as of December 31, 2008 ("Closing

Balance Sheet"), which describes the evaluation of the assets and liabilities of the Absorbed Company as of December
31, 2008 (date of the Absorbed company's accounts).

The date of the Absorbing Company's accounts is December 31, 2007. However, since there shall be no exchange of

shares or other consideration for the transfer of the assets and liabilities in the course of the merger, the accounts of
the Absorbing Company are not relevant to establish the conditions of the cross-border merger in the sense of Section
122c (2) No. 12 UmwG, Art. 5 lit. l) of the Merger Directive.

VII. Evaluation of assets and liabilities (Art. 5 lit. k) of the Merger Directive)

The transferred assets and liabilities shall be carried over at book values in the balance of the Absorbing Company

(Section 122c (2) No. 11 UmwG, Art. 5 lit. k) Merger Directive).

29273

Since all shares of the transferring company are held by the Absorbing Company a merger audit or an audit report

will not be necessary (Sections 122f and 9 (2) UmwG; article 278 of the Luxembourg Law).

VIII. Special rights and special advantages (Art. 5 lit. g), h) of the Merger Directive)

The companies acknowledge that the Absorbed Company has not issued to any person any securities other than the

shares held by the Absorbing Company in the share capital of the Absorbed Company. No special rights concerning the
Companies exist and no special rights will be granted to any shareholder in connection with the merger pursuant to
Section 122c (2) No. 7 UmwG, Art. 5 lit. g) h) Merger Directive and article 261 (2) f) and g) of the Luxembourg Law.

The Companies acknowledge that no special advantage or benefits will be granted to the managers of the Companies

or to any of the persons referred to in Section 122c (2) No. 8 UmwG and article 261 (2) lit. g) of the Luxembourg Law.

IX. Repercussions on employment and employee participation (Art. 5 lit. d) and j) of the Merger Directive)

Neither the Absorbed Company nor the Absorbing Company has any employees. Therefore no particular information

can be given regarding the repercussions of the cross-border merger on employment (Section 122c (2) No. 4 UmwG).

Information on any issues of employee participation (Section 122c (2) No. 10 UmwG) are not required either, because

no employee participation rights exist or will have to be established at the Absorbed Company or the Absorbing Company,
either before or after the cross-border merger.

X. Cancellation of the shares and dissolution without liquidation of the Absorbed Company

As from the Legal Effective Date, the shares held by the Absorbing Company in the Absorbed Company will be cancelled

and the Absorbed Company will cease to exist.

XI. Additional provisions and Statutes of the Absorbing Company (Art. 5 lit i) of the Merger Directive)

The cost of the merger will be incurred by the Absorbing Company. Regarding a potential real estate transfer tax

obligation the parties declare that the Absorbed Company does not own any real estate.

The statutes of the Absorbing Company shall remain unchanged after this merger and are attached to this deed as

Annex 1.

The Companies mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the merger in accordance

with the legal and statutory requirements of both companies.

The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the Merger as

well as the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.

The shareholders of each of the Companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered office

of the said companies, at least one month before the date of the general meeting of the shareholders called to decide on
the Merger: the merger plan, the merger report, annual accounts and annual reports of the Companies for the last three
financial years, if any, and, if necessary, a recent accounting statement. A copy of the above mentioned documents will
be obtainable upon request.

If any provision in this Agreement is completely or partially invalid or if it subsequently looses its legal validity, this shall

not affect the validity of the remaining provisions. Instead of the invalid provision, to the extent legally permissible, such
a reasonable provision shall apply which comes as close as possible in economic terms to what the parties intended or
would have intended had they considered the invalidity of the provision. This applies mutatis mutandis if this Agreement
contains a gap; such gap shall be closed by a provision which corresponds to what the parties intended or would have
intended had they considered the gap herein.

Amendments of and supplements to this Agreement and this clause shall require written form in order to be valid,

unless a stricter, in particular notarial form is prescribed. Any oral agreements have not been made and would be invalid.

The present document has been drafted in Luxembourg on March 11, 2009, in original, in order (i) to be registered

with the Luxembourg Register of Commerce and Companies of the Absorbed Company and to be published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, (ii) to be registered with the German Commercial Register of the
Absorbing Company at least one month prior to the date of the general meeting of the shareholder(s) of each Companies
called to decide on the terms of the merger, in accordance with article 262 of the Luxembourg Law, Section 122d UmwG
and Art. 6 of the Merger Directive..

The present document has been drafted in English, followed by a German version.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes :

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1
Sitz: Berliner Straße 44
D-60311 Frankfurt am Main, Germany
Stammkapital: EUR 25.000,--
Handelsregister Frankfurt am Main: HRB 82417
(nachstehend: übernehmende Gesellschaft)

29274

und
Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 2 S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Sitz: 46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Stammkapital: EUR 12.500,--
Handelsregister Luxemburg: B 124.351
(nachstehend: übertragende Gesellschaft)

VERSCHMELZUNGSPLAN

Verschmelzung durch Aufnahme der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 2

S.à.r.l. in die deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung DIF Erneuerbare Energien GmbH 1.

Die Geschäftsführung der Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 2 S.à.r.l. (nachstehend: übernehmende Gesellschaft)

und die Geschäftsführung der DIF Erneuerbare Energien GmbH 1 (nachstehend: übertragende Gesellschaft, gemeinsam
mit der übernehmenden Gesellschaft als die Gesellschaften bezeichnet) haben entschieden, den folgende Verschmel-
zungsplan gemäß

(i) §§ 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (nachstehend: UmwG),
(ii) Artikel. 261 und 278 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden

Fassung (nachstehend: "Luxemburgisches Gesetz"),

(iii) der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von

Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (nachstehend: "Verschmelzungsrichtlinie")

durchzuführen und den Verschmelzungsplan ihren jeweiligen Gesellschafterversammlungen zu unterbreiten.

<i>Erfordernisse nach Luxemburgischem und Deutschem recht:

I. Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften (Art. 5 a) der Verschmelzungsrichtlinie)

Die übernehmende Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit

Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB
82417. Die übernehmende Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde des Notars Prof. Dr. Dieter Mayer, München,
vom 2. Januar 2008 errichtet. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,--. Es ist vollständig erbracht. Gemäß dem Gesell-
schaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft ist deren Unternehmensgegenstand die Verwaltung des eigenen Vermö-
gens. Die übernehmende Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen. Sie darf sich
an solchen Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin und kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma errichten. Gemäß § 122b Abs. 1 UmwG i. V. m. Art. 4 Abs. 1
lit a) der Verschmelzungsrichtlinie ist die grenzüberschreitende Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung auf eine andere Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig, so dass die übernehmende Gesellschaft Teilnehmer
einer grenzüberschreitenden Verschmelzung sein kann.

Die übertragende Gesellschaft ist eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, errichtet nach luxem-

burgischem Recht, mit Sitz in 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg zu B 124.351, gegründet gemäß notarieller Urkunde des Maître Jean Seckler, Notar,
Junglinster, vom 1. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 19. April 2007,
Nr. 651. Der Gesellschaftsvertrag ist mehrmals geändert worden, zuletzt gemäß Urkunde des Maître Martine Schaeffer,
Notar in Luxemburg, vom 16. Juni 2008, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 13. August
2008, Nr. 1974. Das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft beträgt EUR 12.500,--. Die übernehmende Gesellschaft
hält alle 500 (fünfhundert) Stammanteile der Klasse A mit einem Nennwert von EUR 25,-- (fünfundzwanzig Euros) je
Anteil am Stammkapital von insgesamt EUR 12.500,00 (zwölftausendfünfhundert Euro) an der übertragenden Gesellschaft,
die von ihr übernommen und vollständig eingezahlt worden sind. Bei der übertragenden Gesellschaft bestehen keine
Sonderechte entsprechend § 23 UmwG. Nach dem geltenden innerstaatlichen luxemburgischen Recht, insbesondere Art.
257 des Luxemburgischen Gesetzes, ist die Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf eine andere
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig. Die übertragende Gesellschaft kann daher gem. § 122b Abs. 1 UmwG i.
V. m. Art. 4 Abs. 1 lit. a) der Verschmelzungsrichtlinie auch an einer grenzüberschreitenden Verschmelzung teilnehmen.

II. Verschmelzung

Die übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung

ohne Abwicklung auf die übernehmende Gesellschaft im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung mit einer
bestehenden Gesellschaft ohne die Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft (Verschmelzung durch
Aufnahme) gemäß § 122a UmwG und Art. 278 des Luxemburgischen Gesetzes, insbesondere Art. 274 Abs. 1 lit. a) des
Luxemburgischen Gesetzes, sowie in Übereinstimmung mit diesem Verschmelzungsplan (Verschmelzung).

Die  Übertragung  beinhaltet  sämtliche  (bekannten  und  unbekannten)  Vermögenswerte  und  Verbindlichkeiten  der

übertragenden  Gesellschaft  zum  Zeitpunkt  der  dieser  Verschmelzung  zustimmenden  Gesellschafterversammlung.  Mit

29275

Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft ("rechtlicher Verschmelzungss-
tichtag")  gehen  sämtliche  Aktiva  und  Passiva  auf  die  übernehmende  Gesellschaft  von  Rechts  wegen  im  Innen-  und
Außenverhältnis über.

Die  übertragende  Gesellschaft  garantiert  der  übernehmenden  Gesellschaft,  dass  die  aufgrund  der  Verschmelzung

übertragenen Forderungen bestehen, garantiert jedoch nicht die Zahlungsfähigkeit der jeweiligen Schuldner.

Die übernehmende Gesellschaft übernimmt ab dem rechtlichen Verschmelzungsstichtag die Zahlung sämtlicher Steu-

ern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und Versicherungsprämien, die hinsichtlich des Eigentums der übertragenen Vermö-
genswerte fällig sind oder werden.

Ab  dem  rechtlichen  Verschmelzungsstichtag  erfüllt  die  übernehmende  Gesellschaft  sämtliche  Vereinbarungen  und

Verpflichtungen jeglicher Art, die von der übertragenden Gesellschaft eingegangen worden sind.

Die sich aus den Vermögenswerten der übertragenden Gesellschaft ergebenden Rechte und Ansprüche gehen auf die

übernehmende Gesellschaft mit sämtlichen dinglichen und schuldrechtlichen Sicherheiten über. Die übernehmende Ge-
sellschaft tritt somit ohne Forderungsübertragung in alle dinglichen und schuldrechtlichen Rechte aus sämtlichen Ver-
mögenswerten und im Verhältnis zu sämtlichen Schuldnern ohne Ausnahme ein.

Die übernehmende Gesellschaft übernimmt sämtliche Schulden und Verbindlichkeiten jeglicher Art der übertragenden

Gesellschaft. Insbesondere übernimmt sie die Zahlung von Kapital und Zinsen auf sämtliche Schulden und Verbindlich-
keiten jeglicher Art, die von der übertragenden Gesellschaft eingegangen worden sind.

Sämtliche Unterlagen der übertragenden Gesellschaft sind am Sitz der übernehmenden Gesellschaft in Übereinstim-

mung mit den dort geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufzubewahren.

Die Mandate der Mitglieder der Geschäftsführung sowie etwaiger Abschlussprüfer der übertragenden Gesellschaft

werden zum rechtlichen Verschmelzungsstichtag beendet. Den Mitgliedern der Geschäftsführung sowie den Abschluss-
prüfern wird für die Erfüllung ihres Mandats jeweils vollständige Entlastung erteilt.

III. Neue Anteile (Art. 5 lit. b), c) und e) der Verschmelzungsrichtlinie)

Da die übernehmende Gesellschaft alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, erfolgt keine Gewäh-

rung von Geschäftsanteilen an der übernehmenden Gesellschaft oder sonstiger Gegenleistungen für die Übertragung des
Aktiv- und Passivvermögens gemäß § 122c Abs. 3 UmwG. Somit sind keine besonderen Angaben gemäß § 122c Abs. 2
Nr. 2, 3 und 5 UmwG, Art. 5 lit. b) c) und e) der Verschmelzungsrichtlinie erforderlich.

IV. Zustimmung der Gesellschafter

Die Verschmelzung unterliegt der Zustimmung der Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft gemäß §§ 122g

Abs. 1 und 13 UmwG.

Weiterhin unterliegt die Verschmelzung der Zustimmung der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gemäß

Art. 263 des Luxemburgischen Gesetzes. Die Geschäftsführung der übertragenden Gesellschaft wird für die Zwecke des
Art. 263 des Luxemburgischen Gesetzes so schnell wie möglich nach Ablauf eines Monats nach Anmeldung und Veröf-
fentlichung  des  vorliegenden  Verschmelzungsvorhabens  gemäß  Art.  9  und  262  des  Luxemburgischen  Gesetzes  eine
außerordentliche Gesellschafterversammlung vor einem luxemburgischen Notar zur Erteilung der Zustimmung zu der
Verschmelzung gemäß des vorliegenden Verschmelzungsvorhabens einberufen.

Die Geschäftsführungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften haben der Verschmelzung jeweils bereits

zugestimmt.

V. Abfindungsangebot

Ein Abfindungsangebot gemäß § 122 i UmwG ist nicht erforderlich, da es sich bei der übernehmenden Gesellschaft (als

aufnehmendem Rechtsträger) um eine Gesellschaft nach deutschem Recht handelt. Ein Abfindungsangebot ist auch nicht
gemäß §§ 122a Abs. 2 und 29 Abs. 1 UmwG erforderlich, da sich sämtliche Geschäftsanteile der übertragenden Gesellschaft
(als übertragendem Rechtsträger) in der Hand der übernehmenden Gesellschaft (als aufnehmendem Rechtsträger) be-
finden. Die übernehmende Gesellschaft wird als Alleingesellschafter des übertragenden Gesellschafters in der über die
Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlung vorsorglich auf sämtliche Rechte auf ein Abfindungsangebot
verzichten.

VI. Verschmelzungsstichtag unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung (Art. 5 lit. f) der Verschmel-

zungsrichtlinie) und verwendeten Bilanzstichtage (Art. 5 lit. l) der Verschmelzungsrichtlinie)

Mit Bezug auf die übernehmende Gesellschaft wird die Übernahme des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden

Gesellschaft mit Ablauf des 31. Dezember 2008 ("Verschmelzungsstichtag") wirksam. Ab dem 1. Januar 2009 gelten sämt-
liche  Handlungen  der  übertragenden  Gesellschaft  als  für  Rechnung  der  übernehmenden  Gesellschaft  vorgenommen
(Stichtag gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG, Art. 5 lit. f) der Verschmelzungsrichtlinie).

Der Verschmelzung wird eine Zwischenbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2008 (Schlussbilanz)

zu Grunde gelegt, aus der sich die Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft zum 31.
Dezember 2008 (Bilanzstichtag der übergehenden Gesellschaft) ergibt.

29276

Der Bilanzstichtag der übernehmenden Gesellschaft ist der 31. Dezember 2007. Da jedoch im Verlauf der Verschmel-

zung weder ein Austausch von Anteilen stattfindet noch eine sonstige Gegenleistung für die Übertragung des Aktiv- und
Passivvermögens erfolgt, ist der Jahresabschluss der übernehmenden Gesellschaft zur Bestimmung der Verhältnisse der
grenzüberschreitenden Verschmelzung im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 12 UmwG, Art. 5 lit. l) der Verschmelzungsrichtlinie
nicht erforderlich.

VII. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens (Art. 5 lit. k) der Verschmelzungsrichtlinie)

Das übertragene Aktiv- und Passivvermögen wird zu Buchwerten in der Bilanz der übernehmenden Gesellschaft wei-

tergeführt (§ 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG, Art. 5 lit. k) Verschmelzungsrichtlinie).

Da sich sämtliche Geschäftsanteile der übertragenden Gesellschaft in der Hand der übernehmenden Gesellschaft be-

finden, ist eine Verschmelzungsprüfung oder ein Prüfungsbericht nicht erforderlich (§§ 122f und 9 Abs. 2 UmwG; Art.
278 des Luxemburgischen Gesetzes).

VIII. Sonderrechte und besondere Vorteile (Art. 5 lit. g), h) der Verschmelzungsrichtlinie)

Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erklären, dass die übertragende Gesellschaft außer den von der

übernehmenden Gesellschaft an ihrem Stammkapital gehaltenen Geschäftsanteile keine Wertpapiere an andere Personen
ausgegeben hat. Es bestehen keine Sonderrechte betreffend die Gesellschaften und es werden den Gesellschaftern auch
keine Sonderrechte im Zusammenhang mit der Verschmelzung gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG, Art. 5 lit. g) h) der
Verschmelzungsrichtlinie und Art. 261 (2) f) und g) des Luxemburgischen Gesetzes gewährt.

Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erklären, dass den Geschäftsführern oder sonstigen Personen

gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und Art. 261 Abs. 2 lit. g) des Luxemburgischen Gesetzes keine besonderen Vorteile
oder Leistungen gewährt werden.

IX. Auswirkung der Verschmelzung auf die Beschäftigung und die Arbeitnehmermitbestimmung (Art. 5

lit. d) und j) der Verschmelzungsrichtlinie)

Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft beschäftigt Arbeitnehmer. Aus diesem

Grund können keine Angaben zu den voraussichtlichen Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die
Beschäftigung (§ 122c Abs. 2 Nr. 4 UmwG) gemacht werden.

Auch Angaben zu mitbestimmungsrechtlichen Fragen (§ 122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG) entfallen, weil bei den an der

Verschmelzung beteiligten Gesellschaften weder vor noch nach der grenzüberschreitenden Verschmelzung Mitbestim-
mungsrechte oder ein der Mitbestimmung unterliegendes Gremium bestehen oder einzurichten sind.

X. Einziehung der Anteile und Auflösung ohne Abwicklung der übertragenden Gesellschaft

Mit Wirkung zum rechtlichen Verschmelzungsstichtag werden die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen

Anteile an der übertragenden Gesellschaft eingezogen und die Gesellschaft besteht nicht weiter fort.

XI. Zusätzliche Bestimmungen und Satzung der übernehmenden Gesellschaft (Art. 5 lit. i) der Ver-

schmelzungsrichtlinie)

Die Kosten der Verschmelzung werden von der übernehmenden Gesellschaft getragen. Bezüglich etwaiger Grunder-

werbsteuern erklären die Parteien, dass die übertragende Gesellschaft keinen Grundbesitz hat.

Der Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft besteht nach der Verschmelzung unverändert fort und ist

als Anhang 1 beigefügt.

Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften verpflichten sich gegenseitig zur Mitwirkung bei der Durchführung

der Verschmelzung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und rechtlichen Erfordernissen beider Gesellschaften.

Die übernehmende Gesellschaft verpflichtet sich, sämtliche notwendigen formalen Erfordernisse für die Durchführung

der Verschmelzung sowie die Übertragung des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft auf die über-
nehmende Gesellschaft zu erfüllen.

Die Gesellschafter der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften sind jeweils berechtigt, am Sitz der Gesell-

schaften  mindestens  einen  Monat  vor  der  über  die  Verschmelzung  beschließenden  Gesellschafterversammlung  die
folgenden Unterlagen einzusehen: die Bedingungen der Verschmelzung, den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht
der Gesellschaften in den letzten drei Geschäftsjahren sowie ggf. eine buchhalterische Übersicht neueren Datums. Eine
Kopie dieser Unterlagen ist auf Anfrage erhältlich.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit

später verlieren, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. Das gleiche
gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen Bestimmung
oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, wirtschaftlich dem
am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bei Abschluss dieses Vertrages
bedacht hätten.

29277

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie dieser Klausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform,

soweit nicht eine strengere, insbesondere die notarielle Form zu beachten ist. Mündliche Abmachungen sind nicht ge-
troffen und wären unwirksam.

Das vorliegende Dokument wurde am 11. März 2009 im Original in Luxemburg zum Zweck der (i) Eintragung im

Luxemburgischen Handelsregister der übertragenden Gesellschaft sowie zur Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations, (ii) zur Eintragung im deutschen Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft min-
destens einen Monat vor der über die Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlungen der an der Ver-
schmelzung beteiligten Gesellschaften gemäß Art. 262 des Luxemburgischen Gesetzes, § 122d UmwG und Art. 6 der
Verschmelzungsrichtlinie erstellt.

Draft merger proposal is approved by:
Dem Entrwurf des Verschmelzungsplan wird zugestimmt von:

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1
Represented by / vertreten durch
Allard Ruijs
<i>Managing director / Geschäftsführer

Anhang 1

Annex 1

Gesellschaftsvertrag der DIF Erneuerbare Energien

GmbH 1

Articles of DIF Erneuerbare Energien GmbH 1

§ 1.

Firma der Gesellschaft

§ 1.

Corporate Name, Registered Office

Die Firma der Gesellschaft lautet:

The corporate name of the Company is:

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1

DIF Erneuerbare Energien GmbH 1

§ 2.

Sitz der Gesellschaft

§ 2.

Registered Office

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

The Company has its registered office in Frankfurt am Main.

§ 3.

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

§ 3.

Duration, Business Year

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

(1) The Company is set up for uncertain time.

(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalender-

jahr.

(2) The business year of the Company is the calendar

year.

§ 4.

Gegenstand des Unternehmens

§ 4.

Objects of the Company

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die

Vermögensverwaltung,der Erwerb, das Halten und die Ver-
äußerung von Beteiligungen.

(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben und

Handlungen vornehmen, die geeignet sind, dem Gesell-
schaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen.

(3) Die Gesellschaft darf andere Unternehmen überneh-

mensie darf sich an Unternehmen beteiligen und zwar auch
alspersönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesell-schaft
dar im In- und Ausland Zweigniederlassungen unter gleicher
oder anderer Firma errichten.

(1) Objects of the Company are the administration of

property, the purchase, the holding and the sale of shares.

(2) The Company may do all business being in direct or

indirect coherence with the aforesaid objects.

(3) The Company may acquire interests in other enter-

prises, may purchase or in-corporate enterprises especially
as a personal liable general partner.

The Company is entitled to set up branch offices in Ger-

many or abroad under the same or a similar name.

§ 5.

Stammkapital

§ 5.

Share Capital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00
Euro (in Worten: fünfundzwanzig-tausend Euro). Das

Stammkapital ist voll eingezahlt.

The share capital of the Company amounts to Euro

25.000,00, in words Euro twentyfivethousand. The share
capital hasbeen fully paid in.

§ 6.

Geschäftsführung

§ 6.

Managing Directors

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere,
Geschäftsführer die von der Gesellschafterversammlung

bestellt und abberufen werden.

(2) Die Geschäftsführer sind an Gesetz und Gesellschafts-

vertrag sowie die Beschlüsse der Gesellschafterversamm-
lung gebunden. Sie haben die Gesellschaft mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns zu führen.

(1) The Company has one or more managing directors

who are appointed and dismissed by the shareholders' as-
sembly.

(2) The rights and duties of the managing directors arise

from the governing law and the resolutions of the share-
holders' assembly. They have to run the Company in the
ordinary course of business.

29278

§ 7.

Vertretung

§ 7.

Power of Attorney

(1) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser

die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer-
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertreten.

(2) Die Gesellschafterversammlung kann einem oder-

mehreren Geschäftsführern Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB erteilen. Ebenso kann einem oder
mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis auch
dann erteilt werden, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt
sind.

(1) If only one managing director is appointed, he acts

individually on behalf of the Company. If several managing
directors are appointed, either two managing directors or
one managing director jointly with a registered clerk ("Pro-
kurist") are entitled to act on behalf of the Company.

(2) The shareholders' assembly may release single ma-

naging directors generally or for an individual case from the
restrictions of Sect. 181 of the German Civil Code, so that
they are authorized to act on behalf of the Company in legal
transactions with themselves in person or with themselves
as representatives of a third party. The assembly may also
assign individual power of attorney to one, several or all of
the managing directors.

§ 8.

Bekanntmachungen

§ 8.

Announcements of the Corporation

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im

elektronischen Bundesanzeiger.

Announcements of the Company are published in the

Electronic Federal Gazette.

§ 9.

Gründungskosten

§ 9.

Expenses for Formation

Die Gesellschaft trägt den ihr oder ihrem Gründer so-

wohl bei der rechtlichen Gründung, als auch bei der so
genannten "wirtschaftlichen Neugründung" entstehenden
Gründungsaufwand (Rechtsanwalts-, Notar- und Gerichts-
kosten und Bankgebühren) bis zu insgesamt € 2.500,00.

The Company is liable for the expenses of the legal and

economic formation (lawyer's fees, notary´s fees, fees of
registration and banking fees) up to the aggregate amount
of € 2.500,00.

§ 10.

Wettbewerbsverbot

§ 10.

Release of the Duties of Non-competition

Die Gesellschafter sind von jedwedem
Wettbewerbsverbot befreit und schulden hierfür keine

Vergütung.

The shareholders are released of the legal duty not to

compete with the Company. They owe no compensation.

§ 11.

Salvatorische Klausel

§ 11.

Severability

Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags ganz

oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt. Das gleiche gilt, falls sich herausstellt,
dass der Gesellschaftsvertrag eine Regelungslücke enthält.
Anstelle der unwirksamen Bestimmungen ist eine wirksame
Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Gesellschaf-
tern Gewollten am nächsten kommt; gleiches gilt im Fall
einer Lücke.

If a provision of this Articles of Association should be or

become ineffective or impracticable, the remaining provi-
sions shall stay effective. The same applies to eventual gaps
of this Articles. All parties shall be bound to replace the
ineffective or impracticable provision by a such an effective
one, by which the economic purpose intended with the in-
effective or impracticable provision can be reached as far
as possible in a permitted way.

Référence de publication: 2009034124/2460/447.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04425. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090041753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2009.

Porta Westfalica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 127.157.

<i>Extrait des décisions prises par l’actionnaire unique de la Société en date du 9 février 2009

1. L'actionnaire a décidé de nommer en qualité de gérant de la Société Monsieur Godfrey Abel, né le 2 juillet 1960 à

Brixworth, Grande Bretagne, et ayant son adresse professionnelle au 30, rue de Crecy, L-1364 Luxembourg, avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.

2. Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Monsieur David Cunnington,

29279

- Monsieur Mark Houston,
- Monsieur Michael Chidiac, et
- Monsieur Godfrey Abel.
3. L'actionnaire a décidé de transférer le siège social de la Société de 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 10,

rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2009.

<i>Pour la Société
BOUZROUTI HANAN

Référence de publication: 2009030469/1092/25.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08509. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090033441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2009.

Air Ghelamco, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 122.850.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AIR GHELAMCO
Signature

Référence de publication: 2009031201/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00114. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Renaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8085 Bertrange, 10A, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 60.839.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 02/03/2009.

<i>Pour RENACO S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2009031194/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07911. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

CEREP Investment Parc de Seine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.380.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009031108/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08000. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

29280


Document Outline

2206 Participations S.A.

Accelior S.A.

Air Ghelamco

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 1 S.à r.l.

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 2 S.à r.l.

Allianz Business Cash

Assurgest S.A.

Carmignac Portfolio Advisory Holding S.A.

Centore Société Financière d'Investissements

Cerep Ares GP S.à.r.l.

CEREP II Investment Ten S.à r.l.

CEREP Investment Parc de Seine S.à r.l.

Cinquanteneuf S.A.

Compagnie Financière de Castiglione

Compagnie Financière de Castiglione

Compagnie Financière Française S.A.

CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS

Dotcom S.A.

Dresdner Vermögensplan 15

Dresdner Vermögensplan 25

Dresdner Vermögensplan 35

Dresdner Vermögensplan 65

Dresdner Vermögensplan 80

Europa Managed Assets

Finaris S.A.

Fondation Jean Think. Fonds de Secours

HSBC Property Investment (French Offices)

Immobinvest S.A.

IPC - Portfolio Invest XIII

Kentucky s.à.r.l.

LCF Edmond de Rothschild Conseil

Les Productions du Cercle S.à r.l.

LMA German Investments

LMB German Investments

LMC German Investments

LMD German Investments

LuxCo IIIC S.àr.l.

MEAG Luxembourg S.à r.l.

MEAG Luxembourg S.à r.l.

Nordea Asset Allocation Fund

Observatoire Mondial Géostratégique S.A.

Participe 49, s.à r.l.

Patio

Porta Westfalica S.à r.l.

Promvest S.A.

Quinlan Private Balaton Client Holdings S.à r.l.

Renaco S.à r.l.

Renaco S.à r.l.

SCAP (Société de Courtage en Assurances et Placements)

Steel &amp; Co. S.A.

Sylso Sàrl

Textil Participations S.A.

TLU International S.A.

Triangle Immobilière S.à r.l.

VTS Consulting S.à r.l.