logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 584

17 mars 2009

SOMMAIRE

Abris Holdings 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28008

Adviser I Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28013

Adviser II Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28018

AGFC (Angus Genetic Forest Consulting)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28011

Alginic S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28026

Auto Helfent S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28013

Camile S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28016

Canama S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28015

Chamäleon und Aktivität S.A. . . . . . . . . . . .

28027

Chauffage-Sanitaire Integral S.à r.l.  . . . . . .

28022

Chloride Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

28022

Crefinimmo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28016

DJB G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28014

EB Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28011

Equilease International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

28012

Euro Viti Nature S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28027

Falcon Hansa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28012

Fédération Luxembourgeoise de Gymnas-

tique a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28032

Filti S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28016

Garage FEYEREISEN S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

28018

Gaviota Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28006

Grenache & Cie S.N.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28015

Him-Racing-Kart S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28014

HSH Asset Management S.A.  . . . . . . . . . . .

28026

Inpigest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28016

Johanns & Cie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28026

J.P. Morgan Real Estate Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28014

K-Flat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28028

Lab Document Vault S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

28019

Lafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27986

Lapraille Dupont Esméralda Chloé s.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28020

LBP Luxco GP 2-Resi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

28007

LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l.  . . . . . . . . . .

28006

LBP Luxco GP 6-Hessen S.à r.l. . . . . . . . . . .

28005

Lënster Energie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28009

Lincoln Electric Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

28021

Logoline S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28015

Millenium Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

28012

PAC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28007

PCB & CMR S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28020

Promo Petrole S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28031

Sasfin International Fund  . . . . . . . . . . . . . . .

28008

Selrah S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28032

Selrah S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28032

Seneca Pool S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27986

Seneca Pool S.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . .

27986

Sensata Management Company S.A. . . . . .

28005

Société Luxembourgeoise de Construction

Métallique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28011

Sofecolux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28022

SOFECOLUX S.A., société de gestion de

patrimoine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28022

Spido Oil s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28021

S.R.M.I. International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

28022

Tracom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28006

Valorum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28011

Viva Gestions Hôtelières S.A.  . . . . . . . . . . .

28019

Viva Gestions Hôtelières S.A.  . . . . . . . . . . .

28021

Viva Gestions Immobilières S.A. . . . . . . . . .

28018

Viva Gestions Immobilières S.A. . . . . . . . . .

28019

Vry SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28013

Weather Capital Finance  . . . . . . . . . . . . . . .

28006

Weather Capital Special Purpose 1 S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28007

World Hopper s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28027

WRCA (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

28008

27985

Lafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 83.258.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52627 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028827/211/12.
(090031268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Seneca Pool S.A., SICAR, Société Anonyme,

(anc. Seneca Pool S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 137.358.

In the year two thousand and eight, on the third day of December.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Seneca Pool S.A. (the "Company"), having its registered

office in L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under the number B 137.358, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 19 February 2008 and
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 991 of 22 April 2008.

The meeting is opened at 9.30 a.m. with Mr Nicolas Goulet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms Anita Maggipinto, private employee, professionally residing in Luxembourg,
The meeting elected as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, professionally residing in Luxembourg,
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
- all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance

list attached to these minutes and duly signed by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders repre-
sented and the board of the meeting;

- pursuant to the attendance list, all shareholders are present or represented, and declare that they have been informed

in advance of the agenda of the meeting and waive all convening notices and formalities;

- thus the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Adoption of the SICAR status and subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company

(Corporate Purpose);

2. Conversion of the fixed share capital of the Company into a variable share capital equal at all times to the total net

assets of the Company and divided into shares without nominal value;

3. Creation of an additional class of shares within the Company share capital, entitled to specific distribution rights,

namely the class B2 shares (the "Class B2 Shares");

4. Change in the decision process of the board of directors of the Company;
5. Acceptance of the resignation of the statutory auditors, discharge and appointment of an independent auditor; and

subsequently

6. Full restatement of the articles of association of the Company.
Then, the extraordinary general meeting of shareholders, after deliberation, takes unanimously the following resolu-

tions:

<i>First resolution

Further to the verbal authorization granted by the Commission de Surveillance du Secteur Financier on 14 August

2008, the extraordinary general meeting of shareholders resolves that the Company shall from now on adopt the status
of a SICAR and be governed by the law of 15 June 2004 relating to the société d'investissement en capital à risque as
amended from time to time, and consequently resolved to amend the article 4 of the articles of association of the Company
(Corporate Purpose) which shall now read as follows:

"The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in risk capital within the widest meaning

permitted under the Law of 15 June 2004.

27986

The Company may also invest the funds available to it in any other assets permitted by law and consistent with its

purpose.

Furthermore, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the

fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the Law of 15 June 2004."

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to convert the fixed share capital of the Company into a variable share

capital equal at all times to the total net assets of the Company and divided into shares without nominal value.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to create an additional class of shares within the Company, namely the

Class B2 Shares, entitling their holders to any proceed, capital gain or other income deriving from investments to be
made by the Company in a pool consisting of the ordinary units issued by the company Cipio Partners Fund VI S.C.S.,
SICAR, a company to be incorporated as a société en commandite simple and qualifying as a société d'investissement en
capital à risque within the meaning of the Law of 15 June 2004.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the decision process of the board of directors of the Company,

by requiring the positive vote of at least one class A director for (a) any resolutions related to liabilities, either contractual
or not, which imply (i) recurring annual expenses of an amount superior to one thousand euro (EUR 1,000), (ii) a notice
period of more than one month, or (iii) a fixed term of more than three months, (b) any resolutions related to any other
expenses of an amount superior to one thousand euro (EUR 1,000), as well as (c) any resolutions related to (i) any kind
of investments, divestments and corporate restructurings, (ii) capital calls and distributions, (iii) issuance of shares and
(iv) transfer of shares (altogether the "Special Resolutions").

The extraordinary general meeting further resolves that the Company would be bound by the joint signatures of any

two Directors, provided that these two signatures include the signature of at least one class A Director for all matters
related to the Special Resolutions, or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated
by the board of directors of the Company.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the adoption of the SICAR status by the Company, in accordance with the first resolution, the

extraordinary general meeting resolves to (i) accept the resignation of the statutory auditors of the Company with effect
as of 3 December 2008 and grant discharge to them for the services performed as statutory auditors of the Company
up to the present extraordinary general meeting and (ii) appoint Ernst and Young S.A., with its registered office at 7, Parc
d'Activités Syrdall, L-5365, Luxembourg, as indépendant auditor of the Company for a term to expire at the annual general
meeting of shareholders of the Company to approve the financial statements as of 31 December 2009.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above resolutions, the extraordinary general meeting resolves to restate the entire articles

of association of the Company to read as follows:

I - Definitions

"Articles"

The articles of association of the Company.

"Auditor"

Refers to the Réviseur d'Entreprise Agréé responsible for performing the audit
and monitoring functions set forth in Article 20.

"Board of Directors"

The board of Directors of the Company.

"Business Day"

A day on which banks are generally open for business in Luxembourg.

"Cipio Partners" or "Cipio"

Refers, without identifying the specific entity, to part of the Cipio Partners Group
of companies. Cipio Partners consists of several entities with different roles,
functions and responsibilities. Cipio Partners may also be referred to as "Cipio".

"Class of Shares"

Each class of Shares relating to a Pool of Assets within the Company.

"Class A Shares"

A Class of Shares relating to a specific Pool of Assets comprised of the shares
of Cipio Partners S.àr.l., a company incorporated under Luxembourg laws on
27 July 2007 as a société à responsabilité limitée (S.à r.l.) and registered with
the Luxembourg trade and companies register under number B 131 444 which
acts as general partner of CPF VI.

"Class Bl Shares"

A Class of Shares relating to a specific Pool of Assets comprised of one
participating unit and up to 1,000,000 (one million) ordinary units issued by
CPF VI.

"Class B2 Shares"

A Class of Shares relating to a specific Pool of Assets comprised of ordinary

27987

units issued by CPF VI.

"Company"

Seneca Pool S.A., SICAR is organized as a société anonyme and registered
as a société d'investissement en capital à risque in Luxembourg.

"Connected Persons"

Employees, representatives of Cipio Partners and other persons approved as
holders of Shares of whatever Class of Shares by the Board of Directors.
Connected Persons must qualify as Eligible Investors.

"CPF VI"

Cipio Partners Fund VI S.C.S., SICAR, a company to be incorporated as a société
en commandite simple and qualifying as a société d'investissement en capital à
risque within the meaning of article 1 of the Law of 15 June 2004.

"Directors"

The directors of the Company.

"Eligible Investors"

Institutional Investors, Professional Investors or Well-informed Investors within the
meaning of article 2 of the Law of 15 June 2004 and any other investor which does
not need to qualify as Institutional Investors, Professional Investors or Well-
informed Investors in accordance with article 2 of the Law of 15 June 2004.

"Institutional Investors"

Investors who qualify as institutional investors according to the Luxembourg laws
and regulations.

"Law of 15 June 2004"

The law of 15 June 2004 relating to the société d'investissement en capital à risque
(SICAR), as amended from time to time.

"Memorandum"

The placement memorandum of the Company as amended from time to time.

"Net Asset Value"

The net asset value per Share of the relevant Class of Shares within the relevant
Pool of Assets as determined pursuant to article 10 hereof.

"Pool of Assets"

A portfolio comprising all the assets acquired in the context of a specific investment
program or directly or indirectly deriving therefrom as well as all liabilities directly
or
indirectly deriving from such investment program.

"Professional Investors"

Investors who qualify as professional investors under Annex II of Directive
2004/39/EC on markets in financial instruments.

"Reference Currency"

Euro, the currency of the European Economic and Monetary Union.

"Register"

The register of registered Shares as determined under Article 6 hereof.

"Shareholder"

A holder of Shares.

"Shares"

Shares issued by the Company.

"Special Resolutions"

Any resoluutions listed under article 13 hereof and requiring the vote of at least
one class A Director.

"Valuation Date"

31 December of each year and such other days as determined from time to time
by the Board of Directors.

"Well-informed Investors"

An investor who (i) adheres in writing to the status of well-informed investor and
(ii) either invests a minimum of € 125,000 in the Company or benefits from a
certificate deliveredby a credit institution, another professional of the financial
sector within the meaning of the Directive 2006/48/CE, a investment firm within
the meaning of the Directive 2004/39/CE or a management company within the
meaning of the Directive 2001/107/CE stating that he is experienced enough
to appreciate in an adequate manner an investmentin risk capital.

II - Articles of association

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

of the Company hereafter issued, a company in the form of a société anonyme (S.A.) with variable capital qualifying as a
société d'investissement en capital à risque (SICAR) under the name of "Seneca Pool S.A., SICAR" (the "Company").

The Company shall be governed by the Law of 15 June 2004.

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the Board
of Directors.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

decision of the Board of Directors.

27988

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period. However, it may at any time be dissolved by

a resolution of the general meeting of Shareholders subject to the quorum and majority requirements necessary for the
amendment of the Articles.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in risk capital within the

widest meaning permitted under the Law of 15 June 2004.

The Company may also invest the funds available to it in any other assets permitted by law and consistent with its

purpose.

Furthermore, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the

fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the Law of 15 June 2004.

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is variable and shall at any time be equal to the total net assets

of the Company pursuant to Article 10 hereof. The minimum subscribed capital of the Company, increased by the share
premiums, which must be reached within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorized
as a société d'investissement en capital à risque (SICAR) under Luxembourg law, is one million Euro (€ 1,000,000).

The share capital of the Company shall be represented by:
i) 31,000 "Class A Shares" entitling their holders to any proceed, capital gain or other income deriving from the

investments made by the Company in Cipio Partners S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg laws on 27 July
2007 as a société à responsabilité limitée (S.à r.l.) and registered with the Luxembourg trade and companies register under
number B 131.444

ii) 1,000,001 "Class Bl Shares" entitling their holders to any proceed, capital gain or other income deriving from the

investments made by the Company in a Pool of Assets consisting of the participating unit as well as up to one million
(1,000,000) ordinary units issued by CPF VI, and

No further Class A Shares and Class B1 Shares shall be issued thereafter.
iii) "Class B2 Shares" entitling their holders to any proceed, capital gain or other income deriving from investments

made by the Company in a Pool of Assets consisting of the ordinary units issued by CPF VI. The Class B2 Shares shall be
restricted to Connected Persons.

The Board of Directors may decide to issue, in accordance with Article 7 hereof and the provisions of the Memo-

randum, an unlimited number of Class B2 Shares, without reserving to the existing Shareholders a preferential right to
subscribe for the Class B2 Shares to be issued.

Art. 6. Shares. Shares are exclusively restricted to Eligible Investors within the meaning of article 2 of the Law of 15

June 2004, the Class B2 Shares being further restricted to Connected Persons.

The Shares of any Class of Shares are in registered form and may not be converted into Shares in bearer form.
The Register will be kept at the registered office or with the registrar and transfer agent of the Company (as disclosed

in the Memorandum), where it will be available for inspection by any Shareholder. This Register will in particular contain
the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of Shares held by such
shareholder, the indication of the payments made on the Shares, any transfers of shares and the dates thereof pursuant
to following paragraph as well as any security rights granted on Shares.

Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which the notices

and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders. In the event a
Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register
of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such
other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided to
the Company by such Shareholder. A Shareholder may at any time change his/her/its address as entered in the register
of Shareholders by means of written notification to the Company at its registered office or at such other address as may
be set by the Company from time to time.

The Company will recognize only one holder per Share; in case a Share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the Share will have to appoint one sole proxy to represent the Share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been designated
as the sole owner in relation to the Company.

Fractional Shares may be issued up to three decimal places and shall carry rights in proportion to the fraction of a

Share they represent but shall carry no voting rights except to the extent their number is so that they represent a whole
Share in which case they confer a voting right.

Each Share grants the right to one vote at every meeting of Shareholders and at the meetings of Shareholders holding

Shares of the same Class of Shares.

Art. 7. Issue of Class B2 Shares. Class B2 Shares shall be proposed to Connected Persons on one or more dates or

periods as determined by the Board of Directors, without reserving the existing Shareholders a preferential right to

27989

subscribe for the Class B2 Shares to be issued. Such date(s) or period(s) shall be communicated to the Connected Persons
by prior written notice sent 10 Business Days before the relevant date(s) or period(s).

Class B2 Shares will be issued at a price of one Euro (€ 1) per Share.
Payments for subscriptions to Class B2 Shares shall be made in whole or in part on dates and under the terms and

conditions determined by the Board of Directors, as indicated and more fully described in the Memorandum.

The Board of Directors may determine any other subscription conditions such as minimum subscriptions, default

interests or restrictions on ownership. Such other conditions shall be disclosed and detailed in the Memorandum and in
the subscription agreement.

The Board of Directors may delegate to any Director, manager, officer or other duly authorized agent the power to

accept subscriptions, to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to allot them and record the
subscription in the Register.

The Company may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets, in

compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a special report from
the auditor of the Company and provided that such securities or other assets comply with the investment objectives and
strategy of the Company. All fees and costs linked to such contribution in kind shall be exclusively assumed by such
contributor in kind.

Art. 8. Transfer of Shares. Shares may only be transferred, pledged or assigned with the written consent from the

Board of Directors whose consent shall not be unreasonably withheld. Any transfer or assignment of Shares is subject
to the purchaser or assignee thereof fully and completely assuming in writing, prior to the transfer or assignment, all
outstanding obligations of the seller or assignor under any shareholders or subscription agreements, as the case may be,
entered into by the seller or assignor, with respect to the assigned Shares.

The Board of Directors shall not accept any transfer of Shares to any transferee who may not be considered as an

Eligible Investor.

Any transfer of Shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording of

a declaration of transfer into the Register, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives,
or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any
director may record such transfer in the Register.

The Company, through any of its Directors, may also accept and enter into the Register any transfer referred to in

any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

The Company will not give effect to any transfer of Shares to any investor who may not be considered as an Eligible

Investor.

Art. 9. Redemption of Shares. The Company is a closed-ended investment company, which means that it shall not, at

the unilateral request of Shareholders, redeem its Shares of any Class of Shares.

The Company may however redeem Shares of whatever Class of Shares whenever the Board of Directors considers

a redemption to be in the best interests of the Company. Shares may be redeemed on a pro rata basis from all existing
Shareholders of the relevant Class of Shares as a way to proceed to distribution as more fully described in article 23.

The redemption price shall be equal to the latest available Net Asset Value per Share of the relevant Class of Shares.
The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines, to satisfy in kind the payment of the

redemption price to any Shareholder who agrees by allocating to such Shareholder investments from the portfolio of
assets of the Company equal to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred
in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other Share-
holders and the valuation used shall be confirmed by a special report of the Auditor. The costs of any such transfers shall
be borne by the transferee.

In addition thereto, Shares of a Shareholder may be redeemed compulsorily if (i) such Shareholder ceases to be, or is

found not to be, an Eligible Investor, or, more generally, (ii) following a transfer of Shares which has been made in breach
of the Articles.

In case of compulsory redemption, the Company shall pay to the Shareholders, whose Shares are so redeemed, a

purchase price for its Shares as follows: in the event such Shareholder has paid-up less than 50% of the price of the Shares
he has subscribed for, such Shareholder shall not be entitled to a compensation payment. In the event such Shareholder
has paid-up more than 50% of the price of the Shares he has subscribed for, such Shareholder shall be entitled to a
compensation payment in the lower of:

- 50 % of the payments contributed to the Company;
-  50  %  of  the  book  value  of  the  capital  account  of  the  Shareholder  determined  in  accordance  with  Luxembourg

accounting principles as per the date of compulsory redemption, provided however, that such amount shall not exceed
50% of the fair market value of such Shares.

Unless mutually agreed, the fair market value shall be determined by the Board of Directors. Such valuation is subject

to arbitration.

27990

The purchase price shall be payable in instalments on the same dates on which distributions are made by the Company.

Each instalment shall equal to the amount of distributions such Shareholder would be entitled to if his Shares had not
been compulsorily redeemed. The purchase price shall not bear interest.

Art. 10. Determination of the Net Asset Value. The Net Asset Value will be determined by the Company in Euro,

which shall be the Reference Currency of the Company, under the responsibility of the Board of Directors as of the
Valuation Date.

The Net Asset Value of the Company is equal to the difference between the value of its gross assets and its liabilities.
The value of the assets of the Company, which shall be based on their fair value, shall be determined as follows:
- Investments in CPF VI shall be valued on the basis of the last determined and available net asset value of the same as

determined by CPF VI;

- The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof;

- Any transferable security and any money market instrument negotiated or listed on a stock exchange or any other

organized market will be valued on the basis of the last known price;

- Investments in private equity securities other than the securities mentioned above will be valued by the Board of

Directors which will take into account the updated guidelines and principles for valuation of portfolio companies set out
by the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA);

- The value of any other assets of the Company will be determined on the basis of the acquisition price thereof including

all costs, fees and expenses connected with such acquisition.

The Board of Directors, in its sole discretion, may permit other methods of valuation to be used if it considers on a

consistent basis that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

The Net Asset Value per Class of Shares as of any Valuation Date will be made available to the Shareholders at the

registered office of the Company within hundred (100) calendar days following the relevant Valuation Date.

<i>Allocations of the assets of the Company

Specific Pools of Assets shall be established as follows in the accounts of the Company:
a) The proceeds to be received from the issue of Shares of different Classes of Shares (as allocated to a Pool of Assets)

shall be applied in the books of the Company to the Pool of Assets and, as the case may be, the assets and liabilities and
income and expenditure attributable to such Pool of Assets shall be applied to the corresponding Pool of Assets subject
to the following provisions of this article;

b) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company

to the same Pool of Assets as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or
diminution in value shall be applied to the relevant Pool of Assets;

c) Where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Pool of Assets or to any action taken

in connection with an asset of a particular Pool of Assets, such liability shall be allocated to the relevant Pool of Assets,
provided that all liabilities whatever pool are attributable to, will be binding upon the Company as a whole vis-a-vis third
party;

d) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular

Pool of Assets, such asset or liability shall be allocated to all the Pools of Assets pro rata to the net asset values of the
relevant Pools of Assets.

Assets and liabilities not yet allocated to a Pool of Assets shall be accounted for separately.

<i>Net Asset Value per Class of Shares and Net Asset Value per Share

The Net Asset Value of each Class of Share shall be that proportion of the aggregate Net Asset Value of the Company

that such Class of Shares would receive if the assets of the Pool of Assets were realised at the value reflected in the Net
Asset Value of the Pool of Assets and distributed to the Class of Shares in accordance with the section "Distribution
Policy". The Net Asset Value per Share of each Class of Shares shall be the Net Asset Value of the Class of Shares as
determined in accordance with the foregoing provisions of this section divided by the number of Shares of the Class of
Shares and rounding the resulting sum to the nearest cent of a Euro.

Art. 11. Suspension of the Determination of the Net Asset Value. The Board of Directors may suspend the determi-

nation of the Net Asset Value during:

a) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or accurate valuation

of a substantial portion of the assets owned by the Company attributable to a Pool of Assets would be impracticable; or

b) any breakdown in the means of information normally employed in determining the price or value of any of the

investments attributable to a Pool of Assets or current stock exchange or market price in respect of the assets attributable
to any Pool of Assets; or

27991

c) the suspension of the net asset value of CPF VI or any other investment vehicle in which the Company has made

an investment.

Any Shareholder having asked to be informed of the Net Asset Value will be informed of any such suspension if, in the

opinion of the Board of Directors, it is likely to exceed eight days.

Art. 12. Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members,

who need not to be Shareholders of the Company. The Directors may be either of class A or class B.

They shall be elected for a term not exceeding six years. The Directors shall be elected by the Shareholders at a

general meeting of Shareholders which shall further determine the number of Directors, their class, their remuneration
and the term of their office.

Any Director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general

meeting.

In the event of a vacancy in the office of a Director, the remaining Directors may temporarily fill such vacancy; the

Shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.

Art. 13. Board Meetings. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman. It may choose a

secretary, who needs not be a Director, who shall write and keep the minutes of the meetings of the Board of Directors
and of the Shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, at the place
indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at the meetings of the Directors. In his absence, the board members shall decide by a

majority vote that another Director shall be in the chair of such meetings.

The Board of Directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as

well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the Board of Directors. The officers need not be Directors or Shareholders
of the Company. Unless otherwise provided for by the present Articles, the officers shall have the rights and duties
conferred upon them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours prior

to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax,
electronic mails or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held
at times and places fixed in a resolution adopted by the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax, electronic mails or any

other similar means of communication another Director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues.

Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-

nications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if half of the Directors are present or represented at a meeting

of the Board of Directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented at such meeting except for Special

Resolutions which require the vote of at least one class A Director.

The Special Resolutions are (a) any resolutions related to liabilities, either contractual or not, which imply (i) recurring

annual expenses of an amount superior to one thousand euros (EUR 1,000), (ii) a notice period of more than one month,
or (iii) a fixed term of more than three months, (b) any resolutions related to any other expenses of an amount superior
to one thousand euros (EUR 1,000), as well as (c) any resolutions related to (i) any kind of investments, divestments and
corporate restructurings, (ii) capital calls and distributions, (iii) issuance of shares and (iv) transfer of shares.

In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting

does not have a casting vote.

The Board of Directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the Board of Directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of an original signature by mail,
facsimile  or  any  other  means  of  communication  being  sufficient  proof  thereof.  The  single  document  showing  all  the
signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the
passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or by any

two Directors. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly
signed by the chairman of the meeting or any two Directors.

27992

Art. 14. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition within the purpose of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of Shareholders are in the

competence of the Board of Directors.

Art. 15. Signatory Authority. The Company will be bound by the joint signatures of any two Directors, provided that

these two signatures include the signature of at least one class A Director for all matters related to the Special Resolutions,
or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors.

Art. 16. Conflict of Interests.  Save  as  otherwise  provided  by  law,  any  Director  who  has,  directly  or  indirectly,  a

proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the Board of Directors which conflicts with the Com-
pany's interest, must inform the Board of Directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration
recorded in the minutes of the board meeting.

The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction.
Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of Shareholders prior to taking any reso-

lution on any other item.

Where the Company has a sole Director and the sole Director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a

transaction entered into between the sole Director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such
conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

Art. 17. Indemnification of Directors. The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its
request, of any other company of which the Company is a Shareholder or a creditor and from which he is not entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 18. General Meeting of Shareholders. The general meeting of Shareholders shall represent all the Shareholders

of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the Shareholders of the Company. It shall have the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

General meetings of Shareholders shall be convened by the Board of Directors.
It may also be called upon the request of Shareholders representing at least 10% of the Share capital.
The annual general meeting shall be held on the fourth Wednesday of the month of June, at 2 p.m at the registered

office or at a place in the district of Luxembourg specified in the notice of meeting. If such day is not a Business Day, the
annual general meeting shall be held on the next following Business Day.

Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of

meeting.

General meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered

letter at least eight (8) days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address recorded in the register
of registered Shares. The giving of such notice to registered Shareholders need not be justified to the meeting. The agenda
shall be prepared by the Board of Directors except in the instance where the meeting is called on the written demand
of the Shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.

If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, general meetings may take place without notice of meeting.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to attend

any meeting of Shareholders.

The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each Share of whatever Class of Shares is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and the present

Articles.

A  Shareholder  may  act  at  any  general  meeting  by  giving  a  written  proxy  to  another  person,  who  need  not  be  a

Shareholder and who may be a Director of the Company.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote

of the Shareholders present or represented.

Any resolution of a meeting of Shareholders to the effect of amending the present Articles must be passed with (i) a

presence quorum of fifty (50) percent of the Share capital and if such a quorum is not obtained at a first meeting there
shall be no quorum requirement at the adjourned meeting and (ii) the approval of a majority of at least two-thirds (2./3)

27993

of the votes validly cast at the meeting, which shall not include the votes attached to Shares in respect of which the
Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Notwithstanding the paragraph above, any resolution of a meeting of Shareholders to the effect of rejecting the SICAR

status pursuant to the Law of 15 June 2004 shall be passed with the unanimous approval of all Shareholders.

Art. 19. Depositary. The Company will enter into a depositary agreement with a Luxembourg bank (the "Depositary")

which meets the requirements of the Law of 15 June 2004.

In compliance with usual bank practices, the Depositary may under its responsibility and in good faith, entrust part or

all of the assets that are placed under its custody to other banking institutions or financial intermediaries.

The Company's securities, cash and other permitted assets will be held in custody by or in the name of the Depositary

under its responsibility, which will fulfil the obligations and duties provided for by the Law of 15 June 2004.

If the Depositary desires to withdraw, the Company shall use its best efforts to find a successor Depositary within

two months of the effectiveness of such withdrawal. Until the Depositary is replaced, which must happen within such
period of two months, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests of the
Shareholders of the Company.

The Company may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until

a successor depositary shall have been appointed to act in the place thereof.

The duties of the Depositary shall respectively cease:
a) in the case of voluntary withdrawal of the Depositary or of its removal by the Company; until it is replaced, which

must happen within two months, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests
of the Shareholders of the Company;

b) where the Depositary or the Company have been declared bankrupt, have entered into a composition with credi-

tors, have obtained a suspension of payment, have been put under court controlled management or have been the subject
of a similar proceedings or have been put into liquidation;

c) where the Luxembourg Supervisory Authority withdraws its authorization of the Company or the Depositary;
d) in case of rejection of the SICAR status by the Shareholders.

Art. 20. Auditor. The Company shall appoint an Auditor, chosen from the list of Réviseurs d'Entreprises Indépendants

the appointment of which shall be approved by the Commission for the Supervision of the Financial Sector ("CSSF"). The
Auditor shall be entrusted with the revision of the Company's annual accounts. The Auditor's report and its qualifications,
if any, are set out in full in each annual report.

The Auditor shall, among other duties, promptly notify the CSSF of any fact or decision of which the Auditor has

become aware while carrying out the audit of the accounting information contained in the annual report of the Company
or any other legal issue concerning the Company, where such fact or decision is liable to constitute a material breach of
the Law of 15 June 2004 or the regulations adopted for its execution, or affect the continuous functioning of the Company,
or lead to a refusal to certify the accounts or to the expression of reservations thereon.

The Auditor has extensive duties to inform and notify the CSSF which may require the Auditor to exercise control

over one or several particular aspects of the activities and operations of the Company.

Art. 21. Fiscal Year. The fiscal year of the Company shall start from the first day of January of each year and end on

the last day of December of the same year.

Art. 22. Annual Report. The Company shall publish one annual report within a period of six (6) months as of the end

of the fiscal year concerned.

Art. 23. Distributions. The proceeds arising from investments made by the Company and any other income in each

Pool of Assets will be allocated and paid in the relevant Pool of Assets pro rata the number of Shares of the relevant
Class of Shares held by each Shareholder.

The Board of Directors reserves the right, but not the obligation, to declare annual or other interim distributions to

the Shareholders resulting from the Company's investment income gains and realized capital gains and, if considered
necessary to maintain a reasonable level of dividends, out of any other funds available for distribution. To the extent that
the Company distributes cash or immediately available funds to Shareholders as a return of capital, such Shareholders'
Net Asset Value basis shall be reduced by a like amount.

The Company shall not proceed to distributions, either by way of distribution of dividends or redemption of Shares,

in the event the net assets of the Company, after such distribution, would fall below the minimum of one million Euro (€
1,000,000), required under the Law of 15 June 2004.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and reverted to the

Company.

27994

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of

10 August 1915 on commercial companies and the Law of 15 June 2004.

There being no further business, the meeting is there upon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the German texts, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the date named

at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary this

original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes

Im Jahr zweitausendundacht, am dritten Tag des Monats Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft Seneca Pool S.A. (das "Unterneh-

men"), mit Sitz in L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll, abgehalten. Das Unternehmen wurde am 19. Februar
2008 gemäß einer durch den unterzeichnenden Notar aufgenommenen Urkunde gegründet und ist im luxemburger Han-
dels- und Firmenregister unter der Nummer B 137.358 eingetragen. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 991 vom 22. April 2008 veröffentlicht.

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Nicolas Goulet, Anwalt, mit Berufsanschrift in Luxemburg,

eröffnet,

welcher Fräulein Anita Maggipinto, Privatbeamte, mit Berufsanschrift in Luxemburg, zum Protokollführer ernennt.
Die Versammlung wählte Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in Luxemburg, als Wahlprüfer.
Nachdem das Sitzungspräsidium konstituiert ist, erklärt der Vorsitzende und bat den unterzeichnenden Notar fest-

zustellen dass:

- alle anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber mit der Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien in eine Anwe-

senheitsliste, die dem Protokoll beigefügt bleibt, eingetragen werden und diese ordnungsmäßig von den anwesenden
Aktieninhaber, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktieninhaber und dem Präsidium der Sitzung unterschrieben wer-
den;

- alle Aktieninhaber, die auf der Anwesenheitsliste vermerkt sind, auch anwesend oder vertreten sind und erklären,

dass sie im Voraus über die Tagesordnung der Sitzung informiert worden waren und auf alle Einberafungsschreiben und
Formsachen verzichten;

- damit die laufende Sitzung ordnungsmäßig zusammengetreten, in der Lage und befugt ist, über die folgende Tages-

ordnung zu beraten:

<i>Tagesordnung

1. Annahme des Status einer SICAR und der anschließenden Änderung des Artikels 4 der Gesellschafter-Satzung des

Unternehmens (Zweck der Körperschaft);

2. Umwandlung des gebundenen Aktienkapitals des Unternehmens in variables Aktienkapital, das jeder Zeit dem Netto-

Gesamtvermögen des Unternehmens, das in Aktien ohne Nennwert unterteilt ist, an Wert gleich ist;

3. Schaffung einer zusätzlichen Klasse von Aktien innerhalb des Aktienkapitals des Unternehmens, die mit bestimmten

Zuteilungsrechten ausgestattet ist, nämlich der Aktien der Klasse B2 („Aktien der Klasse B2");

4. Änderungen der Entscheidungsverfahren im Direktorium des Unternehmens;
5. Annahme des Rücktritts der gesetzlichen Wirtschaftsprüfer, ihre Entlastung und Ernennung eines unabhängigen

Wirtschaftsprüfers;

und anschließend
6. Vollständige Neufassung der Gesellschafter-Satzung des Unternehmens.
Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktieninhaber faßt nach eingehenden Erörterungen einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Über die mündliche Zulassung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier vom 14. August 2008 hinaus

beschließt die außerordentliche Hauptversammlung der Aktieninhaber, dass das Unternehmen von nun an Form und
Status einer SICAR nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 mit Bezug auf die société d'investissement en capital à risque in
der jeweils geltenden Fassung annimmt und folglich den Artikel 4 der Gesellschafter-Satzung des Unternehmens (Zweck
der Körperschaft) ändert, der von nun an wie folgt lautet:

„Der Zweck des Unternehmens ist die Investition der hierfür verfügbaren Geldmittel in Risikokapital in seiner nach

dem Gesetz vom 15. Juni 2004 weitest gehenden Bedeutung.

27995

Das Unternehmen kann die dafür verfügbaren Geldmittel auch in jeden anderen Vermögenswert investieren, so weit

dies vom Gesetz erlaubt ist und mit seinem Zweck übereinstimmt.

Des Weiteren kann das Unternehmen alle Maßnahmen ergreifen und alle Transaktionen durchführen, die es für die

Erfüllung und Förderung seines Zweckes als nützlich erachtet, und dies im vollsten unter dem Gesetz vom 15. Juni 2004
erlaubten Umfang."

<i>Zweiter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt das gebundene Aktienkapital des Unternehmens in variables Ak-

tienkapital in gleiche Höhe wie das Netto-Gesamtvermögen des Unternehmens umzuwandeln und es in Aktien ohne
Nennwert zu unterteilen.

<i>Dritter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt eine zusätzliche Klasse von Aktien innerhalb des Unternehmens

zu schaffen, nämlich die Aktien der Klasse B2, die ihre Inhaber zu allen Gewinnen, Kapitalerträgen oder anderen Einkünften
berechtigt, die auf Investitionen beruhen, die das Unternehmen in einen Fonds tätigen wird, der sich aus regulären Stücken
des Unternehmens Cipio Partners Fund VI S.C.S., SICAR, zusammensetzt, eines Unternehmen, das als société en com-
mandite simple gegründet wird und die Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Juni 2004 erfüllt.

<i>Vierter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt das Entscheidungsverfahren im Direktorium des Unternehmens

dahingehend zu ändern, dass für eine Zustimmung die Stimme von mindestens einem Direktor der Klasse A erforderlich
ist und zwar (a) bei allen Beschlüssen, die sich auf Verbindlichkeiten beziehen, ob sie nun vertraglicher Art sind oder nicht,
und die (i) jährlich wiederkehrende Kosten von über eintausend Euro (EUR 1.000) mit (ii) einer Kündigungsfrist von mehr
als einem Monat oder (iii) mit einer Festlaufzeit von über drei Monaten betreffen; (b) bei allen Beschlüssen, die sich auf
andere Kosten beziehen, die einen Betrag von eintausend Euro (EUR 1.000) übersteigen, und (c) bei allen Beschlüssen,
die sich (i) auf jede Art von Investition, Desinvestition und Umstrukturierung der Gesellschaft (ii) auf Kapital-Einzah-
lungsaufforderungen und Ausschüttungen, (iii) auf die Emission von Aktien und (iv) auf die Übertragung von Aktien (alle
zusammen „SpezialBeschlüsse") beziehen.

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt des Weiteren dass das Unternehmen, durch die gemeinsamen

Unterschriften von zwei Direktoren gebunden ist, vorausgesetzt in allen Angelegenheiten, die sich auf SpezialBeschlüsse
beziehen, ist wenigstens eine der beiden Unterschriften die eines Klasse A Direktors, oder durch die alleinige Unterschrift
einer jeden Person, der die Unterzeichnungsvollmacht vom Direktorium des Unternehmens noch übertragen werden
könnte.

<i>Fünfter Beschluss

Als Folge der Annahme des SICAR-Status für das Unternehmen und in Übereinstimmung mit dem ersten Beschluss

beschließt die außerordentliche Hauptversammlung, (i) den Rücktritt der gesetzlichen Wirtschaftsprüfer des Unterneh-
mens mit Wirkung vom 3. Dezember 2008 anzunehmen und ihnen Entlastung zu erteilen für ihre Dienstleistungen, die
sie als gesetzliche, die sie als gesetzliche Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bis zur gegenwärtigen, außerordentlichen
Hauptversammlung erbracht haben, und (ii) Ernst und Young S.A. mit gemeldetem Sitz in 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365
Luxembourg als unabhängigen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für einen Zeitraum zu berufen, der mit der Jahres-
hauptversammlung  der  Aktieninhaber  des  Unternehmens  zur  Billigung  der  Gewinn-  und  Verlustrechnungen  vom  31.
Dezember 2009 abläuft.

<i>Sechster Beschluss

Als eine Konsequenz aus den obigen Beschlüssen beschloss die außerordentliche Hauptversammlung, die gesamte

Gesellschafter-Satzung des Unternehmens neu zu formulieren, und zwar wie folgt:

I - Definitionen

„Artikel"

Artikel der Gesellschafter-Satzung des Unternehmens.

„Auditor"

Bezieht sich auf den Réviseur d'Entreprise Agréé, der für die Durchführung
der in Artikel 20 aufgeführten Revisions- und Aufsichtsfunktionen
verantwortlich ist.

„Direktorium"

Das Direktorium des Unternehmens.

„Geschäftstag"

Ein Tag, an dem in Luxemburg Banken für Geschäfte im Allgemeinen
geöffnet haben.

„Cipio Partner" oder „Cipio"

Bezieht sich, ohne dass eine bestimmte Entität genannt wird, auf einen
Teil der Cipio Partners Unternehmensgruppe. Cipio Partners besteht aus
mehreren Einheiten mit unterschiedlichen Rollen, Funktionen und
Verantwortlichkeiten. Auf „Cipio Partners" kann sich auch die Bezeichnung
„Cipio" beziehen.

27996

„Klasse von Aktien"

Jede Klasse von Aktien innerhalb des Unternehmens, die sich auf einen
Vermögens-Fonds beziehen.

„Aktien der Klasse A"

Eine Klasse von Aktien, die sich auf einen speziellen Vermögens-Fonds
beziehen, der sich aus Aktien der Cipio Partners S.à r.l., zusammensetzt,
eines Unternehmens, das am 27. Juli 2007 nach Luxemburgischem Recht
als eine société à responsabilité limitée (S.à r.l.) gegründet und im
Unternehmens- und Handelsregister Luxemburgs unter Nummer B 131 444
gemeldet worden ist, und das als Komplementär von CPF VI handelt.

"Aktien der Klasse Bl"

Eine Klasse von Aktien, die sich auf einen speziellen Vermögens-Fonds
beziehen, der sich aus einem vorzugsberechtigten Stück und bis zu 1.000.000
(einer Million) gewöhnlichen Stücken der von CPF VI herausgegebenen Aktie
zusammensetzt.

„Aktien der Klasse B2"

Eine Klasse von Aktien, die sich auf einen speziellen Vermögens-Fonds beziehen,
der sich aus gewöhnlichen Stücken der von CPF VI herausgegebenen Aktie
zusammensetzt.

„das Unternehmen"

Seneca Pool S.A., SICAR ist als eine société anonyme organisiert und als eine
société d'investissement en capital-à risque in Luxemburg gemeldet.

„Verbundene Personen"

Angestellte Repräsentanten von Cipio Partners und andere Personen, die das
Direktorium als Inhaber aller Klassen von Aktien bestätigt hat. Verbundene
Personen müssen als diskontfähige Investoren ausgewiesen sein.

„CPF VI"

Cipio Partner Fund VI S.C.S., SICAR, eine Gesellschaft, die als société en
commandite simple gegründet wird und die Voraussetzungen der société
d'investissement en capital à risque im Sinne von Artikel 1 des Gesetzes vom
15. Juni 2004 erfüllt.

„Direktoren"

Die Direktoren des Unternehmens.

"Diskontfähige Investoren"

Institutionelle, professionelle oder gut informierte Investoren im Sinne von Artikel
2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 und jeder andere Investor, der nicht im Sinne
des Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 als institutioneller, professioneller
oder gut informierter Investor ausgezeichnet ist.

„Institutionelle Investoren"

Investoren, die sich nach Recht und Vorschriften Luxemburgs als institutionelle
Investoren erweisen.

„Gesetz vom 15. Juni 2004"

Das Gesetz vom 15. Juni 2004 mit Bezug auf die société d'investissement en
capital à risque (SICAR) in der jeweils geltenden Fassung.

„Mitteilung"

Die Platzierungs-Mitteilung des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit geändert wird.

„Netto-Vermögenswert"

Der Netto-Vermögenswert pro Anteil einer entsprechenden Klasse von Aktien
innerhalb eines entsprechenden Vermögens-Fonds, wie er nach Artikel 10 im
Folgenden definiert wird.

„Vermögens-Fonds"

Ein Portefeuille, das alle Vermögenswerte enthält, die im Zusammenhang mit

einem bestimmten Investitionsprogramm oder direkt oder indirekt daraus
abgeleiteterworben worden sind, ebenso alle Verbindlichkeiten, die sich
direkt oder indirekt aus einem solchen Investitions-Programm herleiten.

„Professionelle Investoren"

Investoren, die sich als professionnelle Investoren nach Anhang II der Richtlinie
2004/39/EC über Märkte in Finanzinstrumenten.

„Referenz-Währung"

Der Euro, die Währung der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen
Union.

„Register"

Das Aktien-Verzeichnis nach Artikel 6 des Folgenden.

„Shareholder"

Ein Inhaber von Aktien.

„Shares"

Vom Unternehmen herausgegebene Aktien.

„Spezial-Beschlüsse"

Jeder Beschluss nach Artikel 13 der Gesellschafter-Satzung, welcher die
Zustimmung eines Direktors der Klasse A benötigt.

„Bewertungs-Datum"

Der 31. Dezember eines jeden Jahres und diejenigen anderen Tage, die von Zeit
zu Zeit vom Direktorium festgesetzt werden können.

„Gut informierte Investoren"

Ein Investor, der (i) sich schriftlich an den Status des wohlunterrichteten Investoren
anschließt und (ii) ein Minimum von EUR 125.000 ins Unternehmen investiert oder
sich eines Zertifikats von einer Kreditinstitution bedient, ein anderer Experte des
Finanzsektors im Sinne der Richtlinie 2006/48/CE, ein Investment-Unternehmen im
Sinne der Richtline 2004/39/CE oder ein Managementunternehmen im Sinne der
Richtlinie 2001/107/CE ist, jemand, der von sich behaupten kann, erfahren genug
zu sein, in angemessener Weise den Wert einer Investition in Risikokapital

27997

einschätzen zu können.

II - Gesellschafter - Satzung

Art. 1. Name. Hiermit wird von den Zeichnern und allen denjenigen, die hernach Inhaber von Aktien dieses Unter-

nehmens werden könnten, ein Unternehmen in Form einer société anonyme (S.A.) mit variablem Kapital gegründet, das
sich als eine société d'investissement en capital à risque (SICAR) mit Namen "Seneca Pool S.A., SICAR" ausweist, (das
„Unternehmen").

Das Unternehmen wird nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 geführt werden.

Art. 2. Gemeldete Geschäftsstelle. Die gemeldete Geschäftsstelle des Unternehmens wird in der Stadt Luxemburg,

des Großherzogtums Luxemburg eingerichtet. Sie kann in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg auf-
grund eines Beschlusses der Hauptversammlung der Aktieninhaber verlegt werden, der entsprechend der Ausführungen
über die Änderung der Gesellschafter-Satzung angenommen worden ist. Innerhalb des gleichen Stadtbezirks kann die
gemeldete Geschäftsstelle durch einfachen Beschluss des Direktoriums verlegt werden.

Zweigstellen, Niederlassungen oder andere Büros können aufgrund einer Entscheidung des Direktoriums im Groß-

herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Dauer. Das Unternehmen wird auf unbegrenzte Dauer gegründet. Allerdings kann es jederzeit aufgrund eines

Beschlusses der Hauptversammlung der Aktieninhaber mit einer beschlussfähigen Mehrheit, wie sie für die Änderung der
Artikel erforderlich ist, aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck. Der Zweck des Unternehmens ist die Investition der hierfür verfügbaren Geldmittel in Risikokapital in

seiner nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 weitest gehenden Bedeutung.

Das Unternehmen kann die dafür verfügbaren Geldmittel auch in jeden anderen Vermögenswert investieren, so weit

dies vom Gesetz erlaubt ist und mit seinem Zweck übereinstimmt.

Des Weiteren kann das Unternehmen alle Maßnahmen ergreifen und alle Transaktionen durchführen, die es für die

Erfüllung und Förderung seines Zweckes als nützlich erachtet, und dies im vollsten unter dem Gesetz vom 15. Juni 2004
erlaubten Umfang."

Art. 5. Aktien - Kapital. Das Aktienkapital des Unternehmens ist variabel und soll jeder Zeit wertgleich mit dem Netto-

Gesamtvermögen des Unternehmens entsprechend Artikel 10 dieser Satzung sein. Das gezeichnete Mindestkapital des
Unternehmens, erhöht durch die Emissionsprämie, muss innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem Datum der Zulas-
sung des Unternehmens als eine société d'investissement en capital à risque (SICAR) nach Luxemburgischem Recht eine
Million Euro (EUR 1.000.000) betragen.

Das Aktienkapital des Unternehmens wird repräsentiert durch:
i) 31.000 „Aktien der Klasse A" berechtigen ihre Inhaber zu allen Gewinnen, Kapitalerträgen oder anderen Einkünften

aus Investitionen, die das Unternehmen bei Cipio Partners S.à r.l. getätigt hat, einem Unternehmen, das am 27. Juli 2007
nach Luxemburgischem Recht als société à responsabilité limitée (S.à r.l.) gegründet und im Unternehmens- und Han-
delsregister Luxemburgs unter der Nummer B 131.444 eingetragen worden ist,

ii) 1.000.001 „Aktien der Klasse Bl" berechtigen ihre Inhaber zu allen Gewinnen, Kapitalerträgen oder anderen Ein-

künften aus Investitionen, die das Unternehmen in einen Vermögens-Fonds getätigt hat, der sich aus vorzugsberechtigten
wie auch aus bis zu einer Million (1.000.000) gewöhnlichen Stücken der von CPF VI herausgegebenen Aktien zusammen-
setzt, und

Danach werden keine weiteren Aktien der Klasse A und Bl herausgegeben.
iii) Aktien der Klasse B2 berechtigen ihre Inhaber zu allen Gewinnen, Kapitalerträgen oder anderen Einkünften aus

Investitionen, die das Unternehmen in einen Anteile-Fonds getätigt hat, der sich aus gewöhnlichen Stücken der von CPF
VI herausgegebenen Aktien zusammensetzt. Die Aktien der Klassen-B2 sind den Verbundenen Personen vorbehalten.

Das Direktorium kann, in Übereinstimmung mit Artikel 7 dieser Satzung und den Bestimmungen der Mitteilung, be-

schließen, eine unbegrenzte Anzahl von Aktien der Klasse B2 herauszugeben, ohne den bisherigen Aktieninhabern ein
Vorkaufsrecht auf den Kauf der noch herauszugebenden Aktien der Klasse B2 einzuräumen.

Art. 6. Aktien. Aktien sind ausschließlich für diskontfähige Investoren im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 15.

Juni 2004 vorbehalten, die Aktien der Klasse B2 sind des Weiteren den Verbundenen Personen vorbehalten.

Die Aktien einer jeden Klasse des Unternehmens liegen in eingetragener Form vor und können nicht in Inhaber-Aktien

umgewandelt werden.

Das Register wird in der gemeldeten Geschäftsstelle oder beim Registrator und Übertragungsagenten des Unterneh-

mens (wie in der Mitteilung bekannt gegeben) hinterlegt, wo es jedem Aktieninhaber zur Einsichtnahme zur Verfügung
steht. Dieses Register wird insbesondere den Namen eines jeden Aktieinhabers, seinen/ihren Wohnsitz oder gemeldeten
Geschäfts- oder Hauptsitz, die Anzahl der Aktien im Besitz dieses Inhabers, den Beleg über die für die Aktien geleisteten
Zahlungen, über alle Übertragungen von Aktien mit Datum entsprechend dem nachfolgenden Paragraph so wie alle auf
die Aktien eingetragenen Besicherungsrechte enthalten.

27998

Aktieninhaber, die zum Empfang eingetragener Aktien berechtigt sind, werden dem Unternehmen eine Adresse an-

geben, an die Bekanntmachungen und Ankündigungen geschickt werden können. Auch diese Adresse wird ins Register
der Aktieninhaber eingetragen. Für den Fall, dass ein Aktieninhaber keine Adresse angibt, kann das Unternehmen einen
dahin gehenden Vermerk ins Register der Aktieninhaber aufnehmen lassen; als Anschrift des Aktieninhabers gilt dann der
gemeldete Geschäftssitz des Unternehmens oder eine andere Anschrift, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit einträgt,
bis dem Unternehmen von diesem Aktieninhaber eine andere Adresse mitgeteilt wird. Ein Aktieninhaber kann jederzeit
seine/ihre Anschrift im Register der Aktieninhaber aufgrund einer schriftlichen Benachrichtigung des Unternehmens an
dessen gemeldete Geschäftsstelle oder an eine andere Adresse, die vom Unternehmen von Zeit zu Zeit mitgeteilt wird,
ändern.

Das Unternehmen wird nur einen Inhaber pro Anteil anerkennen; für den Fall, dass ein Anteil sich im Besitz mehrerer

Person befindet, müssen die Personen mit Anspruch auf den Besitz des Anteils einen alleinigen Bevollmächtigten benennen,
der den Anteil dem Unternehmen gegenüber repräsentiert. Das Unternehmen ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte,
die mit einem solchen Anteil verbunden sind, auszusetzen, bis eine Person als der einzige Inhaber im Verhältnis zum
Unternehmen benannt worden ist.

Bis auf drei Dezimalstellen gestückelte Aktien können ausgegeben werden und sind mit den Rechten im Verhältnis zum

Bruchteil des Anteils, den sie repräsentieren, ausgestattet, doch erhalten sie kein Stimmrecht, es sei denn, ihre Anzahl ist
derart, dass sie einen ganzen Anteil repräsentieren; in diesem Fall beinhalten sie ein Stimmrecht.

Jeder Anteil entspricht einer Stimme bei einem jeden Treffen der Aktieninhaber und einem Treffen der Inhaber von

Aktien der gleichen Klasse.

Art. 7. Ausgabe von Aktien der Klasse B2. Aktien der Klasse B2 werden den Verbundenen Personen zu einem oder

mehren Terminen oder Zeiträumen, die das Direktorium festlegt, angeboten, ohne den bereits vorhandenen Aktienin-
haber ein Vorkaufsrecht zur Zeichnung der zur Ausgabe anstehenden Aktien der Klasse B2 vorzubehalten. Die jeweiligen
Termine oder Zeiträume werden den Verbundenen Personen schriftlich, per Post und 10 Geschäftstage vor dem ent-
sprechenden jeweiligen Termin oder Zeitraum mitgeteilt.

Aktien der Klasse B2 werden zum Preis von einem Euro (EUR 1) pro Anteil ausgegeben.
Die Zahlungen für die Zeichnung von Aktien der Klasse B2 haben insgesamt oder zu Teilen an den Terminen und zu

den Bedingungen zu erfolgen, die das Direktorium festlegt und so, wie sie in der Mitteilung angegeben und ausführlicher
beschrieben werden.

Das Direktorium kann andere Zeichnungsbedingungen wie Mindestzeichnungsmengen, Zinsen bei Voreinstellung oder

Besitzbeschränkungen festlegen. Derartige Bedingungen werden bekannt gegeben und in der Mitteilung und im Zeich-
nungsabkommen ausführlich behandelt.

Das  Direktorium  kann  einen  Direktor,  Manager,  leitenden  Angestellten  oder  einen  anderen  rechtmäßig  befugten

Agenten bevollmächtigen, Zeichnungen anzunehmen, und Zahlungen auf den Preis der neu herauszugebenden Aktien
entgegenzunehmen, sie zuzuteilen und die Zeichnung in das Register einzutragen.

Das Unternehmen kann übereinkommen, Aktien als Gegenwert für einen Beitrag in Form von Wertpapieren oder

anderen Vermögenswerten auszugeben und zwar in Übereinstimmung mit den Bedingungen, die das Luxemburgische
Recht vorgibt, insbesondere mit der Verpflichtung, ein besonderes Gutachten vom Wirtschaftsprüfer des Unternehmens
einzureichen und vorausgesetzt, dass solche Wertpapiere oder andere Vermögenswerte den Investitionszielen und der
Strategie  des  Unternehmens  entsprechen.  Alle  Honorare  und  Kosten  in  Verbindung  mit  derartigen  Beiträgen  gehen
ausschließlich zu Lasten dessen, der einen solchen Beitrag leistet.

Art. 8. Übertragung von Aktien. Aktien können nur mit der schriftlichen Zustimmung des Direktoriums übertragen,

beliehen oder abgetreten werden; dessen Einverständnis soll nicht unangemessen verweigert werden. Bei jeder Über-
tragung  oder  Abtretung  von  Aktien  verpflichtet  sich  der  entsprechende  Käufer  oder  sein  Bevollmächtigter  vor  der
Übertragung oder Abtretung in schriftlicher Form, in alle noch offenen Verpflichtungen des Verkäufers oder Abtretenden
nach allen Vereinbarungen, die gegebenenfalls den Aktieninhaber oder die Zeichnung betreffen und die vom Verkäufer
oder Abtretenden der entsprechenden Aktien eingegangen waren, einzutreten.

Das Direktorium wird keine Übertragung von Aktien auf irgendeinen Übernehmenden akzeptieren, der nicht als dis-

kontfähiger Investor gelten darf.

Eine Übertragung von Aktien wird gegenüber dem Unternehmen und Dritten wirksam entweder durch den Eintrag

einer Übertragungserklärung ins Register, die von dem Abtretenden und dem Übernehmenden oder ihren Vertretern
mit Datum unterschrieben ist, oder aufgrund einer Bekanntgabe der Übertragung mit oder nach der Annahme der Über-
tragung durch das Unternehmen, der entsprechend jeder Direktor die Übertragung in das Register eintragen kann.

Das Unternehmen kann durch jeden seiner Direktoren auch jede Übertragung, auf die in einem Schreiben oder einem

sonstigen Dokument Bezug genommen wird und die das Einverständnis des Abtretenden und Übernehmenden bestätigt,
akzeptieren und in das Register eintragen.

Das Unternehmen wird keine Übertragung von Aktien an irgendeinen Investor wirksam werden lassen, der nicht als

diskontfähiger Investor gelten darf.

27999

Art. 9. Einlösung von Aktien. Das Unternehmen ist eine geschlossene Investmentgesellschaft; das bedeutet, dass sie

nicht aufgrund des einseitigen Antrags von Aktieninhabern deren Aktien einer beliebigen Klasse von Aktien einlösen wird.

Das Unternehmen kann allerdings Aktien jeder beliebigen Klasse von Aktien zurücknehmen, wenn immer das Direk-

torium  eine  Einlösung  für  im  besten  Interessen  des  Unternehmens  hält.  Aktien  können  anteilig  auf  Grundlage  aller
existierenden Aktieninhaber der entsprechenden Klasse von Aktien als eine Art Ausschüttungsvorgang eingelöst werden;
dieser wird in Artikel 23 ausführlicher beschrieben.

Der Rücknahme-Preis soll dem jüngsten verfügbaren Netto-Vermögenswert pro Anteil der entsprechenden Klasse

von Aktien gleichwertig sein.

Das Unternehmen soll, wenn es das Direktorium so entscheidet, das Recht haben, einem jeden Aktieninhaber den

Rücknahme-Preis  in  Sachleistungen  zu  erstatten,  wenn  dieser  zustimmt,  dass  seinem  entsprechenden  Aktieninhaber-
Investment Vermögenswerte aus dem Portefeuille des Unternehmens in einem Wert zugewiesen werden, der dem Wert
der zurückzukaufenden Aktien entspricht. Die Art und der Typus der Vermögenswerte, die in einem solchen Fall über-
tragen werden, sollte auf einer gerechten und sinnvollen Grundlage und ohne die Interessen der übrigen Aktieninhaber
zu beeinträchtigen, festgelegt werden, und die dabei angewendete Wertbestimmung soll durch einen besonderen Bericht
des Wirtschaftsprüfers bestätigt werden. Die Kosten aller solcher Übertragungen trägt der Erwerber.

Außerdem können Aktien eines Aktieninhabers zwangsweise verkauft werden, wenn (i) dieser Aktieninhaber aufhört

zu existieren, oder sich herausstellt, dass er kein diskontfähiger Investor ist, oder allgemeiner (ii) nach einer Übertragung
von Aktien, die unter Verletzung von Bestimmungen dieser Satzung durchgeführt worden ist.

Im Falle einer zwangsweisen Einlösung wird das Unternehmen an den Aktieninhaber, dessen Aktien auf diese Weise

zurückgenommen werden, einen Rückkaufs-Preis für seine/ihre Aktien wie folgt auszahlen: Für den Fall, dass dieser Ak-
tieninhaber weniger als 50 % des Preises der Aktien, für die er gezeichnet hat, einbezahlt hat, soll dieser Aktieninhaber
kein Recht auf eine Entschädigungszahlung haben. Für den Fall, dass ein solcher Aktieninhaber über 50 % des Preises der
Aktien, für die er gezeichnet hat, bezahlt hat, soll dieser Aktieninhaber ein Recht auf Entschädigungszahlung haben und
zwar von unter:

- 50% seiner Zahlungen an das Unternehmen;
- 50 % des Buchwertes des Kapitalkontos des Aktieninhabers in Übereinstimmung mit den Buchhaltungs-Prinzipien

Luxemburgs zum Zeitpunkt der zwangsweisen Einlösung, vorausgesetzt allerdings, dass dieser Betrag nicht 50% des Ver-
kehrswerts dieser Aktien überschreitet.

Wenn dies nicht im gegenseitigen Einvernehmen geschieht, dann soll der Verkehrswert vom Direktorium bestimmt

werden. Diese Wertbestimmung ist einem Schiedsverfahren ausgesetzt.

Der Kaufpreis wird in Raten zu den gleichen Terminen zahlbar, zu denen das Unternehmen Ausschüttungen vornimmt.

Jede Rate soll dem Betrag der Ausschüttung gleichkommen, zu der dieser Aktieninhaber berechtigt wäre, wenn seine
Aktien nicht zwangsweise verkauft worden wären. Der Rückkaufpreis soll nicht verzinst werden.

Art. 10. Bestimmung des Netto-Vermögenswertes. Der Netto-Vermögenswert wird vom Unternehmen und in der

Verantwortlichkeit des Direktoriums zum Termin der Wertbestimmung in Euro, der Referenz-Währung des Unterneh-
mens, bestimmt.

Der Netto-Vermögenswert des Unternehmens ist gleich der Differenz zwischen dem Wert seines Brutto-Vermögens

und dem seiner Verbindlichkeiten.

Der Wert der Vermögenswerte des Unternehmens soll auf ihrem Verkehrswert beruhen und folgendermaßen be-

stimmt werden:

- Investitionen in CPF VI sollen auf Grundlage der letzten von CPF VI festgestellten und verfügbaren Nettovermö-

genswerte derselben bewertet werden;

- Der Wert der gesamten Barbestände in der Kasse oder in Bareinlagen, in Form von offenen Rechnungen, von Sicht-

papieren  und  ausstehenden  a  Konto  Zahlungen,  von  vorausbezahlten  Ausgaben,  Bargelddividenden  und  Zinsen,  die
feststehen oder - wie vorstehend - anfallen und noch nicht eingegangen sind, sollen in ihrem vollen Betrag herangezogen
werden;

- Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse oder auf einem anderen organisierten

Markt gehandelt werden oder dort registriert sind, sollen aufgrund der jüngsten, bekannt gewordenen Preise bewertet
werden;

- Investitionen in Wertpapiere Privater Beteiligungsgesellschaften, die sich von den oben erwähnten Papieren unter-

scheiden, sind vom Direktorium zu bewerten, das dabei die aktualisierten Richtlinien und Prinzipien zur Bewertung der
Unternehmens-Portefeuilles, wie sie von der European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) heraus-
gegeben werden, zu berücksichtigen hat.

- Der Wert aller anderen Vermögenswerte des Unternehmens ist aufgrund ihres Erwerbspreises unter Einbeziehung

aller Kosten, Honorare und mit dem Erwerb verbundener Ausgaben zu bestimmen.

Das Direktorium kann nach alleinigem Ermessen andere Methoden zur Wertbestimmung zulassen, wenn es auf einer

widerspruchsfreien Grundlage zu der Ansicht gelangt, dass solche Wertbestimmungen den Verkehrswert irgendeines
Vermögensbestandteils des Unternehmens besser widerspiegeln

28000

Der Netto-Vermögenswert pro Aktienikiasse wird den Aktieninhabern jeweils ab Bewertungstermin am gemeldeten

Geschäftssitz  des  Unternehmens  innerhalb  von  einhundert  (100)  Kalender-Tagen  nach  dem  entsprechenden  Bewer-
tungstermin zur Verfügung gestellt.

<i>Zuweisungen der Vermögenswerte des Unternehmens

In den Büchern des Unternehmens werden bestimmte Vermögens-Fonds wie folgt eingerichtet:
a) Die Erlöse aus der Ausgabe von Aktien unterschiedlicher Klassen (wie sie dem Vermögenswerte-Fonds zugewiesen

wurden) werden in den Büchern des Unternehmen dem jeweiligen Vermögens-Fonds zugeordnet und gegebenenfalls
auch die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, die einem solchen Vermögens-Fonds nach den
folgenden Vorschriften dieses Artikels zuzuschreiben sind:

b) Wenn ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet wird, soll der derivative Wert in den

Büchern des Unternehmen dem gleichen Vermögens-Fonds zugeordnet werden wie der Vermögenswert, von dem er
abgeleitet worden ist, und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswertes soll die Wert-Steigerung oder -Minderung
dem entsprechenden Vermögens-Fonds zugerechnet werden;

c) Wenn das Unternehmen eine Verbindlichkeit eingeht, die sich auf einen Vermögenswert eines bestimmten Ver-

mögens-Fonds bezieht, oder auf irgendeine Maßnahme, die in Verbindung mit einem Vermögenswert eines bestimmten
Vermögens-Fonds getätigt wurde, soll eine solche Verbindlichkeit dem entsprechenden Vermögens-Fonds zugewiesen
werden; dabei ist vorausgesetzt, dass alle Verbindlichkeiten, welchem Fonds sie auch zuzuordnen sind, für das Unter-
nehmen als Ganzes gegenüber Dritten bindend sind;

d) Im Falle, dass sich herausstellt, dass ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit des Unternehmens sich nicht

einem besonderen Vermögens-Fonds zuordnen lässt, soll ein solcher Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit allen
Vermögens-Fonds anteilig, den Netto-Vermögenswerten der betreffenden Vermögens-Fonds entsprechend zugeordnet
werden.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die noch keinem Vermögens-Fonds zugeordnet sind, sind getrennt zu ver-

buchen.

<i>Netto-Vermögenswert pro Aktien-Klasse und Netto-Vermögenswert pro Anteil

Der Netto-Vermögenswert einer jeden Klasse von Aktien soll derjenige Anteil am Netto-Gesamtvermögen des Un-

ternehmens sein, den diese Klasse von Aktien erhalten würde, wenn die Vermögenswerte der Vermögens-Fonds zu dem
Wert veräußert würden, der sich im Netto-Vermögenswert der Vermögenswerte-Fonds niederschlägt und in Überein-
stimmung  mit  dem  Abschnitts  „Ausschüttungs-Richtlinien"  an  die  jeweilige  Klasse  von  Aktien  ausgeschüttet  werden
würde. Der Netto-Vermögenswert pro Anteil einer jeden Klasse von Antuen soll der Netto-Vermögenswert der Klasse
von Aktien sein soweit er in Übereinstimmung mit den vorangegangenen Vorschriften dieses Abschnitts festgesetzt und
durch die Anzahl der Aktien der Klasse von Aktien geteilt wurde; dabei ist der sich ergebende Betrag auf den nächsten
Euro-Cent abzurunden.

Art. 11. Aussetzen der Festlegung des Netto-Vermögenswertes. Das Direktorium kann die Bestimmung des Netto-

Vermögenswertes aussetzen während:

a) einer gegebenen Sachlage, die einen Notfall darstellt, als dessen Ergebnis die Veräußerung oder genaue Wertbe-

stimmung eines substanziellen Teiles der Vermögenswerte im Besitz des Unternehmens, die einem Vermögens-Fonds
zuzuordnen sind, undurchführbar wären; oder

b) eines Zusammenbruchs der Informations-Mittel, die üblicherweise dazu dienen, den Preis oder Wert eines Invest-

ments zu bestimmen, das einem Vermögens-Fonds zuzuordnen ist, oder einer laufenden Börse oder einem Kurswert
hinsichtlich der Vermögenswerte, die einem Vermögenswerte-Fonds zuzuordnen sind.

c)  der  Aussetzung  des  Netto-Vermögenswert  von  CPF  VI  oder  irgendeines  anderen  Investments,  in  welches  das

Unternehmen investiert hat.

Jeder Aktieninhaber, der darum gebeten hat, über den Netto-Vermögenswert informiert zu werden, ist über eine

solche Aussetzung zu informieren, wenn sie nach Ansicht des Direktoriums wahrscheinlich länger als acht Tage dauern
wird.

Art. 12. Direktoren. Das Unternehmen wird von einem Direktorium geführt, das aus nicht weniger als drei Mitgliedern

besteht, die keine Aktieninhaber des Unternehmens zu sein brauchen. Die Direktoren können entweder der Klasse A
oder der Klasse B zugehören.

Sie werden für einen Zeitraum, der sechs Jahre nicht überschreiten soll, gewählt. Die Direktoren werden von den

Aktieninhabern auf einer Hauptversammlung der Aktieninhaber gewählt; diese wird des Weiteren die Anzahl der Direk-
toren, ihre Klasse, ihre Vergütung und den Zeitraum ihrer Amtsdauer festlegen.

Jeder Direktor kann auf Beschluss der Hauptversammlung jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen abberufen

oder ersetzt werden.

Im Fall einer Vakanz im Amt eines Direktors können die übrigen Direktoren zeitweilig diese Vakanz ausfüllen; die

Aktieninhaber werden über eine solche Nominierung bei ihrer nächsten Hauptversammlung eine endgültige Entscheidung
treffen.

28001

Art. 13. Sitzungen des Direktoriums. Das Direktorium wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Es kann

einen Schriftführer wählen, der kein Direktor zu sein braucht und der während der Sitzungen des Direktoriums und der
Aktieninhabern das Protokoll führt und aufbewahrt. Das Direktorium wird auf die Einberufung durch den Vorsitzenden
oder von zwei Direktoren hin an dem in der Einladung angegebenen Ort tagen.

Der Vorsitzende wird bei den Sitzungen der Direktoren den Vorsitz führen. In seiner Abwesenheit werden die Mit-

glieder  des  Direktoriums  mit  Mehrheitsbeschluss  einem  anderen  Direktor  den  Vorsitz  der  betreffenden  Sitzungen
übergeben.

Das Direktorium kann einen beliebigen leitenden Angestellten, auch einen Geschäftsführer und beliebige Assistenten

der Geschäftsführung sowie andere leitende Angestellte ernennen, die das Unternehmen zur Führung der Geschäfte und
seiner Verwaltung für notwendig hält. Solche Ernennungen können jeder Zeit vom Direktorium annulliert werden. Die
leitenden Angestellten brauchen keine Direktoren oder Aktieninhaber des Unternehmens zu sein. Soweit nicht anders
in der vorliegenden Satzung festgelegt, haben die leitenden Angestellte die Rechte und Pflichten, die ihnen das Direktorium
überträgt.

Eine schriftliche Einladung zu einer jeden Sitzung des Direktoriums soll allen Direktoren wenigstens vierundzwanzig

Stunden vor dem Termin außer in Notfällen zugegangen sein. In einem solchen Fall ist die Art dieser Umstände in der
Einladung zur Sitzung anzugeben. Auf eine Einladung kann aufgrund einer schriftlichen Einwilligung per Telegramm, Telex,
oder Telefax, eine E-mail oder ein Kommunikationsmittel ähnlicher Art verzichtet werden. Eigene Einladungen sind nicht
für Sitzungen erforderlich, die an Orten und zu Zeitpunkten stattfinden, die in einem Beschluss des Direktoriums anbe-
raumt worden sind.

Jeder Direktor ist in jeder Sitzung handlungsfähig, indem er schriftlich per Telegramm, Telex, Telefax oder E-mail oder

durch ein ähnliches Kommunikationsmittel einen anderen Direktor als seinen bevollmächtigten Stellvertreter beruft. Ein
Direktor kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jeder Direktor kann an einer Sitzung des Direktoriums durch Konferenzschaltung oder ein ähnliches Kommunikati-

onsmittel, bei dem alle an der Sitzung teilnehmenden Personen einander hören können, teilnehmen. Die Teilnahme an
einer Sitzung mit einem solchen Mittel soll als persönliche Anwesenheit gelten.

Die Direktoren können nur in ordnungsmäßig einberufenen Sitzungen des Direktoriums auf dieses einwirken.
Überlegungen und Handlungen des Direktoriums sind nur gültig, wenn die Hälfte der Direktoren bei einer Sitzung des

Direktoriums anwesend oder repräsentiert ist.

Entscheidungen werden per Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Direktoren einer solchen Sitzung

gefällt, ausgenommen die Spezial-Beschlüsse, welche die Zustimmung wenigsten eines Direktors der Klasse A benötigen.

Spezial-Beschlüsse sind (a) alle Beschlüssen, die sich auf Verbindlichkeiten beziehen, ob sie nun vertraglicher Art sind

oder nicht; darunter fallen Beschlüsse über (i) jährlich wiederkehrende Kosten von über eintausend Euro (EUR 1.000),
(ii) mit einer Kündigungsfrist von mehr als einem Monat, oder (iii) einer Festlaufzeit von über drei Monaten, (b) alle
Beschlüsse, die sich auf andere Kosten beziehen, die einen Betrag von eintausend Euro (EUR 1.000) übersteigen, und (c)
alle Beschlüsse, die sich (i) auf jede Art von Investition, Desinvestition und Umstrukturierung der Gesellschaft, (ii) auf
Kapital-Einzahlungsforderungen und Ausschüttungen, (iii) auf die Emission von Aktien und (iv) auf die Übertragung von
Aktien beziehen.

Für den Fall, dass bei einer Sitzung die Anzahl der Stimmen für oder gegen einen Beschluss die gleiche ist, hat der

Vorsitzende der Sitzung nicht die entscheidende Stimme.

Das Direktorium  kann  einstimmige  Beschlüsse  auf  schriftlichem Wege fassen;  sie haben  die gleiche Wirkung,  wie

Beschlüsse, die auf einer ordnungsmäßig einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Direktoriums gefasst wurden. Solche
schriftlichen Beschlüsse gelten als gefasst, wenn sie mit Datum von allen Direktoren auf einem einzigen Dokument oder
auf mehreren Gegenstücken unterschrieben worden sind. Die Kopie einer ursprünglichen Unterschrift per Post, Faksimile
oder einem anderen Kommunikationsmittel ist hierfür ein ausreichender Beleg. Ein einzelnes Dokument, das alle Unter-
schriften oder gegebenenfalls die Gesamtheit der unterschriebenen Gegenstücke aufweist, wird die Urkunde sein, die
den Beweis für die Verabschiedung des Beschlusses erbringt. Als Datum des Beschlusses gilt das Datum der letzten
Unterschrift.

Die Beschlüsse des Direktoriums werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden der Sitzung oder von

zwei  beliebigen  Direktoren  unterzeichnet  wird.  Kopien  von  Auszügen  aus  solchen  Protokollen,  die  bei  gerichtlichen
Vorgängen oder sonstwo vorzulegen sind, werden mit der Unterschrift des Vorsitzenden der Sitzung oder denjenigen
von zwei beliebigen Direktoren gültig.

Art. 14. Befugnisse des Direktoriums. Das Direktorium hat die weitestgehenden Befugnisse zur Ausübung aller Ver-

waltungsmaßnahmen und Anordnungen im Rahmen des Unternehmenszweckes.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich vom Gesetz oder von der vorliegenden Satzung der Hauptversammlung der

Aktieninhaber vorbehalten sind, liegen in der Kompetenz des Direktoriums.

Art. 15. Zeichnungsberechtigung. Das Unternehmen wird durch die Unterschriften von zwei der Direktoren vertrag-

lich gebunden, vorausgesetzt, dass diese zwei Unterschriften die Unterschrift mindestens eines Direktors der Klasse A

28002

bei allen Angelegenheiten enthält, die Spezial-Beschlüsse betreffen, oder durch die einzige Unterschrift einer Person, der
das Direktorium die Unterzeichnungsvollmacht übertragen hat.

Art. 16. Interessenkonflikt. Abgesehen von anderen Gesetzesbestimmungen hat jeder Direktor, der direkt oder indi-

rekt ein eigenes Interesse an einer Transaktion hat, die der Zustimmung des Direktoriums vorliegt, und dessen Interesse
im Konflikt mit den Interessen des Unternehmens steht, das Direktorium über diesen Interessenkonflikt zu informieren;
und seine/ihre Erklärung ist im Protokoll der Direktoriumssitzung zu vermerken.

Der entsprechende Direktor darf nicht an den Diskussionen über die entsprechende Transaktion teilnehmen und darf

nicht über sie abstimmen.

Über jeden solcher Interessenkonflikte muss in der nächsten Hauptversammlung der Aktieninhaber, bevor irgendein

Beschluss gefasst oder ein anderer Gegenstand behandelt worden ist, berichtet werden.

Hat das Unternehmen nur einen alleinigen Geschäftsführer und dieser alleinige Geschäftsführer hat direkt oder indirekt

ein eigenes Interesse an einer Transaktion, die zwischen dem alleinigen Geschäftsführenden Direktor und dem Unter-
nehmen ansteht, und steht dieses Interesse dem Interesse des Unternehmens entgegen, dann muss dieser Interessen-
konflikt in der Niederschrift über die entsprechende Transaktion bekannt gemacht werden.

Art. 17. Entschädigung der Direktoren. Das Unternehmen wird die Kosten eines jeden Direktors oder leitenden

Angestellten und seiner Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter entschädigen, die ihm billigerweise in Verbindung
mit einer Klage, einem Prozess oder Verfahren entstanden sind, an der/dem er aufgrund der Tatsache beteiligt ist, dass
er Direktor oder leitender Angestellter des Unternehmens ist oder war, oder aufgrund eines Auftrags des Unternehmens
oder eines Auftrags eines anderen Unternehmens, von dem das Unternehmen Aktien hält oder dessen Gläubiger es ist,
und wenn er bei diesem Unternehmen kein Recht auf Entschädigung hat. Eine Entschädigung erfolgt nicht in Bezug auf
Angelegenheiten, für die der Direktor schließlich in einer/m solchen/m Klage, Prozess oder Verfahren wegen grober
Fahrlässigkeit oder Fehlverhaltens als verantwortlich verurteilt worden ist. Im Falle eines Vergleichs wird Entschädigung
nur in Verbindung mit solchen Angelegenheiten gewährt, in Bezug auf die ein Anwalt das Unternehmen dahingehend
unterrichtet, dass die zu entschädigende Person sich keine Pflichtverletzung zu Schulden kommen hat lassen. Das im
Vorherigen behandelte Recht auf Entschädigung schließt nicht andere Rechte, die der Person zustehen könnten, aus.

Art. 18. Hauptversammlung der Aktien-Inhaber. Die Hauptversammlung der Aktieninhaber repräsentiert alle Aktien-

inhaber des Unternehmens. Ihre Beschlüsse sind für alle Aktieninhaber des Unternehmens bindend. Sie hat die weites-
tgehenden  Befugnisse,  Tätigkeiten  mit  Bezug  auf  die  Geschäftsbereiche  des  Unternehmens  anzuordnen  oder
durchzuführen.

Hauptversammlungen der Aktieninhaber werden vom Direktorium einberufen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktieninhabern, die mindestens 10 % des Aktienkapitals repräsentiert, einberufen werden.
Die Jahreshauptversammlung wird um 14 Uhr am vierten Mittwoch des Monats Juni am Geschäftssitz oder an einem

in der Einladung zu dem Treffen besonders ausgewiesenen Ort im Bezirk Luxemburg stattfinden. Wenn dieser Tag kein
Geschäftstag ist, wird die Jahreshauptversammlung am nächsten darauf folgenden Geschäftstag stattfinden.

Weitere Sitzungen der Aktieninhaber können an Orten und zu Zeiten anberaumt werden, wie sie in einer besonderen

Einladung zu dem Treffen aufzuführen sind.

Die Hauptversammlungen der Aktieninhaber sind mit einer Einladung einzuberufen, welche die Tagesordnung enthält

und per Einschreibebrief mindestens acht (8) Tage vor der Sitzung jedem Aktieninhaber an dessen Anschrift, wie sie im
Register der gemeldeten Aktien aufgezeichnet ist, zugeschickt wird. Das Ergehen einer solchen Einladung an die gemel-
deten Aktieninhaber braucht bei der Sitzung nicht gerechtfertigt zu werden. Die Tagesordnung wird vom Direktorium
vorbereitet, außer für den Fall, dass die Sitzung aufgrund eines schriftlichen Antrags von Aktieninhabern einberufen wird;
in diesem Fall kann das Direktorium eine ergänzende Tagesordnung vorbereiten.

Wenn alle Aktieninhaber anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsmäßig eingeladen und über die Tages-

ordnung informiert betrachten, können Hauptversammlungen ohne Einladung stattfinden.

Das Direktorium kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die Aktieninhaber erfüllen müssen, um an irgendeiner

Sitzung der Aktieninhaber teilzunehmen.

Die auf einer Sitzung der Aktieninhaber abgewickelten Geschäfte sind auf die Angelegenheiten zu beschränken, die auf

der Tagesordnung enthalten sind (die alle von Gesetz geforderten Angelegenheiten zu enthalten hat) und auf Geschäfte,
die sich aus solchen Angelegenheiten beiläufig ergeben.

Jeder Anteil, gleichgültig welcher Klasse von Aktien, verfügt nach Luxemburgischem Recht und der vorliegenden Sat-

zung bei der Abstimmung über eine Stimme.

Ein Aktieninhaber kann auf eine Hauptversammlung einwirken, indem er einer anderen Person, die kein Aktieninhaber

zu sein braucht und die ein Direktor des Unternehmens sein kann, dazu eine schriftliche Vollmacht erteilt.

Außer wenn es nicht anders im Gesetz oder in dieser Satzung verfügt ist, werden Beschlüsse der Hauptversammlung

mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber gefasst.

Alle Beschlüsse einer Sitzung von Aktieninhabern, die darauf zielen, die vorliegende Satzung abzuändern, sind (i) in

Anwesenheit von mindestens fünfzig (50) Prozent des Anteils-Kapitals - wenn ein solches Quorum nicht beim ersten
Treffen zustande kommt, ist für das vertagte Treffen kein solches Quorum mehr erforderlich - und (ii) mit der zustimm-

28003

enden Mehrheit von mindestens Zweidrittel (2/3) der Stimmen zu fassen, die auf der Sitzung gültig abgegeben worden
sind; dabei sind nicht die Stimmen für die Aktien zu berücksichtigen, deren Inhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen
oder sich enthalten oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgeben haben.

Ungeachtet des obigen Paragraphen bedarf jeder Beschluss auf einer Sitzung von Aktieninhabern, der darauf abzielt,

den SICAR-Status nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 abzulegen, der einstimmigen Zustimmung aller Aktieninhaber.

Art. 19. Depotstelle. Das Unternehmen wird ein Depotabkommen mit einer Luxemburger Bank (die Depotstelle)

abschließen, die den Anforderungen des Gesetzes vom 15. Juni 2004 entspricht.

In Übereinstimmung mit der üblichen Bankenpraxis kann die Depotstelle in ihrer eigenen Verantwortung und in gutem

Glauben Teile der oder die gesamten Vermögenswerte, die ihr zur Verwahrung übergeben worden sind, anderen Bank-
institutionen oder Finanzmittelsmännern anvertrauen.

Wertpapiere, Bargeld und andere überlassene Vermögenswerte des Unternehmens werden bei und im Namen der

Depotstelle und in ihrer Verantwortlichkeit in Gewahrsam gehalten. Sie hat ihren Aufgaben und Verpflichtungen nach
dem Gesetz vom 15. Juni 2004 nachzukommen.

Wenn die Depotstelle sich zurückzuziehen wünscht, wird das Unternehmen die größten Anstrengungen unternehmen,

um innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten einer solchen Kündigung eine Nachfolge-Depotstelle zu finden. Bis
die Depotstelle ersetzt worden ist, was innerhalb des Zeitraums von zwei Monaten zu geschehen hat, wird die Depotstelle
alle erforderlichen Schritte unternehmen, um für die gute Wahrung der Interessen der Aktieninhaber des Unternehmens
zu sorgen.

Das Unternehmen kann das Abkommen mit der Depotstelle beenden, wird das Depot aber nicht räumen, wenn nicht

zuvor eine Nachfolge-Depotstelle ernannt worden ist, um an Stelle der bisherigen tätig zu werden.

Die Pflichten der Depotstelle werden entsprechend enden:
a) im Fall eines freiwilliges Zurücktretens der Depotstelle oder der Kündigung seitens des Unternehmens; bis zu Ihrer

Ablösung, was innerhalb von zwei Monaten geschehen muss, wird die Depotstelle alle für die gute Wahrung der Interessen
der Aktieninhaber des Unternehmens notwendigen Schritte unternehmen;

b) wenn die Depotstelle oder das Unternehmen für insolvent erklärt worden ist, in ein Vergleichsverfahren mit Gläu-

bigern eingetreten ist, die Zahlung einstellen musste, unter gerichtliche Verwaltung gestellt oder einem ähnlich Verfahren
ausgesetzt oder in Liquidation gestellt worden ist;

c) wenn die Aufsichtsbehörde Luxemburgs dem Unternehmen oder der Depotstelle die Genehmigung entzieht;
im Falle einer Ablehnung des SICAR-Status durch die Aktieninhaber.

Art. 20. Wirtschaftsprüfer. Das Unternehmen wird einen Wirtschaftsprüfer aus der Liste der Réviseurs d'Entreprises

Indépendants wählen und ernennen; seine Ernennung wird von der Commission for the Supervision of the Financial Sector
("CSSF", Kommission zur Beaufsichtigung des Finanzsektors) zu billigen sein. Der Wirtschaftsprüfer wird mit der Revision
der Jahresabrechnung des Unternehmens betraut werden. Der Bericht des Wirtschaftsprüfers und die Qualifizierungen
des Berichts, wenn es sie gibt, werden in jedem Jahresbericht vollständig aufgeführt.

Der Wirtschaftsprüfer wird neben anderen Verpflichtungen das CSSF umgehend über jede Tatsache oder Entscheidung

informieren, die dem Wirtschaftsprüfer bei der Durchführung der Revision der Buchhaltungsunterlagen für den Jahres-
bericht des Unternehmens oder bei irgendeiner anderen gesetzlichen Angelegenheit mit Bezug auf das Unternehmen
bewusst geworden ist, wenn solche Tatsachen oder Entscheidungen einen materielle Verstoß gegen das Gesetz vom 15.
Juni 2004 oder dessen Ausführungsbestimmungen darstellen oder die weitere Funktionsfähigkeit des Unternehmens be-
rühren,  oder  zu  einer  Weigerung  führen  können,  die  Abrechnung  zu  beglaubigen  oder  ihr  gegenüber  Vorbehalten
anzumelden.

Der Wirtschaftsprüfer hat umfassende Verpflichtungen, das CSSF zu informieren und in Kenntnis zu setzen, die vom

Wirtschaftsprüfer verlangen können, einen oder mehrere besondere Aspekte der Aktivitäten und Geschäftstätigkeiten
des Unternehmens zu kontrollieren.

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr des Unternehmens beginnt am ersten Tag des Monats Januars eines jeden

Jahres und endet am letzten Tag des Monats Dezember des gleichen Jahres.

Art. 22. Jahresbericht. Das Unternehmen wird innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Ende des be-

treffenden Geschäftsjahres einen Jahresbericht veröffentlichen.

Art. 23. Ausschüttungen. Die Erlöse, die sich aus den Investitionen des Unternehmens und allen anderen Einnahmen

eines jeden Vermögens-Fonds ergeben, werden dem entsprechenden Vermögens-Fonds zugeteilt und anteilig jedem Ak-
tieninhabern entsprechend der Anzahl von Aktien der entsprechenden Klasse von Aktien, die er hält, ausbezahlt.

Dem Direktorium bleibt das Recht aber nicht die Verpflichtung vorbehalten, jährlich oder auch zwischenjährlich Aus-

schüttungen an die Aktieninhaber aus den Kapital-Erträgen und Kapital-Verkaufseriösen des Unternehmens auszurufen,
und auch aus jedem anderen für die Ausschüttung verfügbaren Fonds, wenn es die Aufrechterhaltung einer angemessene
Höhe der Dividenden für notwendig erachtet. In dem Umfang, in dem das Unternehmen Bargeld oder sofort verfügbare
Zahlungsmittel an Aktieninhabern als Kapitalertrag ausschüttet, wird die Netto-Vermögenswert-Grundlage dieser Akti-
eninhaber um den gleichen Betrag verringert.

28004

Das Unternehmen wird keine Ausschüttung, weder als Dividendenausschüttung noch in Form der Einlösung von Aktien

in dem Fall vornehmen, dass das Nettovermögen des Unternehmens als Ergebnis einer solchen Ausschüttung unter das
Minimum von einer Million Euro (EUR 1.000.000) absinken würde, welches nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 erfor-
derlich ist.

Keine Zinsen sollen auf eine Dividende bezahlt werden, die vom Unternehmen ausgerufen worden ist und von ihm

zur Abgabe an den Nutznießer bereitgehalten wird.

Eine Ausschüttung, die nicht innerhalb von fünf Jahre nach ihrer Ausrufung in Anspruch genommen worden ist, wird

eingebüßt und fällt an das Unternehmen zurück.

Art. 24. Geltendes Recht. Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, werden in Übereinstimmung

mit dem Gesetz über Wirtschaftsunternehmen vom 10. August 1915 und dem Gesetz vom 15. Juni 2004 und hinsichtlich
der Änderungen dieser Gesetze im Laufe der Zeit oder in Zukunft, entschieden.

Da nichts mehr auf der Tagesordnung steht, wird die Versammlung sogleich beendet.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde auf

English verfasst ist und von einer deutschen Fassung gefolgt ist; auf Anfrage der vor ihm erscheinenden Personen und im
Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. GOULET, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE und J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A. C., le 4 décembre 2008. LAC/2008/48836. Reçu mille deux cent cinquante euros € 1.250,-.

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 20. Januar 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009029075/7241/1087.
(090032180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

LBP Luxco GP 6-Hessen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.704.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54412 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028829/211/12.
(090031539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Sensata Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 114.569.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des Associés prises en date du 13 février 2009

En date du 13 février 2009, l'assemblée Générale de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Jacques de Patoul, administrateur de la Société, avec effet au 23 janvier 2009,
- de nommer Monsieur Frederik Kuiper, né le 9 novembre 1974 à Utrecht, Pays-Bas, ayant comme adresse profes-

sionnelle, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 23 janvier
2009 et à durée déterminée jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2009.

Depuis cette date, le conseil d'administration de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
- Monsieur Ailbhe JENNINGS
- Monsieur Serge Walid SARKIS
- Monsieur Frederik KUIPER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

28005

Luxembourg, le 18 février 2009.

Sensata Management Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2009029119/250/23.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07169. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.706.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54409 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028830/211/12.
(090031543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Weather Capital Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.030.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53335 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028831/211/12.
(090031553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Gaviota Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 35.610.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 45377 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028833/211/12.
(090031594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Tracom S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 91.654.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Suite à une assemblée générale extraordinaire enregistrée à Luxembourg, actes civils le actes civils le 27 janvier 2009,

LAC/2009/3093 et reçue par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 23 janvier
2009, acte n°29, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société TRACOM S.A., qui cessera d'exister.

L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années à l'ancien siège de

la société.

28006

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Jacques DELVAUX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009029292/208/18.
(090031886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

LBP Luxco GP 2-Resi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.517.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54408 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028835/211/12.
(090031628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Weather Capital Special Purpose 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.495.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53336 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028836/211/12.
(090031710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

PAC, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 126.200,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 127.047.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 17 février 2009 au siège social social

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au

412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 Février 2009.

<i>Pour PAC S.à.r.l.
S G G S.A.
412F, route D'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009028839/795/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06723. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

28007

WRCA (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 19.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.459.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 6 février 2009:
- que le siège social de la société est transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412 F Route d'Esch,

L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2009.

S G G S.A.
412F, route D'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009028840/795/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06732. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Abris Holdings 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.624.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53494 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028841/211/12.
(090031715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Sasfin International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.747.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration de la Société prise en date du 6 février 2009 que le siège social de

la Société est transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
avec effet au 6 février 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2009.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009028842/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06730. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

28008

Lënster Energie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies.

R.C.S. Luxembourg B 126.648.

Im Jahre zweitausendneun, den sechzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "L.E.E. S.à r.l.", mit Sitz in L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Com-

merciale Langwies, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
75.534,

hier rechtmäßig vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Jean SCHUMMER, hiernach genannt.
2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GABBANA S.à r.l.", mit Sitz in L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et

Commerciale Langwies, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
67.033,

rechtmäßig vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Luden GABBANA, maître-installateur sanitaire et chauffage,

wohnhaft in L-6180 Gonderange, 18, rue de Bourglinster,

hier vertreten durch Herrn Alexander KIEFFER, Privatbeamter, wohnhaft in L-4019 Esch/Alzette, 6, rue Jean l'Aveugle,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

3) Frau Lydie BECKER-BETTENDORF, Landwirtin, geboren in Diekirch, am 24. April 1960, wohnhaft in L-6150 Alt-

linster, 4, rue de Luxembourg.

4) Herr Marc BECKER, Privatbeamter, geboren in Luxemburg, am 13 Mai 1959, wohnhaft in L-6150 Altlinster, 4, rue

de Luxembourg.

5) Frau Elise HOUWEN-GREISCHER, Rentnerin, geboren in Luxemburg, am 24. Mai 1944, wohnhaft in L-6166 Ernster,

82, rue de Grünewald.

6)  Herr  Gerrit  HOUWEN,  Landwirt,  geboren  in  Venray,  (Niederlande),  am  1.  August  1941,  wohnhaft  in  L-6166

Ernster, 82, rue de Grünewald.

7) Herr Martin HOUWEN, Landwirt, geboren in Venlo, (Niederlande), am 15. Januar 1947, wohnhaft in L-6195 Im-

bringen, 24, route de Luxembourg.

8) Herr Emile KLENSCH, Landwirt, geboren in Neudorf, am 23. August 1948, wohnhaft in L-6150 Altlinster, 5, rue

de Luxembourg.

9) Herr Adolphe WILDGEN, Landwirt, geboren in Olingen, am 24 November 1933, wohnhaft in L-6950 Olingen, 1,

rue de Roodt/Syr.

10) Herr Jean-Luc WILDGEN, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 14. Januar 1975, wohnhaft in L-6950 Olingen, 1,

rue de Roodt/Syr,

hier vertreten durch Herrn Adolphe WILDGEN, vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privats-

chrift.

11) Herr Jean SCHUMMER, Freiberufler, geboren in Luxemburg, am 23. Juli 1967, wohnhaft in L-6136 Junglinster, 3c,

rue de la Montagne.

12) Herr Thorsten KLAES, Diplom-Betriebswirt, geboren in Trier, (Bundesrepublik Deutschland), am 5. Oktober 1977,

wohnhaft in D-54290 Trier, Neustrasse 54,

hier vertreten durch Herrn Marc JACOBY, hiernach genannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privats-

chrift.

13) Herr Marc JACOBY, Privatbeamter, geboren in Luxemburg, am 2. September 1976, wohnhaft in L-5310 Contern,

2, rue de Moutfort.

14) Die Aktiengesellschaft "Soil-Concept", mit Sitz in L-9378 Friidhaff/Diekirch, eingetragen im Handels- und Gesell-

schaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 98398,

rechtmäßig vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Marc DEMOULLING, Diplom Biologe,

wohnhaft in L-8363 Greisch, 8, rue de l'Eglise,

hier vertreten durch Herrn Jean SCHUMMER, vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Vorgenannte Vollmachten, von den Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur' unterschrieben, bleiben

der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Lenster Energie S.à r.l.", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-6131

Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg,
Sektion B, unter der Nummer 126648, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar
am 4. April 2007, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1125 vom 12. Juni 2007.

28009

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft zu sein und dass sie den amtierenden

Notar ersuchen, die von ihnen gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen unter Privatschrift vom 12.

und 13. Dezember 2008, respektive vom 12. Januar 2009

- Herr Carlo SAUBER, Landwirt, wohnhaft in L-6175 Schiltzberg, Maison 6, seine fünfzig (50) Anteile, welche er in der

Gesellschaft hielt, an Herrn Jean SCHUMMER, vorgenannt, abgetreten hat;

- Herr Fernand FRISCH, Landwirt, wohnhaft in L-6171 Godbringen, 4, rue du Cimetière, seine fünfzig (50) Anteile,

welche er in der Gesellschaft hielt, an Herrn Marc BECKER, vorgenannt, abgetreten hat;

- Herr Jacques BERNS, Landwirt, wohnhaft in L-6180 Gonderingen, 10, rue des Près, seine fünfzig (50) Anteile, welche

er in der Gesellschaft hielt, an die Gesellschaft "GABBANA S.à r.l.", vorgenannt, abgetreten hat;

- Herr Marc BECKER, vorgenannt, fünfzig (50) seiner Anteile an der Gesellschaft an die vorgenannte Gesellschaft "Soil-

Concept" abgetreten hat;

- Herr Jean SCHUMMER, vorgenannt:
* fünfundzwanzig (25) Anteile an Herrn Thorsten KLAES, vorgenannt, und
* fünfundzwanzig (25) Anteile an Herrn Marc JACOBY, vorgenannt, abgetreten hat.
Die Gesellschafter erklären diese Übertragungen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäß Artikel 1690 des

Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften,

<i>Zweiter Beschluss

Nach diesen hiervor festgestellten Abtretungen von Gesellschaftsanteilen wird Artikel 6 der Satzungen abgeändert um

ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt sechzigtausend Euro (60.000,- EUR), aufgeteilt in tausendzweihundert (1.200)

Anteile von jeweils fünfzig Euro (50,- EUR), welche voll eingezahlt sind."

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter stellen fest, dass die tausendzweihundert (1.200) Anteile nunmehr wie folgt gehalten werden:

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "L.E.E. S.à r.l.", mit Sitz in L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et

Commerciale Langwies, dreihundert Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GABBANA S.à r.l.", mit Sitz in L-6131 Junglinster, Zone Arti-

sanale et Commerciale Langwies, dreihundertfünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

3) Frau Lydie BECKER-BETTENDORF, Landwirtin, wohnhaft in L-6150 Altlinster, 4, rue de Luxembourg, fünfzig

Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4) Herr Marc BECKER, Privatbeamter, wohnhaft in L-6150 Altlinster, 4, rue de Luxembourg, fünfzig Anteile,

50

5) Herr Gerrit HOUWEN, Landwirt, wohnhaft in L-6166 Ernster, 82, rue de Grünewald, fünfzig Anteile, . . .

50

6) Herr Martin HOUWEN, Landwirt, wohnhaft in L-6195 Imbringen, 24, route de Luxembourg, fünfzig Anteile,

50

7) Frau Elise HOUWEN-GREISCHER, Rentnerin, wohnhaft in L-6166 Ernster, 82, rue de Grünewald, fünfzig

Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

8) Herr Emile KLENSCH, Landwirt, wohnhaft in L-6150 Altlinster, 5, rue de Luxembourg, fünfzig Anteile, . . .

50

9) Herr Jean-Luc WILDGEN, Landwirt, wohnhaft in L-6950 Olingen, 1, rue de Roodt/Syr, fünfzig Anteile, . . .

50

10) Herr Adolphe WILDGEN, Landwirt, wohnhaft in L-6950 Olingen, 1, rue de Roodt/Syr, fünfzig Anteile,

50

11) Herr Jean SCHUMMER, Freiberufler, wohnhaft in L-7640 Christnach, 16b, Fielserstrooss, fünfzig Anteile,

50

11) Herr Thorsten KLAES, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in D-54290 Trier, Neustrasse 54, fünfundzwanzig

Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

12) Herr Marc JACOBY, Privatbeamter, wohnhaft in wohnhaft in L-5310 Contern, 2, rue de Moutfort, fün-

fundzwanzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

13) Die Aktiengesellschaft "Soil-Concept", mit Sitz in L-9378 Friidhaff/Diekirch, fünfzig Anteile, . . . . . . . . . . .

50

Total: tausendzweihundert Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

achthundertfünfzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns dem
Notar unterschrieben.

28010

Signé: SCHUMMER - KIEFFER - BECKER-BETTENDORF - BECKER - HOUWEN-GREISCHER - HOUWEN - HOU-

WEN - KLENSCH - WILDGEN - JACOBY - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 février 2009. Relation GRE/2009/701. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 24 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009029426/231/118.
(090032425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

Société Luxembourgeoise de Construction Métallique, Société à responsabilité limitée,

(anc. EB Lux S.à r.l.).

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 53-55, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 141.236.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54196 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028843/241/12.
(090031477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

AGFC (Angus Genetic Forest Consulting) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6360 Grundhof, 9, route de Beaufort.

R.C.S. Luxembourg B 134.626.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN sàrl
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature

Référence de publication: 2009028845/8482/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA08043. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Valorum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.969.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 6 janvier 2009 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter, avec effet au 1 

er

 septembre 2008, la démission de:

* Monsieur Olivier CONRARD né le 25 août 1965 à Messancy en Belgique, résidant professionnellement au 12, avenue

de la Liberté à L-1930 Luxembourg de sa fonction d'administrateur;

- De nommer comme nouvel administrateur, avec effet au 1 

er

 septembre 2008:

* Monsieur Benoît DESSY, employé privé, né le 9 janvier 1971 à Bastogne en Belgique, résidant professionnellement

au 19/21, boulevard du Prince Henri;

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2011.
- De proroger le mandat des administrateurs suivants:
* Monsieur Vincent THILL, employé privé, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri; Admi-

nistrateur et Président;

* Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri; Ad-

ministrateur;

28011

Lesdits mandats prendront également fin, à l'instar à présent de tous les administrateurs, lors de l'Assemblée Générale

statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VALORUM S.A.
Signature

Référence de publication: 2009029153/24/27.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07651. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Equilease International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 21.042.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028846/242/12.
(090031689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Falcon Hansa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 430.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevrd du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 135.365.

<i>Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le Conseil de Gérance

- Le siège social de la société est transféré du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 43, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, avec effet au 10 octobre 2008.

Fait le 9 février 2009.

FALCON HASA S.à r.l.
J.-R. BARTOLINI / C. KOSSMANN
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009028847/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06726. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Millenium Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 65.541.

<i>Extrait du livre des procès-verbaux

<i>Assemblée générale annuelle du 7 mai 2007

L'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes:
1) Renouvelle, à l'unanimité, le mandat des administrateurs suivants:
- Madame Pagona Loutridou, employée privée, demeurant à 125, rue Spartis, 17675 Athènes, Grèce
- Monsieur Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à 7, Place Jean Jacobs, 1000 Bruxelles, Belgique
- Mademoiselle Ekaterini Mouzaki, avocat, demeurant à 18, rue Akadimias 10671, Athènes, Grèce.
Leur mandant est valable pour deux ans et expirera lors de la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2009.
2) Renouvelle le mandat du Commissaire G. Georgiou-Kostakopoulos, avocat, demeurant à 18, rue Akadimias 10671,

Athènes, Grèce.

Son mandat est valable pour deux ans et expirera lors de la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2009.

28012

Luxembourg, le 7 mai 2007.

Copie conforme du livre des procès-verbaux
<i>Le Bureau / Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur
N. KOROGIANNAKIS
<i>Le Membre du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009029161/2256/25.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06687. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Vry SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3337 Hellange, 13, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 85.488.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN sàrl
32A, rue Meckenneck
L-3321 BERCHEM
Signature

Référence de publication: 2009028848/8482/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02155. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Auto Helfent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 8, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 34.588.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009028850/3006/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08604. - Reçu 93,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Adviser I Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 74.992.

<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16.01.2009

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un

nouveau terme d'un an.

<i>Composition du Conseil d'Administration

Dr. Josef Zellner, président
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)
Thorsten Schwarting, vice président
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)
Jan Ebberg
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)
Hartwig Springenschmid
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)
Niki Ga-Yu Bat,
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)

28013

<i>Réviseur d'Entreprises

KPMG Audit S.à.r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009029168/6633/27.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07238. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

DJB G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7233 Bereldange, 41, Cité Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 66.805.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN sàrl
32A, rue Meckenneck
L-3321 BERCHEM
Signature

Référence de publication: 2009028851/8482/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA08088. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Him-Racing-Kart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 57.089.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN sàrl
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature

Référence de publication: 2009028853/8482/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA08061. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

J.P. Morgan Real Estate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 125.763.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date du 09 février 2009.

L'Associé unique a noté la démission de Madame Helen VALENTINE en tant que gérante de la société en date du 31

octobre 2008.

L'Associé a par conséquent décidé de nommer M. David O'Neill, domicilié professionnellement 6 route de Trèves,

L-2633 Senningerberg, en tant que gérant de la société à compter du 09 février 2009 et ce jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 décembre 2008.

Au 09 février 2009, le Conseil de Gérance se compose comme suit:
- M. Alain Picherit, Gérant;
- M. David O'Neill, Gérant;
- Mme Dale Quarry, Gérante;
- M. Thierry Maes, Gérant;

28014

Certifié conforme
Alain PICHERIT
<i>Gérant

Référence de publication: 2009029133/2205/24.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06647. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Canama S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9759 Knaphoscheid, 1, Am Dahl.

R.C.S. Luxembourg B 103.188.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 10 février 2009.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009028854/2724/13.
(090031219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Logoline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 151, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 33.267.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN sàrl
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature

Référence de publication: 2009028855/8482/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA08082. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Grenache &amp; Cie S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.763.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Grenache &amp; Cie S.N.C.
Société en Nom Collectif
10, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009028857/8452/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08634. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

28015

Inpigest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 74.311.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009028859/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06970. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090032061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Crefinimmo, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-6585 Steinheim, 24, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 130.399.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 19 février 2009.

Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028858/243/12.
(090031107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Camile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 75.831.

<i>Extrait des minutes du Conseil d'Administration tenu le 16 février 2009

Camile S.A. ("la société"), il a été décidé comme suit:
- De transférer le siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers le 2-8, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 février 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009028860/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06259. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Filti S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 137.169.

In the year two thousand and nine on the thirtieth day of January,
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared,

Lucien Holdings S.àr.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the registry of trade
and companies of Luxembourg under number B 90.461, represented by its duly appointed manager in function Maître
Martine Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole shareholder of the limited liability com-

pany  Filti  S.àr.l.,  having  its  registered  office  at  2,  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg  (the  "Company")

28016

incorporated by deed of the undersigned notary on 29 

th

 February, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations (the "Mémorial") number 926 of 15 

th

 April, 2008 and as amended for the last time on 23 October 2008

by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 3036 on 30 December 2008.

The appearing party requested the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder decides to increase the issued corporate capital by fifty thousand Euro (€ 50,000) in order to increase

the actual capital from twenty-three thousand Euro (€ 23,000) to seventy-three thousand Euro (€ 73,000) by the creation
and issue of two thousand (2.000) Shares at a par value of twenty-five Euro (€ 25) each.

The two thousand (2.000) new shares are subscribed and fully paid up by contribution in cash by Lucien Holdings S.àr.l.

so that the amount of fifty thousand Euro (€ 50,000) is at the free disposal of the Company from now on, evidence having
been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Following the preceding capital increase, article 6 of the articles of incorporation will be amended accordingly so as

to read:

Art. 6. The share capital is set at seventy-three thousand Euro (€ 73,000), divided into two thousand nine hundred

and twenty (2.920) Shares (the "Shares") of a par value of twenty-five Euro (€ 25) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed, together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'An deux mille neuf, le trentième jour de janvier,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg,

A comparu,

Lucien Holdings S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 137.169, représentée par un de ses gérants en fonction Maître Martine Elvinger, maître en droit, résidant à
Luxembourg.

La personne présente, représentée tel qu'indiqué, a déclaré être le seul associé de la société à responsabilité limitée

Filti S.àr.l., ayant son siège social à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (la "Société"), constituée par acte
du notaire instrumentant le 29 février 2008, publiée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mé-
morial") le 15 avril 2008, numéro 926; les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 23 octobre 2008 par
acte notarié, publié au Mémorial numéro 3036 du 30 décembre 2008.

La partie présente, représentée tel qu'indiqué, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire décide d'augmenter le capital social émis par cinquante mille euros (€ 50.000) de façon à augmenter le

capital actuel de vingt-trois mille euros (€ 23.000) à soixante-treize mille euros (€ 73.000) par la création et l'émission
de deux mille (2.000) parts sociales à une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25) chacune.

Les deux mille (2.000) nouvelles parts sociales sont souscrits et entièrement libérées par une contribution en numéraire

par Lucien Holdings S.àr.l de manière à ce que le montant de cinquante mille euros (€ 50.000) est à la libre disposition
de la Société à partir de maintenant, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital précédente, l'article six des statuts sera modifié conformément de façon à lire:

Art. 6. Le capital social est fixé à soixante-treize mille euros (€ 73.000) représenté par deux mille neuf cent vingt

(2.920) parts sociales (les "Parts Sociales") d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25) chacune."

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais déclare par la présente qu'à la demande de la personne

présente, cet acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande de la même personne présente
et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, à la suite de quoi le présent acte a été fait à Luxembourg le jour indiqué en début du document.

28017

Le document ayant été lu à la personne présente, connue par le notaire par son nom, prénom, état civil et résidence,

la personne présente a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. ELVINGER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 4 février 2009. Relation: LAC/2009/4350. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 17 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009029061/211/75.
(090031933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Garage FEYEREISEN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8706 Useldange, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 93.345.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 19 février 2009.

Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028863/243/12.
(090031708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Viva Gestions Immobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 74.603.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.02.09.

VIVA GESTIONS IMMOBILIERES S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009028864/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07043. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Adviser II Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.177.

<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16.01.2009

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un

nouveau terme d'un an.

<i>Composition du Conseil d'Administration

Dr. Josef Zellner, président
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)
Thorsten Schwarting, vice président
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)
Jan Ebberg
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)
Hartwig Springenschmid
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)

28018

Niki Ga-Yu Bat
(résidant professionnellement à D-80687 München, Landsberger Strasse 300)

<i>Réviseur d'Entreprises

KPMG Audit S.à.r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009029172/6633/27.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07233. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Viva Gestions Immobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 74.603.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.02.09.

VIVA GESTIONS IMMOBILIERES S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009028865/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07046. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Lab Document Vault S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 51.687.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028866/5770/12.
(090031583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Viva Gestions Hôtelières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 74.602.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.02.09.

VIVA GESTIONS HOTELIERES S.A.
Alexis DE BERNARDI / Daniele MARIANI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009028868/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07051. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

28019

PCB &amp; CMR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 64.073.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société PCB &amp; CMR S.A. du 15 décembre 2008

que:

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg

au

32, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 décembre 2008.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Fiduciaire F.O.R.I.G. s.c.
Signature

Référence de publication: 2009028867/1039/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04740. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090031466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Lapraille Dupont Esméralda Chloé s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 113.503.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le onze février.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

ont comparu:

1) Madame Christelle DUPONT, sans état particulier, née à Huy (Belgique) le 20 avril 1976, demeurant à B-45oo Huy,

rue de l'Amérique;

2) Mademoiselle Esmeralda LAPRAILLE, sans état particulier, née à Virton (Belgique) le 18 septembre 1982, demeurant

à B-675o Musson, rue Late Mussy 1;

3) Mademoiselle Chloé LAPRAILLE, sans état particulier, née à Virton (Belgique) le 18 décembre 1986, demeurant à

B-4557 Tinlot, 45, rue du Village,

ici représentés par Monsieur Sébastien ELISE, comptable, demeurant à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale, né le 21

novembre 1972 à Charleroi en Belgique (matr. 1972 11 21 936), en vertu d'une procuration sous seing privée, datée à
Rombach du 9 février 2009, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,

actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée "Lapraille Dupont Esmeralda Chloé s. à r. l.", en abrégé

"LDEC s. à r. l.", avec siège social à L-8814 Bigonville, Commune de Rambrouch, 34, rue Principale (matr. 2006 24 01
037),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 934 du 12 mai 2006,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 113 503,
lesquels comparants, représentés ès-qualités, représentant actuellement l'intégralité du capital social, ont requis le

notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- que ladite société a cessé toute activité commerciale avec effet au 31 décembre 2008, la clôture des comptes ayant

eu lieu à la même date;

- que les comparants donnent décharge au gérant pour l'exercice de ses fonctions;
- que les comparants décident de dissoudre la société avec effet au 31 décembre 2008;
- que la société a été liquidée aux droits de parties préalablement à la signature des présentes;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq années au domicile du comparant.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

28020

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge des associés.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. DUPONT, E. LAPRAILLE, C. LAPRAILLE, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 13 février 2009. DIE/2009/1650. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME.

Ettelbruck, le 25 février 2009.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2009029475/4917/46.
(090032513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

Lincoln Electric Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 100.755.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028870/5770/12.
(090031552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Viva Gestions Hôtelières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 74.602.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.02.09.

VIVA GESTIONS HOTELIERES S.A.
Alexis DE BERNARDI / Daniele MARIANI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009028871/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07049. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Spido Oil s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 67.206.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/02/2009.

<i>Pour Spido Oil s.à r.l.
World Hopper s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009028872/1588/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08648. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

28021

Chauffage-Sanitaire Integral S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 106, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 121.715.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 20 février 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028886/239/12.
(090031589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

S.R.M.I. International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 33.452.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société S.R.M.I. INTERNATIONAL S.à r.l.

du 25 décembre 2008 que:

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg

au

32, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 décembre 2008

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Fiduciaire F.O.R.I.G. s.c.
Signature

Référence de publication: 2009028873/1039/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04739. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

SOFECOLUX S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme Holding,

(anc. Sofecolux).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 4.584.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 20 février 2009.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009028875/239/13.
(090031639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Chloride Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 360.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.955.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the third day of September.
In front of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

28022

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Chloride Luxembourg S.à r.l.", a "société à res-

ponsabilité limitée", having its registered office at 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 111.955 (the
"Company"), incorporated by a notarial deed enacted on 17 

th

 December 2004, published in Memorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, number 431 of 28 February 2006 and lastly amended by a deed enacted on 31 July 2008 by
Maître Joseph Elvinger, pre-named, awaiting publication.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, "Chloride Luxembourg Holdings S.à r.l.", a company incorporated under the

laws of the Grand-Duchy of Luxembourg laws, having its registered office 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte (the
"Sole Shareholder"), represented by Mr. Regis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg, duly authorised to
act on behalf of the Sole Shareholder by virtue of a proxy given to him under private seal.

The above-mentioned proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder declared and requested the notary to act that:
I. - As it appears from the attendance list annexed to this deed to be registered with it, the 14,400 (fourteen thousand

four hundred) shares of the Company with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the whole
share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of convening notice right;
2. Approval of the dissolution and liquidation of the Company; and
3. Miscellaneous.

<i>First resolution:

The Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently

informed beforehand on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote
upon all the items of the agenda. The Sole Shareholder resolves further that all the documentation produced to the
meeting has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.

<i>Second resolution:

It is resolved to approve the liquidation of the Company:
- The share capital of the Company is fixed at EUR 360,000 (three hundred and sixty thousand Euro) divided into

14,400 (fourteen thousand four hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each and is entirely
subscribed and fully paid up.

- The Sole Shareholder is the sole owner of all the shares of the Company.
-  The  Sole  Shareholder,  (i)  approves  the  balance  sheet  and  the  profit  and  loss  account  of  the  Company  dated  3

September 2008 attached hereto as schedule A (the "Schedule A"), (ii) gives discharge to the managers of the Company,
i.e. Mr. Carl Speecke, Mr. Benjamin J. Morris and Mrs. Leda Pantaleoni, for the performance of their mandate as managers
of the Company until the holding of the present deed and (iii) declares the anticipated dissolution of the Company with
immediate effect.

- The Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and

deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into
effect the purposes of this act.

The Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the Company does no longer carry out any activity,
(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in

Schedule A, are hereby assigned, transferred and conveyed to the Sole Shareholder, which has acknowledged and con-
sented to this assignment and, in particular, the Sole Shareholder undertakes to ensure, in its capacity as liquidator, that
any formalities required to implement the transfer of any cash at bank owned by the Company are duly complied with;

(iii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described

in Schedule A, are hereby assumed, transferred and conveyed to the Sole Shareholder which has acknowledged and
consented to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly supplied with
and the Sole Shareholder irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of
the dissolved Company;

(iv) the Sole Shareholder will take any required action to transfer the funds that are in the bank account of the Company,

to close the said bank account and fulfil any formality necessary to transfer all the liabilities of the Company, it having
been given all powers to that effect.

28023

- The Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed.
- Discharge is given to the following managers of the Company:
- Mr. Carl Speecke, residing professionally at 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Benjamin J. Morris, residing at 41, East Hill, Oxted Surrey RH8 9AE, United Kingdom; and
- Mrs. Leda Pantaleoni, residing at Via Veneza 27, 40068 San Lazzaro Di Savena, Bologna, Italy.
- The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years in Luxembourg at the former

registered office of the Company, 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg.

The share register of the Company has then been cancelled.
- The general meeting of the sole shareholder of the Company also resolves to grant all powers to Mr. Régis Galiotto,

pre-named and/or any member of Noble &amp; Scheidecker, a law firm established in Luxembourg, in order:

(i) to proceed to the filings and publications as required by Article 151 of the Law of 10 August 1915 concerning

commercial companies as amended;

(ii) to do and to execute any document or notices with respect to the filings and publications referred to here above,

and more generally to do, perform and execute any action or document necessary or simply useful for the purpose of
the closure of the Company's liquidation.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about 1,200.- Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le trois septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "Chloride Luxembourg S.à r.L.", une société

à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L- 1331 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 111.955 (la "Société"), constituée le 17 décembre 2004 par acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, au numéro 431 du 28 février 2006 et modifié en dernier lieu par acte notarié du 31 juillet 2008
établi par Maître Joseph Elvinger, susmentionné, en attente de publication, (la "Société").

A comparu:
L'associé unique de la Société, "Chloride Luxembourg Holdings S.à r.l.", une société constituée sous le droit du Grand-

Duché  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  65,  boulevard  Grand-Duchesse  Charlotte,  L-1331  Luxembourg
(l'"Associé Unique"), représentée par M. Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, dûment
autorisé à agir pour le compte de l'Associé Unique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire soussigné, demeurera annexée

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter que:
I.- Il ressort de la liste de présence, annexée à cet acte et qui sera enregistrée avec lui, que les 14,400 (quatorze mille

quatre cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'ensemble du
capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement statuer sur tous les points figurant
à l'ordre du jour.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Dissolution et liquidation de la Société; et
3. Divers.

<i>Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; il reconnaît

avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte

28024

de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la docu-
mentation produite lors de l'assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin
de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d'approuver la liquidation de la Société:
- Le capital social de la Société fixé à 360,000 EUR (trois cent soixante mille euros) divisé en 14,400 (quatorze mille

quatre cents) parts ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) a été entièrement souscrit et totalement
libéré.

- L'Associé Unique est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
- L'Associé Unique, (i) approuve le bilan et le compte de pertes et profits de la Société daté du 3 septembre 2008, ci-

après annexés comme annexe A (l'"Annexe A"), (ii) donne décharge aux gérants de la Société, c'est-à-dire M. Carl Speecke,
M. Benjamin J. Morris et Mme Leda Pantaleoni, pour les actes accomplis en tant que gérants de la Société jusqu'à la
passation du présent acte et (iii) prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

- L'Associé Unique se désigne lui-même comme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs pour signer,

exécuter et délivrer tous actes et documents, faire toute déclaration et faire tout ce qui est nécessaire ou utile aux fins
du présent acte.

- L'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) la Société n'exerce plus aucune activité;
(ii) tous droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux actifs existants de la Société tels que décrits dans

l'Annexe A, sont alloués, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui reconnaît et consent à cette allocation et, en
particulier, l'Associé Unique se charge de s'assurer que, en sa qualité de liquidateur, toute formalité requise pour la mise
en œuvre du transfert de liquidité sur le compte bancaire de la Société est dûment remplie; et

(iii) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux passifs existant de la Société tels que décrits dans

l'Annexe A, sont alloués, transférés et transmis à l'Associé Unique qui reconnaît et consent à cette allocation;tous les
dettes en relation avec la clôture de la liquidation sont dûment réglées et l'Associé Unique s'engage irrévocablement à
reprendre et à régler toute dette présente ou future, connue ou inconnue, impayée relative à la liquidation de la Société;

(iv) l'Associé Unique prendra toute mesure nécessaire pour transférer les fonds qui se trouvent sur le compte bancaire

de la Société, pour clôturer ledit compte et remplir toute formalité nécessaire au transfert de toutes les dettes de la
Société, tout pouvoir lui ayant été donné à cet effet.

L'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée.
- Décharge est donnée aux gérants de la Société:
- M. Carl Speecke, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- M. Benjamin J. Morris, résidant professionnellement au 41, East Hill, Oxted Surrey RH8 9AE, Grande-Bretagne; and
- Mme. Leda Pantaleoni, résidant au 27 Via Veneza, 40068 San Lazzaro Di Savena, Bologne, Italie.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de 5 (cinq) ans à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société au 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Le registre des parts sociales de la Société a ensuite été annulé.
-  L'assemblée  générale  de  l'Associé  Unique de  la  Société  décide également  d'accorder tous pouvoirs à Mr.  Régis

Galiotto, de l'étude notariale Elvinger, et/ou à tout membre du cabinet d'avocats Noble &amp; Scheidecker, établit à Luxem-
bourg, afin de:

(i) procéder aux dépôts et aux publications requises par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales telle qu'amendée;

(ii) établir ou signer tout document ou notification en rapport avec les dépôts et publications mentionnées ci-dessus

et plus généralement de faire, signer et délivrer tout document ou action, nécessaire ou simplement utile dans le cadre
de la liquidation de la Société.

<i>Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, causé par la Société ou devant être payés par elle

en rapport avec cet acte, ont été estimés à 1.200.-Euros.

Dont Acte,
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué au début du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte.

28025

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 5 septembre 2008. Relation: LAC/2008/36283. Reçu douze euros (€12.-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 18 SEP. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009029081/211/183.
(090031990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Johanns &amp; Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich),

R.C.S. Luxembourg B 47.392.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/02/2009.

<i>Pour Johanns &amp; Cie s.à r.l.
World Hopper s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009028876/1588/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08644. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Alginic S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4137 Esch-sur-Alzette, 41, rue de l'Hôpital.

R.C.S. Luxembourg B 82.574.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/02/2009.

<i>Pour Alginic s.à r.l.
World Hopper s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009028877/1588/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08816. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

HSH Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 107.165.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 22.10.2008

Hiermit wird angezeigt, dass Herr Ralph Chammas, geboren am 2. Juni 1964 in Beirut, mit Wirkung vom 15. September

2008 von seiner Funktion als Geschäftsleiter der HSH Asset Management S.A. zurückgetreten ist.

Der Verwaltungsrat nimmt diesen Rücktritt zur Kenntnis.
Weiterhin wird angezeigt, dass Herr Martin Görnig, geboren am 24. September 1964 in Neumünster, mit Wirkung

vom 28. Juni 2008 von seiner Funktion als Geschäftsführer zurückgetreten ist.

Der Verwaltungsrat nimmt diesen Rücktritt zur Kenntnis.
Weiterhin wird angezeigt, dass Herr Thomas D'Avanzo, geboren am 8. Dezember 1960 in Beacon, United States, mit

Wirkung vom 19. September 2009 von seiner Funktion als Geschäftsführer zurückgetreten ist.

Der Verwaltungsrat nimmt diesen Rücktritt zur Kenntnis.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

28026

Luxemburg, den 05.02.2009.

Für gleichlautenden Auszug
Meinert Riessen / Philipp Graf
<i>Head of Legal &amp; Compliance / Legal &amp; Compliance

Référence de publication: 2009029155/37/24.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06453. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Euro Viti Nature S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 116.530.

EXTRAIT

Il  résulte  du  procès-verbal  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  de  la  société  EURO  VITI  NATURE  S.A.  du  15

décembre 2008 que:

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg

au

32, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 décembre 2008

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Fiduciaire F.O.R.I.G. s.c.
Signature

Référence de publication: 2009028878/1039/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04737. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

Chamäleon und Aktivität S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 89.002.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société CHAMALEON UND AKTIVITÄT SA

du 15 décembre 2008 que:

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg

au

32, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 décembre 2008

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Fiduciaire F.O.R.I.G.s.c.
Signature

Référence de publication: 2009028882/1039/20.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04696. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

World Hopper s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 67.063.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

28027

Luxembourg, le 26/02/2009.

<i>Pour World Hopper s.à r.l.
M. Collignon

Référence de publication: 2009028879/1588/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08808. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

K-Flat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 144.861.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le seize février.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

K-DEVELOPMENT IMMO S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, en

cours d'immatriculation au Registre de Commerce et de publication au Mémorial,

ici représentée par deux de ses administrateurs Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés et Madame

Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, toutes deux demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg,
23, rue Aldringen, habilités à engager la société par leur signature conjointe.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de "K-FLAT S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg ou à l'étranger:
- de prendre des participations directement et/ou indirectement, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit

dans des sociétés créées ou à créer;

- l'achat, la vente, l'achat pour revendre, la promotion, la commercialisation, l'exploitation, la mise en valeur et la

location des biens immobiliers de toute nature;

- et généralement toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales ou financières se rattachant directement

ou indirectement à l'objet de la société ou susceptibles d'en assurer le développement.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par MILLE (1.000) actions

d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

28028

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

28029

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième lundi du mois de juin à 12.45 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionnée ci-avant, déclare

souscrire les mille (1.000) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS

(31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

28030

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant profes-

sionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

b) Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 9 octobre 1959, demeurant profes-

sionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

c) Mademoiselle Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant

professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION S.à r.l., ayant son siège social à "Le Dôme", Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 67.501.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'année 2014.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Mamane, M.-L. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 février 2009. Relation: LAC/2009/6458. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 4 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009029088/220/182.
(090031797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Promo Petrole S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.829.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/02/2009.

<i>Pour PROMO PETROLE S.A.
World Hopper s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009028901/1588/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09475. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

28031

FLGym, Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg F 2.902.

Lors de l'Assemblée Générale tenue le 28 mars 1998 à Esch/Alzette, il a été décidé de changer la dénomination de

l'association en «Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique a.s.b.l.», en abrégé «FLGym».

Par conséquent la première phrase de l'article 1.1. des statuts aura la formulation suivante:

1.1. Dénomination

L'association  porte  la  dénomination  FEDERATION  LUXEMBOURGOISE  DE  GYMNASTIQUE  a.s.b.l,  en  abrégé

«FLGym».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Strassen, le 21 janvier 2009.

Paolo FRISING / Roger NEGRI
<i>secrétaire général / président

Référence de publication: 2009029021/3502/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07017. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090032229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Selrah S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 116.831.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 19 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1506 du 7
août 2006.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Selrah S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009028986/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08194. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Selrah S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 116.831.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 19 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1506 du 7
août 2006.

Les comptes au 31 décembre 2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Selrah S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009028987/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08193. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

28032


Document Outline

Abris Holdings 1

Adviser I Funds

Adviser II Funds

AGFC (Angus Genetic Forest Consulting) S.à r.l.

Alginic S.à.r.l.

Auto Helfent S.A.

Camile S.A.

Canama S.A.

Chamäleon und Aktivität S.A.

Chauffage-Sanitaire Integral S.à r.l.

Chloride Luxembourg S.à r.l.

Crefinimmo

DJB G.m.b.H.

EB Lux S.à r.l.

Equilease International S.A.

Euro Viti Nature S.A.

Falcon Hansa S.à r.l.

Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique a.s.b.l.

Filti S.àr.l.

Garage FEYEREISEN S.à r.l.

Gaviota Re S.A.

Grenache &amp; Cie S.N.C.

Him-Racing-Kart S.à r.l.

HSH Asset Management S.A.

Inpigest S.A.

Johanns &amp; Cie S.à r.l.

J.P. Morgan Real Estate Holdings S.à r.l.

K-Flat S.A.

Lab Document Vault S.A.

Lafin S.A.

Lapraille Dupont Esméralda Chloé s.à r.l.

LBP Luxco GP 2-Resi S.à r.l.

LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l.

LBP Luxco GP 6-Hessen S.à r.l.

Lënster Energie S.à r.l.

Lincoln Electric Luxembourg S.à r.l.

Logoline S.à r.l.

Millenium Investments S.A.

PAC

PCB &amp; CMR S.A.

Promo Petrole S.A.

Sasfin International Fund

Selrah S. à r.l.

Selrah S. à r.l.

Seneca Pool S.A.

Seneca Pool S.A., SICAR

Sensata Management Company S.A.

Société Luxembourgeoise de Construction Métallique

Sofecolux

SOFECOLUX S.A., société de gestion de patrimoine familial

Spido Oil s.à r.l.

S.R.M.I. International S.à r.l.

Tracom S.A.

Valorum S.A.

Viva Gestions Hôtelières S.A.

Viva Gestions Hôtelières S.A.

Viva Gestions Immobilières S.A.

Viva Gestions Immobilières S.A.

Vry SA

Weather Capital Finance

Weather Capital Special Purpose 1 S.A.

World Hopper s.àr.l.

WRCA (Luxembourg) S.à r.l.