This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 473
4 mars 2009
SOMMAIRE
321.ECEP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22703
Ambiente Da Cruz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
22686
Asist Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22690
Belisa International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
22690
B.S. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22704
B.S. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22701
B.S. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22702
B.S. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22701
B.S. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22699
Crédit Suisse Group Finance (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22703
Embafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22695
Factory S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22686
Gomes Granit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22686
GS Lux Debt Holdings III S.à r.l. . . . . . . . . .
22675
HIP Oils S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22695
Inter Republic Holdings S.A. . . . . . . . . . . . .
22687
Kheiron S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22685
Lexion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22694
Livenza S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22690
Lonimag S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22700
LUXAIR, Société Luxembourgeoise de
Navigation Aérienne S.A. . . . . . . . . . . . . . .
22693
Magenta Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22695
Mainstay S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22696
Medsup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22694
Medsup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22696
MS Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22699
MS Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22700
MS Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22701
MS Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22699
New Vital Beauté sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22687
Nimalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22694
Octir International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22689
Packaging Technology Participation S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22684
Polytrinity Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . .
22696
S.A. Luxembourgeoise Mobeuro . . . . . . . .
22683
S.A. Luxembourgeoise Mobeuro . . . . . . . .
22686
Sedgewick Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
22701
Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22699
Strategic Management Sàrl . . . . . . . . . . . . .
22700
Strategic Management Sàrl . . . . . . . . . . . . .
22700
Strategic Management Sàrl . . . . . . . . . . . . .
22702
Strategic Management Sàrl . . . . . . . . . . . . .
22702
Strategic Management Sàrl . . . . . . . . . . . . .
22704
Sydenham Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
22702
Sydenham Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
22658
Verdandi Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
22674
Water Instinct S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22675
Winvest Conseil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22704
22657
Sydenham Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.335.
In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of the month of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of Sydenham Holding S.à r.l., a société
à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of
Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, on 18 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 2805 of 4 December 2007, and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under B-133.335 (the "Company"). The Company's articles of association have not been amended yet.
The meeting was declared open at 06.15 p.m. and was presided by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxem-
bourg.
The chairman appointed Mr Christophe Jolk, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
Mr Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer by the Meeting.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1 To create two (2) classes of shares, the ordinary class A shares (the "Class A Shares") and the preference class B
shares (the "Class B Shares"), and to reclassify the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares of
one Cent (EUR 0.01) each into one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) Class A Shares of one Cent
(EUR 0.01) each and one hundred twenty-five thousand (125,000) Class B Shares of one Cent (EUR 0.01) each.
2 To fully restate the articles of incorporation of the Company, which restatement, next to reflecting the above changes
to the issued capital, shall consist inter alia in adopting the following corporate object:
"The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of interests in
Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such assets and/or
interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation
or which are members of its group of companies.
The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object."
3 Miscellaneous.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list
signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of
the meeting; such attendance list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with
this deed.
III. It appears from the said attendance list that out of the issued share capital of the Company all shares are present
or represented at the meeting. The Meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all
the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present
Meeting.
IV. The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the chairman, by unanimous vote adopted
the following resolution:
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVED to create two classes of shares, the ordinary class A shares (the "Class A Shares") and the
preference class B shares (the "Class B Shares"), and RESOLVED to reclassify the existing one million two hundred fifty
thousand (1,250,000) shares of one Cent (EUR 0.01) each into one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000)
Class A Shares of one Cent (EUR 0.01) each and one hundred twenty-five thousand (125,000) Class B Shares of one Cent
(EUR 0.01) each.
22658
As a result, STEG Emerging Markets Real Estate GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung) incorporated and organised under the laws of Germany, with registered office at Freihamer Straße
2, D-82166 Gräfelfing, Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich under HRB 170
816, is holding all of the Class A Shares, and Tottenham Hale S.à r.l., a private limited liability company (société à res-
ponsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 131.760, is holding all the Class B Shares.
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVED that the articles of association of the Company shall be entirely restated to inter alia reflect
the above resolution, so that these articles shall forthwith read as follows:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of association (the "Articles of Association").
The Company may be composed of one (1) single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but
not exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of "Sydenham Holding S.à r.l.".
Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the
Manager(s).
In the event that in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of
interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such
assets and/or interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds
a participation or which are members of its group of companies.
The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the applicable
laws or by these Articles of Association, as the case may be, for any amendment of these Articles of Association.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented
by one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) fully paid class A ordinary shares (the "Class A Shares") and
one hundred twenty-five thousand (125,000) fully paid class B preferred shares (the "Class B Shares"), each of such Class
A Shares and Class B Shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) (the Class A Shares and the Class B Shares
are collectively referred to as the "Shares" and individually as a "Share").
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any Share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
22659
Art. 6. Shares. Each Share entitles to one (1) vote. Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of
Association of the Company and the resolutions validly adopted by the shareholder(s).
Each Share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of Shares must be represented towards the
Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its Shares. When
the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred (i) freely amongst shareholders and
(ii) to non-shareholders only with the authorisation of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the
issued capital.
The terms and conditions in relation to the transfer of Shares issued by the Company may be agreed in writing by the
shareholders. Transfers shall be made in compliance with any such terms and conditions and with these Articles of
Association. The Company is entitled to refuse to register any transfer of Shares unless transferred in accordance with
these Articles of Association or in accordance with any agreement relating to the transfer of Shares to which the Company
is a party. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law, in view of their immediate
cancellation.
Art. 7. Increase and Reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a reso-
lution of the shareholder(s) voting with the quorum and majority rules set by the applicable laws or by these Articles of
Association, as the case may be, for any amendment of these Articles of Association.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed and administered by one (1) or several managers who need not be
shareholders themselves (the "Manager(s)").
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Manager(s) will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of his/their mandate and his/
their number. The Manager(s) is/are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by
a resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") and
class B Managers (the "Class B Managers").
At general meetings of the shareholders resolving on statutory elections, the holder(s) of Class B Shares are entitled
to propose the qualification of the appointed Managers (if two (2) or more Manager(s) have been appointed) into Class
A Managers and Class B Managers.
The holder(s) of Class B Shares are further entitled to propose the Class B Managers for election or removal, whereas
such Class B Managers will be chosen from a list of candidates presented by the holder(s) of Class B Shares, being
understood that there will be one (1) Class B Manager if two (2) Managers are appointed and not less than one third
(1/3) of the Managers will be Class B Managers if at least three (3) Managers are appointed.
Art. 10. Powers of the managers. The Managers or the Board of Managers, as the case may be, are vested with the
broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles of Association to shareholder(s) are in the competence
of the Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be.
Except as provided in the below fourth paragraph of this article 10 (measures involving affiliates of shareholders), the
Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, shall require the prior consent of shareholders holding at least
ninety percent (90%) of the voting rights in the Company in order to effect the following legal transactions and measures:
(i) the purchase or other acquisition by the Company of any real estate assets or any real estate owning legal entity
and the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the purchase or other acquisition of any real estate
assets or any real estate owning legal entity by any of its direct or indirect subsidiaries (if existing);
(ii) any creation of, pledge, sale or other disposal of shares in the Company's direct or indirect subsidiaries (if existent),
or the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the liquidation of the Company's direct or indirect
subsidiaries;
(iii) any sale or disposal of any real estate asset or portfolio of real estate - either by asset or share deal type of
transaction - or any other material fixed asset held by the Company or the exercise of the Company's shareholder rights
in case the real estate asset, portfolio of real estate or other material fixed asset is held by any of the Company's direct
or indirect subsidiaries (if existing);
22660
(iv) the entering into, amending, prepaying or terminating of any third party loan or shareholder loan and the creation
of any pledge or other encumbrance on such loans;
(v) the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the adoption of or changes to the articles of
association of any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing);
(vi) the establishment or closure of branch offices;
(vii) the acquisition, disposal or encumbrance of participations in other enterprises, including silent participations, the
exercise of the Company's shareholder rights with respect to acquisition, disposal or encumbrance of participations in
other enterprises, including silent participations by any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing);
(viii) the acquisition or disposal of businesses or parts of businesses; and
(ix) the granting of proxies by the Company to the benefit of any person to execute a sale and purchase agreement
regarding the sale and transfer of shares in a subsidiary of the Company; and
(x) the exercise of the Company's shareholders rights with respect to the execution, termination or amendment of
any center management or other material service agreement by the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing).
If the contemplated measure under the above third paragraph involves the Company and/or any of its direct or indirect
subsidiaries on the one hand and a shareholder of the Company and/or any of its affiliates on the other hand, then the
Manager(s) or as the case may be the Board of Managers shall in deviation of the above third paragraph require the prior
consent of both the involved shareholder(s) of the Company and of those non-involved shareholder(s) of the Company
holding at least ninety percent (90%) of the voting rights of all non-involved shareholder(s) in the Company in order to
effect such contemplated legal transaction or measure.
In the event that upon fulfilment of the Forward Funding/Purchase Criteria, such fulfilment having been duly acknow-
ledged by the shareholder(s) resolving with simple majority, the holder of Class B Shares reasonably estimates that the
distribution of the consideration agreed on with the purchaser for (a) the transfer of all or any shares in a subsidiary of
the Company; or, as the case may be, (b) the disposition of a real estate project by a subsidiary, would allow each holder
of Class A Shares to receive dividend payments distributed in accordance with Article 24 below in an amount at least
equal to the aggregate of the Invested Capital of such Shareholder and its Preferred Return I (25% IRR) thereon, then
the Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, require only the prior consent of the holder(s) of Class B
Shares, but of no other shareholders, in order to effect the following legal transactions and measures:
(a) the disposal and transfer of all or any shares in a subsidiary of the Company; and
(b) the exercise of the Company's shareholder rights in a subsidiary of the Company with respect to a whole or partial
sale of the real estate project by such subsidiary; and
(c) the granting of proxies by the Company to the benefit of any person to execute a sale and purchase agreement
regarding the sale and transfer of shares in a subsidiary of the Company,
provided that notwithstanding the foregoing, if the contemplated legal transaction or measure involves the Company
and/or an affiliate of the Company on the one hand and holder(s) of Class B Shares and/or any of its/their affiliates on the
other hand, then the Manager(s) or as the case may be the Board of Managers require in addition to the prior consent
of the holder(s) of Class B Shares the prior consent of non-involved shareholders holding at least ninety percent (90%)
of the voting rights of all non-involved shareholders in the Company in order to effect such contemplated legal transaction
or measure.
For the avoidance of doubt, all other acts necessary or useful for accomplishing the Company's object will not be
subject to shareholders' consent, except for those legal transactions and measures listed under items (i) to (x) above
which will continue to require prior shareholder(s) consent of shareholder(s) holding at least ninety percent (90%) of the
voting rights in the Company even after fulfilment of the Forward Funding / Purchase Criteria insofar they are not covered
by items (a) to (c) above.
Art. 11. Meetings of the board of managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) days written
notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place and the agenda of the
meeting. Any Manager may waive his right to be convened as set out above. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office or at such other place as the Board of
Managers may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.
22661
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of half (1/2) of the Managers holding
office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, such
quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One (1) or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several Managers.
Art. 12. Recording of the resolutions of the managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one (1) Manager has been appointed.
Art. 13. Management fees and Expenses. Subject to the approval of the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by him/them in relation with such management of the Company or the pursuit
of the Company's corporate object.
Art. 14. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any Manager is only liable for the performance
of his duties.
The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the relevant
Manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one (1) or more of the Managers or any officer of the Company has
a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Any person
related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that one (1) or more of the Managers of the Company have or may have any
personal interest in any transaction of the Company, they shall make known to the other Manager(s) such personal
interest. The conflicted Manager(s) shall not consider or vote on any such transaction and such transaction and such
Managers' interest therein shall be reported to the shareholder(s).
The foregoing provisions do not apply if and when the relevant transaction is entered into under fair market conditions
and falls within the ordinary course of business of the Company.
Art. 16. Representation of the company - Delegation of powers. The Company will be bound towards third parties
by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two (2) Manager(s) if more than one (1)
Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers and Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.
The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to
persons or committees chosen by them.
The Company will also be bound by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory
power has been delegated, but only within the limits of such power
Art. 17. Auditors. Except where according to the laws the Company's annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
22662
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one (1) or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.
The auditors, if any, will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of their mandate. The
auditors are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the
shareholder(s).
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one (1) single shareholder, the latter exer-
cises the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law are
not applicable to that situation.
If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions
of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions can be documented in a single document or in several
separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several shareholder(s). Should the
resolutions to be adopted, be sent by the Manager(s) to the shareholders, the shareholders are under the obligation to,
within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolutions, cast their written vote and
return it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum
and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis
mutandis apply to the adoption of written resolutions.
Unless there is only one (1) single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon
issuance of a convening notice sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting by the Manager(s), the
auditors or shareholders representing half (1/2) of the corporate capital. The convening notice will specify the time and
place and the agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting should be held in the Grand Duchy of Lu-
xembourg. They may be held abroad if circumstances of force majeure so require.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Powers of the shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to
the Law and these Articles of Association.
Art. 20. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders to be held in case the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such
other place in the Grand Duchy of Luxembourg, as may be specified in the notice convening the meeting, at the latest
within six (6) months after the close of the financial year.
If such day is a day on which banks are not open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next
following Business Day.
Art. 21. Procedure and Vote at meetings. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder, as his
proxy.
Any resolution the purpose of which is to amend the present Articles of Association or the adoption of which is subject
by virtue of the applicable laws or these Articles of Association, as the case may be, to the quorum and majority rules
set for the amendment of the Articles of Association, will be taken by (i) a majority of shareholders in number (ii)
representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Except as otherwise required by the applicable laws or by the present Articles of Association, all other resolutions
will be taken by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first
meeting or consultation in writing, the shareholders shall be convened or consulted a second time and resolutions will
then be taken by a majority of the votes cast notwithstanding the proportion of the capital represented.
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present or their proxyholders
or by the chairman, the secretary and the scrutineer of the meeting if such a bureau has been appointed.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s), as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one (1) Manager has been appointed.
22663
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 22. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 23. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s)
draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
applicable laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 24. Appropriation of profits. From the net profits of the Company, five per cent (5%) shall each year be allocated
to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
The shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to
allocate the whole or part of the remainder to a reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s) as
dividend, each Share entitling to the same proportion in such distributions before the Forward Funding / Purchase Criteria
are met, or, in accordance with the following rules set out in items (iii) to (x) below (subject to prior payment of the
amounts referred to in sections (i) and (ii) below to the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s)), upon
fulfilment of the Forward Funding / Purchase Criteria (such fulfilment having been duly acknowledged by the shareholder
(s) resolving with simple majority):
(i) to the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) an amount equal to the then drawndown and not yet
repaid amounts under any shareholder loans granted to the Company from time to time by the Class A Shareholder(s)
and the Class B Shareholder(s) in proportion to the then drawndown and not yet repaid amounts under their respective
shareholder loans; thereafter
(ii) to the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) an amount corresponding to the interest accrued
and not yet paid under its/their shareholder loan(s); thereafter
(iii) to all shareholders an amount equal to their capital contributions in proportion to their capital contributions
whereby any dividends previously received by the relevant shareholder from the Company, if any, shall be taken into
account and shall accordingly reduce the entitlement of the relevant shareholder under this subsection (iii); thereafter
(iv) to the Class B Shareholder(s) until the Class B Shareholder(s) has/have received under this subsection (iv) an
amount equal to twelve percent (12%) of the effective net construction and related costs (without value added tax)
actually incurred in relation to the completion of the Company's direct or indirect real estate holding(s) as further
determined pursuant to the terms agreed from time to time in writing by the shareholders, whereby any dividends
previously received by the relevant Shareholder from the Company, if any, that have not already been taken in account
under this Article 24 shall be taken into account under this subsection and shall accordingly reduce the entitlement of
the relevant Shareholder under this subsection (iv); thereafter
(v) to the Class B Shareholder(s) until the Class B Shareholder(s) has/have received under this subsection (v) an amount
equal to zero point seventy-five percent (0.75%) of the base completion value of the Company's direct or indirect real
estate holding(s) as further determined pursuant to the terms agreed from time to time in writing by the shareholders,
whereby any dividends previously received by the relevant Shareholder from the Company, if any, that have not already
been taken in account under this Article 24 shall be taken into account under this subsection and shall accordingly reduce
the entitlement of the relevant Shareholder under this subsection (v); thereafter
(vi) to the Class A Shareholder(s) until the Class A Shareholder(s) has/have received under consideration of the interest
payments under its/theirs shareholder loan(s) an Internal Rate of Return of twenty-five percent (25%) per annum on its/
their Invested Capital (the "Preferred Return I"); thereafter
(vii) to the Class B Shareholder(s) as promote until the Class B Shareholder(s) has/have received, considering the
payments under its/their shareholder loan(s), an amount equal to thirty percent (30%) of the sum of (a) the amount
distributed to the Class A Shareholder(s) as Preferred Return I under the preceding subsection (vi) plus (b) the amount
distributed to the Class B Shareholder under this subsection (vii); thereafter
(viii) seventy percent (70%) to the Class A Shareholder(s) and thirty percent (30%) to the Class B Shareholder(s) as
promote until the Class A Shareholder(s) has/have received under consideration of the amounts paid to it/them as
Preferred Return I an Internal Rate of Return of thirty percent (30%) per annum on its/their Invested Capital (the amount
paid to the Class A Shareholder(s) under this subsection being the "Preferred Return II"); thereafter
(ix) to the Class B Shareholder(s) as promote until it/they has/have received, considering the payments under its/their
shareholder loan(s) and the amounts paid to it/them as its/their promote under this Article 24, an amount equal to thirty-
five percent (35%) of the aggregate amount distributed to the Class A Shareholder(s) as Preferred Return I and Preferred
22664
Return II hereunder and the amounts distributed to the Class B Shareholder(s) as promote under subsections (vii) - (ix)
hereunder; thereafter
(x) sixty-five percent (65%) to the Class A Shareholder(s) and thirty-five percent (35%) to the Class B Shareholder(s).
Subject to the conditions fixed by the Law, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The Manager
(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment, always in compliance with and so as to achieve
on an aggregate basis the same economic result as the rules set out in the second paragraph, (i) to (x), above.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s), voting with the
same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Association, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the managers or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the remainder
of the Company's net assets shall be distributed to the shareholder(s) in conformity with and so as to achieve on an
aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out in Article 24, second paragraph (i) to (x), of
the present Articles of Association.
Chapter VII. Applicable law
Art. 26. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance
with the Law.
Chapter VIII. Definitions
Art. 27. Definitions. In addition to the terms defined elsewhere in the present Articles of Association, the capitalised
terms defined below apply throughout the present Articles of Association and these capitalised terms have the meaning
set forth below:
"Business Day" means a day except a Saturday, Sunday or public holiday on which banks are generally opened for
business in the city of Luxembourg.
"Forward Funding / Purchase Criteria" means the cumulative criteria to be fulfilled regarding the development of a real
estate project, such criteria including registrations of the relevant plots of land with the competent land registers, the
receipt of construction permits from the competent local building authorities and the existence of certain pre-lease
agreements.
"Invested Capital" means the balance, as determined from time to time, of the amount invested (whether in form of
an equity contribution or advanced under a shareholder loan) by any shareholder in the Company and not yet returned
by the Company, whereby any dividend distributions received by a shareholder from the Company shall reduce the
amount of such shareholder's Invested Capital accordingly;
"Law" means the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended from time to time;
"Internal Rate of Return" or "IRR" means the annual percentage rate of return, being that annual discount rate which
when applied to the Shareholder Cashflows produces a net present value of those Shareholder Cashflows equal to zero,
on the basis that the rate of return is treated as compounding quarterly, calculated using the XIRR (XINTZINSFUSS)
formula in Microsoft Excel.
"Shareholder Cashflows" means all Shareholder cash inflows and outflows to and from the Company such as, but not
limited to, capital investments, loans, income receipts, interests on loans, redemption proceeds, liquidation profits or
losses and repayments of capital and loans, provided that any fees paid by the Company in accordance with any agreement
relating to the fee arrangements to which the Company is a party shall not be considered for such purpose.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at two thousand five hundred euro.
There being no other business on the agenda, the meeting was closed at 06.30 p.m.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendacht, am neunzehnten Tag des Monats Dezember.
22665
vor Uns, Maître Jean-Joseph Wagner, Notar, mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung (die "Versammlung") der Gesellschaft Sydenham Holding S.à
r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 46A, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde vom 18. Oktober 2007
aufgenommen durch Maître Paul Bettingen, Notar, mit Amtssitz in Niederanven, und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, vom 4. Dezember 2007 unter der Nummer 2805, und eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-133.335 (die "Gesellschaft"), statt. Der Gesellschaftsvertrag wurde
bis dato noch nicht abgeändert.
Die Versammlung wurde um 18.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in
Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende ernennt Herrn Christophe Jolk, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer der Ver-
sammlung.
Herr Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, wird zum Stimmenzähler ernannt.
Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1 Schaffung von zwei (2) Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Stammgesellschaftsanteile der Klasse A (die "Gesell-
schaftsanteile der Klasse A"), und die Vorzugsgesellschaftsanteile der Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B")
und Neueinteilung der existierenden eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem
Nennwert von einem Euro-Cent (EUR 0,01), in eine Million einhundertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) Gesellschafts-
anteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) und einhundertfünfundzwanzigtausend
(125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01).
2 Vollständige Neuformulierung der Gesellschaftssatzung um die oben erwähnten Abänderungen des Gesellschafts-
kapitals wiederzugeben und um, inter alia, folgenden Gesellschaftszweck festzulegen:
"Der Gesellschaftszweck umfasst (i) die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Vermögenswerten und/oder
Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung
solcher Vermögenswerte und/oder Beteiligungen sowie (iii) die unmittelbare und/oder mittelbare finanzielle Unterstüt-
zung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder die Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind.
Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere (i) den Erwerb mittels Zeichnung, Kauf, Tausch oder auf jegliche
andere Weise von Aktien, Anteilen oder anderen Anspruch auf Dividende vermittelnden Wertpapieren, Schuldver-
schreibungen, Anleihen, Einlagenzertifikaten und anderen Schuldinstrumenten und, ganz allgemein, von Wertpapieren und
Finanzinstrumenten, die Eigentumsrechte, Forderungen oder übertragbare Instrumente verbriefen, die von einem privaten
oder öffentlichen Emittenten ausgegeben wurden; (ii) die Ausübung aller mit diesen Wertpapieren und Finanzinstrumen-
ten verbundenen Rechte; (iii) die direkte und/oder indirekte finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist oder welche Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind, und zwar insbesondere mittels der Gewährung
von Darlehen, Finanzhilfen und Sicherheiten jeglicher Form und Laufzeit sowie jegliche sonstige Unterstützung, beispiels-
weise durch Beratung; (iv) die Gewährung von Darlehen und/oder die private Ausgabe von Schuldtiteln in jeglicher Form;
und (v) die Vornahme von Geschäften jeglicher Art, ob kommerzieller, industrieller oder finanzieller Natur, betreffend
bewegliche oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen."
3 Sonstiges.
II. Die Namen der Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile sind in einer Anwesenheitsliste
aufgeführt, welche von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter sowie von
den Mitgliedern des Versammlungsvorstands unterzeichnet wird; die vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die jeweiligen
Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser einregistriert zu werden.
III. Aus der vorliegenden Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesell-
schaftskapital repräsentieren, anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammenge-
treten und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung, über die die anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter in Kenntnis gesetzt worden sind, abstimmen.
IV. Nach Einführung durch den Vorsitzenden fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST die Schaffung von zwei (2) Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Stammgesellschafts-
anteile der Klasse A (die "Gesellschaftsanteile der Klasse A") und die Vorzugsgesellschaftsanteile der Klasse B (die
"Gesellschaftsanteile der Klasse B") und die Neueinteilung der existierenden eine Million zweihundertfünfzigtausend
(1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) in eine Million einhun-
dertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-
Cent (EUR 0,01) und einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert
von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01).
22666
Folglich hält STEG Emerging Markets Real Estate GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts,
mit Sitz in Freihamerstrasse 2, D-82166 Gräfelfing, Deutschland, und im Handelsregister des Münchner Amtsgerichtes
unter HRB 170 816 eingetragen, alle Gesellschaftsanteile der Klasse A, und Tottenham Hale S.à r.l., eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 46A, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B-131.760, hält alle
Gesellschaftsanteile der Klasse B.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST die Abänderung der Gesellschaftssatzung um, inter alia, den oben genannten Beschluss
wiederzugeben. Der Wortlaut der Gesellschaftssatzung ist fortan folgender:
Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die "Gesellschaft") gegründet, die
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und den Bestimmungen der vorliegenden Gesellschaftssatzung unterliegt
(die "Gesellschaftssatzung").
Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren
Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.
Der Name der Gesellschaft ist "Sydenham Holding S.à r.l.".
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der registrierte Gesellschaftssitz befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des/der Geschäftsführer/s oder des Geschäftsführungsrats an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss des/der Geschäftsführer/s im
Großherzogtum Luxemburg gegründet werden.
Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-
scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung
der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vo-
rübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von dem/den Geschäftsführer/n durchzuführen und interessier-
ten Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst (i) die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von
Vermögenswerten und/oder Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung,
Entwicklung und Betreuung solcher Vermögenswerte und/oder Beteiligungen sowie (iii) die unmittelbare und/oder mit-
telbare finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder die Teil ihrer
Gesellschaftsgruppe sind.
Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere (i) den Erwerb mittels Zeichnung, Kauf, Tausch oder auf jegliche
andere Weise von Aktien, Anteilen oder anderen Anspruch auf Dividende vermittelnden Wertpapieren, Schuldver-
schreibungen, Anleihen, Einlagenzertifikaten und anderen Schuldinstrumenten und, ganz allgemein, von Wertpapieren und
Finanzinstrumenten, die Eigentumsrechte, Forderungen oder übertragbare Instrumente verbriefen, die von einem privaten
oder öffentlichen Emittenten ausgegeben wurden; (ii) die Ausübung aller mit diesen Wertpapieren und Finanzinstrumen-
ten verbundenen Rechte; (iii) die direkte und/oder indirekte finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist oder welche Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind, und zwar insbesondere mittels der Gewährung
von Darlehen, Finanzhilfen und Sicherheiten jeglicher Form und Laufzeit sowie jegliche sonstige Unterstützung, beispiels-
weise durch Beratung; (iv) die Gewährung von Darlehen und/oder die private Ausgabe von Schuldtiteln in jeglicher Form;
und (v) die Vornahme von Geschäften jeglicher Art, ob kommerzieller, industrieller oder finanzieller Natur, betreffend
beweglicher oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des (der) Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit
dem nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird.
Kapitel II. Kapital, Gesellschaftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt,
eingeteilt in eine Million einhundertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) voll eingezahlte Stammgesellschaftsanteile der
Klasse A ("Gesellschaftsanteile der Klasse A") und hundertfünfundzwanzigtausend (125.000) voll eingezahlte Vorzugsge-
sellschaftsanteile der Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B"); alle Gesellschaftsanteile der Klasse A und
Gesellschaftsanteile der Klasse B haben einen Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) (Gesellschaftsanteile der
22667
Klasse A und Gesellschaftsanteile der Klasse B werden gemeinsam als "Gesellschaftsanteile" bezeichnet und einzeln als
"Gesellschaftsanteil").
Zusätzlich zu dem genannten Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emis-
sionsaufgelder, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag
dieses internen Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurück-
erwirbt, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die jeweilige Anteilsklasse oder zur Einbringung
in die gesetzlichen Rücklagen verwendet werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschaftsanteil verleiht Anrecht auf eine (1) Stimme. Das Eigentum eines Ge-
sellschaftsanteils bewirkt automatisch die implizite Annahme der Gesellschaftssatzung und der regulär gefassten Be-
schlüsse der Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschafts-
anteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen (1) einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein
Dritter sein kann, vertreten lassen.
Hat die Gesellschaft nur einen (1) Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft
mehrere Gesellschafter, können die Gesellschaftsanteile (i) frei zwischen den Gesellschaftern übertragen werden und (ii)
Nicht-Gesellschaftern können Gesellschaftsanteile nur mit Erlaubnis einer Mehrheit von Gesellschaftern die mindestens
drei Viertel (3/4) des gezeichneten Kapitals darstellt, zugeteilt werden.
Die genauen Bedingungen betreffend die Übertragung der Gesellschaftsanteile können schriftlich von den Gesellschaf-
tern festgelegt werden. Alle Übertragungen erfolgen im Einklang mit diesen Bedingungen sowie der Gesellschaftssatzung.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Übertragung von Gesellschaftsanteilen zu verweigern, es sei denn, die
Übertragung erfolgt im Einklang mit der Gesellschaftssatzung oder anderen vertraglichen Regelungen bezüglich der Über-
tragung von Gesellschaftsanteilen, zu denen die Gesellschaft eine Partei ist. Der Nachweis der Übertragung von
Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.
Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß
Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder
von dieser anerkannt wurde.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.
Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Zur Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschaftska-
pitals sind die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit zu erfüllen, die in der vorliegenden Gesell-
schaftssatzung oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung der vorliegenden Gesellschaftssatzung
vorgesehen sind.
Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird weder durch die
Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das die Gesellschafter
betrifft, aufgelöst.
Kapitel III. Geschäftsführer, Kommissare
Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern, die
nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").
Wenn zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen zu verwalten.
Wenn mehr als zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft als Geschäftsfüh-
rungsrat (der "Geschäftsführungsrat") zu führen.
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine be-
stimmte oder unbestimmte Dauer bestellt. Er/sie ist/sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
Der/die Gesellschafter können die Geschäftsführer in Geschäftsführer der Klasse A (die "Geschäftsführer der Klasse
A") und Geschäftsführer der Klasse B (die "Geschäftsführer der Klasse B") einteilen.
An einer Gesellschafterversammlung, welche über satzungsmäßige Bestellungen zu befinden hat, ist/sind der/die Ei-
gentümer der Gesellschaftsanteile der Klasse B befugt, die Einteilung der Geschäftsführer (wenn zwei (2) oder mehr als
zwei (2) Geschäftsführer bestellt wurden) in Geschäftsführer der Klasse A und Geschäftsführer der Klasse B vorzuschla-
gen.
Der/die Eigentümer der Gesellschaftsanteile der Klasse B ist/sind weiterhin befugt, Geschäftsführer der Klasse B zur
Wahl oder Entlassung vorzuschlagen, wobei die Geschäftsführer der Klasse B von einer Kandidatenliste, welche von dem/
den Eigentümern der Gesellschaftsanteile der Klasse B vorgelegt wurde, bestellt werden; hierbei ist sicherzustellen, dass
ein (1) Geschäftsführer der Klasse B ernannt wird wenn insgesamt zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden, und nicht
weniger als ein Drittel (1/3) der Geschäftsführer der Klasse B sind, wenn insgesamt mindestens drei (3) Geschäftsführer
ernannt werden.
22668
Art. 10. Befugnisse der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführungsrat sind mit den
weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung vorzunehmen, welche für die Ausführung des Gesell-
schaftszweckes notwendig oder dienlich ist.
Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch die vorliegende Gesellschaftssatzung ausdrücklich dem
Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsfüh-
rers, der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats.
Vorbehaltlich der Vorschriften von Artikel 10, Absatz 4, (Maßnahmen betreffend Tochtergesellschaften der Gesell-
schafter), benötigt/benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat eine vorherige Genehmigung der
Gesellschafter, welche mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte halten, um folgende Transaktionen und Maß-
nahmen durchzuführen:
(i) den Kauf oder Erwerb auf sonstige Weise von Immobilien oder von Beteiligungen an juristischen Personen, die
Immobilien besitzen, sowie die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft hinsichtlich des Kaufs oder
Erwerbs von Immobilien oder von Beteiligungen an juristischen Personen, die Immobilien besitzen, durch unmittelbare
oder mittelbare Tochtergesellschaften (sofern solche existieren);
(ii) die Ausgabe, die Verpfändung, der Verkauf oder die anderweitige Übertragung der Anteile an unmittelbaren oder
mittelbaren Tochtergesellschaften (sofern solche existieren), oder die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die
Gesellschaft im Rahmen der Abwicklung unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
(iii) der Verkauf oder die anderweitige Übertragung, im Rahmen eines Asset- beziehungsweise Share-Deals, einer
Immobilie, eines Immobilienportfolios oder eines sonstigen Gegenstandes aus dem Anlagevermögen der Gesellschaft
beziehungsweise die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft wenn sich diese Immobilie, dieses Im-
mobilienportfolio oder dieser Gegenstand aus dem Anlagevermögen im Besitz einer unmittelbaren oder mittelbaren
Tochtergesellschaft der Gesellschaft befinden (sofern solche existieren);
(iv) der Abschluss, die Abänderung, Vorauszahlung oder Beendigung von Darlehensverträgen mit Dritten oder Ge-
sellschaftern und die Verpfändung oder Schaffung von anderen Sicherheiten hinsichtlich solcher Darlehensforderungen;
(v) die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft zwecks Annahme oder Abänderung der Satzungen
unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften der Gesellschaft (falls solche existieren);
(vi) die Errichtung oder Schließung von Zweigniederlassungen;
(vii) der Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, einschließlich stiller
Beteiligungen, die Ausübung der Gesellschafterrechte der Gesellschaft hinsichtlich des Erwerbs, der Veräußerung oder
der Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, einschließlich stiller Beteiligungen, durch unmittelbare oder
mittelbare Tochtergesellschaft der Gesellschaft (falls solche existieren);
(viii) der Erwerb oder die Schließung von Geschäftsbetrieben oder von Teilen solcher Geschäftsbetriebe;
(ix) die Gewährung von Vollmachten an jedermann um Verträge über den Verkauf und die Übertragung von Anteilen
an Tochtergesellschaften der Gesellschaft abzuschließen; und
(x) die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft hinsichtlich des Abschlusses, der Beendigung oder
Änderung von Verträgen zur Hauptverwaltung oder anderer materieller Dienstleistungsverträge durch unmittelbare oder
mittelbare Tochtergesellschaft der Gesellschaft (falls solche existieren).
Wenn an einer unter Absatz drei beabsichtigen Maßnahme die Gesellschaft und/oder irgendeine ihrer unmittelbaren
oder mittelbaren Tochtergesellschaften einerseits und ein Gesellschafter der Gesellschaft und/oder irgendeine seiner
Zweiggesellschaften andererseits beteiligt ist, benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat in Ab-
weichung von Absatz drei die vorherige Zustimmung des/der beteiligten Gesellschafter(s) der Gesellschaft und der nicht
beteiligten Gesellschafter, die mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte aller nicht beteiligten Gesellschafter
halten, um die beabsichtigte Maßnahme durchzuführen.
Wenn bei Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien, die durch eine einfache Mehrheit der Gesellschafter aner-
kannt wurde, der Gesellschafter der Klasse B vernünftigerweise annimmt, dass die Ausschüttung der Gegenleistung, die
mit dem Käufer vereinbart wurde für (a) die Übertragung aller oder einiger Gesellschaftsanteile in einer Tochtergesell-
schaft der Gesellschaft oder in der Gesellschaft, oder für (b) die Verfügung über ein Immobilienprojekt durch eine
Tochtergesellschaft, an jeden Gesellschafter der Klasse A eine Dividendenzahlung gemäß Artikel 24 in Höhe eines Betrages
erlaubt, der mindestens der Summe des Investierten Kapitals eines solchen Gesellschafters und seines Bevorzugten Er-
trages I (25% IZF) darauf entspricht, so benötigten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat nur die
Zustimmung des/der Gesellschafter der Klasse B, aber nicht der anderen Gesellschafter, um die folgenden Rechtsgeschäfte
und Maßnahmen durchzuführen:
(a) die Verfügung über und die Übertragung aller oder einiger Gesellschaftsanteile an einer Tochtergesellschaft;
(b) die Ausübung der Rechte der Gesellschaft als Gesellschafterin einer Tochtergesellschaft hinsichtlich des vollstän-
digen oder teilweisen Verkaufs von Grundeigentum durch eine solche Tochtergesellschaft; und
(c) die Gewährung von Vollmachten durch die Gesellschaft an jedermann um Verträge über den Verkauf und die
Übertragung von Anteilen an Tochtergesellschaften der Gesellschaft abzuschließen.
Gleichwohl, wenn die Gesellschaft und/oder irgendeine ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften einerseits
und ein Gesellschafter der Gesellschaft und/oder irgendeine seiner Zweiggesellschaften andererseits an der beabsichtigten
22669
Maßnahme beteiligt sind, benötigt/benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat zusätzlich zu der
vorherigen Zustimmung der Gesellschafter der Klasse B die vorherige Zustimmung des/der beteiligten Gesellschafter(s)
der Gesellschaft und der nicht beteiligten Gesellschafter, die mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte aller
nicht beteiligten Gesellschafter halten, um die beabsichtigte Maßnahme durchzuführen.
Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgestellt, dass alle anderen Maßnahmen, die für die Erfüllung des Gesellschafts-
zweckes notwendig oder nützlich sind, nicht der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, mit Ausnahme der Maßnahmen
und Rechtsgeschäfte, die oben unter Punkt (i) bis (x) aufgelistet sind, die weiterhin die Zustimmung von Gesellschaftern
benötigen, die mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte in der Gesellschaft halten, auch nach Erfüllung der
Finanzierungs-/Erwerbskriterien, sofern sie nicht von den Punkten (a) bis (c) erfasst werden.
Art. 11. Sitzungen des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende
Regeln:
Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende") benennen. Er kann auch einen
Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Aufnahme der Sitzungspro-
tokolle des Geschäftsführungsrates sowie der Gesellschafterversammlungen zuständig ist (der "Schriftführer").
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen
des Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit
gewährleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung angeben. Jeder Geschäftsführer kann auf seine Einberufung wie oben ausgeführt verzichten. Für Sitz-
ungen, deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine
gesonderte Benachrichtigung erforderlich.
Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-
führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-
schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt.
Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner
amtierenden Mitglieder, wobei im Falle einer der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Ge-
schäftsführer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend sein muss.
Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrates gefasst.
Ein (1) oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschal-
tung oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellt,
teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.
Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in
einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem (1) oder
mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.
Art. 12. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse des/der Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.
Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-
weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn
mehr als ein (1) Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.
Art. 13. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den/die Gesellschafter, kann/können der/die
Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus können
den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des Gesell-
schaftszweckes getätigt wurden, zurückerstattet werden.
Art. 14. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die Geschäftsführer trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich
der aufgrund ihrer Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen. Geschäftsführer sind für die Ausführung
ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-
lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses entstanden sind, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäfts-
führer, Angestellter oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft
für eine andere Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der
gegenüber er nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober
Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich
umfasste Fragen gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der
22670
freizustellenden Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht
zur Freistellung schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.
Art. 15. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner
anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein (1) oder mehrere Ge-
schäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt sind,
oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte oder Angestellte einer solchen Gesellschaft oder Firma sind. Keine
Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft
vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge
oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Gleichwohl, wenn ein Geschäftsführer der Gesellschaft oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches
Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäftsfüh-
rern anzeigen. Er darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen und das Rechtsgeschäft und das
Interesse des Geschäftsführers sind dem/den Gesellschafter(n) bei der nächsten Gesellschafterversammlung anzuzeigen.
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Marktbe-
dingungen eingegangen wurde und in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.
Art. 16. Vertretung der Gesellschaft - Delegation von Befugnissen. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die
alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein (1) Geschäftsführer ernannt worden ist,
durch die gemeinsame Unterschriften von zwei (2) Geschäftsführern, gebunden.
Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben
(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer
B gemeinsam unterzeichnen.
Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die
von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen
gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-
schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer, welche
nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.
Die Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die Gesellschafter ernannt, die ihre Anzahl und die Dauer
ihres Mandats festlegen. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne
Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
Kapitel IV. Gesellschafter
Art. 18. Generalversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem (1) Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse
aus, die per Gesetz der Generalversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes finden diesbezüglich
keine Anwendung.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, können die Be-
schlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche Beschlüsse können in einem einzigen
Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem (1) oder mehreren Ge-
sellschaftern unterzeichnet, festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern an die Gesell-
schafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen seit dem
Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes,
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Bestimmungen zur Beschlussfähig-
keit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sind sinngemäß auf die Be-
schlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.
Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die Gesellschafter auch auf ein Einberufungsschreiben hin
versammeln, das durch Einschreiben acht (8) Tage vor der Versammlung durch die Geschäftsführer, die Wirtschaftsprüfer
oder durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren, versandt wurde. Das an
die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesellschafterver-
sammlung an.
Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über
die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, sollen in Luxemburg abgehalten werden.
Sie können im Ausland abgehalten werden, wenn Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.
Jede regulär einberufene Gesellschafterversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter.
22671
Art. 19. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz
zustehen.
Art. 20. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die abzuhalten ist wenn die Gesell-
schaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt, wird am Gesellschaftssitz der Gesellschaft oder einem anderen,
im Einberufungsschreiben benannten Ort des Großherzogtums Luxemburg binnen sechs (6) Monaten nach Ende des
Geschäftsjahres abgehalten.
Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-
genden Werktag abgehalten.
Art. 21. Verfahren, Wahl. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme- und Re-
derecht.
Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.
Jeder Beschluss zum Zwecke der Satzungsänderung oder dessen Feststellung aufgrund der vorliegenden Gesellschafts-
satzung oder des Gesetzes den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegt,
muss (i) von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des gesamten
Gesellschaftskapitals vertreten.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der anwendbaren Gesetze oder der vorliegenden Gesellschaftssatzung
werden bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von Beschlüssen, die
den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, Beschlüsse von Gesellschaf-
tern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-
schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Anteile, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern oder deren Bevollmächtigten
oder durch den Vorsitzenden, den Schriftführer und den Stimmenzähler der Gesellschafterversammlung, falls ein solches
Komitee vorgesehen wurde, unterzeichnet.
Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter
unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls
der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein (1) Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Gewinnverteilung
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 23. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die
Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter oder dessen Bevollmächtigter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Be-
steht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne
von fünfzehn (15) Kalendertagen bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 24. Ausschüttung und Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent
(5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage
die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-
winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-
jahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die
Gesellschafter ausschütten. Hierbei berechtigt jeder Anteil vor der Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien in
gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung. Nach Zahlung der Beträge gemäß (i) und (ii) an die
Gesellschafter der Klasse A und an die Gesellschafter der Klass B und nach Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien
sind die Gesellschafter gemäß den unter (iii) bis (x) dargelegten Regeln zur Teilnahme an einer Ausschüttung berechtigt
(wobei die Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien durch die Gesellschafter mit einfacher Mehrheit anerkannt
worden sein muss):
(i) Gesellschafter der Klasse A und Gesellschafter der Klasse B sind in Höhe des Betrages berechtigt, der von der
Gesellschaft aufgrund von Gesellschafterdarlehen, wie sie der Gesellschaft von Zeit zu Zeit durch Gesellschafter der
22672
Klasse A und Gesellschafter der Klasse B gewährt werden, in Anspruch genommen aber noch nicht zurückgezahlt wurde;
hiernach sind berechtigt:
(ii) Gesellschafter der Klasse A und Gesellschafter der Klasse B in Höhe des Betrages der für ihre Gesellschafterdar-
lehen angefallenen und nicht ausgezahlten Zinsen; danach sind berechtigt
(iii) alle Gesellschafter in Höhe des Betrages ihrer Kapitaleinlage im Verhältnis ihrer Kapitaleinlage wobei alle bisher
an den jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft gezahlten Dividenden angerechnet werden und die Höhe des Be-
trages, zu dem der Gesellschafter gemäß diesem Unterabsatz (iii) berechtigt ist, entsprechend reduzieren; danach sind
berechtigt:
(iv) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese gemäß diesem Unterabsatz (iv) einen Betrag in Höhe von zwölf Prozent
(12%) der tatsächlichen netto Baukosten und der damit in Zusammenhang stehenden Kosten (ohne Mehrwertsteuer),
die im Hinblick auf die direkte oder indirekte Immobilienbeteiligung der Gesellschaft tatsächlich angefallen sind, erhalten
haben; die Details hierzu werden von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter schriftlich festgelegt. Bei der Berechnung
werden alle bisher an den jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft gezahlten Dividenden angerechnet und die Höhe
des Betrages, zu dem der Gesellschafter gemäß diesem Unterabsatz (iv) berechtigt ist, wird entsprechend reduziert;
danach sind berechtigt:
(v) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese gemäß diesem Unterabsatz (v) einen Betrag in Höhe von null Komma
fünfundsiebzig Prozent (0,75%) des Basisendwertes der direkten oder indirekten Beteiligung der Gesellschaft an Immo-
bilienprojekten erhalten haben; die Details hierzu werden von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter schriftlich festgelegt.
Bei der Berechnung werden alle bisher an den jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft gezahlten Dividenden an-
gerechnet und die Höhe des Betrages, zu dem der Gesellschafter gemäß diesem Unterabsatz (v) berechtigt ist, wird
entsprechend reduziert; danach sind berechtigt:
(vi) Gesellschafter der Klasse A solange bis diese unter Anrechnung der Zinszahlungen auf ihre Gesellschafterdarlehen
einen Internen Zinsfuss von fünfundzwanzig Prozent (25%) pro Jahr auf ihr Investiertes Kapital ("Bevorzugter Ertrag I")
erhalten haben; danach sind berechtigt:
(vii) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese unter Anrechnung der Zinszahlungen auf ihre Gesellschafterdarlehen
einen Betrag in Höhe von dreißig Prozent (30%) der Summe von (a) dem Betrag der an die Gesellschafter der Klasse A
als Bevorzugter Ertrag I gemäß Unterabsatz (vi) ausgeschüttet wurde plus (b) dem Betrag, der an die Gesellschafter der
Klasse B unter diesem Unterabsatz (vii) ausgeschüttet wird, erhalten haben; danach sind berechtigt:
(viii) Gesellschafter der Klasse A zu siebzig Prozent (70%) und Gesellschafter der Klasse B zu dreißig Prozent (30%)
solange bis die Gesellschafter der Klasse A unter Anrechnung der Beträge, die an sie als Bevorzugter Ertrag I ausgeschüttet
wurden, einen Interner Zinsfuss von dreißig Prozent (30%) pro Jahr auf ihr Investiertes Kapital erhalten haben (der Betrag,
der gemäß diesem Unterabsatz (vii) an die Gesellschafter der Klasse A gezahlt wird, ist der "Bevorzugte(r) Ertrag II");
danach sind berechtigt:
(ix) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese unter Anrechnung der Zahlungen auf ihre Gesellschafterdarlehen
und der gemäß diesem Artikel 24 an sie gezahlten Beträge einen Betrag von fünfunddreißig Prozent (35%) der Summe
des an die Gesellschafter der Klasse A gezahlten Bevorzugten Ertrages I und des Bevorzugten Ertrages II und der an die
Gesellschafter der Klasse B gemäß (vii)-(ix) gezahlten Beträge erhalten haben; danach sind berechtigt:
(x) Gesellschafter der Klasse A zu fünfundsechzig Prozent (65%) und Gesellschafter der Klasse B zu fünfunddreißig
Prozent (35%).
Unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen können der/die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende auszahlen.
Der/die Geschäftsführer legen den Betrag und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest; hierbei ist das gleiche
wirtschaftliche Gesamtergebnis zu erzielen, wie es sich aus Absatz zwei, Punkt (i) bis (x), ergibt.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 25. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) aufgelöst werden. Die
Abstimmung über einen solchen Beschluss erfolgt vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen unter Be-
rücksichtigung des Quorums und der Mehrheit, wie sie für eine Satzungsänderung erforderlich sind.
Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche oder
juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt werden.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche, einschließlich der Li-
quidationskosten, wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Gesellschafter verteilt; hierbei ist das gleiche wirtschaft-
liche Gesamtergebnis zu erzielen, wie es sich aus Artikel 24, Absatz zwei, Punkt (i) bis (x) dieser Satzung, ergibt.
22673
Kapitel VII. Geltendes Recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-
stimmen sich nach dem Gesetz.
Kapitel VIII. Definitionen
Art. 27. Definitionen. Zusätzlich zu den Begriffen, die an anderer Stelle in der vorliegenden Satzung definiert werden,
finden die wie folgt definierten Begriffe auf die gesamte Satzung Anwendung:
"Werktag" bezeichnet einen Tag, der kein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag, an dem die Banken in der Stadt
Luxemburg geschäftstätig sind, ist.
"Finanzierungs-/Erwerbskriterien" bezeichnen die Kriterien, die bei der Entwicklung eines Immobilienprojektes kumu-
lativ erfüllt sein müssen; diese Kriterien beinhalten die Registrierung der jeweiligen Flurstücke im örtlichen Grundbuch,
die Beantragung der Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt und das Vorliegen bestimmter Vorpachtverträge.
"Investiertes Kapital" bezeichnet die von Zeit zu Zeit zu berechnende Differenz zwischen dem durch einen Gesell-
schafter investierten Betrag (sei es in Form von Eigenkapital oder in Form von Gesellschafterdarlehen) und dem Betrag,
der noch nicht durch die Gesellschaft zurückgezahlt wurde, wobei alle Dividendenzahlungen, die an einem Gesellschafter
durch die Gesellschaft geleistet wurden, den Betrag seines Investierten Kapitals entsprechend reduzieren.
"Gesetz" bezeichnet die geltende Fassung des luxemburgischen Gesetzes über der Handelsgesellschaften vom 10.
August 1915.
"Interner Zinsfuss" oder "IZF" bezeichnet den jährlichen Prozentsatz der Kapitalverzinsung, der dem jährlichen Ab-
zinsfaktor entspricht, der bei Anwendung auf den Gesellschafter Cashflow und auf der Grundlage einer vierteljährlichen
Kapitalaufzinsung einen Nettozeitwert des Gesellschafter Cashflows von Null ergibt; die Berechnung erfolgt hierbei durch
Anwendung der XIRR (XINTZINSFUSS) Formel in Microsoft Excel.
"Gesellschafter Cashflows" bezeichnet alle Geldzuflüsse und -abflüsse der Gesellschaft wie Kapitaleinlagen, Darlehen,
Einnahmen, Zinsen auf Darlehen, Erträge aus dem Rückkauf von Anteilen, Liquidationserlöse oder -verluste und Rück-
zahlungen auf Kapitaleinlagen und Darlehen unter der Voraussetzung dass alle Gebühren, die von der Gesellschaft in
Übereinstimmung mit von ihr abgeschlossenen Gebührenverträgen, gezahlt wurden, hierbei nicht berücksichtigt werden.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund vorliegender
Urkunde entstehen, wird auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro geschätzt.
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 18.30 Uhr geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der obengenann-
ten erschienen Personen die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf
Anfrage der gleichen Personen und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird der
englische Text vorwiegen.
Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: L. SCHUMMER, C. JOLK., M. MÜLLER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. Dezember 2008. Relation: EAC/2008/15882. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Ge-
sellschaften und Vereinigungen.
Beles, den 02. FEB. 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009022468/239/935.
(090023981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Verdandi Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 26.250,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 130.803.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22674
Luxembourg, le 26 janvier 2009.
<i>Pour Verdandi Management S.à r.l.
i>SGG S.A.
<i>Mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2009022733/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03076. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090024006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Water Instinct S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 114.239.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009022666/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00817. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090024108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
GS Lux Debt Holdings III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 144.570.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twelfth of January.
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware,
registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4298631, having its registered office at The
Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Dela-
ware 19801, USA, acting through its general partner GSCP VI Advisors, L.L.C., here represented by Hassane DIABATE,
lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
2. GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P., an exempted limited partnership formed and existing under the laws of
the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under regis-
tration number MC-19252, having its registered office at M&C Corporate Services Limited, Ugland House, South Church
Street, P.O. Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GSCP VI
Offshore Advisors, L.L.C., here represented by Hassane DIABATE, lawyer, having his professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
3. GS Capital Partners VI GmbH & Co. KG, a Kommanditgesellschaft formed and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany, registered with the Handelsregister at the Amtsgericht Frankfurt am Main under registration num-
ber HRA no 43550, having its registered office at Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60308 Frankfurt am Main, Germany, acting
through its managing limited partner GS Advisors VI, L.L.C., here represented by Hassane DIABATE, lawyer, having his
professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
4. GS Capital Partners VI Parallel, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware,
registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4210108, having its registered office at The
Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting
through its general partner GS Advisors VI, L.L.C., here represented by Hassane DIABATE, lawyer, having his professional
address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxies shall be signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached
to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties, represented as afore said, have requested the notary to draw up the following articles of
incorporation of a société à responsabilité limitée, which they declare to form:
22675
Title I. - Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August
10
th
, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18
th
, 1933 on limited
liability companies, as amended, as well as the present articles of incorporation.
Art. 2. The denomination of the company is "GS Lux Debt Holdings III S.à r.l.".
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-
xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.
Title II. - Capital - Parts
Art. 6. The capital is fixed at twenty thousand US Dollars (20,000.- USD) represented by two million (2,000,000) shares
with a nominal value of one cent US Dollar (0.01 USD) each.
The company shall have an authorized capital of one hundred million US Dollars (100,000,000.- USD) represented by
ten billion (10,000,000,000) shares having a par value of one cent US Dollar (0.01 USD) each.
The Board of Managers is authorised and appointed:
- to increase from time to time the subscribed capital of the company within the limits of the authorised capital, at
once or by successive portions, by issuance of new shares with or without share premium, to be paid up in cash, by
contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, by conversion of convertible preferred equity certificates or
other convertible notes or similar instruments or, upon approval of the annual general meeting of shareholders, by
incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issuance or of the successive issuances, the terms and conditions of
subscription and payment of the additional shares.
Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the incorporation deed of
January 12, 2009.
The period of this authority may be extended by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the
general meeting of shareholders, from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.
The Board of Managers is authorised to determine the conditions attached to any subscription for shares. In case of
issuance of shares, the Board of Managers of the Company may, in its sole discretion, decide the amounts to be issued.
When the Board of Managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above,
it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company's management is
authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the law.
Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non-shareholders may only be
made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial
companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best
interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.
22676
Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be
made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.
Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
shareholder.
Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III. - Management
Art. 10. The company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of
the Company's management and representation. To the extend applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association shall be read as a reference to the "sole manager".
The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of
office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.
The Board of Managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may
preside over the meeting.
A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the
Board to represent him at the meeting and to vote in his name.
Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by
means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.
The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him or by any manager,
as often as the interest of the company so requires.
The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.
The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at
the deliberation.
Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the
chairman of the meeting or any two managers.
Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Managers.
The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers
shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.
In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or
more managers, who will be called Managing Director(s).
The Board of Managers may also delegate the power of company's representation to one or several managers or to
any other person, shareholder or not, who will represent individually or jointly the company for specific transactions as
determined by the Board of Managers.
22677
Any manager, appointed as described in the previous paragraph, may issue a power of attorney, by his or her sole
signature, as required, in order to give a special power to an attorney (ad hoc agent) to represent individually the company
for specific purposes as determined in the special power of attorney.
Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of
up to fifteen thousand US Dollars (15,000.- USD). For decisions having a value of an amount over fifteen thousand US
Dollars (15,000.- USD), the company is bound by the signature of its sole manager and in case of plurality of managers,
by the joint signature of at least two managers.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the company; as a proxy holder he is only responsible for the execution of his mandate.
Title IV. - General meeting of the shareholders
Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case
may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.
In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a
general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31
st
, 2009.
Art. 17. Each year, as of December 31
st
, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a
record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.
At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the company.
Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund
is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of
the general meeting of shareholders.
Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators
who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended.
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of incorporation having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the capital as
follows:
GS Capital Partners VI Parallel, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256,600 shares
GS Capital Partners VI Fund, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
933,600 shares
GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
776,600 shares
GS Capital Partners VI GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,200 shares
TOTAL: two million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,000,000 shares
The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of 20,000.- USD (TWENTY THOUSAND
US DOLLARS) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
22678
<i>Valuation and Costsi>
For registration purposes, the present capital is valued at 14,900.- €.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 2,100.- €.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholders took the following resolutions
unanimously:
1) The number of managers is fixed at five (5).
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
1. Michael FURTH, Managing Director, born in Geneva, Switzerland, on April 29
th
,1968, professionally residing at
133, Fleet Street, Peterborough Court, London EC4A 2BB, United Kingdom;
2. John BOWMAN, Managing Director, born in Maine, USA, on July 16
th
, 1970, professionally residing at 85 Broad
Street, New York, NY 10004, United States of America;
3. Christine VOLLERTSEN, Managing Director, born in New Jersey, USA, on July 22
nd
, 1975, professionally residing
at 85 Broad Street, New York, NY 10004; United States of America;
4. Christophe CAHUZAC, Managing Director, born in Saint-Mard, Belgium, on October 26
th
, 1972, professionally
residing at 9-11, Grand-rue, L-1661, Grand Duchy of Luxembourg;
5. Simon CRESSWELL, Managing Director, born in Perth, Australia, on June 14
th
, 1968, professionally residing at 133
Fleet Street, Peterborough Court, London EC4A 2BB, United Kingdom.
3) The company shall have its registered office at 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, given name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille neuf, le douze janvier.
Par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., un 'limited partnership' constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware,
immatriculé auprès du 'Secretary of State of Delaware' sous le numéro d'immatriculation 4298631, ayant son siège social
au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son 'general partner' GSCP VI Advisors, L.L.C., ici représenté par
Hassane DIABATE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous
seing privé.
2. GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P., un 'limited partnership' constitué et opérant sous le droit des Iles Cayman,
immatriculé auprès du Registre des 'Exempted Limited Partnerships' dans les Iles Cayman sous le numéro d'immatricu-
lation MC-19252, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, P.O.
Box 309GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son 'general partner' GSCP VI
Offshore Advisors L.L.C., ici représenté par Hassane DIABATE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.
3. GS Capital Partners VI GmbH & Co. KG, une 'Kommanditgesellschaft' constituée et opérant sous le droit de la
République Fédérale d'Allemagne, immatriculée au Handelsregister du Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro
d'immatriculation HRA n° 43550, ayant son siège social au 49 Friedrich-Ebert-Anlage, D-60308 Frankfurt am Main, Alle-
magne, agissant par l'intermédiaire de son 'managing limited partner' GS Advisors VI, L.L.C., ici représentée par Hassane
DIABATE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing
privé.
4. GS Capital Partners VI Parallel, L.P., un 'limited partnership' constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware,
immatriculé auprès du 'Secretary of State of Delaware' sous le numéro d'immatriculation 4210108, ayant son siège social
au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
USA, agissant par l'intermédiaire de son 'general partner' GS Advisors VI, L.L.C., ici représentée par M. Hassane DIABATE,
avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.
22679
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant susnommé et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société
à responsabilité limitée et ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement
en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société est "GS Lux Debt Holdings III S.à r.l.".
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société.
Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui
est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 6. Le capital social de la société est fixé à vingt mille Dollars US (20.000,- USD) divisé en deux millions (2.000.000)
de parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent Dollar US (0,01 USD) chacune.
La Société aura un capital social autorisé de cent millions Dollars US (100.000.000,- USD) représenté par dix milliards
(10.000.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent Dollar US (0,01 USD) chacune.
Le Conseil de Gérance est autorisé à, et mandaté pour:
- augmenter le capital social de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches suc-
cessives, par émission de parts sociales nouvelles avec ou sans prime d'émission, à libérer par voie de versements en
espèces, d'apports en nature, par conversion de créances, par conversion de titres préférentiels convertibles ou d'autres
titres convertibles ou instruments similaires ou, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation
de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération de parts sociales nouvelles.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte constitutif du
12 janvier 2009.
La durée de cette autorisation peut être étendue par décision de l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée
générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts.
Le Conseil de Gérance est autorisé à déterminer les conditions de souscription des parts sociales. En cas d'émission
de parts sociales, le Conseil de Gérance de la Société peut décider, à sa seule discrétion, du total des émissions.
Lorsque le Conseil de Gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispositions
mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette
modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution
et la publication de telle modification conformément à la loi.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non
associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
22680
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux
conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.
A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra
être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé
par le Conseil de Gérance.
Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III. - Administration
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
En cas de pluralité de gérants, les gérants constituent un Conseil de Gérance, étant l'organe chargé de la gérance et
de la représentation de la société. Dans la mesure où le terme "gérant unique" n'est pas expressément mentionné dans
les présents statuts, une référence au "Conseil de Gérance" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une
référence au "gérant unique".
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.
L'assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.
Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un autre gérant présent.
Chaque gérant de la société empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par écrit,
télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter
et de voter en son nom.
Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de communi-
cation (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance présents
à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout
moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme
étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les
matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de
Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.
Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui ou par n'importe lequel
de ses gérants, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne
soit par mandataire à telle réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant
valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.
Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont
participé à la réunion.
Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement
signés par le Président de la réunion ou par deux gérants.
Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le Conseil de Gérance soit
en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distri-
bution de ces acomptes sur dividendes.
22681
En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront
la dénomination de gérants délégués.
Le Conseil de Gérance peut également déléguer le pouvoir de représentation de la société à un ou plusieurs gérants
ou à toute autre personne, associé ou non, qui représentera la société individuellement ou conjointement pour des
transactions spécifiques tel que déterminé par le Conseil de Gérance.
Tout gérant, tel que désigné comme décrit dans le paragraphe précédent, peut donner pouvoir spécial, par sa seule
signature, à toute autre personne susceptible d'agir seule comme mandataire ad hoc de la société pour certaines tâches
telles que définies dans le pouvoir spécial.
Art. 13. La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un
montant de quinze mille Dollars US (15.000,- USD). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à quinze mille
Dollars US (15.000,- USD), la société est engagée par la signature de son gérant unique ou par les signatures conjointes
d'au moins deux gérants en cas de pluralité de gérants.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas,
par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.
S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale
ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été
adoptée par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.
Les assemblées générales des associés se tiendront à Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est
admise.
Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier
exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du
passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les
engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.
En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale
des associés en même temps que l'inventaire.
Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,
pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.
Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
L'excédent est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales
applicables.
22682
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts ayant été établis, les comparants déclarent vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:
GS Capital Partners VI Parallel, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256.600 parts sociales
GS Capital Partners VI Fund, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
933.600 parts sociales
GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
776.600 parts sociales
GS Capital Partners VI GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.200 parts sociales
TOTAL: deux millions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 parts sociales
Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de 20.000,- USD (VINGT MILLE DOLLARS
US) par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel
qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.
<i>Evaluation et Fraisi>
Pour les besoins de l'enregistrement, le présent capital est évalué à 14.900,- €.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 2.100,- €.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la société, les associés prénommés ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à cinq (5).
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
1. Michael FURTH, Managing Director, né à Genève, Suisse, le 29 avril 1968, demeurant professionnellement à 133,
Fleet Street, Peterborough Court, Londres EC4A 2BB, Royaume-Uni;
2. John BOWMAN, Managing Director, né dans le Maine, Etats-Unis d'Amérique, le 16 juillet 1970, demeurant pro-
fessionnellement à 85, Broad Street, New York, NY 10004, Etats-Unis d'Amérique;
3. Christine VOLLERTSEN, Managing Director, née le 22 juillet 1975 au New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, demeurant
professionnellement 85, Broad Street, New York, NY 10004, Etats-Unis d'Amérique;
4. Christophe CAHUZAC, Managing Director, né le 26 octobre 1972 à Saint-Mard, Belgique, demeurant profession-
nellement à 9-11 Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
5. Simon CRESSWELL, Managing Director, né le 14 juin 1968 à Perth, Australie, demeurant professionnellement à 133,
Fleet Street, Peterborough Court, Londres EC4A 2BB, Royaume-Uni.
3) Le siège social de la société est établi à L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit comparant
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Diabate, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 janvier 2009. Relation: LAC/2009/1494. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2009.
Paul FRIEDERS.
Référence de publication: 2009022650/212/455.
(090023802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
S.A. Luxembourgeoise Mobeuro, Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 58.186.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
22683
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05.02.2009.
Signature.
Référence de publication: 2009022794/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08432. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Packaging Technology Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 88.945.
L'an deux mille huit, le dix-huit décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PACKAGING TECHNO-
LOGY PARTICIPATION S.A.", ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 88.945, constituée suivant acte reçu le 9 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 1545 du 26 octobre 2002.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre VAN KEYMEULEN, administrateur de sociétés, demeurant à Ei-
schen.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour adressées par recommandé aux
actionnaires en date du 8 décembre 2008.
III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 1.000 (mille) actions, actuellement émises, 966,50 (neuf
cent soixante-six virgule cinquante)
actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par consé-
quent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.
IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Augmentation du capital social à raison de 69.000 euro (soixante neuf mille euro) à réaliser comme suit:
- Suppression de la valeur nominale des actions existantes;
- Scission de chaque action existante en 50 actions nouvelles de sorte à obtenir un capital de 31.000 euro représenté
par 50.000 actions sans valeur nominale;
- Augmentation du capital social à raison de 69.000 euro(soixante neuf mille euro) pour le porter de son montant
actuel de 31.000 euro (trente et un mille euro) à 100.000 euro ( cent mille euro) sans émission d'actions nouvelles;
- Modification afférente de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les modifications ainsi intervenues.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de scinder chaque action existante en 50 (cinquante) actions nouvelles de sorte à obtenir un capital
social de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) représenté par 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de
valeur nominale.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 69.000,- (soixante-neuf mille Euros) pour le
porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 100.000,- (cent mille Euros), sans émission
d'actions nouvelles.
22684
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital, les actionnaires actuels proportionnel-
lement à leur participation dans le capital social de la société.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite sont intervenus les actionnaires actuels, prénommés, représentés par Monsieur Jean-Pierre VAN KEYMEU-
LEN, prénommé, en vertu de procurations dont mention ci-avant;
lesquels ont déclaré souscrire à la présente augmentation de capital proportionnellement à leur participation dans le
capital social de la société, et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre
et entière disposition la somme de EUR 69.000,- (soixante-neuf mille Euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version française
"Le capital souscrit est fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions sans
désignation de valeur nominale.".
Version allemande
"Das gezeichnete Kapital wird auf EUR 100.000,- (hundert tausend Euros) festgesetzt, eingeteilt in 50.000 (fünfzig
tausend) Aktien ohne Nennwert.".
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille deux cents Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J-P. VAN KEYMEULEN, H. JANSSEN, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51547. Reçu à 0,50%: trois cent quarante-
cinq euros (345.- €)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck SCHNEIDER.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations.
Luxembourg, le 15 janvier 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009022513/211/80.
(090024150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Kheiron S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5550 Remich, 53, rue de Macher.
R.C.S. Luxembourg B 108.767.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/02/09.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés Sàrl
Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2009022797/7262/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01484. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
22685
S.A. Luxembourgeoise Mobeuro, Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 58.186.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05.02.2009.
Signature.
Référence de publication: 2009022799/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08439. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090023649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Factory S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 82, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 99.097.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/02/09.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés Sàrl
Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2009022795/7262/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01479. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Ambiente Da Cruz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 8, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 97.163.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2009.
Christine DOERNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009022796/209/12.
(090024084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Gomes Granit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7395 Hunsdorf, 4, rue de Steinsel.
R.C.S. Luxembourg B 76.167.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 03/02/2009.
<i>Pour GOMES GRANIT S.A R.L.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L.
Signature
Référence de publication: 2009022810/1345/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01199. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090024279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
22686
New Vital Beauté sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 2, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 127.902.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/1/2009.
<i>Pour NEW VITAL BEAUTE S.A R.L.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009022808/1345/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10855. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090024275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Inter Republic Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 39.821.
In the year two thousand and eight, on the nineteenth of December
Before us Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A.", a société
anonyme, established in L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, R.C. Luxembourg section B number 39 821, incor-
porated by deed of the notary Marc ELTER, at that time notary, residing in Luxembourg, dated on March 13
th
, 1992,
published in the Mémorial C, number 368 of August 28
th
, 1992 amended the last time by a deed of the notary Joseph
ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, dated November 2, 1999 published in the Mémorial C, number 187 of March
3, 2000.
The meeting is presided by Mrs Marianne GOEBEL, attorney at law, residing at Luxembourg,
The chairman appoints as secretary Mr Eric PRALONG, attorney at law, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Julien RODRIGUES, attorney at law, residing at Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. There has been established an attendance list showing the shareholders present or represented and the number of
shares held by them, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting
and the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed "ne varietur" by the Bureau and the
notary.
II. As appears from the attendance list, all the shares of the company are present or represented. The meeting can
thus validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders were informed before the meeting.
III. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Reduction of the subscribed share capital by an amount of 1,696,619.00.-USD (one million six hundred ninety six
thousand six hundred nineteen United States dollars) so as to decrease it from its present amount of 1,795,187.00.-USD
(one million seven hundred ninety five thousand one hundred and eighty seven United States dollars) to 98.568,00- USD
(ninety eight thousand five hundred sixty eight United States dollars) by the cancellation of 50.300 (fifty thousand three
hundred) shares with no nominal value and by reimbursement of 1,696,619.00.-USD (one million six hundred ninety six
thousand six hundred nineteen United States dollars) to the shareholders.
2. As a consequence, amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation.
3. Miscellaneous
The facts exposed and recognised by the meeting, the President exposed the motives which let the Board of Directors
to submit the proposals indicated on the agenda to the vote of the shareholders.
After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to reduce the subscribed share capital by an amount of 1,696,619.00.-USD (one million
six hundred ninety six thousand six hundred nineteen United States dollars) so as to decrease it from its present amount
of 1,795,187.00.-USD (one million seven hundred ninety five thousand one hundred and eighty seven United States dollars)
22687
to 98.568,00.-USD (ninety eight thousand five hundred sixty eight United States dollars) by the cancellation of 50.300
(fifty thousand three hundred) shares with no nominal value and by reimbursement of 1,696,619.00.-USD (one million
six hundred ninety six thousand six hundred nineteen United States dollars) to the shareholders.
The reimbursement to the shareholders will be made by observing the requirements of the 3
rd
paragraph of article
69 of the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
Following the present resolution, power is given to the Board of Directors to determine all details of the reimburse-
ment to shareholders after the legal deadline has elapsed.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the decision taken by the general meeting under the preceding resolution, the general meeting
resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation of the Company, which will now read
as follows:
Art. 5. 1
st
paragraph. "The subscribed capital is set at USD 98,568.00.-(ninety eight thousand five hundred sixty eight
United States dollars) represented by 2.922 (two thousand nine hundred and twenty two) shares without par value,
carrying one voting right in the general assembly."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, payments or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of
the present deed are estimated at approximately two thousand Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English text shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original
deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTER REPUBLIC HOL-
DINGS S.A., une société anonyme avec siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39 821, constituée suivant acte reçu par le Notaire Marc
ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 13 mars 1992, publié au Mémorial C, numéro 368 du 28
août 1992, modifié en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 2 novembre 1999 publié au Mémorial C, numéro 187 du 3 mars 2000.
La séance est présidée par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg
Le Président désigne comme secrétaire Maître Eric PRALONG, avocat, demeurant à Luxembourg
L'Assemblée élit comme scrutateur Maître Julien RODRIGUES, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du bureau
et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.
II. Qu'il appert de ladite liste de présence que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire. L'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les ac-
tionnaires ont eu connaissance avant la présente assemblée.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de réduire le capital souscrit de la Société à concurrence de 1.696.619,00-. USD (un million six cent quatre
vingt seize mille six cent dix-neuf Dollars américains) pour le ramener de son montant actuel de 1.795.187,00-EUR (un
million sept cent quatre vingt quinze mille cent quatre vingt sept Dollars américains) au montant de 98,568.00.- USD
(quatre vingt dix-huit mille cinq cent soixante huit Dollars américains) par annulation de 50.300 (cinquante mille trois
cents) actions sans valeur nominale et par le remboursement de la somme de 1.696.619,00-. USD (un million six cent
quatre vingt seize mille six cent dix-neuf Dollars américains) aux actionnaires.
2. En conséquence, modification de l'article 5 alinéa 1 des statuts.
22688
3. Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, le Président expose les motifs qui ont amené le conseil d'ad-
ministration à soumettre les propositions mentionnées à l'ordre du jour au vote des actionnaires.
Après avoir délibéré, l'Assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée générale décide de réduire le capital souscrit de la Société à concurrence de 1.696.619,00-. USD (un
million six cent quatre vingt seize mille six cent dix-neuf Dollars américains) pour le ramener de son montant actuel de
1.795.187,00-EUR (un million sept cent quatre vingt quinze mille cent quatre vingt sept Dollars américains) au montant
de 98,568.00.- USD (quatre vingt dix-huit mille cinq cent soixante huit Dollars américains) par annulation de 50.300
(cinquante mille trois cents) actions sans valeur nominale et par le remboursement de la somme de 1.696.619,00-. USD
(un million six cent quatre vingt seize mille six cent dix-neuf Dollars américains) aux actionnaires.
Le remboursement aux actionnaires sera fait sous respect des prescriptions de l'article 69 3
ème
alinéa de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.
A la suite de la présente résolution, pouvoir est donné au conseil d'administration en vue de fixer toutes les modalités
de remboursement aux actionnaires après écoulement des délais légaux.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 alinéa 1des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
Art. 5. alinéa 1. "Le capital souscrit est fixé à USD 98.568,- (quatre vingt dix-huit mille cinq cent soixante huit dollars
américains), représenté par 2.922 (deux mille neuf cent vingt-deux) actions sans désignation de valeur nominale, disposant
chacune d'une voix aux assemblées générales".
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de deux mille Euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte
anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé le présent acte.
Signé: M. GOEBEL, E. PRALONG, J. RODRIGUES, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51927. Reçu douze euros (12.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Pour expedition conforme délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2009022510/211/132.
(090024135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Octir International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 55.149.
Le bilan de clôture de liquidation au 19 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2009022812/1053/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA08905. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
22689
Belisa International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.
R.C.S. Luxembourg B 58.731.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 03/02/2009.
<i>Pour BELISA INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L.
Signature
Référence de publication: 2009022813/1345/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01189. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090024284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Asist Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2221 Luxembourg, 318, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 88.850.
Le Bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28/01/09.
LUCOS COMPANY SERVICES
5, rue Prince Jean
L-4740 PETANGE- LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2009022818/1656/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00452. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090024312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Livenza S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 144.587.
STATUTS
L'an deux mille neuf, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Monsieur Cyril LAMORLETTE, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant à L-8283 Kehlen, 12, rue
Schaarfeneck,
ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/
Aubange (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 12 janvier 2009.
Ladite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de dresser acte d'une société anonyme
qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "LIVENZA S.A.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.
22690
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas
de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'exécution de prestations d'expertise comptable telles qu'elles sont définies à l'article
1
er
de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, de révision d'entreprises telles
qu'elles sont définies à l'article 1
er
de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises,
d'audit ainsi que de conseils en matière économique et fiscale.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le déve-
loppement.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions
sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social
sauf indication contraire dans les convocations.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés
à ces fins.
22691
Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire
tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-
délégué.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.
<i>Assemblée généralei>
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Strassen, tel qu'indiqué dans
la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 14.00 heures.
Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement
l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au
moment de la tenue de l'assemblée.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.
Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant
les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.
La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues
par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée
générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
22692
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l'article 18, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2009 et par dérogation
à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2010.
<i>Souscriptioni>
Toutes les actions ont été souscrites par Monsieur Cyril LAMORLETTE, préqualifié.
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente et un
mille euros (€ 31.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (€ 1.600.-).
<i>Décisions de l'actionnaire uniquei>
Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1) L'actionnaire unique décide de nommer un administrateur unique, à savoir:
Monsieur Cyril LAMORLETTE, expert-comptable et réviseur d'entreprises, né à Metz (France), le 1
er
septembre
1974, demeurant à L-8283 Kehlen, 12, rue Schaarfeneck.
2) L'actionnaire unique décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Monsieur Pierre-François WERY, juriste, né à Liège (Belgique), le 30 octobre 1965, demeurant à B-4550 Nandrin, Place
Félix Gonda, 16.
3) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2014.
4) Le siège de la société est fixé à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 27 janvier 2009. Relation: CAP/2009/266. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 9 février 2009.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2009022467/236/163.
(090024121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 4.109.
<i>Extrait de la résolution du Conseil d'Administration.i>
«Le Conseil d'Administration approuve la nomination de Mme Hjoerdis Stahl, née le 3 avril 1966, demeurant à 29,
Duerfstrooss, Berbourg, aux fonctions de membre du Comité de Direction.
Le Conseil d'Administration approuve la nomination de M. Alberto Kunkel, actuellement membre-adjoint du Comité
de Direction, né le 30 avril 1962, demeurant à 35, rue Laurent Menager, Luxembourg, aux fonctions de membre du
Comité de Direction.
Les adresses professionnelles de Mme Stahl et de M. Kunkel sont fixées à l'Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxem-
bourg.»
22693
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2009.
<i>Pour Luxair
i>Michel Folmer
<i>Secrétaire Générali>
Référence de publication: 2009022858/1706/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06250. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Medsup S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3377 Leudelange, 13, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 103.056.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2008i>
<i>4. Délibérationsi>
1. L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission remise par Madame Monique HOFFMANN, Administrateur, pour
adresse professionnelle, 13, rue de la Gare, L-3377 Leudelange, mettant ainsi fin à son mandat respectif de la S.A. MEDSUP.
Fait à Leudelange, le 27 octobre 2008, pour servir et valoir ce que de droit.
<i>Pour MEDSUP S.A.i>
Référence de publication: 2009022859/1486/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08740. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Lexion SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 130.870.
Le bilan et l'annexe au 30 juin 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LEXION S.A.
i>Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2009022856/45/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03179. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Nimalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 64.240.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 7 mai 2004i>
L'assemblée Générale décide de prolonger les mandats de MM Romain Bontemps et Ronald Weber jusqu'à l'assemblée
générale qui statuera sur les comptes 2008.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 29 décembre 2008i>
L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Marc Hilger, demeurant professionnellement 6, Place de
Nancy à L-2212 Luxembourg, en tant qu'administrateur.
Elle décide de nommer Monsieur Ralph Bourgnon, demeurant professionnellement à 6, Place de Nancy à L-2212
Luxembourg, en remplacement de Monsieur Hilger. Son mandat d'administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale
statuant sur les comptes 2008.
22694
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2008.
<i>Pour la société
i>PKF Weber & Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprises
i>Signatures
Référence de publication: 2009022864/592/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03283. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090023855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Embafin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 46.238.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 décembre 2007 que:
1. La démission de la société «Certifica Luxembourg Sàrl» en sa qualité de Commissaire est acceptée.
2. Est nommée en remplacement du Commissaire démissionnaire, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale
statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012, la société «BF Consulting S.àr.l.», société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 1 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2009.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2009022865/6312/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00731. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
HIP Oils S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 26.445,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 144.242.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2009.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009022866/242/13.
(090023920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Magenta Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 106.592.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22695
<i>Pour MAGENTA HOLDING S.A.
i>Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2009022853/45/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02721. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Medsup S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3377 Leudelange, 13, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 103.056.
Par la présente je suis au regret de vous faire part de ma démission et ce, avec effet immédiat, de ma fonction d'Ad-
ministrateur de la société MEDSUP S.A.
Leudelange, le 23 octobre 2008.
Monique HOFFMANN.
Référence de publication: 2009022860/1486/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08746. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090023905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Mainstay S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 73.857.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/01/2009.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2009023626/717/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01719. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090024527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
Polytrinity Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 130.004.
In the year two thousand nine, on the twenty-seventh day of January.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) Mr Marek JASZCZAK, company's director, residing at Wandzin 15A, 21-100 Lubartow, Poland, born in Lubartow,
on July 14
th
, 1967,
2) Mr Grzegorz Janusz KUZMA, company's director, residing at Ul. Gojdana 14, 21-100 Lubartow, Poland, born in
Lubartow, on November 24
th
, 1965,
3) Mr Jacek KUZMA, company's director, residing at 19c, Majdan Kozlowiecki, 21-100 Lubartow, Poland, born in
Lubartow, on March 13
th
, 1967,
all represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg, 23 rue Aldringen,
by virtue of three proxies dated 21 January 2009.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
22696
- that they are the sole actual shareholders of Polytrinity Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incor-
porated by deed of the undersigned notary on the 5 July 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations number 1904 of 6 September 2007.
- that the shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide the replacement of the current one hundred twenty-six (126) shares with a nominal value of
one hundred euro (EUR 100) each by twelve thousand six hundred (12,600) shares with a nominal value of one euro
(EUR 1) representing the corporate capital, attributed to the actual shareholders proportionally to their respective par-
ticipation in the share capital.
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of THREE THOUSAND FIVE HUNDRED
SIXTY EUROS (EUR 3,560) to bring it from its present amount of TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED EUROS (EUR
12,600) to SIXTEEN THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY EUROS (EUR 16,160) by the issuance of THREE THOU-
SAND FIVE HUNDRED SIXTY (3,560) new shares with a par value of ONE EURO (EUR 1) each, having the same rights
and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes:
1) Mr Grzegorz KUZMA, prenamed, represented as stated hereabove, by Mr Philippe AFLALO, prenamed,
declares to subscribe for ONE THOUSAND NINE HUNDRED NINETY FIVE (1,995) new shares and to have them
fully paid up by contribution in cash,
2) Mr Marek JASZCZAK, prenamed, represented as stated hereabove, by Mr Philippe AFLALO, prenamed,
declares to subscribe for ONE THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY-FIVE (1,565) new shares and to have them fully
paid up by contribution in cash.
The total amount of THREE THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY EUROS (EUR 3,560) is from now on at the disposal
of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend the article 6 of the articles of
incorporation, which will henceforth have the following wording:
" Art. 6. The capital is fixed at SIXTEEN THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY EUROS (EUR 16,160) represented
by SIXTEEN THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY (16,160) shares with a par value of ONE EURO (EUR 1) each, all
fully paid-up."
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately ONE THOUSAND TWO
HUNDRED EURO (EUR 1,200).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil neuf, le vingt-sept janvier.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Marek JASZCZAK, administrateur de société, demeurant à Wandzin 15A, 21-100 Lubartow, Pologne, né
à Lubartow, le 14 juillet 1967,
2) Monsieur Grzegorz Janusz KUZMA, administrateur de société, demeurant à Ul. Gojdana 14, 21-100 Lubartow,
Pologne, né à Lubartow, le 24 novembre 1965,
3) Monsieur Jacek KUZMA, administrateur de société, demeurant à 19c, Majdan Kozlowiecki, 21-100 Lubartow, Po-
logne, né à Lubartow, le 13 mars 1967,
22697
tous trois représentés par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de société, demeurant professionnellement à
L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,
en vertu de trois procurations sous seing privé, datées du 21 janvier 2009.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés de la société Polytrinity Investment S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 5 juillet 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1904 du 6 septembre 2007.
- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident l'annulation des cent vingt six (126) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR
100) chacune et l'émission en remplacement de DOUZE MILLE SIX CENTS (12.600) parts sociales d'une valeur nominale
de UN EURO (EUR 1) représentant le capital social, attribuées aux associés actuels de la société au prorata de leurs
participations dans le capital.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS
(EUR 3.560) pour porter son montant actuel de DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 12.600) à SEIZE MILLE CENT
SOIXANTE EUROS (EUR 16.160) par l'émission de TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE (3.560) parts sociales nou-
velles d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Sont intervenus aux présentes:
1) Monsieur Grzegorz KUZMA, prénommé, représenté comme dit-ci avant, par Monsieur Philippe AFLALO, prén-
ommé,
déclare souscrire MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE (1.995) parts sociales nouvelles et les libérer
moyennant apport en espèces;
2) Monsieur Marek JASZCZAK, prénommé, représenté comme dit-ci avant par Monsieur Philippe AFLALO, prén-
ommé,
déclare souscrire MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ (1.565) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant
apport en espèces.
Le montant total de TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS (EUR 3.560) est dès à présent à la disposition
de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts comme suit:
" Art. 6. Le capital est fixé à SEIZE MILLE CENT SOIXANTE EUROS (EUR 16.160) représenté par SEIZE MILLE CENT
SOIXANTE (16.160) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1) chacune, toutes souscrites entièrement
libérées."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 1.200).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. AFLALO et G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 février 2009. LAC/2009/3952. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75.-)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22698
Luxembourg, le 9 février 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009023565/220/125.
(090025021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
MS Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 102.560.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023602/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01248. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(090025110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
MS Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 102.560.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023601/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01247. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
B.S. Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 45.486.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023597/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01264. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
Spring, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 47.624.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
22699
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/12/2008.
Signature.
Référence de publication: 2009023624/717/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01725. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090024537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
Lonimag S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 51.665.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 10 février 2009.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009022910/219/12.
(090024088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Strategic Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 81.709.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023611/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01252. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
Strategic Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 81.709.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023609/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01251. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
MS Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 102.560.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22700
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023607/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01250. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
MS Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 102.560.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023605/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01249. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
B.S. Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 45.486.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023596/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01263. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
B.S. Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 45.486.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/09.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023595/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01262. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
Sedgewick Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.329.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22701
Belvaux, le 2 février 2009.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009022908/239/12.
(090024019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Sydenham Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.335.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 février 2009.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009022907/239/12.
(090023985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Strategic Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 81.709.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023616/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01254. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
Strategic Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 81.709.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023614/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01253. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
B.S. Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 45.486.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22702
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023594/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01261. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
Crédit Suisse Group Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 84.894.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2009.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2009022899/5770/12.
(090023704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
321.ECEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 18, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 108.141.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2008i>
<i>Résolution n°1i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions
d'administrateur de Madame Suzanne Jeannette Manuela KIRSCH, née le 03 février 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant
à L-4050 Esch-sur-Alzette, rue du Canal, 18.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
<i>Résolution n°2i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions
d'administrateur de Monsieur Alain Joseph Emile SEYLER, né le 12 juin 1951 à Schifflange, demeurant à L-4064 Esch-sur-
Alzette, boulevard Hubert Clément, 16.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
<i>Résolution n°3i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions
d'administrateur de Madame Marcelle Yolande SEYLER-GERSTENKORN, née le 29 juillet 1958 à Thionville (France),
demeurant à L-4064 Esch-sur-Alzette, boulevard Hubert Clément, 16.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
<i>Résolution n°4i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions
d'administrateur de Monsieur René MICHEL, né le 21 février 1942 à Yvoir (Belgique), demeurant à B-4020 Liège, rue
Justin Lenders, 66.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
<i>Résolution n°5i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions
d'administrateur de Madame Francine GILSOUL, née le 03 mai 1945 à Hannut (Belgique), demeurant à B-4020 Liège, rue
Justin Lenders, 66.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2008.
Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
22703
Société d’expertise-comptable
26-28 Bd Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
Signature
Référence de publication: 2009022897/1549/42.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07526. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090024182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.
Strategic Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 81.709.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023617/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01255. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
B.S. Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 45.486.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/02/2009.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2009023591/831/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01259. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090025141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.
Winvest Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 123.591.
EXTRAIT
La Société informe que M. Dirk Jan van Ommeren., gérant de catégorie 2 de la Société, a changé l'adresse profession-
nelle pour résider désormais au Rembrandt Tower, 22nd floor, Amstelplein 1, Amsterdam, 1096 HA, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2009.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2009022198/7665/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01631. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(090023209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
22704
321.ECEP S.A.
Ambiente Da Cruz S.à r.l.
Asist Sàrl
Belisa International S.A.
B.S. Consulting S.A.
B.S. Consulting S.A.
B.S. Consulting S.A.
B.S. Consulting S.A.
B.S. Consulting S.A.
Crédit Suisse Group Finance (Luxembourg) S.A.
Embafin S.A.
Factory S.à r.l.
Gomes Granit S.à r.l.
GS Lux Debt Holdings III S.à r.l.
HIP Oils S.àr.l.
Inter Republic Holdings S.A.
Kheiron S.à r.l.
Lexion SA
Livenza S.A.
Lonimag S.A.
LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A.
Magenta Holding S.A.
Mainstay S.àr.l.
Medsup S.A.
Medsup S.A.
MS Gestion S.A.
MS Gestion S.A.
MS Gestion S.A.
MS Gestion S.A.
New Vital Beauté sàrl
Nimalux S.A.
Octir International S.A.
Packaging Technology Participation S.A.
Polytrinity Investment S.à r.l.
S.A. Luxembourgeoise Mobeuro
S.A. Luxembourgeoise Mobeuro
Sedgewick Holding S.à r.l.
Spring
Strategic Management Sàrl
Strategic Management Sàrl
Strategic Management Sàrl
Strategic Management Sàrl
Strategic Management Sàrl
Sydenham Holding S.à r.l.
Sydenham Holding S.à r.l.
Verdandi Management S.à r.l.
Water Instinct S.à.r.l.
Winvest Conseil S.à r.l.