logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 323

13 février 2009

SOMMAIRE

Acab Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15503

Alcanada S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15467

Alternative Real Investments S.A.  . . . . . . .

15461

ASI 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15458

ASI Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15458

Atex Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15465

Centre Comptable Européen S.A.  . . . . . . .

15460

Claremont Villas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15467

Commercial Company Luxembourg  . . . . .

15459

Considar Metal Marketing S.A.  . . . . . . . . . .

15467

Eastern Property Management Sàrl . . . . . .

15461

Ecom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15470

Edilred S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15466

Edmonds & Associés S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

15503

Erste Europäische Metallhandel und Rohs-

toffveredelung S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15459

European Logistics Feeder S.C.A.  . . . . . . .

15497

European Retail Portfolio (New Mersey)

Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15463

Falcon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15502

F.G. Fashion International s.à r.l.  . . . . . . . .

15462

Finacap Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15466

Finmean Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15465

Flux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15476

Formula Sports SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15463

Frenchie's, Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15463

G.B. Finlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15458

Gib International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15468

Hellaby S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15463

Hezias B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15466

Holding Business International S.A. . . . . . .

15460

Immodiam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15462

ING Industrial Real Estate Luxembourg S.

à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15469

Inkema Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15468

Koch Chemical Technology Group SCS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15459

Laudis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15459

Locamar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15469

Lumos Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

15464

Marius Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

15495

MEIF Luxembourg Feeder S.à r.l. . . . . . . . .

15458

Melrose Real Estate Investment S.A. . . . . .

15462

Melusine Aviation S. à r.l. & Cie, S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15468

MENOS global network AG  . . . . . . . . . . . . .

15468

Methys S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15467

Montclair S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15469

Murex Participations Luxembourg S.A.  . .

15461

Obegi Chemicals Group S.A.  . . . . . . . . . . . .

15468

Ocra (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

15462

Pasucha Klepzig & Associés Architectes &

Ingénieurs S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15460

Private Equity Investors Holding S.A.  . . . .

15460

Property Projects S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

15465

RQ Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15464

Sam et Marie S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15464

Scalene Luxembourg S. à r. l.  . . . . . . . . . . .

15469

Seacat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15465

Smart Private Managers (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15504

TCFE Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15458

Tecnic-Consult-Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

15466

Thunderbird Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

15460

Tiercelet Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

15464

Tishman Speyer French Venture V S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15473

T&T Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15459

Van Cauter - Snauwaert & Co S.à.r.l.  . . . .

15461

15457

G.B. Finlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 143.743.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009014527/5770/12.
(090013730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

MEIF Luxembourg Feeder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.700,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.412.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009014486/242/13.
(090013587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

TCFE Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.454.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 janvier 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009014530/231/14.
(090013353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

ASI Management S.A., Société Anonyme,

(anc. ASI 1 S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 133.707.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 janvier 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Jean SECKLER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009014529/231/15.
(090013810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15458

T&amp;T Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.147.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009014543/5710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06195. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090014015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Koch Chemical Technology Group SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 83.170.

Le Bilan consolidé au 31.12.2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jeanne Hernandez
<i>Director

Référence de publication: 2009014544/4232/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08684. - Reçu 135,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Erste Europäische Metallhandel und Rohstoffveredelung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 142.502.

Le bilan au 29.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

p.o. Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2009014542/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05621. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Laudis S.A., Société Anonyme,

(anc. Commercial Company Luxembourg).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 101.133.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 janvier 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Jean SECKLER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009014531/231/15.
(090013802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15459

Private Equity Investors Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Centre Comptable Européen S.A.).

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 109.136.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 janvier 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Jean SECKLER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009014536/231/15.
(090013790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Thunderbird Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.596.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 janvier 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Jean SECKLER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009014533/231/14.
(090013779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Pasucha Klepzig &amp; Associés Architectes &amp; Ingénieurs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 24, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 103.861.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 23. Januar 2009.

<i>Für die Gesellschaft
Jean SECKLER
<i>Der Notar

Référence de publication: 2009014534/231/13.
(090013911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Holding Business International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.787.

Les Comptes Annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 8/1/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014548/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05713. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15460

Van Cauter - Snauwaert &amp; Co S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.610.

Les Comptes Annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/12/2008.

Signature.

Référence de publication: 2009014549/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03615. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Eastern Property Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.704.

Les Comptes Annuels du 1 

er

 juillet 2007 au 30 juin 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8/1/2008.

Signature.

Référence de publication: 2009014547/553/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05711. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Alternative Real Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 121.772.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALTERNATIVE REAL INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009014574/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06115. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Murex Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 108.040.

<i>Extrait des résolutions prises a la réunion du conseil d'administration du 9 décembre 2008

M. Maroun EDDE, homme d'affaires, demeurant à L-8086 Bertrange, 78, Cité am Wenkel, est nommé comme président

du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 30
septembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014636/280/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05202. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15461

Immodiam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.372.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009014624/636/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07638. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Ocra (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 48.274.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2009014620/634/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05117. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Melrose Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 102.279.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SANTERAMO E.
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009014643/2319/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06493. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

F.G. Fashion International s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 68, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 67.405.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009014637/2319/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06497. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15462

European Retail Portfolio (New Mersey) Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.065.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014638/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04538. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Frenchie's, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 68, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 83.192.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SANTERAMO E.
<i>Gérant

Référence de publication: 2009014641/2319/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06500. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Formula Sports SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 50, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 70.057.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour NOTAFAGUS SARL
Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009014635/597/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05725. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Hellaby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 65.990.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009014618/631/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09955. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15463

RQ Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 97.517.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 Janvier 2009.

Paul Lefering.

Référence de publication: 2009014617/9168/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06080. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Tiercelet Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 108.806.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SANTERAMO E.
<i>Gérant

Référence de publication: 2009014645/2319/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06490. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Sam et Marie S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 24-26, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 116.907.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour SAM ET MARIE SARL
Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009014633/597/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05722. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Lumos Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 89.919.

Le bilan de la société au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009014680/655/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05228. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15464

Seacat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 94.229.

Le bilan au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEACAT S.A.
Signature
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2009014682/1066/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07583. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Atex Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 65.456.

Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009014675/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05258. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Finmean Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 106.269.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009014646/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06511. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Property Projects S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 123.936.

Le bilan au 31.12.07 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009014696/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06150B. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15465

Tecnic-Consult-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 48.549.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/01/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014648/1595/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02707. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Finacap Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 9.516.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009014649/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06510. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Edilred S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 103.512.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009014652/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06502. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Hezias B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,00.

Siège de direction effectif: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.003.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009014672/655/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01515. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15466

Methys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 99.774.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12/10/2007 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Guy GLESENER au 36, rue Frantz Seimetz, L-2531 LU-

XEMBOURG.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009014755/3842/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05413. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Alcanada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 83.617.

<i>Extrait des résolutions prises a l'assemblée générale du 23 décembre 2008

L'assemblée accepte la démission de la société LNR SERVICES LIMITED, BVI, de son mandat d'administrateur avec

effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014654/280/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05196. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Considar Metal Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 3, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 47.816.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CONSIDAR METAL MARKETING S.A.
Serge Weber / Michel Le Clef

Référence de publication: 2009014653/2802/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05946. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Claremont Villas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 46.982.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009014698/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06179. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15467

Melusine Aviation S. à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 130.054.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009014665/1023/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06525. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Obegi Chemicals Group S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. Inkema Group).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 19.689.

Le bilan social au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009014666/35/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07655. - Reçu 48,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

MENOS global network AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.812.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009014664/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06528. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Gib International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 61.588.

Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009014677/655/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05217. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15468

Locamar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 63.487.

Le bilan au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LOCAMAR S.A.
Signature
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2009014683/1066/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07590. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090013339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

ING Industrial Real Estate Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.550,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 114.985.

Le bilan de la société au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ING Industrial Real Estate Luxembourg S.à.r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009014668/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04659. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Montclair S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 76.306.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009014662/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06530. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Scalene Luxembourg S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 125.144.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014640/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04103. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15469

Ecom, Société Anonyme.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 61.067.

In the year two thousand eight, on the thirtieth day of December,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg;
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of ECOM, a public limited liability company

(société anonyme), having its registered office at 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under number B 61 067 (the Company), incorporated
pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, of October 2, 1997, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations of January 12, 1998, under number C- 21. The articles of association of the Company
(the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in
Esch-sur-Alzette, of March 31, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of July 28, 2000,
under number C- 542,

The Meeting is chaired by Ms Caroline Muller, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as Secretary Mr. Benoît Charpentier, lawyer, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as Scrutineer Mr. Gilles Ralet, lawyer, residing in Luxembourg, (the Chairman, the Secretary and

the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The Bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that 20,000 (twenty

thousand) shares, without any par value, and representing the entire share capital of the Company, are duly represented
at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter
reproduced.

II. That the agenda of the Meeting is the following:
1. (i) Presentation of the merger proposal adopted by the directors of the Company on October 31, 2008, and published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2865 of November 29, 2008 (the Merger Proposal); (ii)
acknowledgement of the resolutions taken by the directors of the Company on October 31, 2008 and of the Merger
Proposal; and (iii) approval of the merger of Ixina International, a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), having its registered office at 107 rue de l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 61 347 (Ixina International) and the Company, whereby following its
dissolution without liquidation, Ixina International will transfer to the Company all its assets and liabilities in accordance
with article 278 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as described in the
Merger Proposal (the Merger);

2. Acknowledgment (i) of the dissolution without liquidation of Ixina International by way of the transfer of all assets

and liabilities of Ixina International to the Company in accordance with the Merger Proposal and (ii) of the cancellation
of all the shares issued by Ixina International;

3. Acknowledgment (i) that, from an accounting point of view, the operations of Ixina International will be treated as

having been carried out on behalf of the Company as from January 2, 2008 and (ii) that the Merger will only be effective
vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law; and

4. Empowerment and authorisation of any director of the Company or any lawyer of Loyens &amp; Loeff Luxembourg or

any employee of Fiduciaire Weber &amp; Bontemps, acting individually, with full power of substitution, to execute any docu-
ments and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the
Merger.

III. That, after deliberation, the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting notes that the directors of the Company has presented to it the Merger Proposal, in accordance with

article 262 of the Law and providing for the absorption of Ixina International by the Company.

The Meeting resolves to (i) acknowledge the resolutions taken by the directors of the Company on October 31, 2008

and the Merger Proposal and (ii) approve the Merger, as described in the Merger Proposal, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N° 2865 of November 29, 2008.

The  Meeting  notes  that  all  corporate  documents  required  by  article  267  of  the  Law  have  been  deposited  at  the

registered office of the Company for inspection by the shareholders at least one month before the date of the present
Meeting.

15470

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves to acknowledge (i) that Ixina International shall

be dissolved without liquidation by way of the transfer of all assets and liabilities of Ixina International to the Company
in accordance with the Merger Proposal and (ii) that all the shares issued by Ixina International shall be cancelled.

<i>Third resolution

Further to the approval of the merger by Ixina International, the Meeting resolves to acknowledge (i) that, notwiths-

tanding the provisions of article 273 of the Law, the realisation of the Merger on January 2, 2008, the operations of Ixina
International being treated, from an accounting point of view, as having been carried out on behalf of the Company as
from the same date and (ii) that the Merger will only be effective, vis-à-vis third parties after the publication prescribed
by article 9 of the Law.

<i>Fourth resolution

The  Meeting  resolves  to  empower  and  authorise  any  director  of  the  Company  or  any  lawyer  of  Loyens  &amp;  Loeff

Luxembourg or any employee of Fiduciaire Weber &amp; Bontemps, acting individually, with full power of substitution, to
execute  any  documents  and  to  perform  any  actions  and  formalities  necessary,  appropriate,  required  or  desirable  in
connection with the Merger.

<i>Statement

The undersigned notary states in accordance with article 271 (2) of the Law having verified and certifies the existence

and legality of all the acts and formalities incumbent upon the Company and of the Merger Proposal.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred euros
(EUR 1.200.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the members of the Bureau, the members of the Bureau signed together with the

notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mil huit, le trente décembre,
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la société anonyme ECOM (la

Société), ayant son siège social à 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 61 067, constituée suivant acte reçu par Maître Paul
Decker, notaire de résidence à Luxembourg, du 2 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
C - N° 21, du 12 janvier 1998. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois selon acte de
Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, du 31 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C - 542, du 28 juillet 2000.

L'Assemblée est présidée par Melle Caroline Muller, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme Secrétaire M. Benoît Charpentier, juriste, demeurant à Luxembourg.
L'Assemblée  choisit  comme  Scrutateur  Monsieur  Gilles  Ralet,  avocat,  demeurant  à  Luxembourg,  (le  Président,  le

Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l'Assemblée)

Le Bureau étant constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Il ressort de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que 20.000 (vingt mille) actions, sans

valeur nominale et formant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée, de sorte
que celle-ci est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, ci-après
reproduits.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. (i) Présentation du projet de fusion adopté par le gérant unique de la Société le 31 octobre 2008 et publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2865 du 29 novembre 2008 (le Projet de Fusion); (ii) prise d'acte
des résolutions prises par les administrateurs de la Société le 31 octobre 2008 et du Projet de Fusion et (iii) approbation
de la fusion de Ixina International, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 107, rue de
l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 61 347 (Ixina International) et de la Société, par laquelle, suite à sa dissolution sans liquidation, Ixina Inter-

15471

national transférera à la Société tous ses actifs et passifs conformément à l'article 278 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), tel que décrit dans le Projet de Fusion (la Fusion);

2. Prise d'acte (i) de la dissolution d'Ixina International sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et passifs

à la Société, conformément au Projet de Fusion; et (ii) de l'annulation de toutes les actions émises par Ixina International;

3. Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations d'Ixina International seront traitées comme si elles

avaient été exécutées pour le compte de la Société depuis le 2 janvier 2008 et (ii) que la Fusion ne sera effective vis-à-vis
des tiers qu'après la publication prescrite par l'article 9 de la Loi;

4. Pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société ou tout employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg ou tout

employé de Fiduciaire Weber &amp; Bontemps, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter
tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en
relation avec la Fusion.

III. Que, après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée note que les administrateurs de la Société lui ont présenté le Projet de Fusion, en conformité avec l'article

262 de la Loi et selon lequel Ixina International sera absorbée par la Société.

L'Assemblée décide de prendre acte des résolutions prises par les administrateurs de la Société en date du 31 octobre

2008 et du Projet de Fusion et d'approuver la Fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, No 2865 du 29 novembre 2008.

L'Assemblée note que tous les documents sociaux requis par l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège social de

la Société pour être consultés par l'Associé Unique au moins un mois avant la date de la présente Assemblée.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de prendre acte (i) que Ixina International sera

dissoute sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et passifs à la Société, conformément au Projet de Fusion;
et (ii) que toutes les actions émises par Ixina International seront annulées.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations d'Ixina International seront

traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société depuis le 2 janvier 2008 et (ii) que la Fusion
ne sera effective vis-à-vis des tiers qu'après la publication prescrite par l'article 9 de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de donner pouvoir et autoriser tout administrateur de la Société ou tout employé de Loyens &amp;

Loeff Luxembourg ou tout employé de Fiduciaire Weber &amp; Bontemps, agissant individuellement, avec plein pouvoir de
substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées,
requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l'article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifie l'existence et la légalité

de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu aux membres du Bureau, ces membres du Bureau ont signé avec le notaire instrumentant

le présent acte en original.

Signé: C. Muller, B. Charpentier, G. Ralet et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2009. LAC/2009/358. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER

Référence de publication: 2009014340/5770/162.
(090013747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

15472

Tishman Speyer French Venture V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 457.825,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.596.

In the year two thousand and eight, on the ninth of December
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appears:

Tishman Speyer French Venture Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

incorporated and existing under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34-38, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under
number 134.595,

here represented by Mr. Gael Toutain, private employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, by virtue of a proxy established on December 3rd, 2008.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

established in Luxembourg under the name of "Tishman Speyer French Venture V S.à r.l.", having its registered office at
34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section
B, under number 134.596 (the "Company), incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, enacted on December 12 

th

 , 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

number 155, dated January 21 

st

 , 2008 and whose bylaws have been lastly amended by a deed of the undersigned notary

dated September 30 

th

 , 2008, under process of publication with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is fixed at three hundred fifty thousand three hundred and fifty Euro (EUR 350,350.-)

divided into fourteen thousand and fourteen (14,014) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of one hundred seven

thousand four hundred seventy-five Euro (EUR 107,475.-) to raise it from its present amount of three hundred fifty
thousand three hundred and fifty Euro (EUR 350,350.-) to four hundred fifty-seven thousand eight hundred twenty-five
Euro (EUR 457,825.-) by creation and issue of four thousand two hundred ninety-nine (4,299) new shares of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

IV. The sole shareholder resolves to subscribe for the four thousand two hundred ninety-nine (4,299) new shares of

twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up in the amount of one hundred seven thousand four hundred
seventy-five Euro (EUR 107,475.-) as follows:

(i) by contribution in cash of the amount of sixty-nine thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 69,425.-). This

sum is fully paid up in cash so that the said amount is as of now available to the Company, as it has been justified to the
undersigned notary.

(ii) by contribution in kind in the amount of thirty-eight thousand fifty Euro (EUR 38,050.-) consisting in the conversion

of a receivable in the same amount held by the sole shareholder towards the Company.

<i>Description of the contribution

A liquid, certain and immediately payable claim amounting to thirty-eight thousand fifty Euro (EUR 38,050.-) in aggregate

held by the sole shareholder as represented hereabove against the Company (the "Claim").

<i>Evidence of the contribution's existence and Value

Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary by the interim accounts

of the Company as at 1st December 2008, as well as a certificate issued by the managers of the sole shareholder on 3

rd

 December 2008.

<i>Evaluation of the contribution in kind

The value of the contribution is deemed to amount thirty-eight thousand fifty Euro (EUR 38,050.-).

<i>Effective implementation of the contribution in kind

The sole shareholder, contributor, represented as stated above, hereby declares that:
- it currently holds the Claim against the Company amounting to a counter value of thirty-eight thousand fifty Euro

(EUR 38,050.-);

15473

- the Claim has consequently not been assigned and no legal or natural person other than the sole shareholder is

entitled to receive payment of the Claim;

- The contributed liquid, certain and immediately payable Claim is currently outstanding for an amount of thirty-eight

thousand fifty Euro (EUR 38,050.-).

<i>Report of Company's sole manager

The report of the sole manager of the Company, dated 3 

rd

 December 2008, annexed to the present deed, attests

that Mr Marcel STEPHANY, Category B manager of the sole manager of the Company, and Ms Geraldine COPELAND
WRIGHT, Category A Manager of the sole manager of the Company, acknowledging having been informed beforehand
of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the sole manager of the Company owing the above
described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the
subscription and payment.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

Art. 6. The share capital is fixed at four hundred fifty-seven thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 457,825.-)

represented by eighteen thousand three hundred thirteen (18,313) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholder's meeting are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille huit, le neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Tishman Speyer French Venture Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.595,

ici représentée par Monsieur Gael Toutain, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 3 décembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

"Tishman Speyer French Venture V S.à r.l.", ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.596 (la
"Société"),  constituée  suivant  acte  reçu  par  Me  Joseph  Elvinger,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  en  date  du  12
décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 155 en date du 21 janvier 2008 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire du 30 septembre 2008, en cours
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.  Le  capital  social  de  la  Société  est  fixé  à  trois  cent  cinquante  mille  trois  cent  cinquante  Euros  (EUR  350.350,-)

représenté par quatorze mille quatorze (14.014) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-)
chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent sept mille quatre cent

soixante-quinze Euros (EUR 107.475,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent cinquante mille trois cent
cinquante Euros (EUR 350.350,-) à quatre cent cinquante-sept mille huit cent vingt-cinq Euros (EUR 457.825,-) par la
création et l'émission de quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (4.299) parts sociales nouvelles d'une valeur no-
minale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

15474

IV. L'associé unique décide de souscrire aux quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (4.299) nouvelles parts so-

ciales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et de les libérer intégralement en valeur nominale au montant de cent sept
mille quatre cent soixante-quinze Euros (EUR 107.475,-) comme suit:

(i) par apport en numéraire d'un montant de soixante-neuf mille quatre cent vingt-cinq Euros (EUR 69.425,-). Cette

somme a été entièrement payée en numéraire de sorte qu'elle est dès à présent à la disposition de la société tel qu'il a
été prouvé au notaire soussigné.

(ii) par apport en nature d'un montant de trente-huit mille cinquante Euros (EUR 38.050,-) consistant en la conversion

d'une créance du même montant détenue par l'associé unique sur la Société.

<i>Description de l'apport

Une créance liquide, certaine et immédiatement exigible de trente-huit mille cinquante Euros (EUR 38.050,-) détenue

par l'associé unique à l'encontre de la Société (la "Créance").

<i>Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de la contribution a été donnée au notaire instrumentant à travers d'un bilan

comptable intérimaire de la Société arrêté au 1er décembre 2008 ainsi que d'un certificat émis par les gérants de l'associé
unique en date du 3 décembre 2008.

<i>Evaluation de l'apport

La valeur de l'apport en nature est estimé à trente-huit mille cinquante Euros (EUR 38.050,-).

<i>Réalisation effective de l'apport

L'associé unique, représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il détient une créance d'une valeur de trente-huit mille cinquante euros (EUR 38.050,-) à l'encontre de la Société;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'associé

unique n'a le droit d'acquérir la Créance;

- la Créance apportée est actuellement liquide, certaine, et immédiatement exigible pour un montant de trente-huit

mille cinquante Euros (EUR 38.050,-);

<i>Rapport du gérant unique

Le rapport du gérant unique de la Société en date du 3 décembre 2008, annexé aux présentes, atteste que Monsieur

Marcel STEPHANY, gérant de catégorie B du gérant unique de la Société, et Madame Geraldine COPELAND WRIGHT,
gérant de catégorie A du gérant unique de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur respon-
sabilité, légalement engagée en leur qualité de gérants du gérant unique de la Société à raison de l'apport en nature décrit
plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment
la validité des souscriptions et libérations.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante-sept mille huit cent vingt-cinq Euros (EUR 457.825,-) repré-

senté par dix-huit mille trois cent treize (18.313) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-)
chacune."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Gael Toutain, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 décembre 2008. LAC/2008/49822. Reçu à 0,5%: cinq cent trente-sept euros

trente-huit cents ( 537,38 €)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

15475

Senningerberg, le 22 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009014296/202/162.
(090013562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Flux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 18.975.

In the year two thousand and eight, on the twelfth day of December.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FLUX S.A., a public limited liability company, société

anonyme, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 18.975 (the
"Company"). The Company has been incorporated by deed of Me Jacques DELVAUX, notary residing then in Remich,
on December 18, 1981 and published in the 'Mémorial C' number 73 on April 8, 1982. The articles of association were
subsequently amended several times and for the last time by deed of Me Jacques DELVAUX, notary residing now in
Luxembourg, dated November 19, 2003.

The meeting is presided by Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg,
who  appoints  as  secretary  Natalie  O'SULLIVAN-GALLAGHER,  attorney-at-law,  professionally  residing  in  Luxem-

bourg.

The meeting elects as scrutineer Nicolas RONZEL, avocat, residing in Luxembourg.
The presidency of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned

notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:
1. Approval of interim financial statements of the Company as of 30 November 2008;
2. Transfer of the registered office of the Company from 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg to 22

Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX and consequently, change of the place of incorporation of the Company, with
effect from the date (the "Effective Date") on which a certificate of continuance in respect to the Company is issued by
the Jersey Financial Services Commission in its capacity as the Jersey Companies Registrar in accordance with Article
127O of the Companies (Jersey) Law 1991, as amended, (the "Jersey Law") provided that the Company ceases to be a
Luxembourg company subject to the fulfilment of all applicable provision of the laws of Jersey also as of the Effective Date;

3. Determination of the corporate form of the Company under the Jersey Law and therefore subsequent adoption of

a new memorandum and articles of association of the Company compatible with the Jersey Law (the "New Articles") and
the name under which it is proposed to continue the Company as a body corporate under the Jersey Law with effect
from the Effective Date;

4. Acceptance of the resignation of Pierre LENTZ, Armand HAAS and Guy HORNICK as current directors of the

Company duly appointed under Luxembourg law. The resignation of the current directors shall take effect from the
Effective Date;

5. Granting of a discharge to all three directors of the Company in respect of the performance of their duties until the

Effective Date;

6. Appointment of
a) Charles Stuart HORNBY, born in Liverpool, England, UK on 25 

th

 May 1953, residing professionally at 22 Grenville

Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Director of Client Services for Mourant Private Wealth;

b) Alan BINNINGTON, born in Jersey, CI on 20th January 1958, residing professionally at 22 Grenville Street, St

Helier, Jersey JE4 8PX, Director of Client Services for Mourant Private Wealth;

c) Anthony COOKE-YARBOROUGH, born in Oxford, England, UK on 6 

th

 August 1956, residing professionally at

22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, CEO of Mourant Private Wealth;

as new directors of the Company to take effect on the Effective Date; and
d) Blair KEMPSTER, born in Jersey, CI on 14 

th

 January 1967, residing professionally at 22 Grenville Street, St Helier,

Jersey JE4 8PX, Senior Manager at Mourant Private Wealth

as alternate for each director mentioned in a) to c), to take effect on the Effective Date.
7. Acceptance of the resignation of AUDIEX S.A. as statutory auditor of the Company duly appointed under Luxem-

bourg law on the Effective Date and granting of a discharge to AUDIEX S.A. in respect of the performance of its duties
as of the Effective Date;

8. Confirmation by all shareholders of the Company that (i) the New Articles are consistent with requirements of

Jersey, (ii) the Company will, with effect from the Effective Date, cease to be a Luxembourg company and (iii) that the
Company will, subject to the applicable provisions of the Jersey Law with effect from the Effective Date, be subject only

15476

to the applicable laws of Jersey and (iv) that neither the transfer of the registered office of the Company nor the change
of its place of incorporation and of its corporate form entails the dissolution and/or liquidation of the Company and the
creation of a new legal entity;

9. Delegation of powers to take any action, including without limitation the execution and delivery of any deed, form,

certificate, agreement or other document and the compliance with all applicable filing and publication formalities under
Luxembourg law and the laws of Jersey in connection with the recording of the transfer of the registered office and the
change of the place of incorporation of the Company; and

10. Approval that the books and documents in relation to the Company shall be transferred to the new registered

office of the Company in Jersey as soon as possible following the Effective Date.

II) The attending shareholders of the Company, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the attending shareholders and the officers of this
meeting and, the proxies of the represented shareholders signed by the officers of the meeting and the undersigned notary
will remain annexed to the present deed and will be registered with the deed.

The proxies of the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the proxyholders, the officers

of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to these minutes.

III) It appears from the attendance list that all the EIGHT THOUSAND (8,000) shares having a par value of ONE

THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 1,000.-) issued by the Company, representing the entire issued share capital of the
Company of EIGHT MILLION SWISS FRANCS (CHF 8,000,0000.-) are present or represented at this meeting.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders have

been advised duly in advance.

After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolves to approve the interim financial statements of the Company

as of 30 November 2008.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolves to transfer the registered office of the Company from 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg to 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX and consequently, to
change the place of incorporation of the Company with effect from the Effective Date, and in compliance with articles 2
third  paragraph,  67-1  (1)  and  159  second  paragraph  of  the  Luxembourg  law  dated  August  10,  1915  on  commercial
companies, as amended, and to file any and all documents required under the Jersey Law to give full effect to this resolution,
including the filing of a certified copy of these resolutions with the Jersey Financial Services Commission which states the
Company's new registered office as being 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX upon its continuance into Jersey.

In addition the general meeting of shareholders unanimously resolves to change as of the Effective Date the corporate

form of the Company from a Luxembourg public limited liability company into a private company incorporated in Jersey
subject to the legal and regulatory provisions applicable to such corporate form under the Jersey Law and subsequently
to adopt the New Articles so as to make them being in line with the laws of Jersey; the New Articles are set forth at the
end of this deed.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolves to accept the resignation of the current directors of the

Company duly appointed under Luxembourg law, being of Pierre LENTZ, Armand HAAS and Guy HORNICK. The
resignation of the current directors shall effect from the Effective Date.

In addition the general meeting of shareholders unanimously resolves to discharge from their liability toward the

Company all three directors of the Company in respect of the performance of their duties until and including the Effective
Date.

The general meeting of shareholders unanimously resolves to appoint:
a) Charles Stuart HORNBY, born in Liverpool, England, UK on 25 

th

 May 1953, residing professionally at 22 Grenville

Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Director of Client Services for Mourant Private Wealth;

b) Alan BINNINGTON, born in Jersey, CI on 20 

th

 January 1958, residing professionally at 22 Grenville Street, St

Helier, Jersey JE4 8PX, Director of Client Services for Mourant Private Wealth;

c) Anthony COOKE-YARBOROUGH, born in Oxford, England, UK on 6 

th

 August 1956, residing professionally at

22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, CEO of Mourant Private Wealth;

as new directors of the Company to take effect on the Effective Date; and
d) Blair KEMPSTER, born in Jersey, CI on 14 

th

 January 1967, residing professionally at 22 Grenville Street, St Helier,

Jersey JE4 8PX, Senior Manager at Mourant Private Wealth

as alternate for each director mentioned in a) to c), to take effect on the Effective Date.

15477

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolves to accept the resignation of AUDIEX S.A. as statutory

auditor of the Company duly appointed under Luxembourg law as of the Effective Date.

In addition the general meeting of shareholders unanimously resolves to discharge AUDIEX S.A. from its liability toward

the Company in respect of the performance of its duties until and including the Effective Date.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders unanimously confirms that (i) the New Articles are consistent with requirements

of the laws of Jersey, (ii) the Company will, with effect from the Effective Date, cease to be a Luxembourg company, and
(iii) that the Company will, subject to the applicable provisions of the Jersey Law as of the Effective Date, be subject to
the applicable laws of Jersey, and (iv) that neither the transfer of the registered office of the Company nor the change of
its place of incorporation and of its corporate form entails the dissolution and/or liquidation of the Company and the
creation of a new legal entity.

<i>Sixth resolution

The general meeting further unanimously resolves to appoint Alex SCHMITT, Marcus PETER, Natalie O'SULLIVAN-

GALLAGHER, Nicolas RONZEL, Franz J. MENG (lawyer residing in Switzerland), Mathew SHAXSON (lawyer residing
in Jersey), and Nicolas LEBLANC (lawyer residing in Jersey), each severally, with the broadest powers (including the
power of substitution) to take any action, including without limitation the execution and delivery of any deed, form,
certificate, agreement or other document and the compliance with all applicable filing and publication formalities under
Luxembourg law and the laws of Jersey and in connection with the recording of the transfer of the registered office and
the change of the place of incorporation of the Company at the Luxembourg Register of Commerce and Companies and
the filing of any and all documents required under the Jersey Law to give full effect to this resolution, including the filing
of a certified copy of these resolutions with the Jersey Financial Services Commission which states the Company's new
registered office as being 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX upon its continuance into Jersey, which might be
necessary or useful for the registered office of the Company to be duly and validly transferred to Jersey.

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolves that the books and documents in relation to the Company

shall be transferred to the new registered office of the Company in Jersey as soon as possible following the Effective Date.

* * *

<i>New articles and Memorandum (for the purposes of the jersey law)

I - Memorandum of Association of Flux Limited

1. The name of the Company is Flux Limited.
2. The Company is a private company.
3. The Company is a par value company.
4. The share capital of the Company is CHF 8,000,000 divided into 8, 0 shares of one class designated as Ordinary

Shares with a par value of CHF 1,000 each.

5. The liability of a member of the Company is limited to the amount unpaid (if any) on such member's share or shares.

II - Articles of Association of Flux Limited

1. Definitions and Interpretation.
1.1 In these Articles, unless inconsistent with the subject or context, the following expressions shall have the following

meanings:

"these Articles" means these Articles of Association in their present form or as from time to time altered and "Article"

shall refer to an Article of these Articles.

"auditors" means auditors (if any) of the Company appointed pursuant to these Articles.
"bankrupt" shall have the meaning defined in the Interpretation (Jersey) Law, 1954.
"clear days" in relation to the period of a notice, shall mean that period excluding the day when the notice is served

or deemed to be served and the day for which it is given or on which it is to take effect.

"Directors" means the directors of the Company for the time being.
"Jersey" means the Island of Jersey and its dependencies.
"the Law" means the Companies (Jersey) Law 1991.
"Member" means a person whose name is entered in the Register as the holder of shares in the Company.
"month" means a calendar month.
"notice" means a written notice unless otherwise specifically stated.
"Office" means the registered office of the Company.

15478

"paid up" shall include credited as paid up.
"present in person" in relation to general meetings of the Company and to meetings of the holders of any class of

shares, shall include present by attorney or by proxy or, in the case of a corporate shareholder, by representative.

"Register" means the register of Members to be kept pursuant to Article 8.1.
"Secretary" means any person appointed by the Directors to perform any of the duties of secretary of the Company

(including a temporary or assistant secretary), and in the event of two or more persons being appointed as joint secretaries
any one or more of the persons so appointed.

"Sole Directorship Resolution" has the meaning given in Article 20.2.
"Special Resolution" means a resolution of the Company passed as a special resolution in accordance with the Law.
"Written  Instruments"  means  any  document  or  instrument  in  writing  and  includes  contracts,  agreements,  deeds,

mortgages, hypothecs, charges, conveyances, transfers, assignments, releases, receipts, discharges, all paper writings, all
cheques, drafts or orders for the payment of money and all notes, acceptances and bills of exchange.

1.2 In these Articles, unless inconsistent with the subject or context:
(a) the word "may" shall be construed as permissive and the word "shall" shall be construed as imperative;
(b) the word "signed" shall be construed as including a signature or representation of a signature affixed by mechanical

or other means;

(c) the words "in writing" shall be construed as including written, printed, telexed, electronically transmitted or any

other mode of representing or reproducing words in a visible form;

(d) words importing "persons" shall be construed as including companies or associations or bodies of persons whether

incorporated or unincorporated; words importing the singular number shall be construed as including the plural number
and vice versa; words importing one gender only shall be construed as including any other gender;

(e) a reference to the Company being a private company or a public company is a reference to such status as determined

for the time being in accordance with the Law;

(f) the word "includes" shall mean "includes without limitation";
(g) where any expression is defined or the interpretation of it is set out herein, other parts of speech of such expression

shall have a corresponding meaning; and

(h) references to enactments are to such enactments as are from time to time modified, re-enacted or consolidated

and shall include any enactment made in substitution for an enactment that is repealed.

1.3 The headings herein are for convenience only and shall not affect the construction of these Articles.

2. Preliminary.
2.1 The preliminary expenses incurred in forming the Company may be discharged out of the funds of the Company.
2.2 The business of the Company shall be commenced as soon after the incorporation of the Company as the Directors

think fit.

3. Share Capital.
3.1 The share capital of the Company is as specified in the Memorandum of Association and the shares of the Company

shall have the rights and be subject to the conditions contained in these Articles.

4. Shares.
4.1 Without prejudice to any special rights for the time being conferred on the holders of any class of shares (which

special rights shall not be varied or abrogated except with such consent or sanction as is required by Article 6.1 and
subject to the Law) any share in the Company (including any share created on an increase or other alteration of share
capital) may be issued with such preferred, deferred or other special rights, or such restrictions, whether in regard to
dividends, return of capital, voting or otherwise, as the Company may from time to time, by Special Resolution, determine.

4.2 The unissued shares for the time being in the capital of the Company shall be at the disposal of the Directors, and

they may (subject to the provisions of Article 4.1) allot, grant options over, or otherwise dispose of them to such persons
at such times and on such terms as they think proper, but so that no shares shall be issued at a discount.

4.3 The Directors may issue shares in the Company to any person and without any obligation to offer such shares to

the Members (whether in proportion to the existing shares held by them or otherwise).

4.4 The Company may issue fractions of shares in accordance with and subject to the provisions of the Law, provided

that:

(a) a fraction of a share shall be taken into account in determining the entitlement of a Member as regards dividends

or on a winding up; and

(b) a fraction of a share shall not entitle a Member to a vote in respect thereof.
4.5 Subject to the Law, the Company may, by Special Resolution, convert any existing non-redeemable limited shares

(whether issued or not) into, limited shares that are to be redeemed, or are liable to be redeemed in accordance with
their terms, which may include provision for redemption at the option of either or both of the Company or the holder
thereof.

15479

4.6 The Company may pay commissions as permitted by the Law. Subject to the provisions of the Law, any such

commission may be satisfied either by the payment of cash or by the allotment of fully or partly paid shares or partly in
one way and partly in the other.

4.7 Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust, and

the Company shall not be bound by or recognise any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or
(except only as by these Articles otherwise provided or as by law required) any interest in any fraction of a share, or any
other right in respect of any share, except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

5. Alteration of Share Capital.
5.1 The Company may, by altering its Memorandum of Association by Special Resolution, alter its share capital in any

manner permitted by the Law.

5.2 Any capital raised by the issue of shares shall, unless otherwise provided by the conditions of issue of such shares,

be considered as part of the original capital, and such shares shall be subject to the provisions of these Articles with
reference to the payment of calls, transfer and transmission of shares, lien or otherwise, applicable to the existing shares
in the Company.

5.3 Subject to the provisions of the Law, the Company may, by Special Resolution, reduce its share capital in any way.

6. Variation of Rights.
6.1 Whenever different classes of shares in the capital of the Company are in issue, the special rights attached to any

class, unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class, may be varied or abrogated, either whilst
the Company is a going concern or during or in contemplation of a winding up, with the consent in writing of the holders
of the majority of the issued shares of that class, or with the sanction of a resolution passed at a separate meeting of the
holders of shares of that class, but not otherwise. To every such separate meeting all the provisions of these Articles and
of the Law relating to general meetings of the Company or to the proceedings thereat shall apply, mutatis mutandis,
except that the necessary quorum shall be two persons holding or representing at least one-third in nominal amount of
the issued shares of that class but so that if at any adjourned meeting of such holders a quorum as above defined is not
present, those holders who are present in person shall be a quorum.

6.2 The special rights conferred upon the holders of any class of shares issued with preferred or other special rights

shall be deemed to be varied by the reduction of the capital paid up on such shares and by the creation of further shares
ranking in priority thereto, but shall not (unless otherwise expressly provided by these Articles or by the conditions of
issue of such shares) be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking after or pari passu therewith.

7. Share Certificates.
7.1 Every Member shall be entitled:
(a) without payment, to one certificate for all his shares of each class and, when part only of the shares comprised in

a certificate is sold or transferred, to a new certificate for the remainder of the shares so comprised; or

(b) upon payment of such sum for each certificate as the Directors shall from time to time determine, to several

certificates each for one or more of his shares of any class.

7.2 Every certificate shall be issued within two months after allotment or lodgement of transfer (or within such other

period as the conditions of issue shall provide), shall be issued either under seal or signed by two Directors or by one
Director and the Secretary, and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon and, if so
required by the Law, the distinguishing numbers of such shares.

7.3 In respect of a share held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one

certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such
holders.

7.4 If a share certificate is defaced, damaged, lost or destroyed, it may be renewed on payment of such fee and on such

terms (if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company in relation thereto
as the Directors think fit.

8. Register of Members.
8.1 The Directors shall keep or cause to be kept at the Office or at such other place in Jersey where it is made up, as

the Directors may from time to time determine, a Register in the manner required by the Law. In each year the Directors
shall prepare or cause to be prepared and filed an annual return containing the particulars required by the Law.

9. Joint Holders.
9.1 Where two or more persons are registered as the holders of any share they shall be deemed to hold the same as

joint tenants with the benefit of survivorship, subject to the following provisions:

(a) the Company shall not be bound to register more than four persons as the joint holders of any share;
(b) the joint holders of any share shall be liable, severally as well as jointly, in respect of all payments to be made in

respect of such share;

15480

(c) any one of such joint holders may give a good receipt for any dividend, bonus or return of capital payable to such

joint holders;

(d) only the senior of the joint holders of a share shall be entitled to delivery of the certificate relating to such share

or to receive notices from the Company and any notice given to the senior joint holder shall be deemed notice to all the
joint holders; and

(e) for the purpose of the provisions of this Article, seniority shall be determined by the order in which the names of

the joint holders appear in the Register.

10. Lien.
10.1 The Company shall have a first and paramount lien on every share (not being a fully paid share) for all monies,

whether presently payable or not, called or payable at a fixed time in respect of such shares; and the Company shall also
have a first and paramount lien on all shares (other than fully paid shares) registered in the name of a single Member for
all the debts and liabilities of such Member or his estate to the Company, whether the same shall have been incurred
before or after notice to the Company of any interest of any person other than such Member and whether the period
for the payment or discharge of the same shall have actually commenced or not, and notwithstanding that the same are
joint debts or liabilities of such Member or his estate and any other person whether a Member or not. The Company's
lien (if any) on a share shall extend to all dividends or other monies payable thereon or in respect thereof. The Directors
may resolve that any share shall, for such period as they think fit, be exempt from the provisions of this Article.

10.2 The Company may sell any shares on which the Company has a lien in such manner as the Directors think fit, but

no sale shall be made unless some monies in respect of which the lien exists are presently payable, and fourteen days
have expired after a notice, stating and demanding payment of the monies presently payable and giving notice of intention
to sell in default, shall have been served on the holder for the time being of the shares or the person entitled by reason
of his death or bankruptcy to the shares.

10.3 The net proceeds of such sale, after payment of the costs of such sale, shall be applied in or towards payment or

satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists, so far as the same is presently payable, and any
residue shall (subject to a like lien for debts or liabilities not presently payable as existed upon the shares prior to the
sale) be paid to the person entitled to the shares at the time of the sale. For giving effect to any such sale the Directors
may authorise a person to execute an instrument of transfer of the shares sold to the purchaser thereof. The purchaser
shall be registered as the holder of the shares so transferred and he shall not be bound to see to the application of the
purchase money nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference
to the sale.

11. Calls on Shares.
11.1 The Directors may, subject to the provisions of these Articles and to any conditions of allotment, from time to

time make calls upon the Members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal
amount of the shares or by way of premium), provided that (except as otherwise fixed by the conditions of application
or allotment) no call on any share shall be payable within fourteen days of the date appointed for payment of the last
preceding call, and each Member shall (subject to being given at least fourteen clear days' notice specifying the time or
times and place of payment) pay to the Company at the time or times and place so specified the amount called on his
shares.

11.2 A call may be made payable by instalments. A call may be postponed or wholly or in part revoked as the Directors

may determine. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising
the call was passed.

11.3 If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person

from whom the sum is due may be required to pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to
the time of actual payment at a rate determined by the Directors not exceeding the rate of ten per cent per annum.

11.4 Any sum which by or pursuant to the terms of issue of a share becomes payable upon allotment or at any fixed

date (whether on account of the nominal amount of the share or by way of premium) shall, for all the purposes of these
Articles, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which, by or pursuant to the terms of issue, the
same becomes payable, and in case of non-payment, all the relevant provisions of these Articles as to payment of interest,
forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.

11.5 The Directors may make arrangements on the issue of shares for a difference between the holders in the amount

of calls to be paid and in the times of payment.

11.6 The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance the same, all or any part of the

money uncalled and unpaid upon the shares held by him beyond the sums actually called up thereon as a payment in
advance of calls. Any such payment in advance of calls shall extinguish, so far as the same shall extend, the liability upon
the shares in respect of which it is advanced. The Company may pay interest upon the money so received, or upon so
much thereof as from time to time exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect of which it has
been received, at such rate as the Directors shall think fit provided that any amount paid up in advance of calls shall not
entitle the holder of the shares upon which such amount is paid to participate in respect thereof in any dividend until the
same would but for such advance become presently payable.

15481

12. Forfeiture and Surrender of Shares.
12.1 If a Member fails to pay any call or instalment of a call on or before the day appointed for payment thereof, the

Directors may at any time thereafter, during such time as any part of such call or instalment remains unpaid, serve a
notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may
have accrued and any expenses which may have been incurred by the Company by reason of such non-payment or accept
their surrender instead of causing them to be so forfeited.

12.2 The notice shall name a further day (not earlier than fourteen days from the date of service thereof) on or before

which and the place where the payment required by the notice is to be made, and shall state that in the event of non-
payment at or before the time and at the place appointed, the shares on which the call was made will be liable to be
forfeited.

12.3 If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which such

notice has been given may at any time thereafter, before payment of all calls and interest due in respect thereof have
been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect, and such forfeiture shall include all dividends which
shall have been declared on the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

12.4 When any share has been forfeited in accordance with these Articles, notice of the forfeiture shall forthwith be

given to the holder of the share or the person entitled to the share by transmission, as the case may be, and an entry of
such notice having been given, and of the forfeiture with the date thereof, shall forthwith be made in the Register opposite
to the entry of the share; but no forfeiture shall be invalidated in any manner by any omission or neglect to give such
notice or to make such entry as aforesaid.

12.5 A forfeited or surrendered share may be sold, re-allotted or otherwise disposed of, either to the person who

was before forfeiture or surrender the holder thereof or entitled thereto, or to any other person, upon such terms and
in such manner as the Directors think fit, and at any time before a sale, re-allotment or disposition the forfeiture or
surrender may be cancelled on such terms as the Directors think fit. The Directors may, if necessary, authorise some
person to transfer a forfeited or surrendered share to any other person as aforesaid.

12.6 A Member whose shares have been forfeited or surrendered shall cease to be a Member in respect of the forfeited

or surrendered shares but shall, notwithstanding the forfeiture or surrender, remain liable to pay to the Company all
monies which at the date of forfeiture or surrender were presently payable by him to the Company in respect of the
shares, with interest thereon at a rate determined by the Directors not exceeding ten per cent per annum from the date
of forfeiture or surrender as the case may be until payment and the Directors may enforce payment without any allowance
for the value of the shares at the time of forfeiture or surrender.

12.7 An affidavit by a Director or the Secretary that a share has been duly forfeited or surrendered on the date stated

therein shall be conclusive evidence of the facts so stated as against all persons claiming to be entitled to the share and
such affidavit and the receipt of the Company for the consideration (if any) given for the share on the sale, re-allotment
or disposal thereof, together with the certificate for the share delivered to a purchaser or allottee thereof, shall (subject
to the execution of a transfer if the same be so required) constitute good title to the share and the person to whom the
share is sold, re-allotted or disposed of shall be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to
the application of the consideration (if any), nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in
the proceedings in respect of the forfeiture, surrender, sale, re-allotment or disposal of the share.

12.8 The provisions of these Articles as to forfeiture and surrender shall apply in the case of non-payment of any sum

which by the terms of issue of a share becomes payable at a fixed time (whether on account of the nominal amount of
the share or by way of premium) as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

13. Transfer and Transmission of Shares.
13.1 All transfers of shares shall be effected by notice (a "Transfer Notice") in the usual common form or in any other

form approved by the Directors. All Transfer Notices shall be signed by or on behalf of the transferor and, in the case
of a partly paid share, by the transferee. The transferor shall be deemed to remain the holder of the share until the name
of the transferee is entered on the Register in respect thereof.

13.2 The Directors may in their absolute discretion, and without assigning any reason therefor, refuse to register any

transfer of partly paid shares, including a transfer of such shares to a person of whom they do not approve and may refuse
to register any transfer of shares on which the Company has a lien, but shall not otherwise refuse to register a transfer
of shares made in accordance with these Articles.

13.3 The Directors may decline to recognise any Transfer Notice, unless:
(a) the Transfer Notice is deposited at the Office or such other place as the Directors may appoint accompanied by

the certificate for the shares to which it relates and such other evidence as the Directors may reasonably require to show
the right of the transferor to make the transfer; and

(b) the Transfer Notice is in respect of only one class of shares.
13.4 If the Directors refuse to register any transfer of shares they shall, within two months after the date on which

the Transfer Notice was lodged with the Company, send to the proposed transferor and transferee notice of the refusal.

15482

13.5 All Transfer Notices relating to transfers of shares which are registered shall be retained by the Company, but

any Transfer Notices relating to transfers of shares which the Directors decline to register shall (except in any case of
fraud) be returned to the person depositing the same.

13.6 The registration of transfers of shares or of any class of shares may not be suspended.
13.7 In respect of any allotment of any share the Directors shall have the same right to decline to approve the regis-

tration of any renouncee of any allottee as if the application to allot and the renunciation were a transfer of a share under
these Articles.

13.8 In the case of the death of a Member, the survivors or survivor, where the deceased was a joint holder, and the

executors or administrators of the deceased, where he was a sole or only surviving holder, shall be the only persons
recognised by the Company as having any title to his interest in the shares, but nothing in this Article shall release the
estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share jointly held by him.

13.9 Any guardian of an infant Member and any curator or guardian or other legal representative of a Member under

legal disability and any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency or bankruptcy of
a Member or otherwise by operation of law may, upon such evidence as to his entitlement being produced as may from
time to time be required by the Directors and subject as hereinafter provided, elect either to be registered himself as
the holder of the share or to have some person nominated by him registered as the holder thereof.

13.10 If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself, he shall deliver or send to the Company

a notice signed by him stating that he so elects together with such evidence as to his entitlement as may from time to
time be required by the Directors. If he shall elect to have another person registered, he shall testify his election by signing
a Transfer Notice in favour of that person. All the limitations, restrictions and provisions of these Articles relating to the
right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or Transfer Notice as
aforesaid as would have existed had such transfer occurred before the death, insolvency or bankruptcy of the Member
concerned.

13.11 A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency or bankruptcy of a Member or

otherwise by operation of law shall, upon such evidence as to his entitlement being produced as may from time to time
be required by the Directors, be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if
he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a Member in respect of
the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the Company
provided always that the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered
himself or to transfer the share and if the notice is not complied with within one month such person shall be deemed to
have so elected to be registered himself and all the restrictions on the transfer and transmission of shares contained in
these Articles shall apply to such election.

13.12 Unless otherwise decided by the Directors in their sole discretion, no fee shall be charged in respect of the

registration of any probate, letters of administration, certificate of marriage or death, power of attorney or other docu-
ment relating to or affecting the title to any shares.

14. General Meetings and Class Meetings.
14.1 The provisions of Article 14.2 shall apply with regard to annual general meetings of the Company unless all of the

Members have agreed in writing to dispense with the holding of annual general meetings and any such agreement is and
remains valid in accordance with the Law.

14.2 An annual general meeting shall be held once in every calendar year; but so long as the Company holds its first

annual general meeting within eighteen months of its incorporation it need not hold it in the year of its incorporation or
in the following year. All other general meetings shall be called extraordinary general meetings. Each general meeting shall
be held at such time and such place (either in or outside Jersey) as may be determined by the Directors.

14.3 The Directors may whenever they think fit, and upon a requisition made in writing by Members in accordance

with the Law the Directors shall, convene an extraordinary general meeting of the Company.

14.4 At any extraordinary general meeting called pursuant to a requisition, unless such meeting is called by the Di-

rectors, no business other than that stated in the requisition as the objects of the meeting shall be transacted.

14.5 Save as is provided in this Article and otherwise in these Articles, all the provisions of these Articles and of the

Law relating to general meetings of the Company and to the proceedings thereat shall apply, mutatis mutandis, to every
class meeting. At any class meeting the holders of shares of the relevant class shall, on a poll, have one vote in respect of
each share of that class held by each of them.

15. Notice of General Meetings.
15.1 At least fourteen clear days' notice shall be given of every annual general meeting and of every general meeting

called for the passing of a Special Resolution, and at least fourteen clear days' notice shall be given of all other general
meetings. Every notice shall specify the place, the day and the time of the meeting and in the case of special business, the
general nature of such business and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such. Notice of
every meeting shall be given in the manner hereinafter mentioned to all the Members and to the Directors and to the
auditors.

15483

15.2 A meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in Article

15.1, be deemed to have been duly called if it is so agreed:

(a) in the case of an annual general meeting, by all the Members entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of any other meeting, by a majority in number of Members having a right to attend and vote at the

meeting, being a majority together holding not less than ninety-five per cent of the total voting rights of the Members
who have that right.

15.3 In every notice calling a meeting of the Company there shall appear with reasonable prominence a statement that

a Member entitled to attend and vote is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote instead of him and
that a proxy need not also be a Member.

15.4 It shall be the duty of the Company, subject to the provisions of the Law, on the calling of a meeting on the

requisition in writing of such number of Members as is specified by the Law:

(a) to give to the Members entitled to receive notice of general meetings and to the Directors notice of any resolution

which may properly be moved and which it is intended to move at that meeting; and

(b) to circulate to Members entitled to have notice of any general meeting sent to them, any statement of not more

than one thousand words with respect to the matter referred to in any proposed resolution or the business to be dealt
with at that meeting.

15.5 The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person

entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

16. Proceedings at General Meetings.
16.1 The business of an annual general meeting shall be to receive and consider the accounts of the Company and the

reports of the Directors and auditors, to elect Directors (if necessary), to elect auditors and fix their remuneration, to
sanction a dividend if thought fit so to do, and to transact any other business of which notice has been given.

16.2 No business shall be transacted at any general meeting except the adjournment of the meeting unless a quorum

of Members is present at the time when the meeting proceeds to business. Such quorum shall consist of not less than
two Members present in person, but so that not less than two individuals will constitute the quorum provided that, if at
any time all of the issued shares in the Company are held by one Member, such quorum shall consist of the Member
present in person.

16.3 If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, or if during the meeting

a quorum ceases to be present, the meeting, if convened by or upon the requisition of Members, shall be dissolved. If
otherwise convened the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or
such day, time and place as the Directors shall determine.

16.4 The chairman (if any) of the Directors shall preside as chairman at every general meeting of the Company. If there

is no such chairman, or if at any meeting he is not present, the Members present in person shall choose one of the
Directors present to be chairman, or if no Director shall be present and willing to take the chair the Members present
in person shall choose one of their number to be chairman.

16.5 The chairman may with the consent of any meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the

meeting) adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any
adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When
a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of the original
meeting. Save as aforesaid, it shall not be necessary to give any notice of any adjourned meeting or of the business to be
transacted at an adjourned meeting.

16.6 Minutes of all resolutions and proceedings of general meetings shall be duly and regularly entered in books kept

for that purpose and shall be available for inspection by a Member during business hours without charge. A Member may
require a copy of any such minutes in such manner, and upon payment of such sum, as provided in the Law.

16.7 If a Member is by any means in communication with one or more other Members so that each Member participating

in the communication can hear what is said by any other of them, each Member so participating in the communication is
deemed to be present in person at a meeting with the other Members so participating, notwithstanding that all the
Members so participating are not present together in the same place. A meeting at which any or all of the Members
participate as aforesaid shall be deemed to be a general meeting of the Company for the purposes of these Articles
notwithstanding any other provisions of these Articles and all of the provisions of these Articles and of the Law relating
to general meetings of the Company and to the proceedings thereat shall apply, mutatis mutandis, to every such meeting.

16.8 The Directors and the auditors shall be entitled to receive notice of and to attend and speak at any meeting of

Members.

17. Voting at General Meetings.
17.1 Save where otherwise provided in these Articles, no person shall be entitled to be present or take part in any

proceedings or vote either personally or by proxy at any general meeting unless he has been registered as owner of the
shares in respect of which he claims to vote.

15484

17.2 Save where otherwise provided in the Law or in these Articles, all resolutions shall be adopted if approved by a

majority of the votes cast. In the event of an equality of votes at any general meeting, whether upon a show of hands or
on a poll, the chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

17.3 At any general meeting every question shall be decided in the first instance by a show of hands and, unless a poll

is demanded by the chairman or by any Member, a declaration by the chairman that a resolution has on a show of hands
been carried or not carried, or carried or not carried by a particular majority or lost, and an entry to that effect in the
minutes of the meeting shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes
recorded in favour of or against such resolution.

17.4 On a show of hands every Member present in person shall have one vote.
17.5 If a poll is demanded in the manner mentioned above, it shall be taken at such time (within twenty-one days) and

in such manner as the chairman directs and the results of such poll shall be deemed to be the resolution of the Company
in general meeting. A poll may be demanded upon the election of the chairman and upon a question of adjournment and
such poll shall be taken forthwith without adjournment. Any business other than that upon which a poll has been demanded
may proceed pending the taking of the poll.

17.6 Subject to any special voting powers or restrictions for the time being attached to any shares, as may be specified

in the terms of issue thereof or these Articles, on a poll every Member present in person shall have one vote for each
share held by him.

17.7 On a poll a Member entitled to more than one vote need not use all his votes or cast all the votes he uses in the

same way.

17.8 Where there are joint registered holders of any share, such persons shall not have the right of voting individually

in respect of such share but shall elect one of their number to represent them and to vote whether in person or by proxy
in their name. In default of such election the person whose name appears first in order in the Register in respect of such
share shall be the only person entitled to vote in respect thereof.

17.9 A Member for whom a special or general attorney is appointed or who is suffering from some other legal incapacity

or  interdiction  in  respect  of  whom  an  order  has  been  made  by  any  court  having  jurisdiction  (whether  in  Jersey  or
elsewhere) in matters concerning legal incapacity or interdiction may vote, whether on a show of hands or on a poll, by
his attorney, curator, or other person authorised in that behalf appointed by that court, and any such attorney, curator
or other person may vote by proxy. Evidence to the satisfaction of the Directors of the authority of such attorney, curator
or other person may be required by the Directors prior to any vote being exercised by such attorney, curator or other
person.

17.10 No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at

which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all
purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the chairman of the meeting whose decision shall be
final and conclusive.

17.11 Where a person is authorised under Article 19.8 to represent a body corporate at a general meeting of the

Company the Directors or the chairman of the meeting may require him to produce a certified copy of the resolution
from which he derives his authority.

18. Members' Resolutions in Writing.
18.1 A resolution in writing (including a Special Resolution but excluding a resolution removing an auditor) signed by

all Members who would be entitled to receive notice of and to attend and vote at a general meeting at which such a
resolution would be proposed, or by their duly appointed attorneys, shall be as valid and effectual as if it had been passed
at a general meeting of the Company duly convened and held.

18.2 Any such resolution may consist of several documents in the like form each signed by one or more of the Members

or their attorneys and signature in the case of a corporate body which is a Member shall be sufficient if made by a director
or other duly authorised officer thereof or its duly appointed attorney.

19. Proxies for General Meetings and Corporate Members.
19.1 The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly

authorised in writing or if the appointor is a corporation either under seal or under the hand of an officer or attorney
duly authorised. A proxy need not be a Member.

19.2 The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed,

or a copy of that power or authority certified as a true copy to the satisfaction of the Secretary, shall be deposited at the
Office within such time (not exceeding forty-eight hours) before the time for holding the meeting or adjourned meeting
or for the taking of a poll at which the person named in the instrument proposes to vote as the Directors may from time
to time determine.

19.3 A Member may, by one or more instruments specifically identifying the number (and, if applicable, the class) of

shares to which it relates and otherwise complying with these Articles, appoint different proxies in respect of different
shares held by such Member and who shall each have the right to attend, speak and vote at the meeting for which he is

15485

appointed. Each such proxy shall take effect in accordance with these Articles only in respect of such specified number
of shares held by such Member.

19.4 The instrument appointing a proxy may be in any common form or in any other form approved by the Directors

including the following form:

"(_Insert name of Company_)
I/We (___) of (___) being a Member/Members of the above named Company hereby appoint (___) of (___) or failing

him (___) of (___) as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the (annual or extraordinary as the case may
be) general meeting of the Company to be held on the (___) day of (___) and at any adjournment thereof.

Signed this (___) day of (___)"
19.5 Unless the contrary is stated thereon the instrument appointing a proxy shall be as valid as well for any adjourn-

ment of the meeting as for the meeting to which it relates.

19.6 A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous

death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed
provided that no intimation in writing of such death, insanity or revocation shall have been received by the Company at
the Office before the commencement of the meeting or adjourned meeting or the taking of the poll at which the proxy
is used.

19.7 The Directors may at the expense of the Company send by post or otherwise to the Members instruments of

proxy (with or without provision for their return prepaid) for use at any general meeting or at any separate meeting of
the holders of any class of shares of the Company either in blank or nominating in the alternative any one or more of
the Directors or any other persons. If for the purpose of any meeting invitations to appoint as proxy a person or one or
more of a number of persons specified in the invitations are issued at the Company's expense they shall be issued to all
(and not to some only) of the Members entitled to be sent a notice of the meeting and to vote thereat by proxy.

19.8 Any body corporate which is a Member may by resolution of its directors or other governing body authorise

such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of Members (or of any class of Members) and the
person so authorised shall be entitled to exercise on behalf of the body corporate which he represents the same powers
as that body corporate could exercise if it were an individual. The body corporate may, by one or more of such resolutions,
specifically identifying the number (and, if applicable, the class) of shares to which it relates, appoint different persons in
respect of different shares held by such body corporate. Each such resolution shall take effect in accordance with this
Article only in respect of such specified number of shares held by such body corporate.

20. Directors.
20.1 The Company may by ordinary resolution determine the maximum and minimum number of Directors and unless

and until otherwise so determined or (save where the Law otherwise provides) where only one Director is appointed
by the Subscribers to the Memorandum of Association or by the majority of them pursuant to Article 23.1, the minimum
number of Directors shall be two. The Company shall keep or cause to be kept at the Office a register of its Directors
in the manner required by the Law.

20.2 Save where the Law otherwise provides, the Company may determine by ordinary resolution that there shall be

only one Director. Such resolution (a "Sole Directorship Resolution") shall cease to have effect upon the Company ceasing
to be permitted by the Law to have only one Director and shall not revive if the Company again becomes permitted by
the Law to do so.

20.3 A Director need not be a Member but shall nevertheless be entitled to receive notice of and to attend and speak

at any general meeting or at any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company.

20.4 The Directors shall be paid out of the funds of the Company their travelling and other expenses properly and

necessarily expended by them in attending meetings of the Directors or Members or otherwise on the affairs of the
Company. They shall also be paid by way of remuneration for their services as Directors such sum as shall be fixed by
resolution of the Company, which shall be divided between them as they shall agree or, failing agreement, equally and
shall be deemed to accrue from day to day. If any Director shall be appointed agent or to perform extra services or to
make  any  special  exertions  or  to  go  or  reside  abroad  for  any  of  the  purposes  of  the  Company,  the  Directors  may
remunerate such Director therefor either by a fixed sum or by commission or participation in profits or otherwise or
partly one way and partly in another as they think fit, and such remuneration may be either in addition to or in substitution
for his remuneration hereinbefore provided.

21. Alternate Directors.
21.1 Any Director may at his sole discretion and at any time and from time to time appoint any person (other than a

person disqualified by law from being a director of a company) as an alternate Director to attend and vote in his place at
any meetings of Directors at which he is not personally present. Each Director shall be at liberty to appoint under this
Article more than one alternate Director provided that only one such alternate Director may at any one time act on
behalf of the Director by whom he has been appointed. Every such appointment shall be effective and the following
provisions shall apply in connection therewith:

15486

(a) every alternate Director while he holds office as such shall be entitled to notice of meetings of Directors and to

attend and to exercise all the rights and privileges of his appointor at all such meetings at which his appointor is not
personally present;

(b) every alternate Director shall ipso facto vacate office if and when his appointment expires or the Director who

appointed him ceases to be a Director of the Company or removes the alternate Director from office by notice under
his hand served upon the Company;

(c) every alternate Director shall be entitled to be paid all travelling, hotel and other expenses reasonably incurred by

him in attending meetings. The remuneration (if any) of an alternate Director shall be payable out of the remuneration
payable to the Director appointing him as may be agreed between them;

(d) a Director may act as alternate Director for another Director and shall be entitled to vote for such other Director

as well as on his own account, but no Director shall at any meeting be entitled to act as alternate Director for more than
one other Director; and

(e) a Director who is also appointed an alternate Director shall be considered as two Directors for the purpose of

making a quorum of Directors when such quorum shall exceed two.

21.2 If a Director who has appointed an alternate Director is for the time being temporarily unable to act through ill

health or disability the signature of the alternate Director to any resolution in writing made by the Directors shall be as
effective as the signature of his appointer.

21.3 The instrument appointing an alternate Director may be in any form approved by the Directors including the

following form:

"(_Insert name of Company_)
I, (___) a Director of the above named Company, in pursuance of the power in that behalf contained in the Articles

of Association of the Company, do hereby nominate and appoint (___) of (___) to act as alternate Director in my place
at the meeting of the Directors to be held on the (___) day of (___) and at any adjournment thereof which I am unable
to attend and to exercise all my duties as a Director of the Company at such meeting.

Signed this (___) day of (___)"
21.4 Save as otherwise provided in Article 21.1(b), any appointment or removal of an alternate Director shall be by

notice signed by the Director making or revoking the appointment and shall take effect when lodged at the Office or
otherwise notified to the Company in such manner as is approved by the Directors.

22. Executive Directors.
22.1 The Directors may from time to time appoint one or more of their number to be the holder of any executive

office on such terms and for such periods as they may determine. The appointment of any Director to any executive
office shall be subject to termination if he ceases to be a Director, but without prejudice to any claim for damages for
breach of any contract of service between him and the Company.

22.2 The Directors may entrust to and confer upon a Director holding any executive office any of the powers exer-

cisable by the Directors, upon such terms and conditions and with such restrictions as they think fit, and either collaterally
with or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of
such powers.

23. Appointment of Directors.
23.1 The first Directors shall be appointed in writing by the Subscribers to the Memorandum of Association or by the

majority of them.

23.2 Subject to the provisions of Article 20.1, the Directors shall have power at any time and from time to time to

appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors.

23.3 At any general meeting at which a Director retires or is removed from office the Company may elect a Director

to fill the vacancy, unless the Company determines to reduce the number of Directors in office.

23.4 If the Company in general meeting determines to increase the number of Directors in office the Company shall

elect additional Directors.

23.5 Seven clear days' notice shall be given to the Company of the intention of any Member to propose any person

for election to the office of Director provided always that, if the Members present in person at a general meeting una-
nimously consent, the chairman of such meeting may waive the said notice and submit to the meeting the name of any
person duly qualified and willing to act.

24. Resignation, Disqualification and Removal of Directors.
24.1 The office of a Director shall be vacated if:
(a) he resigns his office by notice to the Company; or
(b) he ceases to be a Director by virtue of any provision of the Law or becomes prohibited or disqualified by law from

being a Director; or

(c) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(d) he is removed from office by resolution of the Members.

15487

24.2 Unless specified otherwise in the instrument or resolution of appointment, a Director shall hold office until he

resigns or is disqualified in accordance with Article 24.1.

25. Powers of Directors.
25.1 The business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all such powers of the Company

as are not by the Law or these Articles required to be exercised by the Company in general meeting, and the power and
authority to represent the Company in all transactions relating to real and personal property and all other legal or judicial
transactions, acts and matters and before all courts of law shall be vested in the Directors. At any time that a Sole
Directorship Resolution is in effect, the business of the Company shall be managed by the sole Director. The Directors'
powers shall be subject to these Articles, the Law and to such regulations, being not inconsistent with these Articles or
the Law, as may be prescribed by the Company in general meeting, but no regulations made by the Company in general
meeting shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if such regulations had not been made.

25.2 The Directors may, by power of attorney, mandate or otherwise, appoint any person to be the agent of the

Company for such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all
or any of his powers.

26. Transactions with Directors.
26.1 A Director, including an alternate Director, may hold any other office or place of profit under the Company

(other than the office of auditor) in conjunction with his office of Director and may act in a professional capacity to the
Company on such terms as to tenure of office, remuneration and otherwise as the Directors may determine.

26.2 Subject to the provisions of the Law, and provided that he has disclosed to the Directors the nature and extent

of any of his interests which conflict or may conflict to a material extent with the interests of the Company at the first
meeting of the Directors at which a transaction is considered or as soon as practical after that meeting by notice in writing
to the Secretary or has otherwise previously disclosed that he is to be regarded as interested in a transaction with a
specific person, a Director notwithstanding his office:

(a) may be a party to, or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the

Company is otherwise interested;

(b) may be a director or other officer of, or employed by, or a party to any transaction or arrangement with, or

otherwise interested in, any body corporate promoted by the Company or in which the Company is otherwise interested;
and

(c) shall not, by reason of his office, be accountable to the Company for any benefit which he derives from any such

office or employment or from any such transaction or arrangement or from any interest in any such body corporate and
no such transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit.

26.3 For the purposes of Article 26.2:
(a) a general notice given to the Directors or Secretary in the manner there specified that a Director is to be regarded

as having an interest of the nature and extent specified in the notice in any transaction or arrangement in which a specified
person or class of persons is interested shall be deemed to be a disclosure that the Director has an interest in any such
transaction of the nature and extent so specified; and

(b) an interest of which a Director has no knowledge and of which it is unreasonable to expect him to have knowledge

shall not be treated as an interest of that Director.

26.4 Where disclosure of an interest is made to the Secretary in accordance with Article 26.2 the Secretary shall

inform the Directors that it has been made and table the notice of the disclosure at the next meeting of the Directors.
Any disclosure at a meeting of the Directors shall be recorded in the minutes of the meeting.

27. Proceedings of Directors.
27.1 The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings

as they think fit. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes. In case of an equality of
votes the chairman shall have a second or casting vote. A Director who is also an alternate Director shall be entitled, in
the absence of the Director whom he is representing, to a separate vote on behalf of such Director in addition to his
own vote. A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, at any time, summon a meeting of
the Directors by giving to each Director and alternate Director not less than twenty-four hours' notice of the meeting
provided that any meeting may be convened at shorter notice and in such manner as each Director or his alternate
Director shall approve provided further that unless otherwise resolved by the Directors notices of Directors' meetings
need not be in writing.

27.2 A meeting of the Directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all powers and discretions

for the time being exercisable by the Directors. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors
may be fixed by the Directors, and unless so fixed at any other number shall be two. At any time that a Sole Directorship
Resolution is in effect, such quorum shall be one. For the purposes of this Article and subject to the provisions of Article
21.1(d), an alternate Director shall be counted in a quorum, but so that not less than two individuals will constitute the
quorum.

15488

27.3 A Director, notwithstanding his interest, may be counted in the quorum present at any meeting at which he is

appointed to hold any office or place of profit under the Company, or at which the terms of his appointment are arranged,
but he may not vote on his own appointment or the terms thereof.

27.4 A Director, notwithstanding his interest, may be counted in the quorum present at any meeting at which any

contract or arrangement in which he is interested is considered and, subject to the provisions of Article 26.2, he may
vote in respect of any such contract or arrangement.

27.5 The continuing Directors or a sole continuing Director may act notwithstanding any vacancies in their number,

but, if the number of Directors is less than the number fixed as the quorum, the continuing Directors or Director may
act only for the purpose of filling vacancies or of calling a general meeting of the Company. This Article shall not apply at
any time that a Sole Directorship Resolution is in effect.

27.6 If there are no Directors or no Director is able or willing to act, then any Member or the Secretary may summon

a general meeting for the purpose of appointing Directors.

27.7 The Directors may from time to time elect from their number, and remove, a chairman and/or deputy chairman

and/or vice-chairman and determine the period for which they are to hold office. The chairman, or in his absence the
deputy chairman, or in his absence, the vice-chairman, shall preside at all meetings of the Directors, but if no such chairman,
deputy chairman or vice-chairman be elected, or if at any meeting the chairman, the deputy chairman and vice-chairman
be not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present may choose one
of their number to be the chairman of the meeting.

27.8 The Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such Directors or Director or such

other persons as they think fit. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to
any  regulations  that  may  be  imposed  on  it  by  the  Directors.  The  meetings  and  proceedings  of  any  such  committee
consisting of two or more persons shall be governed by the provisions of these Articles regulating the meetings and
proceedings of the Directors, so far as the same are applicable and are not superseded by any regulations made by the
Directors under this Article.

27.9 If a Director is by any means in communication with one or more other Directors so that each Director parti-

cipating  in  the  communication  can  hear  what  is  said  by  any  other  of  them,  each  Director  so  participating  in  the
communication is deemed to be present at a meeting with the other Directors so participating, notwithstanding that all
the Directors so participating are not present together in the same place. The place of any such meeting shall be recorded
as the place at which the chairman is present, unless the Directors otherwise determine.

27.10 All acts done bona fide by any meeting of Directors or of a committee appointed by the Directors or by any

person acting as a Director shall, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the
appointment of any such Director or committee or person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified
or had vacated office or were not entitled to vote, be as valid as if every such person had been duly appointed and was
qualified and had continued to be a Director or a member of a committee appointed by the Directors and had been
entitled to vote.

28. Directors' Resolutions in Writing.
28.1 A resolution in writing of which notice has been given to all of the Directors or to all of the members of a

committee appointed pursuant to Article 27.8 (as the case may be), if signed by a majority of the Directors or of the
members of such committee (as the case may be), shall be valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the
Directors or of the relevant committee duly convened and held and may consist of two or more documents in like form
each signed by one or more of the Directors or members of the relevant committee.

29. Minute Book.
29.1 The Directors shall cause all resolutions in writing passed in accordance with Articles 18.1 and 28.1 and minutes

of proceedings at all general meetings of the Company or of the holders of any class of the Company's shares and of the
Directors and of committees appointed by the Directors to be entered in books kept for the purpose. Any minutes of
a meeting, if purporting to be signed by the chairman of the meeting or by the chairman of the next succeeding meeting,
shall be evidence of the proceedings.

30. Secretary.
30.1  The  Secretary  shall  be  appointed  by  the  Directors  and  any  secretary  so  appointed  may  be  removed  by  the

Directors. Anything required or authorised to be done by or to the Secretary may, if the office is vacant or there is for
any other reason no secretary capable of acting, be done by or to any assistant or deputy secretary or if there is no
assistant or deputy secretary capable of acting, by or to any officer of the Company authorised generally or specially in
that behalf by the Directors provided that any provisions of these Articles requiring or authorising a thing to be done by
or to a Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director
and as, or in place of, the Secretary. The Company shall keep or cause to be kept at the Office a register of particulars
with regard to its Secretary in the manner required by the Law.

15489

31. Execution of Instruments, Seals and Authentication of Documents.
31.1 The Company may have a common seal and may, in accordance with the Law, have an official seal for use outside

of Jersey and an official seal for sealing securities issued by the Company or for sealing documents creating or evidencing
securities so issued. The Directors shall provide for the safe custody of all seals. No seal of the Company shall be used
except by the authority of a resolution of the Directors or of a committee of the Directors authorised in that behalf by
the Directors.

31.2 The Directors may, by resolution, authorise a person or persons to witness the affixing of the Company's common

seal to any Written Instrument to which the Company is a party. In the absence of an express authorisation, either
generally or with respect to a specific Written Instrument, any two Directors or a Director and the Secretary, are
authorised to witness the affixing of the Company's common seal to any Written Instrument to which the affixing of the
common seal has been approved by the Directors.

31.3 Written Instruments to which the Company's common seal is not to be affixed may be signed on behalf of the

Company by such person or persons as the Directors may from time to time by resolution authorise. In the absence of
an express authorisation, either generally or with respect to a specific Written Instrument, any one Director is authorised
to sign any Written Instrument on behalf of the Company.

31.4 Any Director or the Secretary or any person appointed by the Directors for the purpose shall have power to

authenticate any documents affecting the constitution of the Company (including the Memorandum of Association and
these Articles) and any resolutions passed by the Company or the Directors and any books, records, documents and
accounts relating to the business of the Company, and to certify copies thereof or extracts therefrom as true copies or
extracts; and where books, records, documents or accounts are elsewhere than at the Office, the local manager or other
officer of the company having the custody thereof shall be deemed to be a person appointed by the Directors as aforesaid.

32. Dividends
32.1 Subject to the provisions of the Law and these Articles, the Company may by resolution declare dividends in

accordance with the respective rights of the Members, but no dividend shall exceed the amount recommended by the
Directors.

32.2 Subject to any particular rights or limitations as to dividend for the time being attached to any shares, as may be

specified in these Articles or upon which such shares may be issued, all dividends shall be declared, apportioned and paid
pro-rata according to the amounts paid up on the shares (otherwise than in advance of calls) during any portion or
portions of the period in respect of which the dividend is paid.

32.3 Subject to the provisions of the Law, the Directors may, if they think fit, from time to time pay to the Members

such interim dividends as appear to the Directors to be justified.

32.4 If at any time the share capital of the Company is divided into different classes, the Directors may pay interim

dividends in respect of those shares in the capital of the Company which confer on the holders thereof deferred or non-
preferred rights, as well as in respect of those shares which confer on the holders thereof preferential rights with regard
to dividend. The Directors may also pay half-yearly, or at other suitable intervals to be settled by them, any dividend
which may be payable at a fixed rate if they are of the opinion that the financial resources of the Company justify the
payment. Provided the Directors act bona fide they shall not incur any personal liability to the holders of shares conferring
a preference for any damage that they may suffer by reason of the payment of an interim dividend on any shares having
deferred or non-preferred rights.

32.5 The Directors may deduct from any dividend or other monies payable to any Member on or in respect of a share

all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the
shares of the Company.

32.6 All unclaimed dividends may be invested or otherwise made use of by the Directors for the benefit of the Company

until claimed. No dividend shall bear interest as against the Company.

32.7 Any dividend which has remained unclaimed for a period of ten years from the date of declaration thereof shall,

if the Directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the Company and shall thenceforth belong to the
Company absolutely.

32.8 Any dividend or other monies payable on or in respect of a share may be paid by cheque or warrant sent through

the post to the registered address of the Member or person entitled thereto, and in the case of joint holders to any one
of such joint holders, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. Every
such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent or to such other person as
the holder or joint holders may in writing direct, and payment of the cheque or warrant shall be a good discharge to the
Company. Every such cheque or warrant shall be sent at the risk of the person entitled to the money represented thereby.

32.9 A general meeting declaring a dividend may, upon the recommendation of the Directors, direct payment of such

dividend wholly or in part by the distribution of specific assets, and in particular of paid up shares or debentures of any
other company, and the Directors shall give effect to such resolution; and where any difficulty arises in regard to the
distribution they may settle the same as they think expedient, and in particular may issue certificates representing part
of a shareholding or fractions of shares, and may fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof,
and may determine that cash payment shall be made to any Members upon the footing of the value so fixed, in order to

15490

adjust the rights of Members, and may vest any specific assets in trustees upon trust for the persons entitled to the
dividend as may seem expedient to the Directors, and generally may make such arrangements for the allotment, accep-
tance and sale of such specific assets or certificates representing part of a shareholding or fractions of shares, or any part
thereof, and otherwise as they think fit.

32.10 Any resolution declaring a dividend on the shares of any class, whether a resolution of the Company in general

meeting or a resolution of the Directors, or any resolution of the Directors for the payment of a fixed dividend on a date
prescribed for the payment thereof, may specify that the same shall be payable to the persons registered as the holders
of shares of the class concerned at the close of business on a particular date, notwithstanding that it may be a date prior
to that on which the resolution is passed (or, as the case may be, that prescribed for payment of a fixed dividend), and
thereupon the dividend shall be payable to them in accordance with their respective holdings so registered, but without
prejudice to the rights inter se in respect of such dividend of transferors and transferees of any shares of the relevant
class.

33. Share Premium Account and Reserve Fund.
33.1 There shall be transferred to a share premium account, as required by the Law, the amount or value of any

premium paid up on shares issued by the Company and the sums for the time being standing to the credit of the share
premium account shall be applied only in accordance with the Law.

33.2 Before the declaration of a dividend the Directors may set aside any part of the net profits of the Company to

create a reserve fund, and may apply the same either by employing it in the business of the Company or by investing it
in such a manner (not being the purchase of or by way of loan upon the shares of the Company) as they think fit. Such
reserve fund may be applied for the purpose of maintaining the property of the Company, replacing wasting assets, meeting
contingencies, forming an insurance fund, or equalising dividends or special dividends, or for any other purpose for which
the net profits of the Company may lawfully be used, and until the same shall be applied it shall remain undivided profits.
The Directors may also carry forward to the accounts of the succeeding year or years any balance of profit which they
do not think fit either to divide or to place to reserve.

34. Capitalisation.
34.1 The Company may upon the recommendation of the Directors, resolve that it is desirable to capitalise any

undistributed profits of the Company (including profits carried and standing to any reserve or reserves) not required for
paying the fixed dividends on any shares entitled to fixed preferential dividends with or without further participation in
profits, or any sum carried to reserve as a result of the sale or revaluation of the assets of the Company (other than
goodwill) or any part thereof or, subject as hereinafter provided, any sum standing to the credit of the Company's share
premium account or capital redemption reserve fund and accordingly that the Directors be authorised and directed to
appropriate the amount resolved to be capitalised to the Members in the proportion in which such amount would have
been divisible amongst them had the same been applicable and had been applied in paying dividends, and to apply such
amount on their behalf, either in or towards paying up the amounts, if any, for the time being unpaid on any shares held
by such Members respectively, or in paying up in full either at par or at such premium as the said resolution may provide,
any unissued shares or debentures of the Company, such shares or debentures to be allotted and distributed, credited
as fully paid up, to and amongst such Members in the proportions aforesaid, or partly in one way and partly in the other
provided that the share premium account and the capital redemption reserve fund and any unrealised profits may not be
applied in the paying up of any debentures of the Company.

34.2 Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Directors shall make all appropriations and

applications of the amount resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares or deben-
tures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to
make such provision by the issue of certificates representing part of a shareholding or fractions of shares or by payments
in cash or otherwise as they think fit in the case of shares or debentures becoming distributable in fractions, and also to
authorise any person to enter on behalf of all the Members entitled to the benefit of such appropriations and applications
into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any
further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalisation, and any agreement made under such
authority shall be effective and binding on all such Members.

35. Accounts and Audit.
35.1 The Company shall keep accounting records and the Directors shall prepare accounts of the Company, made up

to such date in each year as the Directors shall from time to time determine, in accordance with and subject to the
provisions of the Law.

35.2 No Member shall have any right to inspect any accounting records or other book or document of the Company

except as conferred by the Law or authorised by the Directors or by resolution of the Company.

35.3 Where required by the Law or determined to be necessary or appropriate for any other reason, auditors shall

be appointed for any period or periods either by the Directors or the Company by resolution in general meeting, to
examine the accounts of the Company and to report thereon in accordance with the Law.

15491

36. Notices.
36.1 Any notice to be given to or by any person pursuant to these Articles shall be in writing, save as provided in

Article 27.1. In the case of joint holders of a share, all notices shall be given to that one of the joint holders whose name
stands first in the Register in respect of the joint holding and notice so given shall be sufficient notice to all the joint
holders.

36.2 Any notice may be posted to or left at the registered address of any person, and any notice so posted shall be

deemed to be served one clear day after the day it was posted.

36.3 Any Member present in person at any meeting of the Company shall, for all purposes, be deemed to have received

due notice of such meeting and, where requisite, of the purposes for which such meeting was convened.

36.4 Any notice or document served on a Member shall, notwithstanding that such Member be then dead or bankrupt

and whether or not the Company has notice of his death or bankruptcy, be deemed to have been duly served on such
Member as sole or joint holder, unless his name shall at the time of the service of the notice or document have been
removed from the Register, and such service shall for all purposes be deemed a sufficient service of such notice or
document on all persons interested (whether jointly with or as claiming through or under him) in the shares of such
Member.

36.5 Notwithstanding any of the provisions of these Articles, any notice to be given by the Company to a Director or

to a Member may be given in any manner agreed in advance by any such Director or Member.

37. Winding Up.
37.1 Subject to any particular rights or limitations for the time being attached to any shares, as may be specified in

these Articles or upon which such shares may be issued, if the Company is wound up, the assets available for distribution
among the Members shall be applied first in repaying to the Members the amount paid up on their shares respectively,
and if such assets shall be more than sufficient to repay to the Members the whole amount paid up on their shares, the
balance shall be distributed among the Members in proportion to the amount which at the time of the commencement
of the winding up had been actually paid up on their said shares respectively.

37.2 If the Company is wound up, the Company may, with the sanction of a Special Resolution and any other sanction

required by the Law, divide the whole or any part of the assets of the Company among the Members in specie and the
liquidator or, where there is no liquidator, the Directors, may, for that purpose, value any assets and determine how the
division shall be carried out as between the Members or different classes of Members, and with the like sanction, vest
the whole or any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the Members as he with the like sanction
determines, but no Member shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

38. Indemnity.
38.1 In so far as the Law allows, every present or former officer of the Company shall be indemnified out of the assets

of the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been such an officer.

39. Non-Application of Standard Table.
39.1 The regulations constituting the Standard Table in the Companies (Standard Table) (Jersey) Order 1992 shall not

apply to the Company.

* * *

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned by the Chairman.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at EUR 3,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le douze décembre.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FLUX S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 18.975 (la "Société"). La Société a été constituée suivant
acte reçu par Me Jacques DELVAUX notaire de résidence alors à Remich, en date du 18 décembre 1981 et publié au

15492

Mémorial C numéro 73 le 8 avril 1982. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte
de Me Jacques DELVAUX, résidant maintenant à Luxembourg, en date du 19 novembre 2003.

L'assemblée est présidée par Marcus PETER, Rechtsanwalt, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Nicolas RONZEL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis du notaire soussigné d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation des comptes intérimaires de la Société au 30 novembre 2008;
2. Transfert du siège social de la Société de 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg à 22 Greenville Street,

St Helier, Jersey JE4 8PX, et en conséquence, modification du lieu d'enregistrement de la Société, avec effet à compter
de la date (la "Date d'Effet") à partir de laquelle un certificat de maintien concernant la Société est émis par la Jersey
Financial Services Commission en qualité de détenteur du registre des sociétés de Jersey conformément à l'article 127O
de la loi de Jersey sur les sociétés de 1991, telle que modifiée (la "Loi de Jersey") à la condition que la Société cesse d'être
une société luxembourgeoise, sous réserve de la réalisation de toutes les dispositions applicables de droit de Jersey à la
Date d'Effet;

3. Détermination de la forme sociale de la Société selon le droit de Jersey et approbation consécutive de nouveaux

statuts de la Société compatibles avec le droit de Jersey (les "Nouveaux Statuts"), ainsi que de la dénomination sous
laquelle il est proposé que la Société continue d'exister comme société sous la loi de Jersey à compter de la Date d'Effet;

4. Acceptation de la démission de Pierre LENTZ, Armand HAAS et de Guy HORNICK en tant qu'administrateurs

actuels de la Société, dûment nommés en vertu de la loi luxembourgeoise. La démission des administrateurs actuels
prendra effet à compter de la Date d'Effet;

5. Décharge des administrateurs actuels en relation avec l'exécution de leurs fonctions jusqu'à la Date d'Effet;
6. Désignation de
a) Charles Stuart HORNBY, né à Liverpool, Angleterre, le 25 mai 1953, résidant professionnellement à 22 Grenville

Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, directeur du service client de Mourant Private Wealth;

b) Alan BINNINGTON, né à Jersey, CI le 20 janvier 1958, résidant professionnellement à 22 Grenville Street, St Helier,

Jersey JE4 8PX, directeur du serveur client de Mourant Private Wealth,

c) Anthony COOKE-YARBOROUGH, né à Oxford, Angleterre, le 6 août 1956, résidant professionnellement à 22

Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, président de Mourant Private Wealth

comme nouveaux administrateurs de la Société à partir de la Date d'Effet; et
d) Blair KEMPSTER, né à Jersey, CI le 14 janvier 1967, résidant professionnellement à 22 Grenville Street, St Helier,

Jersey JE4 8PX, gérant senior à Mourant Private Wealth

comme suppléant des administrateurs indiqués sous a) à c) à partir de la Date d'Effet;
7. Acceptation de la démission de AUDIEX S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société dûment nommé

en vertu de la loi luxembourgeoise à partir de la Date d'Effet et décharge de AUDIEX S.A. de sa responsabilité pour
l'exécution de ses fonctions jusqu'à la Date d'Effet;

8. Confirmation par tous les actionnaires de la Société que (i) les Nouveaux Statuts sont conformes aux prescriptions

du droit de Jersey, (ii) à partir de la Date d'Effet, la Société cessera d'être une société de droit luxembourgeois et, (iii)
sous réserve des dispositions du droit de Jersey, à partir de la Date d'Effet, la Société sera exclusivement soumise aux
lois de Jersey applicables et (iv) ni le transfert du siège social de la Société, ni le changement de son lieu d'enregistrement,
ni le changement de sa forme sociale n'ont pour effet la dissolution et/ou la liquidation de la Société et la création d'une
nouvelle entité juridique.

9. Délégation de pouvoirs pour réaliser toute action, en ce compris notamment, la signature et la délivrance de tout

acte, formulaire, certificat, contrat ou autre document et l'observation de toutes formalités de dépôt et de publicité
requises d'après le droit luxembourgeois et le droit de Jersey pour l'enregistrement du transfert du siège social et le
transfert du lieu d'enregistrement de la Société.

10. Approbation du transfert des livres et des documents liés à la Société au nouveau siège social de la Société aussitôt

que possible après la Date d'Effet.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires de la Société présents, les procurations des ac-

tionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents ou leurs mandataires, par les membres du bureau et par le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

"ne varietur" par les mandataires, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Il résulte de la liste de présence que l'intégralité des HUIT MILLE (8.000) actions d'une valeur nominale de MILLE

FRANCS SUISSES (CHF 1.000,-), représentant l'intégralité du capital social émis de la Société qui s'élève à HUIT MIL-
LIONS de FRANCS SUISSES (CHF 8.000.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

15493

IV)  Dès  lors,  l'assemblée  est  régulièrement  constituée  et  peut  valablement  délibérer  de  l'ordre  du  jour,  dont  les

actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité par l'assemblée:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité d'approuver les comptes intérimaires de la Société au 30

novembre 2008.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité de transférer le siège social de la Société de 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg à 22 Greenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, et en conséquence, de modifier
le lieu d'enregistrement de la Société, avec effet à compter de la Date d'Effet, et conformément au troisième alinéa de
l'article 2, l'article 67-1 (1) et le deuxième alinéa de l'article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée et de déposer tous les documents requis d'après le droit de Jersey afin de donner plein
effet à ces résolutions, y compris le dépôt d'une copie certifiée de ces résolutions à la Jersey Financial Services Commission
qui confirme qu'à partir de son maintien à Jersey, le nouveau siège social de la Société est situé à 22 Grenville Street, St
Helier, Jersey JE 8PX.

De plus, l'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité de changer à compter de la Date d'Effet la forme

sociale de la Société de société anonyme de droit luxembourgeois, à private company enregistrée à Jersey et soumise
aux dispositions légales et réglementaires applicables à cette forme de société d'après la Loi de Jersey, et en conséquence
d'adopter les Nouveaux Statuts afin de les mettre en conformité avec le droit de Jersey, les Nouveaux Statuts sont indiqués
à la fin du présent acte.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité d'accepter la démission de Pierre LENTZ, Armand HAAS

et de Guy HORNICK en tant qu'administrateurs actuels de la Société, dûment nommés en vertu de la loi luxembourgeoise.
La démission des administrateurs actuels prendra effet à compter de la Date d'Effet.

De  plus  l'assemblée  générale  des  actionnaires  résout  à  l'unanimité  de  décharger  les  administrateurs  actuels  pour

l'exécution de leurs fonctions jusqu'à et y compris la Date d'Effet.

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité de désigner:
a) Charles Stuart HORNBY, né à Liverpool, Angleterre, GB le 25 mai 1953, résidant professionnellement à 22 Grenville

Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, directeur du serveur client de Mourant Private Wealth;

b) Alan BINNINGTON, né à Jersey, CI le 20 janvier 1958, résidant professionnellement à 22 Grenville Street, St Helier,

Jersey JE4 8PX, directeur du serveur client de Mourant Private Wealth;

c) Anthony COOKE-YARBOROUGH, né à Oxford, Angleterre, GB le 6 août 1956, résidant professionnellement 22

Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, président de Mourant Private Wealth

comme nouveaux administrateurs de la Société à partir de la Date d'Effet; et
d) Blair KEMPSTER, né à Jersey, CI le 14 janvier 1967, résidant professionnellement 22 Grenville Street, St Helier,

Jersey JE4 8PX, gérant senior à Mourant Private Wealth

comme suppléant des administrateurs indiqués sous a) à c) à partir de la Date d'Effet.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité d'accepter la démission de AUDIEX S.A. en tant que com-

missaire aux comptes de la Société dûment nommé en vertu de la loi luxembourgeoise à partir de la Date d'Effet.

De plus, l'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité de décharger AUDIEX S.A. de sa responsabilité

pour l'exécution de ses fonctions jusqu'à et y compris la Date d'Effet.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires confirme à l'unanimité que (i) les Nouveaux Statuts sont conformes aux pre-

scriptions du droit de Jersey, (ii) à partir de la Date d'Effet, la Société cessera d'être une société de droit luxembourgeois
et, (iii) sous réserve des dispositions du droit de Jersey, à partir de la Date d'Effet, la Société sera exclusivement soumise
aux lois de Jersey applicables et (iv) ni le transfert du siège social de la Société, ni le changement de son lieu d'enregis-
trement, ni le changement de sa forme sociale n'ont pour effet la dissolution et/ou le liquidation de la Société et la création
d'une nouvelle entité juridique.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale résout à l'unanimité de désigner Alex SCHMITT, Marcus, PETER, Natalie O'SULLIVAN-GAL-

LAGHER, Nicolas RONZEL, Franz J. MENG (avocat résidant en Suisse), Mathew SHAXSON (avocat résidant à Jersey),
et Nicolas LEBLANC (avocat résidant à Jersey) individuellement et avec les pouvoirs les plus étendus (y compris le pouvoir
de substitution), de prendre toute mesure, en ce compris notamment la signature et la délivrance de tout acte, formulaire,

15494

certificat, contrat ou autre document et l'observation de toutes formalités de dépôt et de publicité requises d'après le
droit luxembourgeois et le droit de Jersey pour l'enregistrement du transfert du siège social et le transfert du lieu d'en-
registrement de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et le dépôt de tout document
requis d'après le droit de Jersey, et nécessaire ou utile au transfert diligent et valide du siège social de la Société à Jersey,
afin de donner plein effet à ces résolutions, y compris le dépôt d'une copie certifiée de ces résolutions à la Jersey Financial
Services Commission qui confirme qu'à partir du maintien de la Société à Jersey, le nouveau siège social de la Société sera
situé au 22 Grenville Street, St Helier Jersey JE4 8PX.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale résout à l'unanimité que les livres et documents liés à la Société seront transférés à son nouveau

siège social aussitôt que possible après la Date d'Effet.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée, le président leva l'assemblée.

* * *

NOUVEAU STATUTS

<i>Référence est faite à la version anglaise du présent acte

* * *

<i>Frais

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit incombant à la Société et facturés en

raison du présent acte sont évalués à EUR 3.500.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, lesdits

comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. PETER, N. O'SULLIVAN-GALLAGHER, N. RONZEL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50884. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009014343/242/1102.
(090013471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Marius Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 23, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 144.226.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le cinq janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Marius KUGEL, né à Thionville (France), le 18 janvier 1956, demeurant à F-57100 Thionville, 13, Sentier des

Amoureux,

ici représenté par Monsieur Karl Louarn, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu,
en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une

société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité

limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation de commerces de restauration sur place et à emporter, de salons de thé,

la vente d'articles de boulangerie, de pâtisserie et de viennoiserie avec leurs accessoires, ainsi que l'activité de négoce de
tout ce qui précède. Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

15495

La société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Art. 3. La société prend la dénomination de "Marius Luxembourg S.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés,

laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille neuf.

<i>Souscription et Libération

Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur

Marius Kugel, prénommé.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,-

(douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Décisions de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

15496

- Monsieur Marius KUGEL, commerçant, né à Thionville, le 18 janvier 1956, demeurant à F-57100 Thionville, 13, Sentier

des Amoureux.

Il pourra engager la Société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
2. Le siège social est fixé à L-2561 Luxembourg, 23, rue de Strasbourg.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. LOUARN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2009. Relation: LAC/2009/648. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009014179/242/86.
(090012838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

European Logistics Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 129.820.

In the year two thousand eight, on the nineteenth of December.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mrs Christel Di Marco, employee, with professional address at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, acting as

the representative of European Logistics, (before named LOG), a société anonyme, having its registered office at 7, rue
de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 102.727 and incorporated under Luxembourg law pursuant to a notarial deed
dated on 13 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial C") under number
1125 dated 9 November 2004, page 53954 (the "General Partner"), acting in its capacity of the general partner of the
company European Logistics Feeder SCA, a société en commandite par actions, having its registered office 7, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 129.820 (the "Company"), pursuant to resolutions of the General Partner taken on 7 November 2008, an excerpt of
which, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The appearer, acting in her said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
1. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed on 28 June 2007 and its articles (the "Articles")

were published in the Memorial C under number 1839 dated 30 August 2007, page 88234.

2. The Articles were amended pursuant to:
- a notarial deed of the undersigned notary dated 17 October 2007, enacting two consecutive increase of the share

capital of the Company from thirty-one thousand Euro and fifty cents (€ 31,000.50) to an amount of eighty-three thousand
six hundred seventy-seven Euro and fifty cents (€ 83,677.50), published in the Memorial C under number 2674 dated 21
November 2007, page 128307;

- a notarial deed of the undersigned notary dated 19 November 2007, enacting an increase of the share capital of the

Company from eighty three thousand six hundred seventy-seven Euro and fifty cents (€ 83,677.50) to one hundred ninety-
two thousand thirteen Euro and fifty Cents (€ 192,013.50), published in the Memorial C under number 115 dated 16
January 2008, page 5510;

- a notarial deed of the undersigned notary dated 27 June 2008, enacting an increase of the share capital of the Company

from one hundred ninety two thousand thirteen Euro and fifty Cents (€ 192,013.50) to two hundred fifty thousand seven
hundred eighty Euro and fifty Cents (€ 250,780.50), published in the Memorial C under number 1942 dated 8 August
2008, page 93206; and

- a notarial deed of the undersigned notary dated 1st August 2008, enacting an increase of the share capital of the

Company from two hundred fifty thousand seven hundred eighty Euro and fifty Cents (€ 250,780.50) to three hundred
twenty-eight thousand one hundred fourteen Euro and fifty Cents (€ 328,114.50), published in the Memorial C under
number 2232 dated 12 September 2008, page 107128.

15497

3. The share capital is fixed at three hundred twenty-eight thousand one hundred fourteen Euro and fifty Cents (€

328,114.50), represented by:

- six hundred sixty-seven (667) shares of Unlimited Shareholder (herein referred to as the "actions de commandite"

or "CIass A Shares");

- two hundred eighteen thousand seventy-six (218,076) shares of Limited Shareholder (herein referred to as the

"actions de commanditaire" or "Class B Shares") (together with the Class A Shares, the "Shares").

Each Share has a par value of one Euro fifty cents (€ 1.50).
4. Pursuant to article 6.1 of the Articles, the Company, "for the purposes of the effective performance of the obligations

resulting from any agreement possibly entered into from time to time between, amongst others, the Shareholders and
the Company, has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of thirty-nine million seven hundred two
thousand eight hundred eighty-six Euro (€ 39,702,886.-) to be used in order to issue new Shares or to increase the
nominal value of the Shares."

5. The increase of the share capital shall be realised within the strict limits defined in article 6 of the Articles, which

are as follows:

"6.2 The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Shares or the increase of the nominal

value of the existing Shares in exchange of contribution in cash made by the existing Shareholders in execution of the
capital calls made by the General Partner in compliance with any agreement possibly entered into from time to time
between, amongst others, the Shareholders and the Company.

6.3 Until 28 June 2012 at the latest, and in compliance with any agreement possibly entered into from time to time

between, amongst others, the Shareholders and the Company, the General Partner is authorised to increase, from time
to time, the capital, within the limits of the authorised capital, by the issue of new Shares or increase in nominal value of
existing Shares to the Shareholders or to any other person as approved by the Shareholders in compliance with any
applicable provision of the Law.

6.4 These new Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined by the General

Partner within the strict limits stated in any agreement possibly entered into from time to time between, amongst others,
the Shareholders and the Company.

6.5 In particular, the General Partner may decide to issue the new Shares subject to the constitution of a share premium,

the amount and the allocation of which will be freely decided by the General Partner.

6.6 The General Partner may also determine the date of the issue and the number of new Shares having to be eventually

subscribed and issued. It may proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a preferential right
to subscribe to the new shares under issuance.

6.7 The rights attached to the new Shares will be strictly similar to the rights attached to the existing respective class

of Shares.

6.8 The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for new Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

6.9 The General Partner shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of

capital and the issue of new Shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary
documents evidencing the decision of the General Partner, the above power of attorney, the subscription and the paying
up of the new Shares.

6.10 Upon cash increase of the share capital of the Company by the General Partner within the limits of the authorised

share capital, the amount of the authorised capital specified in article 6.1 of the Articles shall be deemed to be decreased
by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in articles 5 and 6 of the Articles
will be amended accordingly pursuant to the notarial deed enacting the increase of share capital under article 6 of the
Articles."

6. In the resolutions of the General Partner of the Company taken on 7 November 2008, the General Partner of the

Company resolved in compliance with article 6 of the Articles to increase the share capital of the Company with an
amount of twenty-four thousand fifty-four Euro (€ 24,054.-) in order to raise it from the amount of three hundred twenty-
eight thousand one hundred fourteen Euro and fifty Cents (€ 328,114.50) to three hundred fifty-two thousand one
hundred sixty-eight Euro and fifty Cents (€ 352,168.50), by creating and issuing sixteen thousand thirty-six (16,036) new
Class B Shares (the "New Class B Shares") with a par value of one Euro fifty cents (€ 1.50) each, having the same rights
as the existing Class B Shares.

7. The New Class B Shares were fully subscribed by the existing Class B Shareholders exercising their respective

preferential right of subscription i.e.:

1) The Local Government Pensions Institution, established in accordance with and governed by the laws of Finland,

with registered office at Unioninkatu 43, P.O. Box 425 / FIN-00101 Helsinki (Finland), subscribed ten thousand six hundred
ninety-one (10,691) New Class B Shares for an amount of sixteen thousand thirty-six Euro and fifty Cents (€ 16,036.50);
and

2) Regime de Rentes du Mouvement Desjardins, a Canadian Pension Plan incorporated under the laws of Canada,

whose registered office is situated at 100, avenue des Commandeurs Levis, Quebec G6V 7N5 (Canada), registered with

15498

the Commercial and Companies Registry of Quebec, subscribed five thousand three hundred forty-five (5,345) New Class
B Shares for an amount of eight thousand seventeen Euro and fifty Cents (€ 8,017.50).

8. The New Class B Shares have been fully paid up through contributions in cash on 1 December 2008 as evidenced

by the bank certificate issued by Dexia Banque Internationale à Luxembourg on 1 December 2008.

9. The justifying documents of the subscription and of the payment of the New Class B Shares have been produced

to the undersigned notary, who expressly acknowledges receipt. Therefore, the capital increase is effective as of 1 De-
cember 2008 at which the New Class B Shares have been fully paid up.

10. As a consequence of such increase of the share capital of the Company, article 5.1 of the Articles is amended and

reads as follows:

"5.1 The subscribed share capital of the Company is fixed at three hundred fifty-two thousand one hundred sixty-eight

Euro and fifty Cents (€ 352,168.50), represented by:

- six hundred sixty-seven (667) shares of Unlimited Shareholder (herein referred to as the "actions de commandite"

or "Class A Shares");

- two hundred thirty-four thousand one hundred twelve (234,112) shares of Limited Shareholder (herein referred to

as the "actions de commanditaire" or "Class B Shares")

(the Class A Shares together with the Class B Shares, are referred to as the "Shares"), with a par value of one Euro

fifty cents (€ 1.50) each."

11. As a consequence of such increase of the share capital of the Company by way of the authorised capital clause,

article 6.1 of the Articles is amended and reads as follows as of 1 December 2008:

"6.1 For the purposes of the effective performance of the obligations resulting from any agreement possibly entered

into from time to time between, amongst others, the Shareholders and the Company, the Company has an un-issued but
authorised capital of a maximum amount of thirty-nine million six hundred seventy-eight thousand eight hundred thirty-
two Euro (€ 39,678,832.-) to be used in order to issue new Shares or to increase the nominal value of the Share."

12. The General Partner has further decided to have the increase of the share capital enacted by a Luxembourg notary

and to grant:

- Ms Christel Di Marco, employee, with professional address in Luxembourg; and/or
- Ms Sylvie Reisen, employee with professional address in Luxembourg, a power of attorney to have the increase of

the subscribed capital of the Company and the consequential amendment to the Articles of the Company recorded in a
deed of notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.
Par devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Christel Di Marco, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxem-

bourg,  agissant  en  sa  qualité  de  mandataire  spécial  de  European  Logistics,  (anciennement  dénommée  LOG),  société
anonyme, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.727 et constituée selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'un acte notarié en date du 13 juillet 2004, et publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") sous le numéro 1125 du 9 novembre 2004, page 53954, (le "Gérant
Commandité"), agissant en sa qualité de gérant commandité de la société European Logistics Feeder SCA, une société en
commandite par actions, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.820 (la "Société"), en vertu d'un pouvoir
qui lui a été conféré aux termes des résolutions prises par le Gérant Commandité le 7 novembre 2008, dont un extrait,
après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, restera annexé aux présentes pour être soumis avec
elles à la formalité de l'enregistrement.

La comparante, qui agit ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

15499

1. La Société a été constituée en vertu d'un acte notarié en date du 28 juin 2007 et ses statuts (les "Statuts") ont été

publiés au Mémorial C sous le numéro 1839 du 30 août 2007, page 88234.

2. Les Statuts ont été modifiés:
- par acte notarié du notaire instrumentant du 17 octobre 2007, constatant deux augmentations consécutives du capital

social de la Société de trente et un mille Euros et cinquante centimes (31.000,50 €) à quatre-vingt-trois mille six cent
soixante-dix-sept Euros et cinquante centimes (83.677,50 €) publié au Mémorial C sous le numéro 2674 du 21 novembre
2007, page 128307;

- par acte notarié du notaire instrumentant du 19 novembre 2007, constatant une augmentation du capital social de

la Société de quatre-vingt-trois mille six cent soixante-dix-sept Euros et cinquante centimes (83.677,50 €) à cent quatre-
vingt-douze mille treize Euros et cinquante centimes (192,013,50 €) publié au Mémorial C sous le numéro 115 du 16
janvier 2008, page 5510;

- par acte notarié du notaire instrumentant du 27 juin 2008, constatant une augmentation du capital social de la Société

de cent quatre-vingt-douze mille treize Euros et cinquante centimes (192,013,50 €) à deux cent cinquante mille sept cent
quatre-vingt Euros et cinquante centimes (250.780,50 €) publié au Mémorial C sous le numéro 1942 du 8 août 2008, page
93206; et

- par acte notarié du notaire instrumentant du 1 

er

 août 2008, constatant une augmentation du capital social de la

Société de deux cent cinquante mille sept cent quatre-vingt Euros et cinquante centimes (250.780,50 €) à trois cent vingt-
huit mille cent quatorze Euros et cinquante centimes (328.114,50 €) publié au Mémorial C sous le numéro 2232 du 12
septembre 2008, page 107128.

3. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trois cent vingt-huit mille cent quatorze Euros et cinquante centimes

(328.114,50 €) représenté par:

- six cent soixante-sept (667) actions d'Actionnaire Commandité (ci-après les "actions de commandité" ou "Actions

de Classe A");

-  deux  cent  dix-huit  mille  soixante-seize  (218.076)  actions  d'Actionnaire  Commanditaire  (ci-après  les  "actions  de

commanditaire" ou "Actions de Classe B"); (ensemble avec les Actions de Classe A, les "Actions").

Chaque Action a une valeur nominale d'un Euro et cinquante centimes (1,50 €).
4. Conformément à l'article 6.1 des Statuts, "afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant des

dispositions de toute convention pouvant intervenir à tout moment entre, parmi d'autres, les Actionnaires et la Société,
la Société disposera d'un capital autorisé d'un montant maximum de trente-neuf millions sept cent deux mille huit cent
quatre-vingt-six Euros (39.702.886,- €) pour émettre de nouvelles Actions ou pour augmenter la valeur nominale des
Actions."

5. L'augmentation du capital social de la Société doit être réalisée dans le strict respect des limites et conditions définies

à l'article 6 des Statuts, qui sont les suivantes:

"6.2 Ce capital autorisé a pour seul objectif de permettre la création d'Actions nouvelles ou l'augmentation de la valeur

nominale des Actions existantes en contrepartie et rémunération d'apports en numéraire effectués par les Actionnaires
existants en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant Commandité aura procédé conformément à toute con-
vention pouvant intervenir à tout moment entre, parmi d'autres, les Actionnaires et la Société.

6.3 Jusqu'au 28 juin 2012 au plus tard, et conformément aux engagements pris par le Gérant Commandité dans toute

convention pouvant intervenir à tout moment entre, parmi d'autres, les Actionnaires et la Société, le Gérant Commandité
pourra augmenter à tout moment le capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émission
de nouvelles Actions ou par l'augmentation de la valeur nominale des actions existantes aux Actionnaires actuels ou à
toutes autres personnes approuvées par les Actionnaires conformément aux dispositions applicables de la Loi.

6.4 Ces nouvelles Actions pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminés par le Gérant Commandité,

tout en restant dans la stricte observance des conditions précisées par toute convention pouvant intervenir à tout moment
entre, parmi d'autres, les Actionnaires et la Société.

6.5 Le Gérant Commandité peut décider en particulier d'émettre les nouvelles Actions avec prime d'émission. Le

montant et l'affectation de cette prime d'émission seront déterminés à la discrétion du Gérant Commandité.

6.6 Le Gérant Commandité déterminera également la date d'émission et le nombre d'Actions devant être, le cas

échéant, souscrites et émises. Il pourra procéder à cette augmentation sans délivrer aux Actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription sur les nouvelles parts à émettre.

6.7 Les droits attachés aux Actions nouvelles seront identiques à ceux attachés respectivement aux classes d'Actions

déjà émises.

6.8 Le Gérant Commandité pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter des souscri-

ptions et la réception des paiements pour les Actions nouvelles représentant tout ou partie des montants augmentés du
capital social.

6.9 Le Gérant Commandité désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux

fins de constater authentiquement l'émission des Actions nouvelles et l'augmentation du capital, sur présentation des

15500

pièces justificatives de la décision du Gérant Commandité, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les sou-
scriptions et libérations des Actions nouvelles.

6.10 Lors de chaque augmentation du capital social de la Société effectuée par le Gérant Commandité dans les limites

du capital autorisé, le montant du capital autorisé précisé à l'article 6.1 des Statuts sera considéré comme diminué du
montant correspondant à cette augmentation. En conséquence, les montants précisés aux articles 5 et 6 des Statuts seront
ainsi modifiés en vertu d'un acte notarié constatant l'augmentation de capital en vertu de l'article 6 des Statuts de la
Société."

6. Dans les résolutions prises le 7 novembre 2008 par le Gérant Commandité de la Société, celui-ci a décidé, confor-

mément à l'article 6 des Statuts, d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de vingt-quatre
mille cinquante-quatre Euros (24.054,- €) pour porter ainsi le capital social de la Société du montant de trois cent vingt-
huit mille cent quatorze Euros et cinquante centimes (328.114,50 €) à trois cent cinquante-deux mille cent soixante-huit
Euros et cinquante centimes (352.168,50 €), par la création et l'émission de seize mille trente-six (16.036) nouvelles
Actions de Classe B (les "Nouvelles Actions de Classe B ") d'une valeur nominale d'un Euro et cinquante centimes (1,50
€) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les Actions de Classe B existantes.

7. Les Nouvelles Actions de Classe B ont été entièrement souscrites par les Actionnaires existants de Classe B exerçant

leur droit de souscription préférentielle respectif comme suit:

1) The Local Government Pensions Institution, établi conformément avec et gouverné selon les lois de Finlande, ayant

son siège social à Unioninkatu 43, P.O. Box 425 / FIN-00101 Helsinki (Finlande), a souscrit dix mille six cent quatre-vingt-
onze (10.691) Nouvelles Actions de Classe B pour un montant de seize mille trente-six Euros et cinquante centimes
(16.036,50 €); et

2) Régime de Rentes du Mouvement Desjardins, un Plan de Pension Canadien constitué selon les lois du Canada, dont

le siège social est situé à 100, avenue des Commandeurs Lévis, Québec G6V 7N5 (Canada), immatriculé avec le registre
du Commerce et des Sociétés de Quebec, a souscrit cinq mille trois cent quarante-cinq (5.345) Nouvelle Actions de
Classe B pour un montant de huit mille dix-sept Euros et cinquante centimes (8.017,50 €).

8. Les Nouvelles Actions de Classe B ont été entièrement libérées par apport en numéraire le 1 

er

 décembre 2008,

tel que constaté par le certificat bancaire émis par Dexia Banque Internationale à Luxembourg le 1 

er

 décembre 2008.

9. Les documents justificatifs de la souscription et de la libération des Nouvelles Actions de Classe B ont été présentés

au notaire soussigné, qui en prend expressément acte. Dès lors, l'augmentation de capital prend effet au 1 

er

 décembre

2008 date à laquelle les Nouvelles Actions de Classe B ont été entièrement libérées.

10. A la suite de cette augmentation du capital social de la Société, l'article 5.1 des Statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

"5.1  Le  capital  social  souscrit  de  la  Société  est  fixé  à  trois  cent  cinquante-deux  mille  cent  soixante-huit  Euros  et

cinquante centimes (352.168,50 €) représenté par:

- six cent soixante-sept (667) actions d'Actionnaire Commandité (ci-après les "actions de commandité" ou "Actions

de Classe A");

- deux cent trente-quatre mille cent douze (234.112) actions d'Actionnaire Commanditaire (ci-après les "actions de

commanditaire" ou "Actions de Classe B"); (les Actions de Classe A, ensemble avec les Actions de Classe B, sont reprises
ci-après comme les "Actions"), d'une valeur nominale d'un Euro et cinquante centimes (1,50 €), chacune."

11. A la suite de cette augmentation du capital social de la Société ainsi réalisée par voie de capital autorisé, l'article

6.1 des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante à compter du 1 

er

 décembre 2008:

"6.1 Afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant des dispositions de toute convention pouvant

intervenir à tout moment entre, parmi d'autres, les Actionnaires et la Société, la Société disposera d'un capital autorisé
d'un montant maximum de trente-neuf millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent trente-deux Euros (39.678.832,-
€) pour émettre de nouvelles Actions ou pour augmenter la valeur nominale des Actions."

12. Le Gérant Commandité a également décidé de faire acter l'augmentation de capital social par un notaire luxem-

bourgeois et de donner pouvoir à:

- Madame Christel Di Marco, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg; and/or
- Madame Sylvie Reisen, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg;
afin de faire enregistrer par acte notarié l'augmentation précédente du capital souscrit de la Société et la modification

des Statuts en découlant.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, est évalué à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

15501

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. Di Marco, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC/2008/52053. Reçu: cent vingt euros vingt-sept cents (120,27

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009013526/220/278.
(090013223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Falcon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 84.283.

L'an deux mille huit, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FALCON S.A." (numéro

d'identité 2001 22 25 793), avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 84.283, constituée sous la dénomination de "FALCON HOLDING S.A." suivant acte reçu par le notaire
Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, en date du 1 

er

 mars 1991, publié au Mémorial C, numéro 339 du 14

septembre 1991 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le prédit notaire Christine DOERNER, en
date du 8 février 1994, publié au Mémorial C, numéro 210 du 30 mai 1994 et par le notaire instrumentant, en date du
12 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 345 du 2 mars 2002, ledit acte contenant notamment change-ment de
la dénomination sociale en "FALCON S.A.".

L'assemblée est présidée par Madame Ana NEVES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Au-

bange (Belgique).

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence,

laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau,
restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Que la société a un capital social de trente-deux mille euros (€ 32.000.-), représenté par dix mille (10.000) actions.
IV.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Que la présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés

à l'ordre du jour,

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société de droit britannique "DAMSOR LIMITED", avec siège

social à BS25 1AG Somerset (Royaume Uni), 40, Woodborough Road, Winscombe, inscri-te au registre des sociétés
pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 7261567.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

15502

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,

pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer la société de droit britannique "IAS CONSULTING LIMITED", avec siège social à LN1

1XG, 15, Lincoln (Royaume-Uni), Newland, inscrite au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous
le numéro 4261567 comme commissaire-vérificateur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximative-ment à huit cents euros (€ 800.-), sont à charge

de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: NEVES, JANIN, J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2008. Relation: CAP/2008/3919. Reçu douze euros (12.-).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 21 janvier 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009014213/236/71.
(090013542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Edmonds &amp; Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 63.554.

COMPTES ANNUELS

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Référence de publication: 2009014612/636/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01623. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Acab Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 77.567.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

15503

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009014660/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06479. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Smart Private Managers (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 124.966.

L'an deux mille huit, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société "Smart Managers (Lu-

xembourg) S.A.", (ci-après la "Société"), société anonyme, ayant son siège social au 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx en date du 12 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 829 du 9 mai 2007.

L'Assemblée élit comme président Monsieur Joachim Cour, licencié en droit, demeurant au Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Kathrin Kraemer, maître en droit, demeurant au Luxembourg.
L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Sébastien Moies, licencié en droit, demeurant au Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

Modification de l'article 8, premier alinéa, des statuts afin de fixer la date de l'assemblée générale annuelle des action-

naires au deuxième mardi du mois d'avril à 10.00 heures et suppression du libellé "et pour la première fois en 2008".

II.- Que tous les actionnaires sont représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent chacun est indiqué sur une liste

de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par leur mandataire, les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que l'ensemble des actions actuellement émises par la Société sont représentées

à la présente Assemblée. Tous les actionnaires représentés déclarent avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour
et  ont  décidé  de  renoncer  aux  formalités  de  convocation.  L'Assemblée  est  dès  lors  valablement  constituée  et  peut
valablement délibérer et décider sur le point porté à l'ordre du jour.

Après avoir délibéré, l'Assemblé prend, à l'unanimité, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires au deuxième mardi du mois

d'avril à 10.00 heures ainsi que de supprimer le libellé "et pour la première fois en 2008". L'article 8, 1 

er

 alinéa des statuts,

qui aura désormais la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le deuxième mardi du mois d'avril
à 10.00 heures du matin. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement
que des circonstances exceptionnelles le requièrent".

Aucun point ne figurant plus à l'ordre du jour, l'Assemblée est dès lors close.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à l'Assemblée, aux membres du bureau tous connus du notaire par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte,
aucun actionnaire n'étant présent et n'ayant donc exprimé le souhait de signer.

Signé: J. COUR, K. KRAEMER, S. MOIES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52928. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009013312/242/48.
(090012980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

15504


Document Outline

Acab Holding S.A.

Alcanada S.A.

Alternative Real Investments S.A.

ASI 1 S.A.

ASI Management S.A.

Atex Finance S.A.

Centre Comptable Européen S.A.

Claremont Villas S.A.

Commercial Company Luxembourg

Considar Metal Marketing S.A.

Eastern Property Management Sàrl

Ecom

Edilred S.A.

Edmonds &amp; Associés S.A.

Erste Europäische Metallhandel und Rohstoffveredelung S.à r.l.

European Logistics Feeder S.C.A.

European Retail Portfolio (New Mersey) Lux S.à r.l.

Falcon S.A.

F.G. Fashion International s.à r.l.

Finacap Holding S.A.

Finmean Holding S.A.

Flux S.A.

Formula Sports SA

Frenchie's, Sàrl

G.B. Finlux S.A.

Gib International S.A.

Hellaby S.A.

Hezias B.V.

Holding Business International S.A.

Immodiam S.A.

ING Industrial Real Estate Luxembourg S. à r.l.

Inkema Group

Koch Chemical Technology Group SCS

Laudis S.A.

Locamar S.A.

Lumos Investments S.A.

Marius Luxembourg S.à r.l.

MEIF Luxembourg Feeder S.à r.l.

Melrose Real Estate Investment S.A.

Melusine Aviation S. à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s.

MENOS global network AG

Methys S.A.

Montclair S.A.

Murex Participations Luxembourg S.A.

Obegi Chemicals Group S.A.

Ocra (Luxembourg) S.A.

Pasucha Klepzig &amp; Associés Architectes &amp; Ingénieurs S.à r.l.

Private Equity Investors Holding S.A.

Property Projects S.à r.l.

RQ Luxembourg S.à r.l.

Sam et Marie S.àr.l.

Scalene Luxembourg S. à r. l.

Seacat S.A.

Smart Private Managers (Luxembourg) S.A.

TCFE Immo S.A.

Tecnic-Consult-Invest S.A.

Thunderbird Holdings S.à r.l.

Tiercelet Real Estate S.à r.l.

Tishman Speyer French Venture V S.à r.l.

T&amp;T Consult S.A.

Van Cauter - Snauwaert &amp; Co S.à.r.l.