This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2960
15 décembre 2008
SOMMAIRE
Agence Immobilière Hein et Cie S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142039
Alatrava S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142080
Alro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142045
Arzak S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142043
Avelca S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142038
B2C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142046
BarconcepT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142043
Basis Consulting Services Sàrl . . . . . . . . . . .
142045
Biosys SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142044
Bunker Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142078
Caprice S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142045
Carlson Fund Management Company S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142041
C Chateau VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142064
Compagnie Helvétique de Déstockage S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142038
Continental Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
142044
DBST S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142036
DC Immo Concept S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
142046
D'Owstellgleis S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142044
Edil Re S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142076
Etoile Promotions "Eral" S.à r.l. . . . . . . . . .
142034
Etoile Promotions "E", société à responsa-
bilité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142038
Eurochapes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142037
European Building S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
142072
First Target S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142078
Flecha Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142035
Fortis AG Fund L2 Management . . . . . . . . .
142040
GENERALI LUXEMBOURG, Compagnie
Luxembourgeoise d'Assurances . . . . . . . .
142080
Geradpark SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142037
Gestatec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142036
Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142040
HG Patrimoine S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142035
Imbellux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142046
Interbio Medical Service S.A. . . . . . . . . . . . .
142039
International Tracing and Technology S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142043
Jardinier-Paysagiste Lemmer S.à r.l. . . . . .
142039
Kloose G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142036
Laborde S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142038
La Cave du Sommelier . . . . . . . . . . . . . . . . .
142034
LaSalle UK Ventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142070
LDM Corp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142046
Lubwater S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142034
Metal Cad Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
142073
Michiko S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142045
Mimosas Finance Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142044
Night-Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142063
Oceanis Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
142041
Oxford Aviation Academy Luxembourg 2
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142040
Oxford Aviation Academy Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142039
P5 Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142064
Participations Amandari S.A. . . . . . . . . . . .
142035
Potende S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142041
Potende S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142042
Potende S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142040
Proteactive Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
142042
RM International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142041
Rosa'h SCI, Société Civile Immobilière . .
142035
Scan Inter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142043
SDV (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
142037
Seban S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142067
Silver Spring Holding S. à r. l. . . . . . . . . . . .
142047
Sport Holding Overseas Patent S.A. . . . . .
142034
Taurumi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142042
Team-Trans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142037
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. . .
142075
VEE Estepona A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142042
Ventana Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
142036
142033
Lubwater S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 114.646.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008151923/507/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01372. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080179234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Etoile Promotions "Eral" S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 30, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 67.004.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Etoile promotions «Eral» s.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008151917/3222/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2008, réf. LSO-CW06176. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
La Cave du Sommelier, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8436 Steinfort, 2, rue de Kleinbettingen.
R.C.S. Luxembourg B 90.316.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5/12/08.
<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008151904/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01405. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Sport Holding Overseas Patent S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 79.915.
Il est constaté, en date du 14 novembre 2008, que l'agent domiciliataire, Euro-Suisse Audit (Luxembourg), dont le siège
social est situé à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, immatriculée au R.C.S. Luxembourg B 28.027, a dénoncé
le siège de la société anonyme SPORT HOLDING OVERSEAS PATENT S.A. avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2008.
Euro-Suisse Audit (Luxembourg)
Signature
Référence de publication: 2008151286/636/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008, réf. LSO-CX00507. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080178750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.
142034
HG Patrimoine S.A.H., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 109.721.
Aux actionnaires de la société
Nous vous informons par la présente que nous dénonçons le siège de la société HG PATRIMOINE S.A.H., RC: B
109.721, actuellement domiciliée au 24, rue Léon Kauffman à L-1853 Luxembourg-Cents, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 20 novembre 2008.
CCF S.A. (anciennement Eliolux S.A.)
René Moris
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2008151261/1801/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09932. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080178214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.
Flecha Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 95.892.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 décembre 2008.
Signature
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008151898/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008, réf. LSO-CX00477. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Rosa'h SCI, Société Civile Immobilière, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3938 Mondercange, 20, rue Neuve.
R.C.S. Luxembourg E 2.446.
DISSOLUTION
Par décision de l'assemblée des associés du 20.08.2008, il a été décidé à l'unanimité de dissoudre la société civile
immobilière ROSA'H. Tout l'actif et le passif ainsi que les frais et charges éventuels sont repris à part égale par les associés.
Mondercange, le 20.08.2008.
Salvatore CESAREO / Katayon KAVEH.
Référence de publication: 2008151258/5212/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08685. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080178553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.
Participations Amandari S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 76.926.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 décembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008151908/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01354. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
142035
Ventana Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 76.932.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 décembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008151907/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01326. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080179095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Gestatec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 86.750.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Gestatec S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008151919/3222/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2008, réf. LSO-CW06179. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
DBST S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2423 Luxembourg, 27, rue de Pont-Rémy.
R.C.S. Luxembourg B 94.830.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5/12/08.
<i>Pour VO Consulting Lux S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008151905/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01404. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Kloose G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 175, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 18.024.
Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008151932/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008, réf. LSO-CX00529. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
142036
SDV (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.
R.C.S. Luxembourg B 22.706.
Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008151931/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008, réf. LSO-CX00526. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080179362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Team-Trans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 40.318.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 décembre 2008.
Signature
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008151896/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008, réf. LSO-CX00472. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Geradpark SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 30, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 60.635.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Geradpark S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008151915/3222/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2008, réf. LSO-CW06172. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Eurochapes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8057 Bertrange, 7, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 17.167.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 05.12.2008.
Signature.
Référence de publication: 2008151909/3341/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02570. - Reçu 91,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
142037
Laborde S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 28.099.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 décembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008151906/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07691. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080179099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Etoile Promotions "E", société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 30, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 60.543.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Etoile promotions «E» s.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008151913/3222/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2008, réf. LSO-CW06170. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Compagnie Helvétique de Déstockage S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 97.059.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 Décembre 2008.
Signature
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008151895/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008, réf. LSO-CX00474. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Avelca S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3473 Dudelange, 19, An der Foxenhiel.
R.C.S. Luxembourg B 132.525.
Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008151927/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008, réf. LSO-CX00514. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
142038
Oxford Aviation Academy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 123.624.
Les comptes annuels au 30 avril 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008151920/260/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01768. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080178967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Agence Immobilière Hein et Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 30, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 22.430.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Agence Immobilière Hein et Cie s.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008151925/3222/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2008, réf. LSO-CW06192. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Interbio Medical Service S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 41.430.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 décembre 2008.
Signature
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008151897/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008, réf. LSO-CX00475. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Jardinier-Paysagiste Lemmer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7397 Hunsdorf, 4, rue Alsbich.
R.C.S. Luxembourg B 50.326.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 décembre 2008.
<i>Pour JARDINIER-PAYSAGISTE LEMMER SARL
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2008151935/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2008, réf. LSO-CX00729. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
142039
Oxford Aviation Academy Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 123.879.
Les comptes annuels au 30 avril 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008151918/260/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01769. - Reçu 38,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080178971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 224.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 112.071.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Münsbach, le 4 décembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008151894/4407/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02540. - Reçu 99,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Fortis AG Fund L2 Management, Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 49.672.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2008.
<i>Pour FORTIS AG FUND L2 MANAGEMENT
i>Fortis Banque Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2008151939/584/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01463. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080179389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Potende S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 106.297.
EXTRAIT
Par la présente, Monsieur Christophe ANTINORI, informe avoir démissionné en date du 14 octobre 2008 de son
mandat d'administrateur de la société POTENDE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 14 octobre 2008.
Christophe ANTINORI.
Référence de publication: 2008148144/1384/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV08911. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080174246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
142040
RM International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 51.954.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008151946/9120/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01518. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080179403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Oceanis Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 108.523.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCEANIS INVESTMENTS S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008151951/815/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01682. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080178864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Potende S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 106.297.
EXTRAIT
Par la présente, Monsieur Christian BÜHLMANN, informe avoir démissionné en date du 14 octobre 2008 de son
mandat d'administrateur de la société POTENDE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2008.
Christian BÜHLMANN.
Référence de publication: 2008148152/1384/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05278. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080174229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
Carlson Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 34.518.
En date du 17 novembre 2008, l'Assemblé Générale Extraordinaire a décidé:
- de nommer Mr Jorgen HJEMDAL, DnB NOR Asset Management, Øvre Slottsgate 3, N-0021 Oslo, en qualité d'ad-
ministrateur en date du 17 novembre 2008 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2009.
Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration
Référence de publication: 2008148151/1024/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07980. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080174488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
142041
VEE Estepona A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 123.743.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour VEE ESTEPONA A.G.
Romain THILLENS
<i>Administrateur de catégorie Ai>
Référence de publication: 2008148308/565/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2008, réf. LSO-CW06329. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080174388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
Potende S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 106.297.
EXTRAIT
Par la présente, Monsieur Edouard MAIRE, informe avoir démissionné en date du 14 octobre 2008 de son mandat
d'administrateur de la société POTENDE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2008.
Edouard MAIRE.
Référence de publication: 2008148143/1384/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV08913. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080174251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
Taurumi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.120.000,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 123.471.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/08.
Signature.
Référence de publication: 2008148642/4286/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07533. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
Proteactive Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 74.643.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/08.
Signature.
Référence de publication: 2008148644/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07535. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
142042
Scan Inter S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 32.292.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/08.
Signature.
Référence de publication: 2008148643/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07534. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080175319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
International Tracing and Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 77.662.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008148589/8473/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2008, réf. LSO-CW06757. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
BarconcepT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5240 Sandweiler, 30, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 92.389.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26/11/2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008148603/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07020. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
Arzak S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 115.954.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27.11.08.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
<i>Cabinet d'experts comptables
i>Signature
Référence de publication: 2008148598/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07753. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
142043
Biosys SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 51.457.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008148646/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07537. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080175328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
Mimosas Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 105.154.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/08.
Signature.
Référence de publication: 2008148645/4286/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07536. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
D'Owstellgleis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6985 Hostert, 9, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 40.643.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26/11/2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008148606/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07029. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
Continental Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 18.197.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27.11.08.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
<i>Cabinet d'experts comptables
i>Signature
Référence de publication: 2008148597/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07756. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
142044
Alro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 97.625.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008148652/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07543. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080175337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
Basis Consulting Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 69.227.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/08.
Signature.
Référence de publication: 2008148650/4286/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07540. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
Caprice S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 79.921.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008148604/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07025. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
Michiko S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 30.233.
Les documents de clôture de l'année 20007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le ... novembre 2008.
<i>Pour MICHIKO S.A.
i>Arend Consult S.à r.l., Mersch
Signature
Référence de publication: 2008148591/8537/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07380. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
142045
LDM Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 92.932.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/08.
Signature.
Référence de publication: 2008148647/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07538. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080175331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
DC Immo Concept S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 117.563.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/08.
Signature.
Référence de publication: 2008148649/4286/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07539. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
B2C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 615, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 105.786.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26/11/2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008148602/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07018. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
Imbellux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 8.250.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27.11.08.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
<i>Cabinet d'experts comptables
i>Signature
Référence de publication: 2008148599/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07750. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080175680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.
142046
Silver Spring Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.336.
In the year two thousand and eight, on the seventh day of the month of November,
before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "Silver Spring Holding S.à r.l.", a
société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed
of Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, on 18 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 2800 of 4 December 2007, and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under B-133.336 (the "Company"). The Company's articles of association have not been amended yet.
The meeting was declared open at 5.15 p.m. and was presided by Mrs Carolin Weirauch, lawyer, residing in Luxem-
bourg.
The chairman appointed Mr Christophe Jolk, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
Mr Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer by the Meeting.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1 To create two (2) classes of shares, the ordinary class A shares (the "Class A Shares") and the preference class B
shares (the "Class B Shares"), and to reclassify the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares of
one Cent (EUR 0.01) each into one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) Class A Shares of one Cent
(EUR 0.01) each and one hundred twenty-five thousand (125,000) Class B Shares of one Cent (EUR 0.01) each.
2 To fully restate the articles of incorporation of the Company, which restatement, next to reflecting the above changes
to the issued capital, shall consist inter alia in adopting the following corporate object:
"The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of interests in
Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such assets and/or
interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation
or which are members of its group of companies.
The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object."
3 Miscellaneous.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list
signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of
the meeting; such attendance list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with
this deed.
III. It appears from the said attendance list that out of the issued share capital of the Company all shares are present
or represented at the meeting. The Meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all
the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present
Meeting.
IV. The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the chairman, by unanimous vote adopted
the following resolution:
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVED to create two classes of shares, the ordinary class A shares (the "Class A Shares") and the
preference class B shares (the "Class B Shares"), and RESOLVED to reclassify the existing one million two hundred fifty
thousand (1,250,000) shares of one Cent (EUR 0.01) each into one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000)
142047
Class A Shares of one Cent (EUR 0.01) each and one hundred twenty-five thousand (125,000) Class B Shares of one Cent
(EUR 0.01) each.
As a result, STEG Emerging Markets Real Estate GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung) incorporated and organised under the laws of Germany, with registered office at Freihamer Straße
2, D-82166 Gräfelfing, Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich under HRB 170
816, is holding all of the Class A Shares, and Tottenham Hale S.à r.l., a private limited liability company (société à res-
ponsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 131.760, is holding all the Class B Shares.
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVED that the articles of association of the Company shall be entirely restated to inter alia reflect
the above resolution, so that these articles shall forthwith read as follows:
Chapter I. Form, name, registered office, object, duration
Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of association (the "Articles of Association").
The Company may be composed of one (1) single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but
not exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of " Silver Spring Holding S.à r.l.".
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the
Manager(s).
In the event that in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of
interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such
assets and/or interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds
a participation or which are members of its group of companies.
The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the applicable
laws or by these Articles of Association, as the case may be, for any amendment of these Articles of Association.
Chapter II. Capital, shares
Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented
by one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) fully paid class A ordinary shares (the "Class A Shares") and
one hundred twenty-five thousand (125,000) fully paid class B preferred shares (the "Class B Shares"), each of such Class
A Shares and Class B Shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) (the Class A Shares and the Class B Shares
are collectively referred to as the "Shares" and individually as a "Share").
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any Share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
142048
Art. 6. Shares. Each Share entitles to one (1) vote. Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of
Association of the Company and the resolutions validly adopted by the shareholder(s).
Each Share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of Shares must be represented towards the
Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its Shares. When
the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred (i) freely amongst shareholders and
(ii) to non-shareholders only with the authorisation of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the
issued capital.
The terms and conditions in relation to the transfer of Shares issued by the Company may be agreed in writing by the
shareholders. Transfers shall be made in compliance with any such terms and conditions and with these Articles of
Association. The Company is entitled to refuse to register any transfer of Shares unless transferred in accordance with
these Articles of Association or in accordance with any agreement relating to the transfer of Shares to which the Company
is a party. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law, in view of their immediate
cancellation.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a
resolution of the shareholder(s) voting with the quorum and majority rules set by the applicable laws or by these Articles
of Association, as the case may be, for any amendment of these Articles of Association.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Managers, auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed and administered by one (1) or several managers who need not be
shareholders themselves (the "Manager(s)").
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Manager(s) will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of his/their mandate and his/
their number. The Manager(s) is/are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by
a resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") and
class B Managers (the "Class B Managers").
At general meetings of the shareholders resolving on statutory elections, the holder(s) of Class B Shares are entitled
to propose the qualification of the appointed Managers (if two (2) or more Manager(s) have been appointed) into Class
A Managers and Class B Managers.
The holder(s) of Class B Shares are further entitled to propose the Class B Managers for election or removal, whereas
such Class B Managers will be chosen from a list of candidates presented by the holder(s) of Class B Shares, being
understood that there will be one (1) Class B Manager if two (2) Managers are appointed and not less than one third
(1/3) of the Managers will be Class B Managers if at least three (3) Managers are appointed.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers or the Board of Managers, as the case may be, are vested with the
broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles of Association to shareholder(s) are in the competence
of the Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be.
Except as provided in the below fourth paragraph of this article 10 (measures involving affiliates of shareholders), the
Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, shall require the prior consent of shareholders holding at least
ninety percent (90%) of the voting rights in the Company in order to effect the following legal transactions and measures:
(i) the purchase or other acquisition by the Company of any real estate assets or any real estate owning legal entity
and the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the purchase or other acquisition of any real estate
assets or any real estate owning legal entity by any of its direct or indirect subsidiaries (if existing);
(ii) any creation of, pledge, sale or other disposal of shares in the Company's direct or indirect subsidiaries (if existent),
or the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the liquidation of the Company's direct or indirect
subsidiaries;
(iii) any sale or disposal of any real estate asset or portfolio of real estate - either by asset or share deal type of
transaction - or any other material fixed asset held by the Company or the exercise of the Company's shareholder rights
in case the real estate asset, portfolio of real estate or other material fixed asset is held by any of the Company's direct
or indirect subsidiaries (if existing);
142049
(iv) the entering into, amending, prepaying or terminating of any third party loan or shareholder loan and the creation
of any pledge or other encumbrance on such loans;
(v) the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the adoption of or changes to the articles of
association of any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing);
(vi) the establishment or closure of branch offices;
(vii) the acquisition, disposal or encumbrance of participations in other enterprises, including silent participations, the
exercise of the Company's shareholder rights with respect to acquisition, disposal or encumbrance of participations in
other enterprises, including silent participations by any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing);
(viii) the acquisition or disposal of businesses or parts of businesses; and
(ix) the granting of proxies by the Company to the benefit of any person to execute a sale and purchase agreement
regarding the sale and transfer of shares in a subsidiary of the Company; and
(x) the exercise of the Company's shareholders rights with respect to the execution, termination or amendment of
any center management or other material service agreement by the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing).
If the contemplated measure under the above third paragraph involves the Company and/or any of its direct or indirect
subsidiaries on the one hand and a shareholder of the Company and/or any of its affiliates on the other hand, then the
Manager(s) or as the case may be the Board of Managers shall in deviation of the above third paragraph require the prior
consent of both the involved shareholder(s) of the Company and of those non-involved shareholder(s) of the Company
holding at least ninety percent (90%) of the voting rights of all non-involved shareholder(s) in the Company in order to
effect such contemplated legal transaction or measure.
In the event that upon fulfilment of the Forward Funding/Purchase Criteria, such fulfilment having been duly acknow-
ledged by the shareholder(s) resolving with simple majority, the holder of Class B Shares reasonably estimates that the
distribution of the consideration agreed on with the purchaser for (a) the transfer of all or any shares in a subsidiary of
the Company; or, as the case may be, (b) the disposition of a real estate project by a subsidiary, would allow each holder
of Class A Shares to receive dividend payments distributed in accordance with Article 24 below in an amount at least
equal to the aggregate of the Invested Capital of such Shareholder and its Preferred Return I (25% IRR) thereon, then
the Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, require only the prior consent of the holder(s) of Class B
Shares, but of no other shareholders, in order to effect the following legal transactions and measures:
(a) the disposal and transfer of all or any shares in a subsidiary of the Company; and
(b) the exercise of the Company's shareholder rights in a subsidiary of the Company with respect to a whole or partial
sale of the real estate project by such subsidiary; and
(c) the granting of proxies by the Company to the benefit of any person to execute a sale and purchase agreement
regarding the sale and transfer of shares in a subsidiary of the Company,
provided that notwithstanding the foregoing, if the contemplated legal transaction or measure involves the Company
and/or an affiliate of the Company on the one hand and holder(s) of Class B Shares and/or any of its/their affiliates on the
other hand, then the Manager(s) or as the case may be the Board of Managers require in addition to the prior consent
of the holder(s) of Class B Shares the prior consent of non-involved shareholders holding at least ninety percent (90%)
of the voting rights of all non-involved shareholders in the Company in order to effect such contemplated legal transaction
or measure.
For the avoidance of doubt, all other acts necessary or useful for accomplishing the Company's object will not be
subject to shareholders' consent, except for those legal transactions and measures listed under items (i) to (x) above
which will continue to require prior shareholder(s) consent of shareholder(s) holding at least ninety percent (90%) of the
voting rights in the Company even after fulfilment of the Forward Funding / Purchase Criteria insofar they are not covered
by items (a) to (c) above.
Art. 11. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) days written
notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place and the agenda of the
meeting. Any Manager may waive his right to be convened as set out above. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office or at such other place as the Board of
Managers may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.
142050
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of half (1/2) of the Managers holding
office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, such
quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One (1) or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several Managers.
Art. 12. Recording of the resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one (1) Manager has been appointed.
Art. 13. Management Fees and Expenses. Subject to the approval of the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by him/them in relation with such management of the Company or the pursuit
of the Company's corporate object.
Art. 14. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any Manager is only liable for the performance
of his duties.
The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the relevant
Manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one (1) or more of the Managers or any officer of the Company has
a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Any person
related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that one (1) or more of the Managers of the Company have or may have any
personal interest in any transaction of the Company, they shall make known to the other Manager(s) such personal
interest. The conflicted Manager(s) shall not consider or vote on any such transaction and such transaction and such
Managers' interest therein shall be reported to the shareholder(s).
The foregoing provisions do not apply if and when the relevant transaction is entered into under fair market conditions
and falls within the ordinary course of business of the Company.
Art. 16. Representation of the Company - Delegation of Powers. The Company will be bound towards third parties
by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two (2) Manager(s) if more than one (1)
Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers and Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.
The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to
persons or committees chosen by them.
The Company will also be bound by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory
power has been delegated, but only within the limits of such power
Art. 17. Auditors. Except where according to the laws the Company's annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one (1) or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.
142051
The auditors, if any, will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of their mandate. The
auditors are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the
shareholder(s).
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one (1) single shareholder, the latter
exercises the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law
are not applicable to that situation.
If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions
of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions can be documented in a single document or in several
separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several shareholder(s). Should the
resolutions to be adopted, be sent by the Manager(s) to the shareholders, the shareholders are under the obligation to,
within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolutions, cast their written vote and
return it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum
and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis
mutandis apply to the adoption of written resolutions.
Unless there is only one (1) single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon
issuance of a convening notice sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting by the Manager(s), the
auditors or shareholders representing half (1/2) of the corporate capital. The convening notice will specify the time and
place and the agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting should be held in the Grand Duchy of Lu-
xembourg. They may be held abroad if circumstances of force majeure so require.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to
the Law and these Articles of Association.
Art. 20. Annual General Meeting of Shareholders. The annual general meeting of shareholders to be held in case the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such
other place in the Grand Duchy of Luxembourg, as may be specified in the notice convening the meeting, at the latest
within six (6) months after the close of the financial year.
If such day is a day on which banks are not open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next
following Business Day.
Art. 21. Procedure and Vote at Meetings. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder, as his
proxy.
Any resolution the purpose of which is to amend the present Articles of Association or the adoption of which is subject
by virtue of the applicable laws or these Articles of Association, as the case may be, to the quorum and majority rules
set for the amendment of the Articles of Association, will be taken by (i) a majority of shareholders in number (ii)
representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Except as otherwise required by the applicable laws or by the present Articles of Association, all other resolutions
will be taken by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first
meeting or consultation in writing, the shareholders shall be convened or consulted a second time and resolutions will
then be taken by a majority of the votes cast notwithstanding the proportion of the capital represented.
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present or their proxy holders
or by the chairman, the secretary and the scrutineer of the meeting if such a bureau has been appointed.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s), as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one (1) Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, distribution of profits
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 23. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s)
draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
applicable laws.
142052
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 24. Appropriation of Profits. From the net profits of the Company, five per cent (5%) shall each year be allocated
to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
The shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to
allocate the whole or part of the remainder to a reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s) as
dividend, each Share entitling to the same proportion in such distributions before the Forward Funding / Purchase Criteria
are met, or, in accordance with the following rules set out in items (iii) to (x) below (subject to prior payment of the
amounts referred to in sections (i) and (ii) below to the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s)), upon
fulfilment of the Forward Funding / Purchase Criteria (such fulfilment having been duly acknowledged by the shareholder
(s) resolving with simple majority):
(i) to the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) an amount equal to the then drawndown and not yet
repaid amounts under any shareholder loans granted to the Company from time to time by the Class A Shareholder(s)
and the Class B Shareholder(s) in proportion to the then drawndown and not yet repaid amounts under their respective
shareholder loans; thereafter
(ii) to the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) an amount corresponding to the interest accrued
and not yet paid under its/their shareholder loan(s); thereafter
(iii) to all shareholders an amount equal to their capital contributions in proportion to their capital contributions
whereby any dividends previously received by the relevant shareholder from the Company, if any, shall be taken into
account and shall accordingly reduce the entitlement of the relevant shareholder under this subsection (iii); thereafter
(iv) to the Class B Shareholder(s) until the Class B Shareholder(s) has/have received under this subsection (iv) an
amount equal to twelve percent (12%) of the effective net construction and related costs (without value added tax)
actually incurred in relation to the completion of the Company's direct or indirect real estate holding(s) as further
determined pursuant to the terms agreed from time to time in writing by the shareholders, whereby any dividends
previously received by the relevant Shareholder from the Company, if any, that have not already been taken in account
under this Article 24 shall be taken into account under this subsection and shall accordingly reduce the entitlement of
the relevant Shareholder under this subsection (iv); thereafter
(v) to the Class B Shareholder(s) until the Class B Shareholder(s) has/have received under this subsection (v) an amount
equal to zero point seventy-five percent (0.75%) of the base completion value of the Company's direct or indirect real
estate holding(s) as further determined pursuant to the terms agreed from time to time in writing by the shareholders,
whereby any dividends previously received by the relevant Shareholder from the Company, if any, that have not already
been taken in account under this Article 24 shall be taken into account under this subsection and shall accordingly reduce
the entitlement of the relevant Shareholder under this subsection (v); thereafter
(vi) to the Class A Shareholder(s) until the Class A Shareholder(s) has/have received under consideration of the interest
payments under its/theirs shareholder loan(s) an Internal Rate of Return of twenty-five percent (25%) per annum on its/
their Invested Capital (the "Preferred Return I"); thereafter
(vii) to the Class B Shareholder(s) as promote until the Class B Shareholder(s) has/have received, considering the
payments under its/their shareholder loan(s), an amount equal to thirty per cent (30%) of the sum of (a) the amount
distributed to the Class A Shareholder(s) as Preferred Return I under the preceding subsection (vi) plus (b) the amount
distributed to the Class B Shareholder under this subsection (vii); thereafter
(viii) seventy per cent (70%) to the Class A Shareholder(s) and thirty per cent (30%) to the Class B Shareholder(s) as
promote until the Class A Shareholder(s) has/have received under consideration of the amounts paid to it/them as
Preferred Return I an Internal Rate of Return of thirty per cent (30%) per annum on its/their Invested Capital (the amount
paid to the Class A Shareholder(s) under this subsection being the "Preferred Return II"); thereafter
(ix) to the Class B Shareholder(s) as promote until it/they has/have received, considering the payments under its/their
shareholder loan(s) and the amounts paid to it/them as its/their promote under this Article 24, an amount equal to thirty-
five per cent (35%) of the aggregate amount distributed to the Class A Shareholder(s) as Preferred Return I and Preferred
Return II hereunder and the amounts distributed to the Class B Shareholder(s) as promote under subsections (vii) - (ix)
hereunder; thereafter
(x) sixty-five per cent (65%) to the Class A Shareholder(s) and thirty-five per cent (35%) to the Class B Shareholder
(s).
Subject to the conditions fixed by the Law, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The Manager
(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment, always in compliance with and so as to achieve
on an aggregate basis the same economic result as the rules set out in the second paragraph, (i) to (x), above.
142053
Chapter VI. Dissolution, liquidation
Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s), voting with the
same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Association, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the managers or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the remainder
of the Company's net assets shall be distributed to the shareholder(s) in conformity with and so as to achieve on an
aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out in Article 24, second paragraph (i) to (x), of
the present Articles of Association.
Chapter VII. Applicable law
Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance
with the Law.
Chapter VIII. Definitions
Art. 27. Definitions. In addition to the terms defined elsewhere in the present Articles of Association, the capitalised
terms defined below apply throughout the present Articles of Association and these capitalised terms have the meaning
set forth below:
"Business Day" means a day except a Saturday, Sunday or public holiday on which banks are generally opened for
business in the city of Luxembourg.
"Forward Funding / Purchase Criteria" means the cumulative criteria to be fulfilled regarding the development of a real
estate project, such criteria including registrations of the relevant plots of land with the competent land registers, the
receipt of construction permits from the competent local building authorities and the existence of certain pre-lease
agreements.
"Invested Capital" means the balance, as determined from time to time, of the amount invested (whether in form of
an equity contribution or advanced under a shareholder loan) by any shareholder in the Company and not yet returned
by the Company, whereby any dividend distributions received by a shareholder from the Company shall reduce the
amount of such shareholder's Invested Capital accordingly;
"Law" means the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended from time to time;
"Internal Rate of Return" or "IRR" means the annual percentage rate of return, being that annual discount rate which
when applied to the Shareholder Cashflows produces a net present value of those Shareholder Cashflows equal to zero,
on the basis that the rate of return is treated as compounding quarterly, calculated using the XIRR (XINTZINSFUSS)
formula in Microsoft Excel.
"Shareholder Cashflows" means all Shareholder cash inflows and outflows to and from the Company such as, but not
limited to, capital investments, loans, income receipts, interests on loans, redemption proceeds, liquidation profits or
losses and repayments of capital and loans, provided that any fees paid by the Company in accordance with any agreement
relating to the fee arrangements to which the Company is a party shall not be considered for such purpose.
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 5.45 p.m.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundacht, am siebten Tag des Monats November,
vor Uns, Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar, mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
fand eine außerordentlicher Gesellschafterversammlung (die "Versammlung") der Gesellschaft Silver Spring Holding
S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 46A, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde vom 18. Oktober 2007
aufgenommen durch Maître Paul Bettingen, Notar, mit Amtssitz in Niederanven, und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, vom 4. Dezember 2007 unter der Nummer 2800, und eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-133.336 (die "Gesellschaft"), statt. Der Gesellschaftsvertrag wurde
bis dato noch nicht abgeändert.
Die Versammlung wurde um 17.15 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Carolin Weirauch, Rechtsanwältin, wohnhaft in
Luxemburg, eröffnet.
142054
Die Vorsitzende ernennt Herrn Christophe Jolk, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer der Ver-
sammlung.
Herr Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, wird zum Stimmenzähler ernannt.
Die Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1 Schaffung von zwei (2) Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Stammgesellschaftsanteile der Klasse A (die "Gesell-
schaftsanteile der Klasse A"), und die Vorzugsgesellschaftsanteile der Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B")
und Neueinteilung der existierenden eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem
Nennwert von einem Euro-Cent (EUR 0,01), in eine Million einhundertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) Gesellschafts-
anteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) und einhundertfünfundzwanzigtausend
(125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01).
2 Vollständige Neuformulierung der Gesellschaftssatzung um die oben erwähnten Abänderungen des Gesellschafts-
kapitals wiederzugeben und um, inter alia, folgenden Gesellschaftszweck festzulegen:
"Der Gesellschaftszweck umfasst (i) die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Vermögenswerten und/oder
Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung
solcher Vermögenswerte und/oder Beteiligungen sowie (iii) die unmittelbare und/oder mittelbare finanzielle Unterstüt-
zung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder die Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind.
Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere (i) den Erwerb mittels Zeichnung, Kauf, Tausch oder auf jegliche
andere Weise von Aktien, Anteilen oder anderen Anspruch auf Dividende vermittelnden Wertpapieren, Schuldver-
schreibungen, Anleihen, Einlagenzertifikaten und anderen Schuldinstrumenten und, ganz allgemein, von Wertpapieren und
Finanzinstrumenten, die Eigentumsrechte, Forderungen oder übertragbare Instrumente verbriefen, die von einem privaten
oder öffentlichen Emittenten ausgegeben wurden; (ii) die Ausübung aller mit diesen Wertpapieren und Finanzinstrumen-
ten verbundenen Rechte; (iii) die direkte und/oder indirekte finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist oder welche Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind, und zwar insbesondere mittels der Gewährung
von Darlehen, Finanzhilfen und Sicherheiten jeglicher Form und Laufzeit sowie jegliche sonstige Unterstützung, beispiels-
weise durch Beratung; (iv) die Gewährung von Darlehen und/oder die private Ausgabe von Schuldtiteln in jeglicher Form;
und (v) die Vornahme von Geschäften jeglicher Art, ob kommerzieller, industrieller oder finanzieller Natur, betreffend
bewegliche oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen."
3 Sonstiges.
II. Die Namen der Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile sind in einer Anwesenheitsliste
aufgeführt, welche von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter sowie von
den Mitgliedern des Versammlungsvorstands unterzeichnet wird; die vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die jeweiligen
Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser einregistriert zu werden.
III. Aus der vorliegenden Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesell-
schaftskapital repräsentieren, anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammenge-
treten und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung, über die die anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter in Kenntnis gesetzt worden sind, abstimmen.
IV. Nach Einführung durch die Vorsitzende fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST die Schaffung von zwei (2) Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Stammgesellschafts-
anteile der Klasse A (die "Gesellschaftsanteile der Klasse A") und die Vorzugsgesellschaftsanteile der Klasse B (die
"Gesellschaftsanteile der Klasse B") und die Neueinteilung der existierenden eine Million zweihundertfünfzigtausend
(1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) in eine Million einhun-
dertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-
Cent (EUR 0,01) und einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert
von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01).
Folglich hält STEG Emerging Markets Real Estate GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts,
mit Amtssitz in Freihamerstrasse 2, D-82166 Gräfelfing, Deutschland, und im Handelsregister des Münchner Amtsge-
richtes unter HRB 170 816 eingetragen, alle Gesellschaftsanteile der Klasse A, und Tottenham Hale S.à r.l., eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit Amtssitz in 46A,
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter
Nummer B-131.760, hält alle Gesellschaftsanteile der Klasse B.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung BESCHLIESST die Abänderung der Gesellschaftssatzung um, inter alia, den oben genannten Beschluss
wiederzugeben. Der Wortlaut der Gesellschaftssatzung ist fortan folgender:
142055
Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die "Gesellschaft") gegründet, die
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und den Bestimmungen der vorliegenden Gesellschaftssatzung unterliegt
(die "Gesellschaftssatzung").
Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren
Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.
Der Name der Gesellschaft ist "Silver Spring Holding S.à r.l.".
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der registrierte Gesellschaftssitz befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des/der Geschäftsführer/s oder des Geschäftsführungsrats an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss des/der Geschäftsführer/s im
Großherzogtum Luxemburg gegründet werden.
Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-
scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die normale Geschäftsführung der
Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung zwi-
schen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vo-
rübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von dem/den Geschäftsführer/n durchzuführen und interessier-
ten Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst (i) die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von
Vermögenswerten und/oder Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung,
Entwicklung und Betreuung solcher Vermögenswerte und/oder Beteiligungen sowie (iii) die unmittelbare und/oder mit-
telbare finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder die Teil ihrer
Gesellschaftsgruppe sind.
Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere (i) den Erwerb mittels Zeichnung, Kauf, Tausch oder auf jegliche
andere Weise von Aktien, Anteilen oder anderen Anspruch auf Dividende vermittelnden Wertpapieren, Schuldver-
schreibungen, Anleihen, Einlagenzertifikaten und anderen Schuldinstrumenten und, ganz allgemein, von Wertpapieren und
Finanzinstrumenten, die Eigentumsrechte, Forderungen oder übertragbare Instrumente verbriefen, die von einem privaten
oder öffentlichen Emittenten ausgegeben wurden; (ii) die Ausübung aller mit diesen Wertpapieren und Finanzinstrumen-
ten verbundenen Rechte; (iii) die direkte und/oder indirekte finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist oder welche Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind, und zwar insbesondere mittels der Gewährung
von Darlehen, Finanzhilfen und Sicherheiten jeglicher Form und Laufzeit sowie jegliche sonstige Unterstützung, beispiels-
weise durch Beratung; (iv) die Gewährung von Darlehen und/oder die private Ausgabe von Schuldtiteln in jeglicher Form;
und (v) die Vornahme von Geschäften jeglicher Art, ob kommerzieller, industrieller oder finanzieller Natur, betreffend
beweglicher oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des (der) Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit
dem nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird.
Kapitel II. Kapital, gesellschaftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt,
eingeteilt in eine Million einhundertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) voll eingezahlte Stammgesellschaftsanteile der
Klasse A ("Gesellschaftsanteile der Klasse A") und hundertfünfundzwanzigtausend (125.000) voll eingezahlte Vorzugsge-
sellschaftsanteile der Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B"); alle Gesellschaftsanteile der Klasse A und
Gesellschaftsanteile der Klasse B haben einen Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) (Gesellschaftsanteile
der Klasse A und Gesellschaftsanteile der Klasse B werden gemeinsam als "Gesellschaftsanteile" bezeichnet und einzeln
als "Gesellschaftsanteil").
Zusätzlich zu dem genannten Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emis-
sionsaufgelder, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag
dieses internen Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurücker-
wirbt, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die jeweilige Anteilsklasse oder zur Einbringung
in die gesetzlichen Rücklagen verwendet werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschaftsanteil verleiht Anrecht auf eine (1) Stimme. Das Eigentum eines Ge-
sellschaftsanteils bewirkt automatisch die implizite Annahme der Gesellschaftssatzung und der regulär gefassten Be-
schlüsse der Gesellschafterversammlung.
142056
Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschafts-
anteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen (1) einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein
Dritter sein kann, vertreten lassen.
Hat die Gesellschaft nur einen (1) Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft
mehrere Gesellschafter, können die Gesellschaftsanteile (i) frei zwischen den Gesellschaftern übertragen werden und (ii)
Nicht-Gesellschaftern können Gesellschaftsanteile nur mit Erlaubnis einer Mehrheit von Gesellschaftern die mindestens
drei Viertel (3/4) des gezeichneten Kapitals darstellt, zugeteilt werden.
Die genauen Bedingungen betreffend die Übertragung der Gesellschaftsanteile können schriftlich von den Gesellschaf-
tern festgelegt werden. Alle Übertragungen erfolgen im Einklang mit diesen Bedingungen sowie der Gesellschaftssatzung.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Übertragung von Gesellschaftsanteilen zu verweigern, es sei denn, die
Übertragung erfolgt im Einklang mit der Gesellschaftssatzung oder anderen vertraglichen Regelungen bezüglich der Über-
tragung von Gesellschaftsanteilen, zu denen die Gesellschaft eine Partei ist. Der Nachweis der Übertragung von
Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.
Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß
Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder
von dieser anerkannt wurde.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.
Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Zur Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschaftska-
pitals sind die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit zu erfüllen, die in der vorliegenden Gesell-
schaftssatzung oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung der vorliegenden Gesellschaftssatzung
vorgesehen sind.
Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird weder durch die
Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das die Gesellschafter
betrifft, aufgelöst.
Kapitel III. Geschäftsführer, Kommissare
Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern, die
nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").
Wenn zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen zu verwalten.
Wenn mehr als zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft als Geschäftsfüh-
rungsrat (der "Geschäftsführungsrat") zu führen.
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine be-
stimmte oder unbestimmte Dauer bestellt. Er/sie ist/sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
Der/die Gesellschafter können die Geschäftsführer in Geschäftsführer der Klasse A (die "Geschäftsführer der Klasse
A") und Geschäftsführer der Klasse B (die "Geschäftsführer der Klasse B") einteilen.
An einer Gesellschafterversammlung, welche über satzungsmäßige Bestellungen zu befinden hat, ist/sind der/die Ei-
gentümer der Gesellschaftsanteile der Klasse B befugt, die Einteilung der Geschäftsführer (wenn zwei (2) oder mehr als
zwei (2) Geschäftsführer bestellt wurden) in Geschäftsführer der Klasse A und Geschäftsführer der Klasse B vorzuschla-
gen.
Der/die Eigentümer der Gesellschaftsanteile der Klasse B ist/sind weiterhin befugt, Geschäftsführer der Klasse B zur
Wahl oder Entlassung vorzuschlagen, wobei die Geschäftsführer der Klasse B von einer Kandidatenliste, welche von dem/
den Eigentümern der Gesellschaftsanteile der Klasse B vorgelegt wurde, bestellt werden; hierbei ist sicherzustellen, dass
ein (1) Geschäftsführer der Klasse B ernannt wird wenn insgesamt zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden, und nicht
weniger als ein Drittel (1/3) der Geschäftsführer der Klasse B sind, wenn insgesamt mindestens drei (3) Geschäftsführer
ernannt werden.
Art. 10. Befugnisse der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführungsrat sind mit den
weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung vorzunehmen, welche für die Ausführung des Gesell-
schaftszweckes notwendig oder dienlich ist.
Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch die vorliegende Gesellschaftssatzung ausdrücklich dem
Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsfüh-
rers, der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats.
Vorbehaltlich der Vorschriften von Artikel 10, Absatz 4, (Maßnahmen betreffend Tochtergesellschaften der Gesell-
schafter), benötigt/benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat eine vorherige Genehmigung der
Gesellschafter, welche mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte halten, um folgende Transaktionen und Maß-
nahmen durchzuführen:
(i) den Kauf oder Erwerb auf sonstige Weise von Immobilien oder von Beteiligungen an juristischen Personen, die
Immobilien besitzen, sowie die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft hinsichtlich des Kaufs oder
142057
Erwerbs von Immobilien oder von Beteiligungen an juristischen Personen, die Immobilien besitzen, durch unmittelbare
oder mittelbare Tochtergesellschaften (sofern solche existieren);
(ii) die Ausgabe, die Verpfändung, der Verkauf oder die anderweitige Übertragung der Anteile an unmittelbaren oder
mittelbaren Tochtergesellschaften (sofern solche existieren), oder die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die
Gesellschaft im Rahmen der Abwicklung unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
(iii) der Verkauf oder die anderweitige Übertragung, im Rahmen eines Asset- beziehungsweise Share-Deals, einer
Immobilie, eines Immobilienportfolios oder eines sonstigen Gegenstandes aus dem Anlagevermögen der Gesellschaft
beziehungsweise die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft wenn sich diese Immobilie, dieses Im-
mobilienportfolio oder dieser Gegenstand aus dem Anlagevermögen im Besitz einer unmittelbaren oder mittelbaren
Tochtergesellschaft der Gesellschaft befinden (sofern solche existieren);
(iv) der Abschluss, die Abänderung, Vorauszahlung oder Beendigung von Darlehensverträgen mit Dritten oder Ge-
sellschaftern und die Verpfändung oder Schaffung von anderen Sicherheiten hinsichtlich solcher Darlehensforderungen;
(v) die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft zwecks Annahme oder Abänderung der Satzungen
unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften der Gesellschaft (falls solche existieren);
(vi) die Errichtung oder Schließung von Zweigniederlassungen;
(vii) der Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, einschließlich stiller
Beteiligungen, die Ausübung der Gesellschafterrechte der Gesellschaft hinsichtlich des Erwerbs, der Veräußerung oder
der Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, einschließlich stiller Beteiligungen, durch unmittelbare oder
mittelbare Tochtergesellschaft der Gesellschaft (falls solche existieren);
(viii) der Erwerb oder die Schließung von Geschäftsbetrieben oder von Teilen solcher Geschäftsbetriebe;
(ix) die Gewährung von Vollmachten an jedermann um Verträge über den Verkauf und die Übertragung von Anteilen
an Tochtergesellschaften der Gesellschaft abzuschließen; und
(x) die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft hinsichtlich des Abschlusses, der Beendigung oder
Änderung von Verträgen zur Hauptverwaltung oder anderer materieller Dienstleistungsverträge durch unmittelbare oder
mittelbare Tochtergesellschaft der Gesellschaft (falls solche existieren).
Wenn an einer unter Absatz drei beabsichtigen Maßnahme die Gesellschaft und/oder irgendeine ihrer unmittelbaren
oder mittelbaren Tochtergesellschaften einerseits und ein Gesellschafter der Gesellschaft und/oder irgendeine seiner
Zweiggesellschaften andererseits beteiligt ist, benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat in Ab-
weichung von Absatz drei die vorherige Zustimmung des/der beteiligten Gesellschafter(s) der Gesellschaft und der nicht
beteiligten Gesellschafter, die mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte aller nicht beteiligten Gesellschafter
halten, um die beabsichtigte Maßnahme durchzuführen.
Wenn bei Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien, die durch eine einfache Mehrheit der Gesellschafter aner-
kannt wurde, der Gesellschafter der Klasse B vernünftigerweise annimmt, dass die Ausschüttung der Gegenleistung, die
mit dem Käufer vereinbart wurde für (a) die Übertragung aller oder einiger Gesellschaftsanteile in einer Tochtergesell-
schaft der Gesellschaft oder in der Gesellschaft, oder für (b) die Verfügung über ein Immobilienprojekt durch eine
Tochtergesellschaft, an jeden Gesellschafter der Klasse A eine Dividendenzahlung gemäß Artikel 24 in Höhe eines Betrages
erlaubt, der mindestens der Summe des Investierten Kapitals eines solchen Gesellschafters und seines Bevorzugten Er-
trages I (25% IZF) darauf entspricht, so benötigten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat nur die
Zustimmung des/der Gesellschafter der Klasse B, aber nicht der anderen Gesellschafter, um die folgenden Rechtsgeschäfte
und Maßnahmen durchzuführen:
(a) die Verfügung über und die Übertragung aller oder einiger Gesellschaftsanteile an einer Tochtergesellschaft;
(b) die Ausübung der Rechte der Gesellschaft als Gesellschafterin einer Tochtergesellschaft hinsichtlich des vollstän-
digen oder teilweisen Verkaufs von Grundeigentum durch eine solche Tochtergesellschaft; und
(c) die Gewährung von Vollmachten durch die Gesellschaft an jedermann um Verträge über den Verkauf und die
Übertragung von Anteilen an Tochtergesellschaften der Gesellschaft abzuschließen.
Gleichwohl, wenn die Gesellschaft und/oder irgendeine ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften einerseits
und ein Gesellschafter der Gesellschaft und/oder irgendeine seiner Zweiggesellschaften andererseits an der beabsichtigten
Maßnahme beteiligt sind, benötigt/benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat zusätzlich zu der
vorherigen Zustimmung der Gesellschafter der Klasse B die vorherige Zustimmung des/der beteiligten Gesellschafter(s)
der Gesellschaft und der nicht beteiligten Gesellschafter, die mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte aller
nicht beteiligten Gesellschafter halten, um die beabsichtigte Maßnahme durchzuführen.
Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgestellt, dass alle anderen Maßnahmen, die für die Erfüllung des Gesellschafts-
zweckes notwendig oder nützlich sind, nicht der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, mit Ausnahme der Maßnahmen
und Rechtsgeschäfte, die oben unter Punkt (i) bis (x) aufgelistet sind, die weiterhin die Zustimmung von Gesellschaftern
benötigen, die mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte in der Gesellschaft halten, auch nach Erfüllung der
Finanzierungs-/Erwerbskriterien, sofern sie nicht von den Punkten (a) bis (c) erfasst werden.
142058
Art. 11. Sitzungen des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende
Regeln:
Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende") benennen. Er kann auch einen
Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Aufnahme der Sitzungspro-
tokolle des Geschäftsführungsrates sowie der Gesellschafterversammlungen zuständig ist (der "Schriftführer").
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen
des Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit
gewährleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung angeben. Jeder Geschäftsführer kann auf seine Einberufung wie oben ausgeführt verzichten. Für Sitz-
ungen, deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine
gesonderte Benachrichtigung erforderlich.
Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-
führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-
schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt.
Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner
amtierenden Mitglieder, wobei im Falle einer der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Ge-
schäftsführer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend sein muss.
Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrates gefasst.
Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung
oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellt, teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.
Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in
einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem oder
mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.
Art. 12. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse des/der Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.
Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-
weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.
Art. 13. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den/die Gesellschafter, kann/können der/die
Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus können
den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des Gesell-
schaftszweckes getätigt wurden, zurückerstattet werden.
Art. 14. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die Geschäftsführer trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich
der aufgrund ihrer Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen. Geschäftsführer sind für die Ausführung
ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-
lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses entstanden sind, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäfts-
führer, Angestellter oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft
für eine andere Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der
gegenüber er nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober
Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich
umfasste Fragen gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der
freizustellenden Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht
zur Freistellung schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.
Art. 15. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner
anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein (1) oder mehrere Ge-
schäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt sind,
oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte oder Angestellte einer solchen Gesellschaft oder Firma sind. Keine
Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft
vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge
oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
142059
Gleichwohl, wenn ein Geschäftsführer der Gesellschaft oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches
Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäftsfüh-
rern anzeigen. Er darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen und das Rechtsgeschäft und das
Interesse des Geschäftsführers sind dem/den Gesellschafter(n) bei der nächsten Gesellschafterversammlung anzuzeigen.
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Marktbe-
dingungen eingegangen wurde und in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.
Art. 16. Vertretung der Gesellschaft - Delegation von Befugnissen. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die
alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch
die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.
Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben
(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.
Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die
von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen
gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-
schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer, welche
nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.
Die Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die Gesellschafter ernannt, die ihre Anzahl und die Dauer
ihres Mandats festlegen. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne
Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
Kapitel IV. Gesellschafter
Art. 18. Generalversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem (1) Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse
aus, die per Gesetz der Generalversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes finden diesbezüglich
keine Anwendung.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, können die Be-
schlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche Beschlüsse können in einem einzigen
Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem (1) oder mehreren Ge-
sellschaftern unterzeichnet, festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern an die Gesell-
schafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen seit dem
Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes,
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Bestimmungen zur Beschlussfähig-
keit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sind sinngemäß auf die Be-
schlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.
Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die Gesellschafter auch auf ein Einberufungsschreiben hin
versammeln, das durch Einschreiben acht (8) Tage vor der Versammlung durch die Geschäftsführer, die Wirtschaftsprüfer
oder durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren, versandt wurde. Das an die
Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesellschafterver-
sammlung an.
Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über
die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, sollen in Luxemburg abgehalten werden.
Sie können im Ausland abgehalten werden, wenn Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.
Jede regulär einberufene Gesellschafterversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter.
Art. 19. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz
zustehen.
Art. 20. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die abzuhalten ist wenn die Gesell-
schaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt, wird am Gesellschaftssitz der Gesellschaft oder einem anderen,
im Einberufungsschreiben benannten Ort des Großherzogtums Luxemburg binnen sechs (6) Monaten nach Ende des
Geschäftsjahres abgehalten.
Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-
genden Werktag abgehalten.
142060
Art. 21. Verfahren, Wahl. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme- und Re-
derecht.
Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.
Jeder Beschluss zum Zwecke der Satzungsänderung oder dessen Feststellung aufgrund der vorliegenden Gesellschafts-
satzung oder des Gesetzes den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegt,
muss (i) von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des gesamten
Gesellschaftskapitals vertreten.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der anwendbaren Gesetze oder der vorliegenden Gesellschaftssatzung
werden bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von Beschlüssen, die
den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, Beschlüsse von Gesellschaf-
tern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-
schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Anteile, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern oder deren Bevollmächtigten
oder durch den Vorsitzenden, den Schriftführer und den Stimmenzähler der Gesellschafterversammlung, falls ein solches
Komitee vorgesehen wurde, unterzeichnet.
Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter
unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls
der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Gewinnerzielung
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 23. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die
Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter oder dessen Bevollmächtigter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Be-
steht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne
von fünfzehn (15) Kalendertagen bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 24. Ausschüttung und Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent
(5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage
die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-
winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-
jahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die
Gesellschafter ausschütten. Hierbei berechtigt jeder Anteil vor der Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien in
gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung. Nach Zahlung der Beträge gemäß (i) und (ii) an die
Gesellschafter der Klasse A und an die Gesellschafter der Klass B und nach Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien
sind die Gesellschafter gemäß den unter (iii) bis (x) dargelegten Regeln zur Teilnahme an einer Ausschüttung berechtigt
(wobei die Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien durch die Gesellschafter mit einfacher Mehrheit anerkannt
worden sein muss):
(i) Gesellschafter der Klasse A und Gesellschafter der Klasse B sind in Höhe des Betrages berechtigt, der von der
Gesellschaft aufgrund von Gesellschafterdarlehen, wie sie der Gesellschaft von Zeit zu Zeit durch Gesellschafter der
Klasse A und Gesellschafter der Klasse B gewährt werden, in Anspruch genommen aber noch nicht zurückgezahlt wurde;
hiernach sind berechtigt:
(ii) Gesellschafter der Klasse A und Gesellschafter der Klasse B in Höhe des Betrages der für ihre Gesellschafterdar-
lehen angefallenen und nicht ausgezahlten Zinsen; danach sind berechtigt
(iii) alle Gesellschafter in Höhe des Betrages ihrer Kapitaleinlage im Verhältnis ihrer Kapitaleinlage wobei alle bisher
an den jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft gezähnten Dividenden angerechnet werden und die Höhe des
Betrages, zu dem der Gesellschafter gemäß diesem Unterabsatz (iii) berechtigt ist, entsprechend reduzieren; danach sind
berechtigt:
142061
(iv) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese gemäß diesem Unterabsatz (iv) einen Betrag in Höhe von zwölf Prozent
(12%) der tatsächlichen netto Baukosten und der damit in Zusammenhang stehenden Kosten (ohne Mehrwertsteuer),
die im Hinblick auf die direkte oder indirekte Immobilienbeteiligung der Gesellschaft tatsächlich angefallen sind, erhalten
haben; die Details hierzu werden von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter schriftlich festgelegt. Bei der Berechnung
werden alle bisher an den jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft gezähnten Dividenden angerechnet und die Höhe
des Betrages, zu dem der Gesellschafter gemäß diesem Unterabsatz (iv) berechtigt ist, wird entsprechend reduziert;
danach sind berechtigt:
(v) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese gemäß diesem Unterabsatz (v) einen Betrag in Höhe von null Komma
fünfundsiebzig Prozent (0,75%) des Basisendwertes der direkten oder indirekten Beteiligung der Gesellschaft an Immo-
bilienprojekten erhalten haben; die Details hierzu werden von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter schriftlich festgelegt.
Bei der Berechnung werden alle bisher an den jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft gezähnten Dividenden
angerechnet und die Höhe des Betrages, zu dem der Gesellschafter gemäß diesem Unterabsatz (v) berechtigt ist, wird
entsprechend reduziert; danach sind berechtigt:
(vi) Gesellschafter der Klasse A solange bis diese unter Anrechnung der Zinszahlungen auf ihre Gesellschafterdarlehen
einen Internen Zinsfuss von fünfundzwanzig Prozent (25%) pro Jahr auf ihr Investiertes Kapital ("Bevorzugter Ertrag I")
erhalten haben; danach sind berechtigt:
(vii) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese unter Anrechnung der Zinszahlungen auf ihre Gesellschafterdarlehen
einen Betrag in Höhe von dreißig Prozent (30%) der Summe von (a) dem Betrag der an die Gesellschafter der Klasse A
als Bevorzugter Ertrag I gemäß Unterabsatz (vi) ausgeschüttet wurde plus (b) dem Betrag, der an die Gesellschafter der
Klasse B unter diesem Unterabsatz (vii) ausgeschüttet wird, erhalten haben; danach sind berechtigt:
(viii) Gesellschafter der Klasse A zu siebzig Prozent (70%) und Gesellschafter der Klasse B zu dreißig Prozent (30%)
solange bis die Gesellschafter der Klasse A unter Anrechnung der Beträge, die an sie als Bevorzugter Ertrag I ausgeschüttet
wurden, einen Interner Zinsfuss von dreißig Prozent (30%) pro Jahr auf ihr Investiertes Kapital erhalten haben (der Betrag,
der gemäß diesem Unterabsatz (vii) an die Gesellschafter der Klasse A gezahlt wird, ist der "Bevorzugte(r) Ertrag II");
danach sind berechtigt:
(ix) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese unter Anrechnung der Zahlungen auf ihre Gesellschafterdarlehen
und der gemäß diesem Artikel 24 an sie gezähnten Beträge einen Betrag von fünfunddreißig Prozent (35%) der Summe
des an die Gesellschafter der Klasse A gezähnten Bevorzugten Ertrages I und des Bevorzugten Ertrages II und der an die
Gesellschafter der Klasse B gemäß (vii)-(ix) gezähnten Beträge erhalten haben; danach sind berechtigt:
(x) Gesellschafter der Klasse A zu fünfundsechzig Prozent (65%) und Gesellschafter der Klasse B zu fünfunddreißig
Prozent (35%).
Unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen können der/die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende auszahlen.
Der/die Geschäftsführer legen den Betrag und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest; hierbei ist das gleiche
wirtschaftliche Gesamtergebnis zu erzielen, wie es sich aus Absatz zwei, Punkt (i) bis (x), ergibt.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 25. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) aufgelöst werden. Die
Abstimmung über einen solchen Beschluss erfolgt vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen unter Be-
rücksichtigung des Quorums und der Mehrheit, wie sie für eine Satzungsänderung erforderlich sind.
Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche oder
juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt werden.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-
quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Gesellschafter verteilt; hierbei ist das gleiche wirtschaft-
liche Gesamtergebnis zu erzielen, wie es sich aus Artikel 24, Absatz zwei, Punkt (i) bis (x) dieser Satzung, ergibt.
Kapitel VII. Geltendes recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-
stimmen sich nach dem Gesetz.
Kapitel VIII. Definitionen
Art. 27. Definitionen. Zusätzlich zu den Begriffen, die an anderer Stelle in der vorliegenden Satzung definiert werden,
finden die wie folgt definierten Begriffe auf die gesamte Satzung Anwendung:
"Werktag" bezeichnet einen Tag, der kein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag, an dem die Banken in der Stadt
Luxemburg geschäftstätig sind, ist.
"Finanzierungs-/Erwerbskriterien" bezeichnen die Kriterien, die bei der Entwicklung eines Immobilienprojektes kumu-
lativ erfüllt sein müssen; diese Kriterien beinhalten die Registrierung der jeweiligen Flurstücke im örtlichen Grundbuch,
die Beantragung der Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt und das Vorliegen bestimmter Vorpachtverträge.
"Investiertes Kapital" bezeichnet die von Zeit zu Zeit zu berechnende Differenz zwischen dem durch einen Gesell-
schafter investierten Betrag (sei es in Form von Eigenkapital oder in Form von Gesellschafterdarlehen) und dem Betrag,
der noch nicht durch die Gesellschaft zurückgezahlt wurde, wobei alle Dividendenzahlungen, die an einem Gesellschafter
durch die Gesellschaft geleistet wurden, den Betrag seines Investierten Kapitals entsprechend reduzieren.
142062
"Gesetz" bezeichnet die geltende Fassung des luxemburgischen Gesetzes über der Handelsgesellschaften vom 10.
August 1915.
"Interner Zinsfuss" oder "IZF" bezeichnet den jährlichen Prozentsatz der Kapitalverzinsung, der dem jährlichen Ab-
zinsfaktor entspricht, der bei Anwendung auf den Gesellschafter Cashflow und auf der Grundlage einer vierteljährlichen
Kapitalaufzinsung einen Nettozeitwert des Gesellschafter Cashflows von Null ergibt; die Berechnung erfolgt hierbei durch
Anwendung der XIRR (XINTZINSFUSS) Formel in Microsoft Excel.
"Gesellschafter Cashflows" bezeichnet alle Geldzuflüsse und -abflüsse der Gesellschaft wie Kapitaleinlagen, Darlehen,
Einnahmen, Zinsen auf Darlehen, Erträge aus dem Rückkauf von Anteilen, Liquidationserlöse oderverluste und Rückzah-
lungen auf Kapitaleinlagen und Darlehen unter der Voraussetzung dass alle Gebühren, die von der Gesellschaft in
Übereinstimmung mit von ihr abgeschlossenen Gebührenverträgen, gezahlt wurden, hierbei nicht berücksichtigt werden.
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 17.45 Uhr geschlossen, aufgenommen wurde zu
Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der obengenann-
ten erschienen Personen die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf
Anfrage der gleichen Personen und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird der
englische Text vorwiegen.
Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: C. WEIRAUCH, C. JOLK, M. MÜLLER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 11. November 2008, Relation: EAC/2008/13940. — Erhalten zwölf Euro (12,-
EUR).
<i>Der Einnehmei> r (gezeichnet): SANTIONI.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Beles, den 21. November 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008151701/239/932.
(080179285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Night-Liner, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss.
R.C.S. Luxembourg B 141.091.
Im Jahre zweitausendacht, den achtzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Herr Erik RAUW, Freiberufler, geboren in Malmedy, (Belgien), am 18. Juni 1974, wohnhaft in B-4750 Nidrum, Auf
Köttenberg 10, (Belgien),
hier vertreten durch Herrn Dirk HEINEN, Privatbeamter, wohnhaft in B-4780 Sankt-Vith, Rodter Straße 58/F, (Bel-
gien), auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, nach "ne varietur" Paraphierung durch den
Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben wird, um mit ihr einre-
gistriert zu werden.
Welcher Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht zu beurkunden, dass er der
einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "NIGHT-LINER", mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 53,
Gruuss-Strooss, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
141091, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 21. August 2008, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2237 vom 12. September 2008, ist und
dass er den amtierenden Notar ersucht, den von ihr gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:
<i>Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt den Gesellschaftssitz von Weiswampach nach L-9753, Heinerscheid, 10, Kierches-
trooss, zu verlegen und dementsprechend den ersten Satz von Artikel 4 der Satzungen abzuändern wie folgt:
" Art. 4. (erster Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Heinerscheid, (Großherzogtum Luxemburg)."
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr sechshundertfünfzig
Euro.
142063
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, namens handelnd
wie hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort be-
kannt, hat dieselbe zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: HEINEN - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 2008, Relation GRE/2008/4728. — Reçu douze euros. 12,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 4 décembre 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008151772/231/40.
(080179573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
P5 Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 90.267.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, lei>
<i>17 novembre 2008i>
Les démissions de Messieurs Régis DONATI, Daniele MARIANI et Alexis DE BERNARDI de leurs postes d'adminis-
trateurs de la société sont acceptées.
Monsieur HUBERT Thierry, dirigeant, né le 06.06.1962, à Etterbeek (Belgique), résidant au 135, avenue des Dames
Blanches, B-1150 Bruxelles (Belgique), Monsieur Giovanni GARCEA, employé privé, né le 08.11.1980, à Padova (Italie),
résidant professionnellement au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et Madame Cristina LEVIS, employée privée,
née le 16.02.1981, à Belluno (Italie), résidant professionnellement au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, sont
nommés nouveaux administrateurs de la société. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2011.
Le siège social de la société est transféré au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>P5 INVESTMENTS S.A.
i>Giovanni GARCEA / Cristina LEVIS
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008151243/545/25.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW10045. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080178390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.
C Chateau VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 122.954.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of November.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) WB International Holdings VII S. à r. l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under
the laws of Luxembourg, with registered office at 33, avenue Monterey in L-2163 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.729, hereby represented by Mr Vincenzo ARNO,
employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in New York
and Luxembourg on November 21st, 2008;
2) WB Co-Investment International Holdings VII S. à r. l., a limited liability company (société à responsabilité limitée),
existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 33, avenue Monterey in L-2163 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 125.624, hereby represented by Mr Vincenzo
ARNO, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in
New York and Luxembourg on November 21st, 2008;
142064
3) D Chateau VII S. à r. l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of
Luxembourg, with registered office at 33, avenue Monterey in L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 122.955, hereby represented by Mr Vincenzo ARNO, employee, pro-
fessionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in New York and Luxembourg
on 21st November, 2008,
(the Shareholders).
The powers of attorney of the Shareholders, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf
of the Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.
The Shareholders hold the entire share capital of C Chateau VII S. à r. l., a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée) with registered office at 33, avenue Monterey in L-2163 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 122.954 (the Company), incorporated on November
15th, 2006 pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary then residing in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association C
- N
o
241 of February 23rd, 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several
times and for the last time on May 29th, 2008 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N
o
1637 of July 3rd, 2008.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders hold all the five hundred (500) shares of twenty-five euro (EUR 25) each in the share capital
of the Company amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), and the Shareholders exercise the
powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with Article 200-2 of the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended.
II. that the agenda of the resolutions of the Shareholders is worded as follows:
1. Modification of the financial year, to the effect that it begins on January 1st and ends on December 31st of each
year;
2. Subsequent amendment of articles 23 and 24 of the Company's bylaws;
3. Miscellaneous.
III. that the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to change the financial year so that it should from now on begin on January 1st and end on
December 31st of each year.
Therefore the running financial year which started on December 1st, 2007 shall exceptionally end on December 31st,
2008.
<i>Second resolutioni>
As a consequence, the Shareholders resolve to amend articles 23 and 24 first sentence, of the bylaws of the Company
so that they shall henceforth have the following wording:
" Art. 23. The Company's financial year begins on January 1st and ends December 31st of each year."
" Art. 24. first sentence. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an
inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities."
There being no further business the meeting was closed.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,000 (one thousand Euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
142065
1) WB International Holdings VII S. à r. l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège
social au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 122.729, ici représentée par Monsieur Vincenzo ARNO, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à New York et Luxembourg le 21 novembre
2008;
2) WB Co-Investment International Holdings VII S. à r. l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
avec siège social au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 125.624, ici représentée par Monsieur Vincenzo ARNO, employé privé, demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à New York et Luxembourg le
21 novembre 2008;
3) D Chateau VII S. à r. l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 33, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 122.955, ici représentée par Monsieur Vincenzo ARNO, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à New York et Luxembourg le 21 novembre 2008,
(les Associés).
Les procurations des Associés, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des
Associés et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps
avec celui-ci.
Les Associés détiennent l'intégralité du capital social de C Chateau VII S. à r. l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois avec siège social au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.954 (la Société), constituée le 15 novembre 2006 suivant
un acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N
o
241 du 23 février 2007.
Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 29 mai 2008 suivant un
acte du notaire instrumentant, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N
o
1637
du 3 juillet 2008.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que les Associés détiennent toutes les cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune dans le
capital social de la Société s'élevant à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), et les Associés exercent les pouvoir
dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée;
II. que l'ordre du jour des résolutions des Associés est libellé comme suit:
1. Modification de l'année sociale de sorte à ce qu'elle commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année;
2. Modification afférente des articles 23 et 24 des statuts de la Société;
3. Divers.
III. que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'année sociale de la Société de sorte à ce qu'elle commence le 1
er
janvier et se
termine le 31 décembre de chaque année.
En conséquence l'année sociale en cours ayant commencé le 1
er
décembre 2007 se terminer le 31 décembre 2008.
<i>Deuxième résolutioni>
Par conséquent, les Associés décident de modifier les articles 23 et 24, première phrase des statuts de la Société de
telle sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:
" Art. 23. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."
" Art. 24. première phrase. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance a été levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par
la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 1.000 (mille euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de la même partie comparante, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
142066
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: V. Arno et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 27 novembre 2008, LAC/2008/47695. — Reçu douze euros Eur 12,-.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008151700/5770/137.
(080179291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.
Seban S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5533 Remich, 43, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 143.177.
STATUTS
L'an deux mille huit, le vingt-huit novembre.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
ont comparu:
1.- Madame Clotilde Sophie CREMONA, consultant, épouse de Monsieur Alexander LUDORF, née à Mont St Martin
(France) le 20 février 1970, demeurant à L-5533 Remich, 43, Esplanade,
agissant en son nom personnel.
2.- Monsieur Xavier Marie-Agnès Luc LEBECQUE, consultant, né à Namur (B) le 21 janvier 1969, demeurant à B-6747
Saint Leger, 11A, rue du Vieux Moulin,
agissant en son nom personnel.
3.- Monsieur Denis DELCROIX, cuisinier, né à Charleroi (B) le 16 août 1968, demeurant à L-8391 Nospelt, 8, rue des
Fleurs,
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
Art; 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts
sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de "SEBAN S.à r.l.".
Art. 3. Le siège social est établi à Remich.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des
gérants qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée
aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l'article dix des statuts.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité
simple du capital social.
Art. 5. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec établissement
de restauration, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières et toutes
142067
opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son
extension.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)
parts sociales de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté,
à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision
prise à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article dix
des statuts, à l'exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé
à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.
Art. 10. a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas prévisés aux
articles quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.
b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui
entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d'autre un expert
pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.
c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire
savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.
d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption
est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir
de la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.
Art. 11. La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat
de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article dix.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par
l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des
fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du
capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.
142068
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,
résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-
ci atteint le dixième du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que
l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité
du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de
l'an deux mille huit.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux parts sociales créées de la manière suivante:
1. Madame Clotilde Sophie CREMONA, prénommée, quatre-vingt-quatorze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2. Monsieur Xavier Marie-Agnès Luc LEBECQUE, prénommé, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3. Monsieur Denis DELCROIX, prénommé, une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée par la suite, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme approximative de mille
deux cents euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-5533 Remich, 43, Esplanade.
Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Madame Clotilde Sophie CREMONA, consultant, épouse de Monsieur Alexander LUDORF, née à Mont St Martin
(France) le 20 février 1970, demeurant à L-5533 Remich, 43, Esplanade,
agissant en sa qualité de gérante administrative.
b) Monsieur Denis DELCROIX, cuisinier, né à Charleroi (B) le 16 août 1968, demeurant à L-8391 Nospelt, 8, rue des
Fleurs,
agissant en sa qualité de gérant technique.
La société est valablement engagée soit:
1) par la signature unique du gérant technique;
2) par les signatures conjointes des gérants technique et administratif.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
142069
Signé: C. Cremona, X. Lebecque, D. Delcroix, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 1
er
décembre 2008. Relation: EAC/2008/14652. Reçu soixante-deux euros cinquante
cents 12.500,- € à 0,5%: 62,50 €
<i>Le Receveur ffi> (signé): N.Boica.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2008.
Blanche MOUTRIER.
Référence de publication: 2008150544/272/142.
(080177575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.
LaSalle UK Ventures, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 116.220.
In the year two thousand and eight, on the third day of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
"LaSalle UK Ventures Holdings Limited", a private limited company incorporated and existing under the laws of Jersey,
registered with the Registrar of Companies under number 93310, having its registered office at 22 Grenville Street, St
Helier, Jersey JE4 8PX,
here represented by Mrs Cathy BLONDEL, legal assistant, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Jersey,
on 28 October 2008.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of "LaSalle UK Ventures" (hereinafter the "Company"), a société à responsa-
bilité limitée, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 116.220, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on May
4, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on July 12, 2006, number 1344. The articles
of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on September 22,
2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 18, 2008, number 2554.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner further decides to increase the Company's share capital by an amount of ninety-six thousand five
hundred and forty pound sterling (GBP 96,540.-), so as to raise it from its current amount of four hundred and thirteen
thousand three hundred and twenty pound sterling (GBP 413,320.-) up to five hundred and nine thousand eight hundred
and sixty pound sterling (GBP 509,860.-) through the issue of four thousand eight hundred and twenty-seven (4,827)
shares, having a nominal value of twenty pound sterling (GBP 20.-) each.
The four thousand eight hundred and twenty-seven (4,827) new shares have been subscribed by "LaSalle UK Ventures
Holdings Limited", prenamed, paid up by a contribution in cash of a total amount of one hundred and six thousand two
hundred pound sterling (GBP 106,200.-).
The total contribution of one hundred and six thousand two hundred pound sterling (GBP 106,200.-) will be allocated
as follows: (i) ninety-six thousand five hundred and forty pound sterling (GBP 96,540.-) will be allocated to the share
capital of the Company and (ii) nine thousand six hundred and sixty pound sterling (GBP 9,660.-) will be allocated to the
share premium account.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the
Company is amended and now reads as follows:
Art. 5 (first paragraph) . "The Company's share capital is set at five hundred and nine thousand eight hundred and sixty
pound sterling (GBP 509,860.-) represented by twenty-five thousand four hundred and ninety-three (25,493) shares with
a par value of twenty pound sterling (GBP 20.-) each."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to three thousand euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
142070
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing known to the notary by name, first name,
civil status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trois novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
"LaSalle UK Ventures Holdings Limited", une société à responsabilité limitée régie selon les lois de Jersey et ayant son
siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, enregistrement auprès du Registrar of Companies, sous le
numéro 93.310,
ici représentée par Madame Cathy BLONDEL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée à Jersey, le 28 octobre 2008.
La procuration paraphée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant est l'associé unique de "LaSalle UK Ventures" (ci-après la "Société"), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.220, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
4 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1344 au 12 juillet 2006. Les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 septembre 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2554 au 18 octobre 2008.
Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-seize mille cinq cent quarante livres
sterling (96.540,- GBP) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent treize mille trois cent vingt livres sterling
(413.320,- GBP) à cinq cent neuf mille huit cent soixante livres sterling (509.860,- GBP) par l'émission de quatre mille huit
cent vingt-sept (4.827) parts sociales d'une valeur de vingt livres sterling (20,- GBP) chacune.
Les quatre mille huit cent vingt-sept (4.827) parts sociales nouvelles sont souscrites par "LaSalle UK Ventures Holdings
Limited", prénommée, payées par un apport en numéraire pour un montant total de cent six mille deux cents livres
sterling (106.200,- GBP).
L'apport de cent six mille deux cents livres sterling (106.200,- GBP) sera alloué au capital social pour le montant de
quatre-vingt-seize mille cinq cent quarante livres sterling (96.540,- GBP) et neuf mille six cent soixante livres sterling
(9.660,- GBP) seront alloués au compte de prime d'émission.
Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié
et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5 (premier alinéa). "Le capital social est fixé à la somme de cinq cent neuf mille huit cent soixante livres sterling
(509.860,- GBP) représentée par vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-treize (25.493) parts sociales d'une valeur de
vingt livres sterling (20,- GBP) chacune. "
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à trois mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. BLONDEL, J.J. WAGNER.
142071
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 5 novembre 2008. Relation: EAC/2008/13744. Reçu six cent soixante-quatorze euros
vingt-six cents. 134.852,43 à 0,5% = 674,26 €.
<i>Le Receveuri> <i>ffi> . (signé): N. BOICA.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Sanem, le 1
er
décembre 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008150491/239/106.
(080177677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.
European Building S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 135.945.
L'an deux mille huit, le vingt-quatre juillet,
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
"GRAND BAIE S.A.", société anonyme, ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 60.395,
représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt,
- Madame Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roo-
sevelt.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare être l'unique associée de la société à responsabilité
limitée "EUROPEAN BUILDING S.à r.l", ayant son siège social à L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville, dont le siège
social a été transféré d'Italie au Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 31 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 560 du 6 mars 2008, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 135.945, au capital social
de quatre-vingt-dix-huit mille huit cents euros (EUR 98.800,00), représenté par trois mille neuf cent cinquante-deux
(3.952) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.
L'associée unique prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'accepter la démission de Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeu-
rant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, de ses fonctions de gérant de la société, et de
lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
L'associée unique décide de nommer en son remplacement en qualité d'administrateur Monsieur Abel BENITEZ,
comptable, né à Panama City (République de Panama), le 24 avril 1961, demeurant professionnellement à Calle Elvira
Mendez, Edificio Vallarino, Primer Piso, Apartado Postal 3382, Balboa (Ancon).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg en République de Panama, à Calle Elvira
Mendez, Edificio Vallarino, Primer Piso, Apartado Postal 3382, Balboa (Ancon), la société devenant de ce fait une société
de nationalité et de droit panaméen, et décide d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit
panaméen.
Le transfert de siège se fait en pleine continuation de la personnalité morale de la société et prend effet au jour de la
présente assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
L'associée décide de conférer mandat à la société "CARIBBEAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED",
ayant son siège social à Calle Elvira Mendez, Edificio Vallarino, Primer Piso, Apartado Postal 3382, Balboa (Ancon), afin
d'accomplir en République de Panama toutes les démarches nécessaires qui se rattachent au transfert et à l'enregistrement
de la société en République de Panama et au dépôt de ses statuts auprès des autorités compétentes, et décide de conférer
mandat à la "FIDUCIAIRE FERNAND FABER", avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, afin
d'accomplir au Luxembourg toutes les démarches nécessaires à cette même opération, y compris le dépôt des déclarations
fiscales à la date du transfert de la société auprès des autorités luxembourgeoises.
142072
<i>Quatrième résolutioni>
L'associée unique décide de charger la société "CARIBBEAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED",
prénommée, de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale extraordinaire en République de Panama,
par-devant un notaire panaméen, afin de constater le transfert de siège, avec l'ordre du jour suivant:
1. Constatation de la décision de transférer le siège social du Luxembourg en République du Panama, à Calle Elvira
Mendez, Edificio Vallarino, Primer Piso, Apartado Postal 3382, Balboa (Ancon), la société étant devenue de ce fait une
société de nationalité et de droit panaméen, et de la décision d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité
limitée de droit panaméen.
2. Refonte intégrale des statuts pour les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit panaméen.
3. Pouvoirs pour le Registre de Commerce et les autres formalités.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants de la comparante, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures,
ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Capiaux, J. Piek, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juillet 2008. LAC/2008/31062. — Reçu douze euros 12 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 4 août 2008.
Emile SCHLESSER.
Référence de publication: 2008148021/227/66.
(080174707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
MCC S.A., Metal Cad Concept S.A., Société Anonyme.
Enseigne commerciale: by chantal peyrat.
Siège social: L-3333 Hellange, 28, route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 87.078.
L'an deux mille huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "METAL CAD CONCEPT
S.A." en abrégé "MCC S.A." (numéro d'identité 2002 22 10 336), avec siège social à L-3333 Hellange, 28, route de
Bettembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 87.078, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 avril 2002, publié au Mémorial C, numéro 1053 du 10 juillet 2002 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mai 2008, publié au Mémorial C,
numéro 1594 du 28 juin 2008.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WALLERICH, administrateur de société, demeu-
rant professionnellement à Hellange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-
gique).
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel ANTONY, employé privé, demeurant professionnellement à
Esch-sur-Alzette.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Modification de l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:
"La société a pour objet le négoce et la vente, l'import et l'export de mobilier et d'objets d'art et de décoration.
Elle peut exercer son activité sous l'enseigne "by chantal peyrat".
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet."
2) Acceptation des démissions de Monsieur Daniel CLAUSS comme administrateur et de Monsieur Alain WALLERICH
comme administrateur, respectivement administrateur-délégué et décharge à leur donner.
3) Nomination de Madame Liliane WALLERICH et de Monsieur Bertrand WALLERICH comme nouveaux adminis-
trateurs de la société et détermination de la durée de leurs mandats.
4) Reconduction des mandats d'administrateur, respectivement d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Marc
WALLERICH.
142073
5) Révocation de Monsieur Luc HEYSE comme commissaire aux comptes et décharge à lui donner.
6) Nomination de la société "FIDUCIAIRE ACCURA S.A." comme nouveau commissaire aux comptes et détermination
de la durée de son mandat.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
1L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. La société a pour objet le négoce et la vente, l'import et l'export de mobilier et d'objets d'art et de décoration.
Elle peut exercer son activité sous l'enseigne "by chantal peyrat".
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter les démissions de Monsieur Daniel CLAUSS comme administrateur et de Monsieur
Alain WALLERICH comme administrateur, respectivement administrateur-délégué de la société et leur donne décharge
de leurs fonctions.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
a) Madame Liliane WALLERICH, employée privée, née à Veckring (France) le 3 septembre 1956, demeurant à F-57100
Thionville, 25, rue des Mûriers.
b) Monsieur Bertrand WALLERICH, administrateur de société, né à Thionville (France), le 8 octobre 1986, demeurant
à F-57100 Thionville, 1, rue Gravelotte.
Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2014.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de reconduire, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2014:
I) le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marc WALLERICH, directeur, né à Thionville (France), le 1
er
mai
1956, demeurant à L-57100 Thionville, 25, rue des Mûriers;
II) le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Marc WALLERICH, préqualifié, lequel est habilité à engager
valablement la société par sa signature individuelle.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer Monsieur Luc HEYSE comme commissaire aux comptes de la société et lui donne
décharge de sa fonction.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la société anonyme "FIDUCIAIRE ACCURA S.A.", avec siège social à L-4123 Esch-sur-
Alzette, 40-42, rue du Fossé, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 93.675, comme nouveau commissaire aux comptes
de la société.
Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2014.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des
présentes, s'élèvent approximativement à huit cent cinquante euros (€ 850,-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: WALLERICH, J.M. WEBER, ANTONY, A. WEBER.
142074
Enregistré à Capellen, le 18 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3497. Reçu douze euros (€ 12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 28 novembre 2008.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2008150500/236/93.
(080177974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 58.535.
Im Jahre zweitausendundacht, dem vierzehtnen November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft UBS Fund Services (Lu-
xembourg) S.A., mit Sitz in L-1855, Luxemburg, 33 A, avenue J.F. Kennedy, gegründet am 10. März 1997 unter dem Namen
KEYFUNDS SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. veröffentlicht im Memorial C, Nummer 334 vom 2. Juli 1997, eingetragen
im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B Nummer 58.535, versammelt.
Die Versammlung wird um 16.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Michaela Imwinkelried, mit geschäftlicher Adresse
in 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer und Stimmenzähler Herrn Martin RAUSCH, mit geschäftlicher Adresse in
33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg.
Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl der jeweils gehaltenen Aktien werden
auf einer Anwesenheitsliste vermerkt, welche von den anwesenden Aktionären und den Bevollmächtigten der vertretenen
Aktionäre unterschrieben wird. Die Versammlungsteilnehmer beziehen sich auf die von den Mitgliedern des Büros ers-
tellte Liste.
Nachdem die vorgenannte Liste, ne varietur' von den Parteien und dem diensttuenden Notar unterschrieben wurde,
wird sie dem Protokoll beigelegt und mit ihm hinterlegt.
Dem Protokoll ebenfalls beigelegt und mit ihm hinterlegt, werden die Vollmachten der Aktionäre welche an der ge-
genwärtigen Versammlung vertreten sind,, ne varietur' von den Parteien und dem diensttuenden Notar unterschrieben.
Der Vorsitzende stellt fest und bittet den Notar zu beurkunden
I. dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung von Artikel 4 und 20 der Statuten der Gesellschaft auf folgenden Wortlaut:
1. Abwandlung von Artikel 4 und 20 der Statuten der Gesellschaft auf folgenden Wortlaut:
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich der administrativen Tätig-
keiten von Organismen für gemeinsame Anlagen. Dies umfasst unter anderem namentlich die im Rahmen der Fondsver-
waltung vorgeschriebenen Rechnungslegungsdienstleistungen, die Beantwortung von Kundenanfragen, die Bewertung und
Preisfestsetzung (einschliesslich der Berechung und Publikation von Steuerkennzahlen), das Erstellen sämtlicher Fonds-
dokumente, die Überwachung und Einhaltung von Rechtsvorschriften, das Führen von Aktien- und Anteilsinhaberregistern
die Gewinnausschüttung, die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Kontrakt-abrechungen, Führen von Aufzeichnungen,
die Domizilierung von Organismen für gemeinsamen Anlagen und deren Verwaltungsgesellschaften. Weiter wird auch
die Domizilierung anderer Gesellschaften mit umfasst, die zur rechtlichen Vertretung von Finanzmarktprodukten im
weitesten Sinne notwendig erscheint.
Die Gesellschaft kann ebenfalls Verwaltungsdienstleistungen für andere Personen erbringen. Ausserdem kann die Ge-
sellschaft die Tätigkeit des Börsenmaklers ausüben sowie die Einführung und Notierung von Finanzinstrumenten an der
Börse veranlassen. Sie kann generell sämtliche Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt im weitesten Sinne diesen
Gesellschaftszweck fördern.
„ Art. 20. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
Sie kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer Dividende beschliessen.
Der Verwaltungsrat ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ermächtigt, Zwischendividenden auszuzahlen."
2. Alle weiteren notwendigen Korrekturen der Statuten dwchzuführen, die nicht Inhaltlicher natur sind sondern die
die Präsentation und Korrektur von Schreibfehlern betreffen.
3. Sonstiges:
142075
II. Dass die zwei Tausend Fünfhundert (2.500) Aktien welche das gesamte Kapital darstellen, an dieser Versammlung
vertreten sind, welche somit gültig zusammengesetzt und für die verschiedenen Punkte auf der Tagesordnung beschluss-
fähig ist, ohne vorhergehende Einberufung.
III. Die Versammlung der Aktionäre stimmt den Erklärungen des Vorsitzenden zu, erachtet sich als ordnungsgemäss
gebildet und einberufen, berät und fasst einstimmig, durch getrennte Abstimmung, folgenden Beschluss:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Versammlung beschliesstArtikel 4 und 20 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und ihnen folgenden Wortlaut
zu erteilen:
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich der administrativen Tätig-
keiten von Organismen für gemeinsame Anlagen. Dies umfasst unter anderem namentlich die im Rahmen der Fondsver-
waltung vorgeschriebenen Rechnungslegungsdienstleistungen, die Beantwortung von Kundenanfragen, die Bewertung und
Preisfestsetzung (einschliesslich der Berechung und Publikation von Steuerkennzahlen), das Erstellen sämtlicher Fonds-
dokumente, die Überwachung und Einhaltung von Rechtsvorschriften, das Führen von Aktien- und Anteilsinhaberregistern
die Gewinnausschüttung, die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Kontrakt-abrechungen, Führen von Aufzeichnungen,
die Domizilierung von Organismen für gemeinsamen Anlagen und deren Verwaltungsgesellschaften. Weiter wird auch
die Domizilierung anderer Gesellschaften mit umfasst, die zur rechtlichen Vertretung von Finanzmarktprodukten im
weitesten Sinne notwendig erscheint.
Die Gesellschaft kann ebenfalls Verwaltungsdienstleistungen für andere Personen erbringen. Ausserdem kann die Ge-
sellschaft die Tätigkeit des Börsenmaklers ausüben sowie die Einführung und Notierung von Finanzinstrumenten an der
Börse veranlassen. Sie kann generell sämtliche Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt im weitesten Sinne diesen
Gesellschaftszweck fordern.
„ Art. 20. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
Sie kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer Dividende beschliessen.
Der Verwaltungsrat ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ermächtigt, Zwischendividenden auszuzahlen."
Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 16.55 Uhr.
<i>Schätzung der Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 950,-EUR.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. IMWINKELRIED, M. RAUSCH, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 novembre 2008, Relation: LAC/2008/46127. — Reçu € 12.- (douze euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25. November 2008.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2008148024/206/87.
(080174763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
Edil Re S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 136.350.
L'an deux mille huit, le vingt-quatre juillet,
Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Ont comparu:
1.-"GRAND BAIE S.A.", société anonyme, ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 60.395,
représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt,
- Madame Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roo-
sevelt,
142076
2.- Monsieur Fabio PAONE, employé privé, demeurant à I-00040 Pomezia, 13, Via Cerqueto,
représenté par Madame Sabine LEMOYE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,
15, boulevard Roosevelt,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 27 juin 2008,
laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité
limitée "EDIL RE S.à r.l.", ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, dont le siège social a été
transféré d'Italie au Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 décembre
2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 981 du 21 avril 2008, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 136.350, au capital social de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Les associés prennent ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant
professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, de ses fonctions de gérant de la société, et de lui
donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Les associés décident de nommer en son remplacement en qualité d'administrateur Monsieur Abel BENITEZ, comp-
table, né à Panama City (République de Panama), le 24 avril 1961, demeurant professionnellement à Calle Elvira Mendez,
Edificio Vallarino, Primer Piso, Apartado Postal 3382, Balboa (Ancon).
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg en République de Panama, à Calle Elvira
Mendez, Edificio Vallarino, Primer Piso, Apartado Postal 3382, Balboa (Ancon), la société devenant de ce fait une société
de nationalité et de droit panaméen, et décide d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit
panaméen.
Le transfert de siège se fait en pleine continuation de la personnalité morale de la société et prend effet au jour de la
présente assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de conférer mandat à la société "CARIBBEAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMI-
TED", ayant son siège social à Calle Elvira Mendez, Edificio Vallarino, Primer Piso, Apartado Postal 3382, Balboa (Ancon),
afin d'accomplir en République de Panama toutes les démarches nécessaires qui se rattachent au transfert et à l'enregis-
trement de la société en République de Panama et au dépôt de ses statuts auprès des autorités compétentes, et décide
de conférer mandat à la "FIDUCIAIRE FERNAND FABER", avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roo-
sevelt, afin d'accomplir au Luxembourg toutes les démarches nécessaires à cette même opération, y compris le dépôt
des déclarations fiscales à la date du transfert de la société auprès des autorités luxembourgeoises.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de charger la société "CARIBBEAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED", prén-
ommée, de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale extraordinaire en République de Panama, par
devant un notaire panaméen, afin de constater le transfert de siège, avec l'ordre du jour suivant:
1. Constatation de la décision de transférer le siège social du Luxembourg en République du Panama, à Calle Elvira
Mendez, Edificio Vallarino, Primer Piso, Apartado Postal 3382, Balboa (Ancon), la société étant devenue de ce fait une
société de nationalité et de droit panaméen, et de la décision d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité
limitée de droit panaméen.
2. Refonte intégrale des statuts pour les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit panaméen.
3. Pouvoirs pour le Registre de Commerce et les autres formalités.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants des comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils
ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Capiaux, J. Piek, S. LEMOYE, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juillet 2008. LAC/2008/31063. - Reçu douze euros, 12 €.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 4 août 2008.
Emile SCHLESSER.
Référence de publication: 2008148022/227/70.
(080174709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
142077
First Target S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9660 Insenborn, Maison 84.
R.C.S. Luxembourg B 77.031.
EXTRAIT
Il résulte de procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 septembre 2008 que:
Le mandat de l'administrateur Monsieur Pierre Moncheur, né le 01.04.1954 à Louvain (Belgique), demeurant à L-9660
Insenborn, Maison 84, est reconduit pour une période de six ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
statuaire de 2013.
Le mandat du commissaire aux comptes, la société Fidu-Concept Sàrl, avec siège social à L-2132 Luxembourg, 36,
avenue Marie-Thérèse, est reconduit pour une période de six ans.
Son mandat prendra fin à l'issue l'assemblée générale statuaire de 2013.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2008148146/3560/19.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06902. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080174683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
Bunker Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 69.591.
DISSOLUTION
In the year two thousand eight, on the fourteenth of October
Before Maître Aloyse BIEL, notary residing in Esch/Alzette.
THERE APPEARED:
The company SBI Holding BV, with registered office in Heresingel, 1-9711EP Groningen, Nederland,
duly represented by the company "Seatrade Holding B.V." with registered office in Laan Corpus den Hoorn 200, 9728JS
Groningen, represented by its director Mr. Henricus Gerardus Alphonsus Maria NIJHOUT, residing in Rijksstraatweg
226/C, 9752 CJ Haren, The Netherlands,
here represented by Mr Philippe JANSSENS, captain, residing in L-2146, Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
by virtue of a proxy given in Groningen under private seal the 27th September 2008, said proxy initialled "ne varietur"
by the appearing partie and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the regis-
tration authorities.
Which appearing company has requested the executive notary to place on record as follows:
I. That there exists a public limited company (société anonyme) under the name «BUNKER LUX S.A.», with registered
office in L-2146, Luxembourg, 63-65, rue de Merl, incorporated according to a deed drawn up on 15th April 1999 by
Maître Edmond SCHROEDER, then notary residing in Mersch, and published in the official journal Mémorial Recueil
Spécial C number 523 of the year 1999,
amended by the minutes under private seal of the general meeting held on 18th December 2001, the extract of the
minutes of said general meeting having been published in the official journal Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et
associations number 585 of the year 2002,
II. That the corporate capital totally subscribed and paid up in cash is set at thirty thousand nine hundred eighty-six
euros and sixty-nine cents (30.986,69 EUR), represented by one thousand two hundred fifty (1250) shares without par
value.
III. That the undersigned has subsequently become the owner of all the corporate shares.
IV. That in the capacity of sole shareholder, the undersigned expressly declares to dissolve and liquidate the company
as from the present day, as the company has ceased all activities.
V. That the undersigned is perfectly aware of the financial situation and of the articles of incorporation of the company.
VI. That the undersigned, as sole shareholder, considering itself as the liquidator, declares having paid or credited all
the liabilities of the company and that it shall be personally liable for any debts of the company, and for all its commitments,
even if they were to be unknown on the present day.
VII. That the undersigned expressly grants discharge to the directors and to the statutory auditor for the carrying out
of their mission until the date of the notarial instrument.
142078
VIII. That the undersigned hands over personally to the public notary with all the shares of the company in its possession,
for destruction.
IX. That, therefore, the liquidation of the company is completed.
X. That the records and documents of the company will be kept for a term of five (5) years at the former registered
office of the company at L-2146, Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
<i>Assessment of the costsi>
The amount of the costs, expenses, and charges in any form, which fall to the company or are charged to it on the
grounds of the present deed, amount to the sum of eight hundred euros (800.-€).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.
Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le quatorze octobre
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A COMPARU:
La société SBI Holding BV, avec siège social à Heresingel , 1-9711 EP Groningen, Pays-Bas, représentée par la société
«Seatrade Holding B.V, avec siège social à Laan Corpus den Hoorn 200, 9728JS Groningen, représentée par son directeur
Monsieur Henricus Gerardus Alphonsus Maria NIJHOUT, demeurant à Rijksstraatweg 226/C, 9752 CJ Haren, Pays-Bas,
ici représenté par Monsieur Philippe JANSSENS, capitaine au long cours, demeurant professionnellement à L-2146,
Luxembourg, 63-65, rue de Merl, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Groningen, en date du 27
septembre 2008, lequel pouvoir après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera
annexé aux présentes, pour être formalisés avec elles.
Laquelle société représentée comme il vient d'être dit a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Qu'il existe une société anonyme sous la dénomination de «BUNKER LUX S.A.», avec siège social à L-2146, Lu-
xembourg, 63-65, rue de Merl, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 15 avril 1999, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 523 de l'année 1999,
modifiée par un procès-verbal d'assemblée générale sous seing privé tenue en date du 18 décembre 2001 et dont
l'extrait du procès-verbal de ladite assemblée générale a été publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et asso-
ciations, numéro 585 de l'année 2002.
II. Que le capital social intégralement souscrit et libéré à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-
neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1250) actions sans désignation de valeur nominal.
III. Que la soussignée est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société.
IV. Qu'en tant que seul actionnaire, la soussignée déclare expressément dissoudre et liquider la société à compter de
ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité.
V. Que la soussignée connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la société.
VI. Que la soussignée, actionnaire unique, se considérant comme le liquidateur, déclare avoir réglé ou provisionné tout
le passif de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même
inconnus à ce jour.
VII. Que la soussignée donne décharge expresse aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution
de leur mandat jusqu'à la date de l'acte notarié.
VIII. Que la soussignée remet au notaire toutes les actions de la société en sa possession, pour destruction.
IX. Que partant la liquidation de la société est achevée.
X. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l'ancien siège
social de la société, à L-2146, Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à
sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de huit cents (800.- ).
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le
présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
142079
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Janssens, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 2008, Relation: EAC/2008/12985. — Reçu douze euros. 12.- €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. BOICA.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2008.
Aloyse BIEL.
Référence de publication: 2008148029/203/102.
(080174916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
Alatrava S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 50.716.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemble générale extraordinaire des actionnaires du 7 novembre 2008 et d'une résolution du conseil
d'administration du même jour que les modifications suivantes ont été adoptées:
- Administrateur: Le mandat d'administrateur de M. Patrick Meunier, demeurant professionnellement au siège de la
société, a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.
- Administrateur délégué: M. Patrick Meunier, demeurant professionnellement au siège de la société, a été reconduit
dans ses fonctions d'administrateur Délégué de la société jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.
La société tient également à signaler ce qui suit:
- Administrateur: Madame Anna De Meis demeure professionnellement au siège de la société
- Commissaire aux comptes: depuis le 29 avril 1997, le commissaire aux comptes de la société, à savoir CONSULT-
LUX S.A, a changé de dénomination sociale pour s'appeler MRM CONSULTING S.A, dont le siège est actuellement au
5, rue de l'Ecole, L-4394 Pontpierre. Le mandat de la société MRM CONSULTING S.A a été renouvelé depuis l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 03 janvier 2006 et se poursuit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>ALATRAVA SA
i>Patrick Houbert
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008148141/6102/26.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04091. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080174309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
GENERALI LUXEMBOURG, Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances, Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 47.774.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 octobre 2008i>
L'Assemblée Générale de la société anonyme Generali Luxembourg, Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances a
pris acte de la fin du mandat de délégué à la gestion journalière de Madame Nathalie DE MEYERE, Directeur Général,
avec effet au 15 octobre 2008 et a supprimé tous les pouvoirs antérieurement conférés dans le cadre de la gestion de la
Société, avec effet au 15 octobre 2008.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 novembre 2008.
Joëlle BADEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008148154/7241/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07226. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080174400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
142080
Agence Immobilière Hein et Cie S.à r.l.
Alatrava S.A.
Alro S.A.
Arzak S.A.
Avelca S.à r.l.
B2C S.à r.l.
BarconcepT S.à r.l.
Basis Consulting Services Sàrl
Biosys SA
Bunker Lux S.A.
Caprice S.àr.l.
Carlson Fund Management Company S.A.
C Chateau VII S.à r.l.
Compagnie Helvétique de Déstockage S.A.
Continental Holdings S.A.
DBST S.à r.l.
DC Immo Concept S.àr.l.
D'Owstellgleis S.à.r.l.
Edil Re S.à r.l.
Etoile Promotions "Eral" S.à r.l.
Etoile Promotions "E", société à responsabilité limitée
Eurochapes S.à r.l.
European Building S.à r.l.
First Target S.A.
Flecha Holding S.A.
Fortis AG Fund L2 Management
GENERALI LUXEMBOURG, Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances
Geradpark SA
Gestatec S.A.
Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l.
HG Patrimoine S.A.H.
Imbellux S.A.
Interbio Medical Service S.A.
International Tracing and Technology S.à r.l.
Jardinier-Paysagiste Lemmer S.à r.l.
Kloose G.m.b.H.
Laborde S.A.
La Cave du Sommelier
LaSalle UK Ventures
LDM Corp S.A.
Lubwater S.A.
Metal Cad Concept S.A.
Michiko S.A.
Mimosas Finance Sàrl
Night-Liner
Oceanis Investments S.A.
Oxford Aviation Academy Luxembourg 2 S.à r.l.
Oxford Aviation Academy Luxembourg S.à r.l.
P5 Investments S.A.
Participations Amandari S.A.
Potende S.A.
Potende S.A.
Potende S.A.
Proteactive Europe S.A.
RM International S.A.
Rosa'h SCI, Société Civile Immobilière
Scan Inter S.A.
SDV (Luxembourg) S.A.
Seban S.à r.l.
Silver Spring Holding S. à r. l.
Sport Holding Overseas Patent S.A.
Taurumi S.à r.l.
Team-Trans S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
VEE Estepona A.G.
Ventana Investments S.A.