This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2844
27 novembre 2008
SOMMAIRE
Avon Capital Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
136504
Banque BCP, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136467
Beppe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136468
Brasserie 1900 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136504
Brindisi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136469
CB Richard Ellis European Warehousing
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136466
Copefi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136468
Crane International Capital S.à r.l. . . . . . .
136467
Domus-Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
136511
DVD Futur Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136512
DVD Futur Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136512
DVD Futur Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136512
First Data Luxembourg IV S.à r.l. . . . . . . . .
136511
Fitness Lounge S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136511
Garage Schiltz Frères S.A. . . . . . . . . . . . . . .
136508
GM Italy Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
136505
Immobilière Betz & Hettinger . . . . . . . . . .
136466
Immoselle G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136468
ING RPFFB Soparfi A S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
136505
Jetcom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136504
Jolux Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136510
Protrust International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
136466
Rival Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
136508
Rootness S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136509
Sitalux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136506
SPE Finance Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136505
Tansen Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
136507
Verger International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
136467
Villefranche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136509
136465
CB Richard Ellis European Warehousing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 93.200,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 94.323.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 16 juin 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
790 du 28 juillet 2003.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>CB Richard Ellis European Warehousing S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008144964/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02724. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080170216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Protrust International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 65.542.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 novembre 2008 que:
1) La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS en sa qualité d'administrateur de catégorie «A» est acceptée.
2) Monsieur Patrick MOINET, licencié en droit, de nationalité belge, né le 6 juin 1975 à Bastogne (Belgique), demeurant
professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg est nommé administrateur de catégorie «A», son
mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008144902/6312/19.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04900. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
IBH, Immobilière Betz & Hettinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 76, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 60.381.
Constituée par-devant M
e
Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 30 juillet 1997, acte publié au
Mémorial C no 633 du 12 novembre 1997, modifié par-devant le même notaire en date du 18 décembre 1998, acte
publié au Mémorial C no 207 du 26 mars 1999, capital converti en EURO suivant avis publié au Mémorial C no 1292
du 6 septembre 2002.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2008.
<i>Pour IMMOBILIERE BETZ ET HETTINGER en abrégé IBH
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008145073/1261/19.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09662. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
136466
Crane International Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.425,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 104.655.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2008.
Mandaté à cet effet
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2008144542/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02661. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080169384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Verger International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 39.325.
Le soussigné Bernard MAREVOET, administrateur de sociétés, né à Ottignies (Belgique) le 9 juin 1962, demeurant à
B-1180 Bruxelles, 1457, Chaussée de Waterloo,
déclare par la présente donner sa démission en sa qualité d'administrateur-délégué de la société avec effet immédiat:
VERGER INTERNATIONAL S.A.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2008.
B. Marevoet.
Enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 11 novembre 2008. Référence: LSO-CW/03464. — Reçu (€) quatorze.
<i>Pr le Receveuri> (signé): G. Reuland.
Pour mention, délivrée à la demande de la Société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2008.
Gérard LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008144840/220/19.
(080170350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Banque BCP, S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 7.648.
<i>Composition du Directoirei>
Suite au changement de gouvernance da la Banque, décidé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11/12/2007,
le Directoire se compose comme suit:
1. José VEIGA DOS SANTOS, Président, demeurant à 5, rue des Mérovingiens, Op Bourmicht, L-8070 Bertrange,
Luxembourg.
Nomination: Assemblée Générale Extraordinaire du 11/12/2007, pour une durée de 6 ans.
2. Serge TONDU, Membre, demeurant à 5, rue des Mérovingiens, Op Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg.
Nomination: Conseil de Surveillance du 16/09/2008, pour une durée de 3 ans.
BANQUE BCP, S.A.
José Veiga
<i>Président du Directoirei>
Référence de publication: 2008144838/1076/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02822. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
136467
Immoselle G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5413 Canach, 32, Schéiffeschgaard.
R.C.S. Luxembourg B 58.496.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17/11/2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl, Luxembourg
Référence de publication: 2008144318/7262/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03307. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080169547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Beppe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 130.827.
<i>Résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société,i>
<i>qui a eu lieu au Luxembourg le 15 septembre 2008i>
Liste de présence:
- Peter Engelberg (Modem Treuhand SA)
<i>Résolutioni>
L'Assemblée Générale décide d'approuver le transfert du siège social de la société du 11, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Il a été également résolu que le procès-verbal a été signé par le Président et un autre associé.
Aucun autre point n'étant porté à l'agenda, l'assemblée a été clôturée.
Peter Engelberg.
<i>Resolution of an Extraordinary General Meeting by the Manager (s) of the Company,i>
<i>taken at a meeting in Luxembourg on 15 September 2008i>
Attendance List:
- Peter Engelberg (Modern Truhand SA)
<i>Resolutioni>
The Manager (s) of the Company RESOLVED to move the registered office of the Company from 11, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, to 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
It was further resolved that these minutes be signed by the Chairman and one other manager.
With no other matters on the agenda the meeting was closed. Signed as above.
Peter Engelberg.
Référence de publication: 2008144805/1369/29.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08543. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Copefi, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3590 Dudelange, 59, place de l'Hôtel de Ville.
R.C.S. Luxembourg B 52.307.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008145075/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04646. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
136468
Brindisi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 122.893.
PROJET DE FUSION / FUSIONSPLAN / MERGER PLAN
13 November, 2008
Pour la fusion entre / For fusionen mellem / for the merger between
Banchory Investments ApS
CVR-nr. / CVR No. 29978522
Frederiksgade 21, 1
1265 København K
et / og / and
Brindisi SA
RCS Luxembourg B n° 122.893
avec siège social au 11A, bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Les organes les plus élevés des sociétés concernées, savoir le conseil d'administration de Brindisi SA et le conseil de
direction de Banchory Investments ApS établissent par les présentes le projet de fusion entre Brindisi S.A. comme société
absorbante (la Société absorbante) et Banchory Investments ApS comme société absorbée (la Société absorbée).
(La Société absorbante et la Société absorbée, ci-après dénommée collectivement "les sociétés fusionnantes")
La fusion sera opérée sur base de la directive 2005/56/EC du Parlement Européen et du Conseil (la "Directive")
La base de la loi luxembourgeoise sur les sociétés pour les fusions est la Directive et pour la société absorbante, les
articles 257 et suivants de la loi luxembourgeoises sur les sociétés du 10 août 1915 telle que modifiée ("LLAW"). La loi
danoise sur les sociétés pour les fusions est la directive et les dispositions du chapitre 15 et 15A de la loi danoise sur les
sociétés (649/2006) ("DCA") cf. Chapitre 10A du Danish Private Company Act.
<i>1. Informations sur les sociétés fusionnantes (Directive 5/a/art. DCA 137a (1); et art. 261 2a de la loi luxembourgeoise du 10 aoûti>
<i>1915 telle que modifiée)i>
<i>La Société absorbantei>
La Société absorbante est "Brindisi S.A.", une société anonyme inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro 122.893.
Le siège social de la société absorbante est établi actuellement à L-1724 Luxembourg, 11a, bd du Prince Henri.
<i>La Société absorbéei>
La société absorbée est "Banchory Investments ApS", une société privée danoise à responsabilité limitée inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés Rubrique Société CVR n° 29978522.
Le siège social de la société absorbée est actuellement à Frederiksgade 21, 1. DK-1265 Copenhague, Danemark.
La Société absorbante et la Société absorbée sont chacune en ce qui les concerne assujetties à l'impôt sur les sociétés
dans l'état dont elles sont résidentes.
<i>2. Les contreparties de la fusion (directive 5(b) art. DCA 137a 1. 2, art. 262/2 b. c et d.)i>
La Société absorbante détient l'entièreté du capital de la Société absorbée. En conséquence il n'y aura aucune répar-
tition à l'actionnaire de la société absorbée.
Il ne sera pas émis de nouvelles actions par la société absorbante et ainsi il n'y aura aucune indication par rapport à la
date d'émission et les droits attachés à de nouvelles actions, il ne sera réalisé aucun échange d'actions de la société
absorbante contre des actions de la société absorbée, aucun rapport d'échange n'est à calculer et aucun expert ne sera
nommé en vue d'émettre un rapport sur le rapport d'échange. La fusion aura pour conséquence que tous les actifs et
passifs de la Société absorbée seront transférés à la Société absorbante. Parmi les actifs de la Société absorbée figurent
les biens immobiliers suivants:
Sur la Commune de TOURRETTE-SUR-LOUP (ALPES-MARITIMES) 900, chemin Saint Martin,
Une PROPRIETE comprenant:
- Une maison à usage d'habitation composée d'un séjour, une cuisine, quatre petites chambres, trois pièces d'eau,
- Une chapelle en ruine attenante,
- Un atelier
Et terrain autour avec piscine.
Figurant au cadastre savoir:
136469
Section N
o
Lieudit
Surface
C
306 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a90ca
C
307 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 06a79ca
C
308 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 14a18ca
C
309 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 07a40ca
C
310 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 10a85ca
C
314 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a48ca
C
315 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 03a03ca
C
316 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 03a29ca
C
317 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 07a02ca
C
318 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a68ca
C
319 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 10a10ca
C
320 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 08a09ca
C
321 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a45ca
C
322 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 05a16ca
C
323 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 03a56ca
C
324 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 22a90ca
C
325 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 04a81ca
C
326 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 19a55ca
C
327 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 08a62ca
Total surface: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01ha 41a86ca
Ces immeubles prédésignés sont grevés des hypothèques/et ou privilèges et/ou droits de résolutions suivants:
- une hypothèque conventionnelle prise conformément à un acte notarié pour un montant de EUR 1.150.000 en
principal
- une hypothèque conventionnelle prise conformément à un acte notarié pour un montant de EUR 450.000 en principal
Lorsque la fusion deviendra effective, la nouvelle propriétaire de ces propriétés immobilières devra être transcrites
sur les registres officiels tenus par le Conservateur des Hypothèques du lieu de la situation la propriété immobilière. Les
actions de la Société absorbée seront annulées et la Société absorbée disparaîtra sans liquidation par suite de la fusion
<i>3. Effets probables de la fusion sur l'emploi (Directive 5(d) art. DCA 137a 1 4)i>
Les sociétés fusionnantes n'ont pas de travailleurs à l'exception des gérants dans la Société absorbée ci-après énumérés.
Des engagements de travailleurs ou d'autres mesures qui affecteraient le nombre de travailleurs ou les conditions
d'emploi de la Société absorbée ou de la Société absorbante, ne sont pas prévus ou connus au moment de la signature
des présentes.
Dans la Société absorbée toutefois, les membres du conseil de direction démissionneront de leur fonction à la date
ou la fusion prendra effet.
<i>4. Date de la fusion sur le plan comptable (Directive 5 (f) art; DCA 137a 1 6 et art. 262 2 e)i>
Les sociétés fusionnantes seront fusionnées, du point de vue comptable, au 31 octobre 2008, date à partir de laquelle
tous les droits et obligations de la Société absorbée sont censées pour les besoins comptables et fiscaux, transférés à la
Société absorbante.
<i>5. Droits des détenteurs spéciaux (Directive 5 (g) art. DCA 137a 1 (7) et art. 262 f.)i>
Les sociétés fusionnantes n'ont pas émis des droits conférant à leurs détenteurs des droits spéciaux ou à des détenteurs
des titres autres que des actions représentatives du capital social de la société ou d'autres droits spéciaux donnant droit
à des actions y compris des droits d'options.
<i>6. Avantages et droits particuliers (Directive 5(h) art.; DCA 137a:1 (8); et art. 262 (2) gi>
Aucun avantage ou droit spécial est conféré aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance
ou de contrôle des sociétés qui fusionnent. Les surveillants et les experts indépendants des sociétés fusionnantes rece-
vront une rémunération sur base d'une facture en conformité des usages d'affaires.
<i>7. Statuts de la Société absorbante (Directive 5(i) art.; DCA 137a:1 (9);i>
La fusion n'entraîne aucune modification des statuts de la société absorbante.
Les statuts de la société absorbante dans leur forme actuelle au moment de la signature des conditions du projet
restent attachés comme ANNEXE 1
ère
.
<i>8. Evaluation des actifs et passifs de la société absorbée (Directive 5(k) art.; DCA 137a:1 (11));i>
La Société absorbée était fondée le 15 octobre 2006.
136470
La situation financière avec annexes de la société absorbée couvrant la période du 15 octobre 2006 au 31 décembre
2007 forment ANNEXE 2 et les comptes intérimaires pour la période du 1
er
janvier au 31 octobre 2008 restent annexés
à titre d'ANNEXE 3. Les comptes ont été préparés en conformité avec les lois comptables danoises et les principes
comptables généralement admis.
Les situations financières avec appendixes de la Société absorbante couvrant la période du 1
er
octobre 2007 au 30
septembre 2008 formant ANNEXE 4 et les comptes intérimaires pour la période du 1
er
octobre au 31 octobre 2008
restent annexés à titre d'ANNEXE 5. Ces comptes ont été préparés en conformité avec les lois comptables luxembour-
geoises et les principes comptables généralement acceptés.
Ces situations financières sont à la disposition des actionnaires et des créanciers et travailleurs des sociétés qui fu-
sionnent à leur siège respectifs.
<i>9. La date des comptes des sociétés fusionnantes utilisées comme base de la fusion (Directive 5(I) art; DCA 137a: 1 12);i>
La date des comptes utilisée comme base de la fusion pour la Société absorbée est celle du 31 octobre 2008
La date des comptes utilisée comme base de la fusion pour la Société absorbante est celle du 31 octobre 2008.
<i>10. Rapport du Conseil d'Administration / de direction (Directive 7; DCA 134b et 137b, art. 265)i>
Un rapport spécial du conseil d'administration/conseil de direction des sociétés fusionnantes, a été signé à la même
date que le projet de fusion. Ce rapport est à la disposition des actionnaires, créanciers et employé(e)s aux sièges sociaux
des sociétés fusionnantes, dont l'adresse est indiquée sub 1
er
du présent projet de fusion.
Les droits des créanciers de la société absorbante sont déterminés par l'article 268 de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés. Les créanciers de la Société absorbante dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes
constatant la fusion, peuvent dans les 2 mois de cette publication, demander au magistrat présidant la Chambre du Tribunal
d'Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de
sûretés pour des créances échues ou non échues au cas ou l'opération de fusion réduirait le gage de ces créanciers. Des
informations exhaustives sur ces modalités peuvent être obtenues sans frais au siège social de la Société absorbante plus
amplement spécifiés sous le point 1
er
du présent projet de fusion.
Comme indiqué dans le rapport de fusion, les créanciers de la Société absorbée sont protégés par les dispositions de
DCA. Dans un rapport d'un expert indépendant daté du 7 novembre 2008 émis par BDO ScanRevision en conformité
avec DCA 134 - 4, il est déclaré que les créances des créanciers de la Société absorbée sont considérées comme suffi-
samment garanties après la fusion.
Le présent projet de fusion devient définitif seulement après avoir été approuvé par les assemblées générales des
sociétés fusionnantes, lesquelles ne pourront se tenir que 4 semaines après la publication du projet de fusion au Danemark
et un mois après la publication du projet de fusion au Grand-Duché de Luxembourg, en conformité avec la loi applicable.
<i>11. Languesi>
Les langues officielles du présent projet de fusion sont la langue danoise et la langue française. La langue anglaise n'existe
que pour des besoins d'information
<i>12. Contrepartiei>
Ce projet de fusion a été exécuté et signé en 4 exemplaires étant identiques dans leurs langues, une pour la société
absorbante, une pour la société absorbée et deux pour les autorités compétentes au Grand-Duché de Luxembourg et
au Danemark mentionnées au présent projet sub 1
er
.
<i>Annexesi>
1 Statuts de la Société absorbante
2 Comptes de la Société absorbée au 31 décembre 2007
3 Situation intérimaire de la Société absorbée pour la période du 1
er
janvier au 31 octobre 2008
4 Comptes de la Société absorbante au 30 septembre 2008
5 Situation intérimaire de la Société absorbante pour la période du 1
er
octobre au 31 octobre 2008
Det øverste ledelsesorgan i de implicerede selskaber, dvs. Bestyrelsen i Brindisi SA og Direktionen i Banchory Invest-
ments ApS opretter herved denne plan for fusionen mellem Brindisi SA som det fortsættende selskab ("det Fortsættende
Selskab") og Banchory Investments ApS som det ophørende selskab ("det Ophørende Selskab").
(Det Fortsættende Selskab og det Ophørende Selskab herefter tilsammen kaldet "de Fusionerende Selskaber").
Fusionen skal gennemføres i overensstemmelse med og på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv
2005/56/EF af 26. oktober 2005 ("Direktivet").
Det luxembourgske selskabsretlige grundlag for fusionen udgøres af Direktivet og for så vidt angår det Fortsættende
Selskab af artikel 257 og den luxembourgske selskabslov af 19. august 1915 med senere ændringer ("LLAW"). Det danske
selskabsretlige grundlag for fusionen udgøres af Direktivet og den danske aktieselskabslovs kap. 15 og 15 A
(lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006) ("A/S-loven"), jf. den danske anpartsselskabslovs kap. 10 A.
136471
<i>1. Oplysninger om de Fusionerende Selskaber (Direktivets artikel 5(a), A/S-lovens § 137a, stk. 1, litra 1, LLAW artikel 261 2 a)i>
<i>Det Fortsættende Selskabi>
Det Fortsættende Selskab er Brindisi SA, et luxembourgsk "société anonyme" registreret i the Registrar of Commerce,
under nr. 122.893.
Det nuværende hjemsted for det Fortsættende Selskab er: L-1724 Luxembourg, 11a, bld du Prince Henri.
<i>Det Ophørende Selskabi>
Det Ophørende Selskab er Banchory Investments ApS, et dansk anpartsselskab registreret i Erhvervs- og Selskabss-
tyrelsen, CVR nr. 29978522.
Det nuværende hjemsted for det Ophørende Selskab er: Frederiksgade 21, 1. 1265 København K, Danmark.
Det Fortsættende Selskab og det Ophørende Selskab er begge underlagt selskabsbeskatning i deres respektive hjem-
lande.
<i>2. Fusionsvederlag (Direktivets artikel 5(b), A/S-lovens § 137a, stk. 1, litra 2, LLAW 262 2 b. c og d.)i>
Det Fortsættende Selskab ejer den samlede kapital i det Ophørende Selskab. Der betales som følge heraf ikke vederlag
til anpartshaveren i det Ophørende Selskab.
Der vil ikke blive udstedt nye aktier i det Fortsættende Selskab, og der skal således ikke anføres nogen udstedelsesdato,
nye aktiers rettigheder skal ikke angives, ingen udveksling af aktier i det Fortsættende Selskab mod aktier i det Ophørende
Selskab skal finde sted, der skal ikke udregnes nogen kurs, og der skal ikke udpeges en vurderingsmand til at udarbejde
vurderingsrapport hvad angår kurs. Fusionen vil indebære, at alle aktiver og passiver i det Ophørende Selskab overdrages
til det Fortsættende Selskab. I det Ophørende Selskabs aktiver indgår nedennævnte faste ejendom:
I TOURRETTE-SUR-LOUP (ALPES-MARITIMES) kommune, 900, chemin Saint Martin,
En ejendom bestående af:
Et beboelseshus bestående af en stue, et køkken, fire små værelser, tre badeværelser,
en tilstødende kirkeruin,
et værksted
og et omliggende stykke jord med swimmingpool
Opført i matriklen som:
Sektion Nr Adresse
Areal
C
306 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a90ca
C
307 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 06a79ca
C
308 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 14a18ca
C
309 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 07a40ca
C
310 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 10a85ca
C
314 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a48ca
C
315 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 03a03ca
C
316 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 03a29ca
C
317 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 07a02ca
C
318 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a68ca
C
319 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 10a10ca
C
320 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 08a09ca
C
321 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a45ca
C
322 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 05a16ca
C
323 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 03a56ca
C
324 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 22a90ca
C
325 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 04a81ca
C
326 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 19a55ca
C
327 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 08a62ca
Samlet areal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01ha 41a86ca
Ovennævnte ejendom er behæftet med følgende pantehæftelser panteprivilegier og rettigheder i henhold til kendelser/
beslutninger:
- et aftalebestemt pant i overensstemmelse med notardokumentet med en hovedstol på 1.150.000 EUR.
- et aftalebestemt pant i overensstemmelse med notardokumentet med en hovedstol på 450.000 EUR.
Når fusionen er gennemført, vil den nye ejer af den nævnte faste ejendom skulle indføres i det officielle register
(Conservateur des Hypothèques) hvor ejendommen er beliggende. Det Ophørende Selskabs aktier vil blive annulleret,
og det Ophørende Selskab vil blive opløst uden likvidation i forbindelse med fusionen.
136472
<i>3. Fusionens sandsynlige følger for beskæftigelsen (Direktivets artikel 5(d), A/S-lovens § 137a, stk. 1, litra 4)i>
Der er ingen ansatte i de Fusionerende Selskaber ud over de nedenfor anførte direktører i det Ophørende Selskab.
Der er ikke på tidspunktet for underskrivelsen af fusionsplanen planlagt eller kendskab til nogen ansættelser eller andre
tiltag, som vil indvirke på antallet af ansatte eller ansættelsesvilkårene i det Ophørende Selskab eller i det Fortsættende
Selskab.
I det Ophørende Selskab vil direktionens medlemmer dog fratræde deres stillinger ved fusionens gennemførelse.
<i>4. Det regnskabsmæssige fusionstidspunkt (Direktivets artikel 5(f), A/S-lovens § 137a, stk. 1, litra 6, LLAW artikel 262 2 e)i>
De Fusionerende Selskaber fusioneres med regnskabsmæssig virkning fra 31. oktober 2008, fra hvilket tidspunkt det
Ophørende Selskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt og skattemæssigt skal anses for overgået til det Fort-
sættende Selskab.
<i>5. Rettigheder tilsikret selskabsdeltagere med særlige rettigheder (Direktivets artikel 5(g), A/S-loven § 137a, stk. 1, litra 7; LLAWi>
<i>262 f.)i>
De Fusionerende Selskaber har ikke indrømmet nogen rettigheder til selskabsdeltagere med særlige rettigheder eller
til indehavere af andre værdipapirer end aktier/anparter eller andre særlige rettigheder, der giver ret til aktier/anparter,
herunder optionsrettigheder.
<i>6. Særlige fordele og rettigheder (Direktivets artikel 5(h), A/S-lovens § 137a, stk. 1, litra 8, LLAW artikel 262(2) g)i>
Der er ikke indrømmet særlige fordele eller rettigheder til medlemmerne af de Fusionerende Selskabers administra-
tions-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer. Vederlæggelsen af de Fusionerende Selskabers revisorer og uafhængige
eksperter skal ske i henhold til faktura som led i den normale virksomhed.
<i>7. Vedtægter for det Fortsættende Selskab (Direktivets artikel 5(i), A/S-loven § 137a, stk. 1, litra 9)i>
Det er ikke som følge af fusionen nødvendigt at ændre vedtægterne for det Fortsættende Selskab.
De eksisterende vedtægter for det Fortsættende Selskab på tidspunktet for underskrivelse af denne fusionsplan er
vedhæftet som BILAG 1.
<i>8. Værdiansættelse af det Ophørende Selskabs aktiver og passiver (Direktivets artikel 5(k), A/S-loven § 137a, stk. 1, litra 11)i>
Det Ophørende Selskab er stiftet 15. oktober 2006.
Det Ophørende Selskabs årsregnskab for perioden 15. oktober 2006 - 31. december 2007 er vedhæftet som BILAG
2, og det Ophørende Selskabs mellembalance for perioden 1. januar - 31. oktober 2008 er vedhæftet som BILAG 3.
Regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning og almindeligt anerkendte regnskabs-
principper.
Det Fortsættende Selskabs årsregnskab for perioden 1. oktober 2007 - 30. september 2008 er vedhæftet som BILAG
4, og det Fortsættende Selskabs mellembalance for perioden 1. oktober - 31. oktober 2008 er vedhæftet som BILAG 5.
Regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med luxembourgsk regnskabslovgivning og almindeligt anerkendte
regnskabsprincipper.
Regnskaberne er fremlagt til eftersyn for anpartshaverne, kreditorerne og medarbejdere på de Fusionerende Selskabers
kontorer.
<i>9. Datoen for de Fusionerende Selskabers regnskaber anvendt som grundlag for fusionen (Direktivets artikel 5(l), A/S-loven § 137a,i>
<i>stk. 1, litra 12)i>
Balancedatoen for det Ophørende Selskabs regnskab anvendt som grundlag for fusionen er 31. oktober 2008.
Balancedatoen for det Fortsættende Selskabs regnskab anvendt som grundlag for fusionen er 31. oktober 2008.
<i>10. Bestyrelsens / direktionens redegørelse (Direktivets artikel 7, A/S-lovens § 134b og § 137b, LLAW 265)i>
En af Bestyrelsen / Direktionen i de Fusionerende Selskaber udarbejdet redegørelse underskrives på datoen for un-
derskrivelsen af denne Fusionsplan. Fusionsredegørelsen er tilgængelig for gennemsyn for aktionærer, kreditorer og
medarbejdere på hver af de Fusionerende Selskabers kontorer på de under pkt. 1 ovenfor nævnte adresser.
Det Fortsættende Selskabs kreditorers rettigheder følger af § 268 i Luxembourgs selskabslovning. Det Fortsættende
Selskabs kreditorer, hvis krav ligger forud for offentliggørelsen af de dokumenter, hvori fusionen vedtages, har ret til inden
2 måneder efter offentliggørelsen at anmode retsformanden for den afdeling ved retten i Luxembourg, der behandler
erhvervsretlige sager om ved hastesagsbehandling at stille sikkerhed for sådanne krav, forfaldne som uforfaldne, for det
tilfælde, at fusionen vil forringe disse kreditorers sikkerhed for at blive fyldestgjort. Yderligere detaljerede oplysninger
kan indhentes uden omkostninger på det Fortsættende Selskabs kontorer som anført under punkt 1 af nærværende
fusionsplan.
Som anført i fusionsredegørelsen beskyttes kreditorerne i det Ophørende Selskab af A/S-lovens bestemmelser. I en
uvildig vurderingsmands erklæring dateret den 7. november 2008 udarbejdet af BDO ScanRevision i overensstemmelse
med A/S-lovens § 134c, stk. 4, anføres det, at kreditorerne i det Ophørende Selskab antages at være tilstrækkeligt sikrede
efter fusionen.
136473
Nærværende fusionsplan skal godkendes af de Fusionerende Selskabers generalforsamlinger, som tidligst kan afholdes
4 uger efter offentliggørelse af fusionsplanen i Danmark og 1 måned efter offentliggørelsen i Luxembourg i overensstem-
melse med gældende lov.
<i>11. Forrangi>
De officielle sprog for denne fusionsplan er henholdsvis dansk og fransk. Den engelsksprogede kolonne er alene til
orientering
<i>12. Eksemplareri>
Denne Fusionsplan er underskrevet i fire (4) enslydende eksemplarer, hvoraf henholdsvis det Fortsættende Selskab og
det Ophørende Selskab hver får et (1) eksemplar og to (2) eksemplarer er til brug for de under pkt. 1 ovenfor nævnte
relevante myndigheder i henholdsvis Luxembourg og Danmark.
<i>Bilagi>
1 Vedtægter for det Fortsættende Selskab
2 Årsregnskab pr. 31. december 2007 for det Ophørende Selskab
3 Mellembalance for perioden 1. januar - 31. oktober 2008 for det Ophørende Selskab
4 Årsregnskab pr. 30. september 2008 for det Fortsættende Selskab
5 Mellembalance for perioden 1. oktober - 31. oktober 2008 for det Fortsættende Selskab
The highest managerial body in the companies involved, i.e. the Board of Directors of Brindisi SA and the Board of
Management of Banchory Investments ApS hereby establish this plan for the merger between Brindisi SA as the continuing
company ("the Continuing Company") and Banchory Investments ApS as the discontinuing company ("the Discontinuing
Company").
(The Continuing Company and the Discontinuing Company hereinafter collectively referred to as "the Merging Com-
panies").
The merger is to be carried out in accordance with and on the basis of Directive 2005/56/EC of the European Parliament
and of the Council (the "Directive").
The Luxembourg corporate law basis for the merger is the Directive and with respect to the Continuing Company,
the articles 257 and following of Luxembourg Company law of August 19, 1915 as amended ("LLAW"). The Danish
corporate law basis for the merger is the Directive and the provisions of chapter 15 and 15 A of the Danish Companies
Act (649/2006) ("DCA"), cf. chapter 10 A of the Danish Private Company Act.
<i>1. Information of the Merging Companies (Directive 5(a) art.; DCA 137a:1 (1); LLAW art. 261 2 a)i>
<i>The Continuing Companyi>
The Continuing Company is the Brindisi SA, a Luxembourg "société anonyme", registered into the Registrar of Com-
merce and Companies of Luxembourg B no. 122.893.
The registered address for the Continuing Company is at present in L-1724 Luxembourg, 11a, bd du Prince Henri.
<i>The Discontinuing Companyi>
The Discontinuing Company is Banchory Investments ApS, a Danish private limited company registered in the Danish
Commerce and Companies Agency, Company No. 29978522 .
The registered address for the Discounting Company is at present: Frederiksgade 21, 1. DK-1265 Copenhagen, Den-
mark.
The Continuing Company and the Discontinuing Company are both subject to the corporate income tax in their
respective country of residence.
<i>2. Merger consideration (Directive 5(b) art.; DCA 137a: 1 (2); art. 262 2. b. c and d.)i>
The Continuing Company owns the entire share capital of the Discontinuing Company. As a consequence, there will
be no consideration to the shareholder of the Discontinuing Company.
No new shares will be issued by the Continuing Company, so no further indication of the date of issue and the rights
of the new shares is to be indicated, no exchange of shares of the Continuing Company against shares of the Discontinuing
Company will occur, no rate of exchange has to be calculated and no expert nominated in order to do a report on
exchange rate. The merger will have as consequence that all assets and liabilities of the Discontinuing Company will be
transferred to the Continuing Company. In the assets of the Discontinuing Company are comprised the following real
estate:
In the Commune of TOURRETTE-SUR-LOUP (ALPES-MARITIMES) 900, chemin Saint Martin,
A PROPERTY comprising:
A house used for residential purposes composed of a living room, a kitchen, four small bedrooms, three bathrooms,
A ruined chapel adjoining,
A workshop
136474
And surrounding land with swimming pool
Shown at the land registry as:
Section N
o
Adress
Surface
C
306 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a90ca
C
307 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 06a79ca
C
308 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 14a18ca
C
309 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 07a40ca
C
310 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 10a85ca
C
314 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a48ca
C
315 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 03a03ca
C
316 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 03a29ca
C
317 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 07a02ca
C
318 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a68ca
C
319 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 10a10ca
C
320 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 08a09ca
C
321 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 01a45ca
C
322 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 05a16ca
C
323 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 03a56ca
C
324 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 22a90ca
C
325 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 04a81ca
C
326 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 19a55ca
C
327 SAINT MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00ha 08a62ca
Total surface: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01ha 41a86ca
The above mentioned real estate is charged with the following mortgages/or and liens/ and or resolutions rights:
- a conventional mortage pursuant to a contractual deed up to an amount of EUR 1,150,000 in principal
- a conventional mortage pursuant to a contractual deed up to an amount of EUR 450,000 in principal
When the merger becomes effective, the new owner of the real estate will have to be transcribed in the official register
of real estates. held with the Conservateur des Hypothèques of the lieu of location of the real estate. The shares of the
Discontinuing Company will be cancelled and the Discontinuing Company will disappear without liquidation through the
merger.
<i>3. Likely repercussions of the merger on employment (Directive 5(d) art.; DCA 137a 1 (4))i>
There are no employees in the Merging Companies except from the managers of the Discontinuing Company men-
tioned below.
No employee appointments or other measures affecting the number of employees or employment conditions in the
Discontinuing Company or in the Continuing Company have been planned or are known at the moment of signing of the
terms.
In the Discontinuing Company, the members of the Board of Management will, however, resign their positions at the
date on which the merger takes effect.
<i>4. Merger date for accounting purposes (Directive 5(f) art.; DCA 137a:1 (6); LLAW art. 262 2 e)i>
The Merging Companies shall be merged with effect for accounting purposes from 31 October 2008 from which date
all rights and obligations of the Discontinuing Company for accounting and tax purposes are deemed to have been
transferred to the Continuing Company.
<i>5. Rights of holders of specific rights (Directive 5(g) art.; DCA 137a:1 (7); LLAW art. 262 f.)i>
The Merging Companies have not issued any rights conferred on holders enjoying special rights, or on holders of
securities other than shares representing the company capital or any other special rights entitling to shares, including
option rights.
<i>6. Special advantages and rights (Directive 5(h) art.; DCA 137a:1 (8); LLAW art. 262 (2) g)i>
No special advantages and rights are conferred to members of the administrative, management, supervisory or con-
trolling bodies of the Merging Companies. The auditors and the independent experts of the Merging Companies shall be
paid remuneration based on an invoice in due course of business.
<i>7. Articles of Association of the Continuing Company (Directive 5(i) art.; DCA 137a:1 (9))i>
The merger does not require any amendments in the Articles of Association of the Continuing Company.
The Articles of Association of the Continuing Company in the form as they are at the moment of signing of these
terms are attached as APPENDIX 1
136475
<i>8. Evaluation of the assets and liabilities of the Discontinuing Company (Directive 5 (k) art.; DCA 137a:1 (11))i>
The Discontinuing Company is established on 15 October 2006.
The financial statements with appendixes of the Discontinuing Company covering the period 15. October 2006 - 31
December 2007, are attached as APPENDIX 2, and intermediate accounts for the period 1 January - 31 October 2008,
are attached as APPENDIX 3. The accounts have been prepared according to Danish accounting legislation and generally
accepted accounting principles.
The financial statements with appendixes of the Continuing Company covering the period 1 October 2007 - 30 Sep-
tember 2008, are attached as APPENDIX 4, and intermediate accounts for the period 1 October - 31. October 2008,
are attached as APPENDIX 5. The accounts have been prepared according to Luxembourg accounting legislation and
generally accepted accounting principles.
Those financial statements are at the disposal of the shareholders and of the creditors and employees of the merging
companies on their respective registered offices.
<i>9. The date of Accounts of the Merging Companies as the basis for the merger (Directive 5(l) art.; DCA 137a: 1 (12 ))i>
The balance sheet date of the accounts forming the basis for the merger of the Discontinuing Company's accounts is
the 31 October 2008.
The balance sheet date of the accounts forming the basis for the merger of the Continuing Company's accounts is 31
October 2008.
<i>10. Report from the board of directors / the board of management (Directive 7; DCA 134b and 137b; LLAW art. 265)i>
A separate report of the Board of Directors / the Board of Management of the Merging Companies has been signed
on the same day as these Terms. The Report is available for shareholders, creditors and employees in the registered
offices of the merging Companies the addresses of which are stated in item 1 of these Terms.
The rights of the creditors of the continuing Company are determined by article 268 of Luxembourg Company Law.
The creditors of the Continuing Company whose claims are dated prior to the date of publication of the deeds deciding
the merger, have within 2 months of said publication, the right to ask the magistrate, presiding the commercial chamber
of the Circuit Court in Luxembourg as an urgent matter to issue guarantees in respect of claims due or not due, in case
the operation was to reduce their guaranty of reimbursement. Further detailed information can be obtained without
costs at the registered office of the Continuing Company indicated under 1. of the present merger draft.
As stated in the merger report the creditors of the Discontinuing Company are protected by the provisions of the
DCA. In an independent expert's statement dated on 7 November 2008 issued by BDO ScanRevision in accordance with
DCA 134c:4, it is stated that the claims of the creditors in Discontinuing Company are expected to be sufficiently secured
after the merger.
The present merger draft becomes effective only after it has been approved by the general meetings of the Merging
Companies that can only be held 4 weeks after this merger plan has been published in Denmark and 1 month after this
plan has been published in Luxembourg, in conformity with the relevant laws.
<i>11. Prevailing languagesi>
The official languages of these terms are Danish and French, respectively. The English column is for information pur-
poses only.
<i>12. Counterpartsi>
These Terms have been executed and signed in four (4) identical counterparts being identical in wording, one (1) of
which for the Continuing Company, one (1) of which for the Discontinuing Company and two (2) for the competent
authorities in Luxembourg and Denmark stated under item 1 of these Terms.
<i>Appendicesi>
1 Articles of Association of the Continuing Company
2 Accounts of the Discontinuing Company per 31 December 2007.
3 Intermediate accounts of the Discontinuing Company for the period 1 January - 31 October 2008.
4 Accounts of the Continuing Company per 30 September 2008
5 Intermediate accounts of the Continuing Company for the period 1 October - 31 October 2008.
Le conseil d'administration / Bestyrelsen for / The Board of Directors of
the Continuing Company:
Thierry Fleming / Claude Schmitz / Guy Hornick
Le conseil de direction de / Direktionen for / The Management Board of
the Discontinuing Company:
Jørgen Kvist Hansen / Daniel Arthur Reece / Mathieu Vincent Henri-Francois Pouletty
RAPPORT DE FUSION / FUSIONSREDEGØRELSE / MERGER REPORT
13 November 2008
136476
Pour la fusion entre / For fusionen mellem / for the merger between
Banchory Investments ApS CVR-nr. / CVR No. 29978522 Frederiksgade 21, 1 1265 København K
et / og / and
Brindisi SA
RCS Luxembourg B n° 122.893
avec siège social au 11A, bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Le conseil d'administration de Brindisi SA et le conseil de direction de Banchory Investments ApS établissent par les
présentes le projet de fusion entre Brindisi S.A. comme société absorbante («la Société absorbante») et Banchory In-
vestments ApS comme société absorbée («la Société absorbée»).
(La Société absorbante et la Société absorbée, ci-après dénommée collectivement «les sociétés fusionnantes»)
La fusion sera opérée sur base de la directive 2005/56/EC du Parlement Européen et du Conseil (la "Directive")
La base de la loi luxembourgeoise sur les sociétés pour les fusions est la Directive et pour la société absorbante, les
articles 257 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés du 10 août 1915 telle que modifiée ("LLAW"). La loi
danoise sur les sociétés pour les fusions est la directive et les dispositions du chapitre 15 et 15A de la loi danoise sur les
sociétés (649/2006) ("DCA") cf. Chapitre 10A du Danish Private Company Act.
Les conseils d'administration / Conseil de direction (selon le cas) de chaque société fusionnante sont invités à émettre
un rapport de direction dans le cadre de la présente fusion. Cependant, les conseils d'administration / Conseil de direction
des Sociétés Fusionnantes émettront des rapports de direction Identiques; Ainsi, ces rapports ont été annexés aux pré-
sentes («Le Rapport»)
<i>1 Les Sociétés Fusionnantesi>
Les Sociétés Fusionnantes appartiennent au même groupe de sociétés de telle sorte que la Société absorbante détient
100 % du capital de la Société absorbée.
<i>2 Aspects légaux et économiques de la fusioni>
La fusion est réalisée au Luxembourg, lorsque sont Intervenues les décisions concordantes au sein des sociétés fu-
sionnantes. Elle prendra effet à l'égard des tiers par la publication, laquelle interviendra après l'enregistrement auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois. A compter de cette date, tous les droits et obligations de la
Société absorbée seront transférés à la Société absorbante et la Société absorbée cessera d'exister.
Les engagements de la Société absorbée seront considérés d'un point de vue comptable comme ayant été ceux de la
Société absorbante à compter du 31 octobre 2008.
<i>3 Conséquences de la fusion pour les actionnaires des sociétés fusionnantesi>
La Société absorbée cessera d'exister lorsque la fusion deviendra juridiquement effective.
Aucune contrepartie ne sera attribuée à l'actionnaire de la Société absorbée
<i>4 Conséquences de la fusion pour les créanciers des sociétés fusionnantesi>
Les créanciers de la Société Absorbante sont protégés par les dispositions de la loi luxembourgeoise, plus spécialement
de l'article 268
Les droits des créanciers de la société absorbante sont déterminés par l'article 268 de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés. Les créanciers de la Société absorbante dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes
constatant la fusion, peuvent dans les 2 mois de cette publication, demander au magistrat présidant la Chambre du Tribunal
d'Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de
sûretés pour des créances échues ou non échues au cas ou l'opération de fusion réduirait le gage de ces créanciers. Des
informations exhaustives sur ces modalités peuvent être obtenues sans frais au siège social de la Société absorbante plus
amplement spécifiés sous le point 1 du projet de fusion.
Les créanciers de la Société absorbée sont protégés par les dispositions de la loi sur les sociétés danoises («DCA»).
Dans un rapport d'expert indépendant daté du 7 novembre 2008 émis par BDO ScanRevision conformément à l'article
134c:4, il est établi que les créances des créanciers de la Société absorbée sont suffisamment garanties après la fusion
Lorsque la fusion deviendra juridiquement effective, la Société absorbante prendra à sa charge les engagements de la
Société absorbée et sera pleinement responsable de l'exécution de ses engagements.
<i>5 Conséquences de la fusion sur les employés des sociétés fusionnantesi>
La société absorbée n'a pas de salariés outre les membres du conseil de direction au jour de la signature des présentes.
Les membres du conseil de direction démissionneront de leur fonction à la date où la fusion prendra effet.
Les droits et obligations de la Société absorbante issus des contrats de travail ou de relation de travail et existant à la
date où la fusion prendra effet ne seront pas affectés par la fusion.
A ce jour il n'existe aucun engagement ou autre mesure affectant le nombre ou les conditions des employés en lien
avec la fusion.
136477
Bestyrelsen i Brindisi SA og Direktionen i Banchory Investments ApS opretter herved denne fusionsredegørelse for
fusionen mellem Brindisi SA som det fortsættende selskab ("det Fortsættende Selskab") og Banchory Investments ApS
som det ophørende selskab ("det Ophørende Selskab").
(Det Fortsættende Selskab og det Ophørende Selskab herefter tilsammen kaldet "de Fusionerende Selskaber").
Fusionen skal gennemføres i overensstemmelse med og på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv
2005/56/EF af 26. oktober 2005 ("Direktivet").
Det luxembourgske selskabsretlige grundlag for fusionen udgøres af Direktivet og for så vidt angår det Fortsættende
Selskab af artikel 257 og den luxembourgske selskabslov af 19. august 1915 med senere ændringer ("LLAW"). Det danske
selskabsretlige grundlag for fusionen udgøres af Direktivet og den danske aktieselskabslovs kap. 15 og 15 A (lovbekendt-
gørelse nr. 649 af 15. juni 2006) ("A/S-loven"), jf. den danske anpartsselskabslovs kap. 10 A.
Bestyrelsen / Direktionen i hver af de Fusionerende Selskaber er forpligtet til at udarbejde en skriftlig redegørelse om
den foreslåede fusion. Idet Bestyrelsens / Direktionens redegørelse for hver af de Fusionerende Selskaber vil være ensl-
ydende, er disse redegørelser samlet i denne fælles redegørelse ("Fusionsredegørelse").
<i>1 De Fusionerende Selskaberi>
De Fusionerende Selskaber er koncernforbundne, idet det Fortsættende Selskab ejer hele anpartskapitalen i det
Ophørende Selskab.
<i>2 Fusionens juridiske og økonomiske aspekteri>
Fusionen er gennemført i Luxembourg, når overensstemmende beslutninger er truffet af de Fusionerende Selskaber.
Den har virkning over for tredjemand, når den er offentliggjort, hvilket sker, når den er registreret hos registrerings-
myndigheden i Luxembourg (le "Registre du Commerce et des Sociétés"). Samtlige det Ophørende Selskabs aktiver og
forpligtelser vil med virkning fra denne dato overgå til det Fortsættende Selskab, og det Ophørende Selskab vil ophøre.
Det Ophørende Selskabs dispositioner anses regnskabsmæssigt for foretaget for det Fortsættende Selskab pr. 31.
oktober 2008.
<i>3 Fusionens virkning for aktionærerne i de Fusionerende Selskaberi>
Det Ophørende Selskab ophører med at eksistere ved fusionens endelige gennemførelse.
Der skal ikke betales vederlag til anpartshaveren i det Ophørende Selskab.
<i>4 Fusionens virkning for de Fusionerende Selskabers kreditoreri>
Kreditorerne i det Fortsættende Selskab beskyttes af bestemmelserne i den luxembourgske selskabslovgivning nær-
mere bestemt artikel 268.
Det Fortsættende Selskabs kreditorers rettigheder følger af § 268 i Luxembourgs selskabslovning. Det Fortsættende
Selskabs kreditorer, hvis krav ligger forud for offentliggørelsen af de dokumenter, hvori fusionen vedtages, har ret til inden
2 måneder efter offentliggørelsen at anmode retsformanden for den afdeling ved retten i Luxembourg, der behandler
erhvervsretlige sager om ved hastesags behandling at stille sikkerhed for sådanne krav, forfaldne som uforfaldne, for det
tilfælde, at fusionen vi! forringe disse kreditorers sikkerhed for at blive fyldestgjort. Yderligere detaljerede oplysninger
kan indhentes uden omkostninger på det Fortsættende Selskabs kontor som anført under punkt 1 i fusionsplanen.
Kreditorerne i det Ophørende Selskab beskyttes af A/S-lovens bestemmelser. I en uvildig vurderingsmands erklæring
dateret den 7. november 2008 udarbejdet af BDO ScanRevision i overensstemmelse med A/S-lovens § 134c, stk. 4, anføres
det, at kreditorerne i det Ophørende Selskab antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.
Ved fusionens endelige gennemførelse overtager det Fortsættende Selskab det Ophørende Selskabs gældsforpligtelser
og hæfter herefter for betalingen af disse gældsforpligtelser.
<i>5 Fusionens følger for medarbejderne i de Fusionerende Selskaberi>
Foruden direktionens medlemmer har det Ophørende Selskab ingen ansatte på tidspunktet for underskrivelsen af
fusionsplanen.
Direktionens medlemmer vil fratræde deres stillinger ved fusionens gennemførelse.
Det Fortsættende Selskabs rettig heder og forpligtelser i henhold til ansættelseskontrakter eller i forbindelse med
ansættelsesforhold på datoen for fusionens endelige gennemførelse, vil ikke blive påvirket af fusionens gennemførelse.
Der er ikke i forbindelse med fusionen planlagt nogen ansættelser eller andre tiltag, som kan indvirke på antallet af
ansatte eller ansættelsesforholdene i det Fortsættende Selskab.
The Board of Directors of Brindisi SA and the Board of Management of Banchory Investments ApS hereby establishes
this plan for the merger between Brindisi SA as the continuing company ("the Continuing Company") and Banchory
Investments ApS as the discontinuing company ("the Discontinuing Company").
(The Continuing Company and the Discontinuing Company hereinafter collectively referred to as "the Merging Com-
panies").
The merger is to be carried out in accordance with and on the basis of Directive 2005/56/EC of the European Parliament
and of the Council (the "Directive").
136478
The Luxembourg corporate law basis for the merger is the Directive and with respect to the Continuing Company,
the articles 257 and following of Luxembourg Company Law of August 19,1915 as amended ("LLAW"). The Danish
corporate law basis for the merger is the Directive and the provisions of chapter 15 and 15 A of the Danish Companies
Act (649/2006) ("DCA"), cf. chapter 10A of the Danish Private Company Act.
The Boards of Directors / Board of Management (as the case may be) in each of the Merging Companies are required
to issue a separate report of the management regarding the proposed merger. However, the Boards of Directors / Board
of Management of the Merging Companies will issue identical reports of the management; as a result these reports have
been consolidated in this joint report ("Report").
The Merging Companies
The Merging Companies belong to the same group of companies as the Continuing Company owns the entire share
capital of the Discontinuing Company.
Legal and economic aspects of the merger
The merger is realized in Luxembourg when the congruent decisions have been taken by the Merging Companies. It
takes effect vis-à-vis third parties by its publication that occurs after it has been registered with the Register of Commerce
and Company in Luxembourg. As from that date all rights and liabilities of the Discontinuing Company will transfer to
the Continuing Company and the Discontinuing Company ceases to exist.
The transactions of the Discontinuing Company will be treated for accounting purposes as being those of the Con-
tinuing Company as from 31 October 2008.
Implications of the merger for the shareholders of the Merging Companies
The Discontinuing Company ceases to exist when the merger becomes legally effective.
There will be no consideration to the shareholder of the Discontinuing Company.
Implications of the merger for the creditors of the Merging Companies
The creditors of the Continuing Company are protected by the provisions of the Luxembourg Law, in particular by
article 268.
The rights of the creditors of the Continuing Company are determined by article 268 of Luxembourg Company Law.
The creditors of the Continuing Company whose claims are dated prior to the date of publication of the deeds deciding
the merger have within 2 months of said publication, the right to ask the magistrate presiding the commercial chamber
of the Circuit Court in Luxembourg as an urgent matter to issue guarantees in respect of claims due or not due, in case
the operation was to reduce their guaranty of reimbursement. Further detailed information can be obtained without
costs at the registered office of the Continuing Company indicated under 1. of the merger plan.
The creditors of the Discontinuing Company are protected by the provisions of the DCA. In an independent expert's
statement dated on 7 November 2008 issued by BDO ScanRevision in accordance with DCA 134c:4, it is stated that the
claims of the creditors in Discontinuing Company are expected to be sufficiently secured after the merger.
When the merger becomes legally effective, the Continuing Company will take over the liabilities of the Discontinuing
Company and be fully liable for the payment of the liabilities.
Implications of the merger for the employees of the Merging Companies
In addition to the members of the Board of Management, the Discontinuing Company does not have any employees
at the time of signing of the merger plan.
The members of the Board of Management will resign their positions at the date on which the merger takes effect.
The rights and liabilities of the Continuing Company arising from contracts of employment or from employment
relationships and existing at the date on which the merger takes effect, will not be affected by the merger.
No employee appointments or other measures affecting the number of employees or employment conditions have
been planned in connection with the merger in of the Continuing Company.
Le conseil d'administration / Bestyrelsen for / The Board of Directors of
the Continuing Company:
Thierry Fleming / Claude Schmitz / Guy Hornick
Le conseil de direction de / Direktionen for / The Management Board of
the Discontinuing Company:
Jørgen Kvist Hansen / Daniel Arthur Reece / Mathieu Vincent Henri-Francois Pouletty
<i>Appendix 1i>
Brindisi S.A.
Société anonyme
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, Bd Prince Henri
Constitution de société du 13 décembre 2006
Numéro 6877
L'an deux mille six, le treize décembre 2006
136479
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Claude SCHMITZ, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, bd de la Foire,
2) Monsieur Thierry FLEMIMG, Expert-Comptable, ici représenté par Monsieur Claude SCHMITZ, prénommé, en
vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 11 décembre 2006, laquelle restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter
les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, siège social, objet, durée
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de "BRINDISI S.A." (la "Société").
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège
sera faite en apportée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux prix pour le faire dans ces
circonstances.
Art. 3. La société est, constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de
prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles la société
détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.
Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier
sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UNE MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté trois cent dix (310)
actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 1.00) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de TRENTE
ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) à DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 2.500.000,-), par la création
et l'émission de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
En conséquence, le conseil d'administration est autorisé à:
- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions
pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;
- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversions dans les limites du
capital autorisé, des obligations convertibles;
En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle
le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.
De plus, le conseil d'administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur
ou autre sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toute autre condition y ayant trait,
Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations des présents statuts.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les
formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette
modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute autre personne qu'il
aura mandatée à ses fins.
136480
Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de sou-
scription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas
d'apport en nature.
La Société pourra, aux tenues et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs, émoluments sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires.
Le poste d'un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par lu loi d'occuper le poste
d'administrateur, ou
Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de
perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.
Art. 7. Le conseil d'administration pourra choisir un président parmi ses membres.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique
ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et
d'entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en personne
de l'administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront rédigées
sous forme de résolutions.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises
lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un docu-
ment unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre fax ou tout autre
moyen de communication.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition conformément à l'objet social de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pus expressément réservés par la loi ou parles présents statuts à rassemblée générale
sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts,
de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure dès contrats d'échanges sur devises: et taux d'intérêt,
étant entendu que ces décisions devront être prises à la majorité par les administrateurs. Le conseil d'administration peut
payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales,
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs,
ou par la signature individuelle du président, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas
de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents
statuts.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs,
qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs
directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires,
qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société,
Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme détendeur, seront traités
au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet
effet
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
136481
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, ou à l'endroit de la commune du siège social spécifié
dans la convocation, le premier jeudi du mois de décembre à 10.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant
Titre VI.- Année sociale, répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale de la société commence le 1
er
octobre et finit le 30 septembre de chaque année.
Art. 15. L'excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais
reprend son cours si, pour une pause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,
la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour touts les points non réglés par les présents statuts, les parties se référent à la loi du 10 août 1915 et à
la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 30 septembre 2007.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:
1. Mr Claude SCHMITZ, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 actions
2. Mr Thierry FLEMING, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 actions
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310 actions
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié
ultérieurement, sont remplies,
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombant à la
société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement a mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-),
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
Monsieur Thierry FLEMING, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié proféssionnelement à
Luxembourg, 5, bd de la Foire.
Monsieur Claude SCHMITZ, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1911, domicilie professionnellement
à Luxembourg, 5, bd de la Foire.
Monsieur Guy HORNICK, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à
Luxembourg, 5, bd de la Foire,
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469.
136482
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires
qui se tiendra en 2012.
5, Le siège social de la société est fixé 11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Cl. Schmitz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2006. Volume 30CS, folio 84, case 12. — Reçu trois cent dix euros (€
310.-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
Gérard LECUIT.
<i>Appendix 2i>
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Banchory Investments ApS
CVR-NR. 29 97 85 22
CVR-NO. 29 97 85 22
Arsrapport 2006/07 / Annual Report 2006/07
1. Regnskabsar / 1st Financial year
Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
The Annual Report has been presented and adopted at the Company's Annual General Meeting
The 11/7/2008.
Signature
<i>Dirigent, Chairman of the meetingi>
<i>Selskabsoplysninger / Company Detailsi>
Selskabet / The Company:
Banchory Investments ApS
Frederiksgade 21,1.
1265 København K
CVR.: 29 97 85 22
Stiftet: 15. oktober 2006
Incorporated: 15 October 2006
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Financial year. 1 January-31 December
Hjemstedskommune: København
Municipality of domicile: Copenhagen
Direktion / Management board:
Mr. Jørgen Kvist Hansen
Mr. Mathieu Vincent Pouletty
Mr. Daniel Arthur Reece
Revisior / Auditor:
BDO ScanRevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
1561 København V
<i>Ledelsespåtegningi>
Direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 15. oktober 2006 - 31. december 2007
for Banchory Investments ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvi-
sende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
136483
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
<i>Statement by Board of Management on the Annual Reporti>
The Management Board has today considered and adopted the Annual Report of Banchory Investments ApS for the
financial year 15 October 2006 - 31 December 2007.
The Annual Report was prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.
We consider the accounting policies applied to be appropriate, and in our opinion, the Annual Report presents fairly,
in all material respects, the assets, liabilities, financial position and results of operations.
We recommend that the annual report be adopted at the Annual General Meeting
København, den 30. maj 2008 / Copenhagen, 30 May 2008.
Direktion / Management board
Mr. Jørgen Kvist Hansen / Mr. Mathieu Vincent Pouletty / Mr. Daniel Arthur Reece
<i>Den uafhængige revisors påtegningi>
Til anpartshaverne i Banchory Investments ApS.
Vi har revideret årsrapporten for Banchory Investments ApS for regnskabsåret 15. oktober 2006 - 31. december 2007,
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
<i>Ledelsens ansvar for årsrapporteni>
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der
er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis
og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
<i>Revisors ansvar og den udførte revisioni>
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlin-
formation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten.
De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i
årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede,
med henblik på at udforme révisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er
rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
<i>Konklusioni>
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 15. oktober 2006 - 31. december 2007
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
<i>Supplerende bemærkningeri>
Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi gøre opmærksom på, at selskabet har tabt mere end 50% af an-
partskapitalen. Vi henviser til ledelsesberetningen vedrørende dette punkt.
<i>Independent Auditor's Reporti>
To the Shareholders of Banchory Investments ApS.
We have audited the Annual Report of Banchory Investments ApS for the financial year 15 October 2006 - 31 De-
cember 2007, which comprises the Statement of the Board of Management on the Annual Report, Management's Review,
accounting policies, the income statement, balance sheet and notes.
The Annual Report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act
<i>The Board of Management's Responsibility for the Annual Reporti>
The Board of Management are responsible for the preparation and fair presentation of this Annual Report in accordance
with the Danish Financial Statements Act. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining Internal
control relevant to the preparation and fair presentation of an Annual Report that is free from material misstatement,
136484
whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates
that are reasonable in the circumstances.
<i>Auditor's Responsibility and Basis of Opinioni>
Our responsibility is to express an opinion on this Annual Report based on our audit. We conducted our audit in
accordance with Danish Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Annual Report is free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Annual
Report. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material
misstatement of the Annual Report, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers
internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the Annual Report in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effec-
tiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Management, as well as evaluating the overall
presentation of the Annual Report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Our audit has not resulted in any qualification.
<i>Opinioni>
In our opinion, the Annual Report gives a true and fair view of the company's financial position at 31 December 2007
and of the results of the company's operations for the financial year 15 October 2006 - 31 December 2007 in accordance
with the Danish Financial Statements Act.
<i>Additional informationi>
The company has lost more than 50% of the share capital. We refer to the management report regarding this issue.
It has not affected our conclusions in any way.
København, den 30. maj 2008 / Copenhagen, 30 May 2008.
BDO ScanRevision
<i>Statsautoriseret revisionsaktieselskab
i>Brian Olsen Halling
<i>Statsautoriseret revisor, State Authorised Public Accountanti>
<i>Ledelsesberetningi>
<i>Hovedaktiviteteri>
Selskabets primære aktivitet er investering i ejendomme, primært men ikke kun i Frankrig.
<i>Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdi>
Årets resultat er som forventet. Selskabet har i 2007 erhvervet en ejendom i Frankrig, som på nuværende tidspunkt
er under renovering. Renoveringsarbejdet forventes afsluttet medio 2008, hvorefter ledelsen forventer at sælge ejen-
dommen. Selskabet har tabt mere en 50% af anpartskapitalen. Ledelsen forventer at fortjenesten fra salget af ejendommen
vil retablere anpartskapitalen i 2008.
<i>Begivenheder efter regnskabsårets afslutningi>
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finan-
sielle situation.
<i>Anvendt regnskabspraksisi>
<i>Regnskabsgrundlagi>
Årsrapporten for Banchory Investments ApS for 2006/07 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabs-
lovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
<i>Generelt om indregning og målingi>
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle
aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskriv-
ninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som bes-
krevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
136485
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente
over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag
af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages neds-
krivning til den lavere genindvindingsværdi
<i>Valutai>
Årsrapporten er aflagt i EUR. Mellemværende i udenlandsk valuta er indregnet til balancedagens valutakurs. Realiserede
såvel som urealiserede kursreguleringer indgår i resultatopgørelsen.
<i>Resultatopgørelseni>
<i>Andre eksterne omkostningeri>
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
<i>Finansielle posteri>
Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede
og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af
finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
<i>Skat af årets resultati>
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del,
der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på
egenkapitalen.
<i>Balanceni>
<i>Materielle anlægsaktiveri>
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Der er ikke beregnet afskrivninger i 2007, idet ejendommen er under renovering.
Aktiver med en kostpris på under EUR 1556, pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffel-
sesåret
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgø-
relsen under afskrivninger.
<i>Skyldig skat og udskudt skati>
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi,
hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende,
når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.
<i>Finansielle gældsforpligtelseri>
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte låneomkostnin-
ger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi
ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resul-
tatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
<i>Omregning af fremmed valutai>
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem trans-
aktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner
anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
136486
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes
til balancedagens valutakurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgø-
relsen under finansielle indtægter og omkostninger.
<i>Management Reviewi>
<i>Principal activitiesi>
The principal activity of the company is investing in real estate particularly but not exclusively in France.
<i>Development in the activities and financial affairsi>
The result for the year is as expected. The company has in 2007 acquired a property in France, which is currently
being renovated. The renovation work should be finalised mid 2008 after which the management expects to sell the
property. The company has lost more than 50% of the share capital. The management is expecting that the gain from the
sale of the property, will restore the share capital in 2008.
<i>Events after the financial year-endi>
No events have occurred after the end of the financial year that may have a material impact on the company's financial
position.
<i>Accounting Policiesi>
<i>Basis of accountingi>
The Annual Report of Banchory Investments ApS for 2006/07 has been prepared according to the provisions of the
Danish Financial Statements Act for companies in reporting class B.
<i>Basis of opinioni>
In the income statement, all income is recognised as it is earned, including value adjustments of financial assets and
liabilities. Similarly, all costs are recognised as they accrue, including depreciation, amortisation and write-down.
Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits attributable to the asset
will flow to the company and the value of the asset can be measured reliably.
Assets and liabilities are initially measured at cost. Subsequently, assets and liabilities are measured as described for
each item below.
Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that there will be an outflow of future economic
benefits from the company and the value of the liability can be measured reliably.
Certain financial assets and liabilities are measured at amortised cost, which involves the recognition of a constant
effective yield to maturity. Amortised cost is calculated as original cost less repayments, and with the addition/deduction
of the accumulated amortisation of the difference between cost and the nominal amount payable upon maturity.
Recognition and measurement take into account all circumstances, including anticipated risks and losses, arising before
the preparation of the annual report, which confirm or invalidate circumstances existing at the balance sheet date.
The booked value on the intangible fixed assets and the tangible assets is yearly reviewed to determine if there is any
indication for impairment besides the normal depreciation. In cases where there is a lower value an impairment charge
will booked to reconcile to the recoverable amount.
<i>Currencyi>
The annual account has been prepared in EUR. Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated
at the exchange rate of the balance sheet date. Both realised and unrealised currency gains and fosses are entered in the
income statement.
<i>Income statementi>
<i>Other external expensesi>
Other external expenses comprise of costs related to distribution, sales, advertising, administration, rent, loss on
debtors, leasing related to operations, etc.
<i>Financial itemsi>
Financial income and expenses and similar items are recognised in the income statement with the amounts relating to
the financial year. The financial items comprise interest income and expenses, financial expenses in connection with finance
leases, realised and unrealised exchange rate adjustments as well as non-deductible charges and allowances under the tax
on account scheme.
<i>Tax for the yeari>
The tax for the year consists of the current tax and the deferred tax for the year. The tax in the profit/loss calculation
is recognised in the income statement, whereas the tax directly relating to equity entries is taken directly to equity.
136487
<i>Balance sheeti>
<i>Tangible assetsi>
Tangible assets are measured at cost price less accumulated depreciation.
No depreciation is provided on land.
No depreciation is provided on the real estate in 2007, due to renovation work.
Assets with a cost price below EUR 1556, are entered directly in the income statement at the time of purchase.
Gains or losses by sale of tangible assets are measured as the difference between the sales price deducted with the
cost of sales and the booked value at the time of sale. Gains or losses are entered in the income statement under
depreciation.
<i>Tax payable and deferred taxi>
Current tax liabilities and tax receivables are recognised in the balance sheet as calculated tax of taxable income for
the financial year, adjusted for the tax paid in previous years and tax paid on account.
Deferred tax is measured on all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their
carrying amounts in the financial statements.
Deferred tax assets, including the tax value of tax loss carry-forwards, are measured at the value at which the asset is
expected to be realised, either by elimination against tax on future earnings or by setoff against deferred tax liabilities
within the same legal tax entity and jurisdiction.
Deferred tax is measured on the basis of the tax rules and tax rates effective by the balance sheet date when the
deferred tax is expected to crystallise as current tax. The applicable tax rate in the current year is 25%.
<i>Financial debti>
Financial liabilities are recognised at the time of the proceeds received net of transaction expenses incurred. In sub-
sequent periods, the financial liabilities are measured at amortised cost equal to the capitalised value using the effective
interest method, so that the difference between the proceeds and the nominal value is recognised in the income statement
over the loan period.
Other liabilities are measured at amortised cost, which usually corresponds to the nominal value.
<i>Translation policiesi>
Transactions in foreign exchange are translated at the transaction date rates. Exchange rate adjustments arising bet-
ween the transaction date rates and the rates at the date of payment are recognised under Financial income and expenses
in the income statement. When exchange rate transactions are considered as hedging of future cash flows, the adjustments
are recognised directly in equity.
Receivables, payables and other monetary items in foreign exchange not settled at the balance sheet date are translated
at the exchange rates at the balance sheet date. Differences between the exchange rates at the balance sheet date and
the transaction date rates are recognised under financial income and expenses in the income statement.
RESULTATOPGØRELSE FOR 15. OKTOBER 2006 - 31. DECEMBER 2007 / INCOME STATEMENT FOR 15 OCTOBER
2006 - 31 DECEMBER 2007
Note 2006/07
EUR
Andre eksterne omkostninger / Other external expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 -20.710
Driftsresultat / Loss from Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-20.710
Finansielle indtægter / Financial income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
Finansielle omkostninger / Financial expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 -69.520
Arets resultat for skat / Loss for the year before taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-90.227
Skat af årets resultat / Tax on profit for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
0
ARETS RESULTAT / LOSS FOR THE YEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-90.227
Resultat overfort til næste år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-90.227
I alt / Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -90.227
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007 / BALANCE AS AT 31 DECEMBER 2007
<i>AKTIVER / ASSETSi>
Note 2006/07
EUR
Grunde og bygninger / Land and buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 1.715.360
Materielle anlægsaktiver i alt / Tangible fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.715.360
Likvide beholdninger / Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.394
Omsætningsaktiver i alt / Total current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.394
AKTIVER I ALT / TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.721.754
136488
<i>PASSIVER / EQUITY AND LIABILITIESi>
Note 2006/07
EUR
Anpartskapital / Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
17.000
Overfort resultat / Retained earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
-90.227
Egenkapital i alt / Total equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-73.227
Gæld til tilknyttede virksomheder / Liabilities to group companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 138.781
Gæld til tredje part / Debt to third party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 1.595.537
Langfristede gældsforpligtelser i alt / Total long-term liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.734.318
Gæld til tredje part / Debt to third party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.181
Leverandører af varer og tjenesteydelser / Trade payables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.340
Selskabsskat / Corporation tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
0
Anden gæld / Other debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.142
Kortfristet gæld i alt / Total current liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.663
PASSIVER I ALT / TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.721.754
Ejerforhold / Ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser / Mortgages and securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Eventualforpligtelser / Contingent liabillities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NOTER TIL ARSRAPPORTEN / NOTES TO THE ANNUAL REPORT
2006/07
EUR
1 Ledelsesvederlag / Management remuneration
Direktionen har ikke modtaget vederlag og der var ingen ansatte i regnskabsåret / The management did
not receive any remuneration and there were no employees
2 Finansielle indtægter / Financial income
Renter, bank / Interest, bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3 Finansielle omkostninger / Financial expenses
Renter, tilknyttede virksomheder / Interest, group companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.481
Renter, Tredje part Interest / Interest, Third party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.038
Realiserede valutakurstab / Realised loss on currency transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
69.520
4 Grunde og bygninger / Land and buildings
Saldo pr. 15. oktober 2006 / Balance as at 15 October 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Arets anskaffelser til kontantværdi / Acquisitions during the year at cash value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.715.360
Saldo pr. 31. december 2007 / Balance as at 31 December 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.715.360
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2007 / Book value at 31 December 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.715.360
5 Anpartskapital / Share capital
Saldo pr. 15. oktober 2006 / Balance as at 15 October 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.000
Saldo pr. 31. december 2007 / Balance as at 31 December 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.000
Anpartskapitalen er registreret med EUR 17000 / The registered share capital is EUR 17000
6 Overført resultat / Retained earnings
Saldo pr. 15. oktober 2006 / Balance as at 15 October 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Overført jf. resultatanvendelsen / Carried forward per allocation of profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-90.227
Saldo pr. 31. december 2007 / Balance as at 31 December 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-90.227
7 Skat / Tax
Aktuel skat / Current tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
8 Langfristede gældsforpligtelser / Long-term liabilities
Gæld pr. 15. oktober 2006 / Liabilities as per 15 October 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Gæld pr. 31. december 2007 / Liabilities as per 31 December 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.734.317
Afdrag næste år / Repayment next year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Restgæld efter 5 år / Debt outstanding after 5 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138.781
9 Ejerforhold / Ownership
136489
Følgende anpartshavere er noteret i Banchory Investments ApS' anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af
stemmerne eller anpartskapitalen:
The following shareholders are recorded in Banchory Investments ApS' register of shareholders as owning more than
5% of the votes or the share capital:
Brindisi SA
11A, boulevard Prince-Henri L-1724 Luxembourg, Luxembourg
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser / Mortgages and securities
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut, har selskabet tinglyst et pantebrev på EUR 1.600.000
The company has granted a mortgage deed for a total value of EUR 1.600.000
11 Eventualforpligtelser / Contingent liabillities
Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser, udover hvad der følger af den ordinære drift.
The Company has not undertaken liabilities outside of the ordinary course of its business.
<i>Appendix 3i>
Banchory Investments Aps
CVR-NR. / CVR NO. 29 97 58 22
<i>Perioderegnskab / Interim Accountsi>
1. januar 2008 - 31. oktober 2008 / 1 January 2008 - 31 October 2008
Perioderegnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
The Interim Accounts has been presented and adopted at the Company's Annual General Meeting
14/11/2008
Signature
<i>Dirigent / Chairman of the meetingi>
Selskabsoplysninger / Company Details:
Selskabet / The Company:
Banchory Investments ApS
Frederiksgade 21,1.
1265 København K
CVR.: 29 97 85 22
Stiftet: 15. oktober 2006
Incorporated: 15 October 2006
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Financial year: 1 January - 31 December
Hjemstedskommune: København
Municipality of domicile: Copenhagen
Direktion / Management board
Mr. Jørgen Kvist Hansen
Mr. Mathieu Vincent Pouletty
Mr. Daniel Arthur Reece
Revisior / Auditor
BDO ScanRevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
1561 København V
<i>Ledelsespåtegningi>
Direktionen har dags dato aflagt og godkendt perioderegnskabet for 1. januar - 31. oktober 2008 for Banchory In-
vestments ApS.
Perioderegnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at perioderegnskabet efter vor opfattelse, giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Perioderegnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
136490
<i>Statement by Board of Management on the Annual Reporti>
The Management Board has today considered and adopted the Interim Accounts of Banchory Investments ApS for 1
January - 31 October 2008.
The Interim Accounts was prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.
We consider the accounting policies applied to be appropriate, and in our opinion, the Interim Accounts presents
fairly, in all material respects, the assets, liabilities, financial position and results of operations.
We recommend that the interim accounts be adopted at the Annual General Meeting
København, den 7. november 2008 / Copenhagen, 7 November 2008.
Direktion / Management board
Mr. Jørgen Kvist Hansen / Mr. Mathieu Vincent Pouletty / Mr. Daniel Arthur Reece
<i>Den uafhængige revisors påtegningi>
Til anpartshaverne i Banchory Investments ApS.
Vi har revideret perioderegnskabet for Banchory Investments ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. oktober 2008,
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Perioderegnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.
<i>Ledelsens ansvar for perioderegnskabeti>
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et perioderegnskab der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der
er relevante for at udarbejde og aflægge et perioderegnskab der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis
og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
<i>Revisors ansvar og den udførte revisioni>
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om perioderegnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision
i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt plan-
lægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at perioderegnskabet ikke indeholder
væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i perioderegns-
kabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation
i perioderegnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et perioderegnskab, der giver et
retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regns-
kabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af perioderegnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
<i>Konklusioni>
Det er vor opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. oktober 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. oktober 2008 i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven.
<i>Independent Auditor's Reporti>
To the Shareholders of Banchory Investments ApS.
We have audited the Interim accounts of Banchory Investments ApS for the financial year 1 January - 31 October
2008, which comprises the Statement of the Board of Management on the Annual Report, Management's Review, ac-
counting policies, the income statement, balance sheet and notes.
The Interim Accounts has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.
<i>The Board of Management's Responsibility for the Interim Accountsi>
The Board of Management are responsible for the preparation and fair presentation of this Interim Accounts in ac-
cordance with the Danish Financial Statements Act, This responsibility includes: designing, implementing and maintaining
internal control relevant to the preparation and fair presentation of an Interim Accounts that is free from material
misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accoun-
ting estimates that are reasonable in the circumstances,
<i>Auditor's Responsibility and Basis of Opinioni>
Our responsibility is to express an opinion on this Interim Accounts based on our audit. We conducted our audit in
accordance with Danish Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and
136491
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Interim Accounts is free from material misstate-
ment.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures In the Interim
Accounts. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material
misstatement of the Interim Accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the Interim Accounts in order to
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Management, as well as evaluating
the overall presentation of the Interim Accounts.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Our audit has not resulted in any qualification.
<i>Opinioni>
In our opinion, the Interim Accounts gives a true and fair view of the company's financial position at 31 October 2008
and of the results of the company's operations for the period 1 January - 31 October 2008 in accordance with the Danish
Financial Statements Act.
København, den 7. november 2008 / Copenhagen, 7 November 2008.
BDO ScanRevision
<i>Statsautoriseret revisionsaktieselskab
i>Ole Christian Nielsen
<i>Statsautoriseret revisor, State Authorised Public Accountanti>
<i>Ledelsesberetningi>
<i>Hovedaktiviteteri>
Selskabets aktivitet består i at eje og administrere udlejningsejendom i Frankrig.
<i>Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdi>
Selskabet indgår i fusion 31. oktober 2008.
<i>Begivenheder efter regnskabsårets afslutningi>
Selskabet har indgået aftale om grænseoverskridende fusion pr. 31. oktober 2008.
Herudover er der ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning som kunne påvirke selskabets finansielle
situation.
<i>Anvendt regnskabspraksisi>
<i>Regnskabsgrundlagi>
Perioderegnskabet for Banchory Investments ApS for 2008 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregns-
kabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
<i>Generelt om indregning og målingi>
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle
aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskriv-
ninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som bes-
krevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente
over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag
af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden perioderegnskabet aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages neds-
krivning til den lavere genindvindingsværdi.
136492
<i>Valutai>
Perioderegnskabet er aflagt i EUR. Mellemværende i udenlandsk valuta er indregnet til balancedagens valutakurs. Re-
aliserede såvel som urealiserede kursreguleringer indgår i resultatopgørelsen.
<i>Resultatopgørelseni>
<i>Andre eksterne omkostningeri>
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, saig, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
<i>Finansielle posteri>
Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede
og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af
finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
<i>Skat af årets resultati>
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del,
der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på
egenkapitalen.
<i>Balanceni>
<i>Materielle anlægsaktiveri>
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Der er ikke beregnet afskrivninger i hverken 2007 eller 2008, idet ejendommen er under renovering.
Aktiver med en kostpris på under EUR 1595, pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffel-
sesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgø-
relsen under afskrivninger.
<i>Skyldig skat og udskudt skati>
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi,
hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens. lovgivning vil være gældende,
når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.
<i>Finansielle gældsforpligtelseri>
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte låneomkostnin-
ger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi
ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resul-
tatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
<i>Omregning af fremmed valutai>
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem trans-
aktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner
anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes
til balancedagens valutakurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgø-
relsen under finansielle indtægter og omkostninger.
<i>Management Reviewi>
<i>Principal activitiesi>
The Company operates in the area of owning and administate a rental property in France.
<i>Development in the activities and financial affairsi>
The company will be merged as per 31 October 2008.
136493
<i>Events after the financial year-endi>
The company has entered into an agreement of a cross-border merger as per 31 October 2008.
Beside that no events have occurred after the end of the financial year that could have a material impact on the
company's financial position.
<i>Accounting Policiesi>
<i>Basis of accountingi>
The Interim Accounts of Banchory Investments ApS for 2008 has been prepared according to the provisions of the
Danish Financial Statements Act for companies in reporting class B.
The accounting policies applied are the same as in the previous year.
<i>Basis of opinioni>
In the income statement, all income is recognised as it is earned, including value adjustments of financial assets and
liabilities. Similarly, all costs are recognised as they accrue, including depreciation, amortisation and write-down.
Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits attributable to the asset
will flow to the company and the value of the asset can be measured reliably.
Assets and liabilities are initially measured at cost. Subsequently, assets and liabilities are measured as described for
each item below.
Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that there will be an outflow of future economic
benefits from the company and the value of the liability can be measured reliably.
Certain financial assets and liabilities are measured at amortised cost, which involves the recognition of a constant
effective yield to maturity. Amortised cost is calculated as original cost less repayments, and with the addition/deduction
of the accumulated amortisation of the difference between cost and the nominal amount payable upon maturity.
Recognition and measurement take into account all circumstances, including anticipated risks and losses, arising before
the preparation of the interim accounts, which confirm or invalidate circumstances existing at the balance sheet date.
The booked value on the intangible fixed assets and the tangible assets is yearly reviewed to determine if there is any
indication for impairment besides the normal depreciation. In cases where there is a lower value an impairment charge
will booked to reconcile to the recoverable amount.
<i>Currencyi>
The Interim Accounts has been prepared in EUR. Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated
at the exchange rate of the balance sheet date. Both realised and unrealised currency gains and losses are entered in the
income statement.
<i>Income statementi>
<i>Other external expensesi>
Other external expenses comprise of costs related to distribution, sales, advertising, administration, rent, loss on
debtors, leasing related to operations, etc.
<i>Financial itemsi>
Financial income and expenses and similar items are recognised in the income statement with the amounts relating to
the financial year. The financial items comprise interest income and expenses, financial expenses in connection with finance
leases, realised and unrealised exchange rate adjustments as well as non-deductible charges and allowances under the tax
on account scheme.
<i>Tax for the yeari>
The tax for the year consists of the current tax and the deferred tax for the year. The tax in the profit/loss calculation
is recognised in the income statement, whereas the tax directly relating to equity entries is taken directly to equity.
<i>Balance sheeti>
<i>Tangible assetsi>
Tangible assets are measured at cost price less accumulated depreciation.
No depreciation is provided on land.
No depreciation is provided on the real estate in either 2007 or 2008, due to renovation work.
Assets with a cost price below EUR 1,595, are entered directly in the income statement at the time of purchase.
Gains or losses by sale of tangible assets are measured as the difference between the sales price deducted with the
cost of sales and the booked value at the time of sale. Gains or losses are entered In the income statement under
depreciation.
136494
<i>Tax payable and deferred taxi>
Current tax liabilities and tax receivables are recognised in the balance sheet as calculated tax of taxable income for
the financial year, adjusted for the tax paid in previous years and tax paid on account.
Deferred tax is measured on all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their
carrying amounts in the financial statements.
Deferred tax assets, including the tax value of tax loss carry-forwards, are measured at the value at which the asset is
expected to be realised, either by elimination against tax on future earnings or by setoff against deferred tax liabilities
within the same legal tax entity and jurisdiction.
Deferred tax is measured on the basis of the tax rules and tax rates effective by the balance sheet date when the
deferred tax is expected to crystallise as current tax. The applicable tax rate in the current year is 25%.
<i>Financial debti>
Financial liabilities are recognised at the time of the proceeds received net of transaction expenses incurred. In sub-
sequent periods, the financial liabilities are measured at amortised cost equal to the capitalised value using the effective
interest method, so that the difference between the proceeds and the nominal value is recognised in the income statement
over the loan period.
Other liabilities are measured at amortised cost, which usually corresponds to the nominal value.
<i>Translation policiesi>
Transactions in foreign exchange are translated at the transaction date rates. Exchange rate adjustments arising bet-
ween the transaction date rates and the rates at the date of payment are recognised under financial income and expenses
in the income statement. When exchange rate transactions are considered as hedging of future cash flows, the adjustments
are recognised directly in equity.
Receivables, payables and other monetary items in foreign exchange not settled at the balance sheet date are translated
at the exchange rates at the balance sheet date. Differences between the exchange rates at the balance sheet date and
the transaction date rates are recognised under financial income and expenses in the income statement.
RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. OKTOBER 2008 / INCOME STATEMENT FOR 1 JANUARY - 31 OC-
TOBER 2008
Note
2008 2006/07
EUR
EUR
Andre eksterne omkostninger / Other external expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 -26.925 -20.710
Driftsresultat / Loss from Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-26.925 -20.710
Finansielle indtægter / Financial income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
3
Finansielle omkostninger / Financial expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 -90.433 -69.520
Årets resultat før skat / Loss for the year before taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-117.358 -90.227
Skat af årets resultat / Tax on profit for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
0
0
ÅRETS RESULTAT / LOSS FOR THE YEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-117.358 -90.227
Resultat overført til næste år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-117.358 -90.227
I alt / Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -117.358 -90.227
BALANCE PR. 31. OKTOBER 2007 / BALANCE AS AT 31 OCTOBER 2007
<i>AKTIVER / ASSETSi>
Note
2008 2006/07
EUR
EUR
Grunde og bygninger / Land and buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3.100.000 1.715.360
Materielle anlægsaktiver i alt / Tangible fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100.000 1.715.360
Likvide beholdninger / Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.049
6.394
Omsætningsaktiver i alt / Total current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.049
6.394
AKTIVER I ALT / TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.101.049 1.721.754
<i>PASSIVER / EQUITY AND LIABILITIESi>
Note
2008 2006/07
EUR
EUR
Anpartskapital / Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
17.000
17.000
Reserve for opskrivning af grunde og bygninger / Reserve for revaluation of land and buil-
dings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 1.215.190
0
Overført resultat / Retained earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 -207.585
-90.227
Egenkapital i alt / Total equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.024.605
-73.227
Gæld til tilknyttede virksomheder / Liabilities to group companies . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 445.117 138.781
Gæld til tredje part / Debt to third party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 1.600.000 1.595.537
136495
Langfristede gældsforpligtelser i alt / Total long-term liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.045.117 1.734.318
Gæld til tredje part / Debt to third party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.708
12.181
Leverandører af varer og tjenesteydelser / Trade payables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.619
1.340
Selskabsskat / Corporation tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
0
0
Anden gæld / Other debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
47.142
Kortfristet gæld i alt / Total current liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.327
60.663
PASSIVER I ALT / TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.101.049 1.721.754
Ejerforhold / Ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Eventualforpligtelser / Contingent liabillities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NOTER TIL PERIODEREGNSKABET / NOTES TO THE INTERIM ACCOUNTS
2008
EUR
1 Ledelsesvederlag / Management remuneration
Direktionen har ikke modtaget vederlag og der var ingen ansatte i regnskabsåret / The management did
not receive any remuneration and there were no employees
2 Finansielle omkostninger / Financial expenses
Renter, bank / Interest, bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657
Renter, tilknyttede virksomheder / Interest, group companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.536
Renter, Tredje part / Interest, Third party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.224
Realiserede valutakurstab / Realised loss on currency transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
90.433
3 Grunde og bygninger / Land and buildings
Saldo pr. 1. januar 2008 / Balance as at 1 january 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.719.823
Årets anskaffelser til kontantværdi / Acquisitions during the year at cash value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164.987
Saldo pr. 31. oktober 2008 / Balance as at 31 October 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.884.810
Årets opskrivning / Revaluation of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.215.190
Opskrivninger pr. 31. oktober 2008 / Revaluation as at 31 October 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.215.190
Regnskabsmæssigværdi pr. 31. oktober 2008 / Book value at 31 October 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100.000
4 Anpartskapital / Share capital
Saldo pr. 1. januar 2008 / Balance as at 1 January 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.000
Saldo pr. 31. oktober 2008 / Balance as at 31 October 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.000
Anpartskapitalen er registreret med EUR 17000 / The registered share capital is EUR 17000
5 Reserve for dagsværdi af investeringsaktiver / Reserves for fair value of Investments assets
Saldo pr. 1. januar 2008 / Balance as at 1 January 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Opskrivning i årets løb / Revaluations during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.215.190
Saldo pr. 31. oktober 2008 / Balance as at 31 October 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.215.190
6 Overført resultat / Retained earnings
Saldo pr. 1. januar 2008 / Balance as at 1 January 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-90.227
Overført jf. resultatanvendelsen / Carried forward per allocation of profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -117.358
Saldo pr. 31. oktober 2008 / Balance as at 31 October 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -207.585
7 Skat / Tax
Aktuel skat / Current tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
8 Langfristede gældsforpligtelser / Long-term liabilities
Gæld pr. 1. januar 2008 / Liabilities as per 1 January 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.734.317
Gæld pr. 31. oktober 2008 / Liabilities as per 31 October 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.045.116
Afdrag næste år / Repayment next year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Restgæld efter 5 år / Debt outstanding after 5 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.045.116
9 Ejerforhold / Ownership
Følgende anpartshavere er noteret i Banchory Investments ApS' anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af
stemmerne eller anpartskapitalen:
The following shareholders are recorded in Banchory Investments ApS' register of shareholders as owning more than
5% of the votes or the share capital:
Brindisi SA
136496
11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg
10 Pantsætning og sikkerhedsstillelser / Mortgages and securities
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut, har selskabet tinglyst et pantebrev på EUR 1.600.000
The company has granted a mortgage deed for a total value of EUR 1,600,000
11 Eventualforpligtelser / Contingent liabillities
Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser, udover hvad der følger af den ordinære drift.
The Company has not undertaken liabilities outside of the ordinary course of its business.
<i>Appendix 4i>
Brindisi S.A.
Société Anonyme
11A, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
RCS LUXEMBOURG B-122.893
COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (EXPRIMÉ EN EUR)
30 SEPTEMBRE 2008
<i>ACTIFi>
2008
2007
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations financières (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
63 300.00
Total Actif Immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
63 300.00
ACTIF CIRCULANT
Créances (note 4) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . .
14 764.11
558.38
Valeurs Mobilières (note 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 477 694.60
0.00
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèque postaux, chèques et encaisse . . . . . . .
1 160.04
5 804.86
Total Actif Circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 493 618.75
6 363.24
COMPTE DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 499.96
2 553.57
TOTAL DE L'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 496 120.71
72 216.81
<i>PASSIFi>
2008
2007
CAPITAUX PROPRES (note 6)
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 000.00
31 000.00
Résultats reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(9 966.44)
0.00
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (515 485.52)
(9 966.44)
Total Capitaux Propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (494 451.96)
21 033.56
DETTES (note7)
Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 572.67
51 183.25
Dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000.00
0.00
Total Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 990 572.67
51 183.25
TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 496 120.71
72 216.81
CHARGES
2008
2007
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 940.97 10 308.82
Corrections de valeur sur immobilisations financières (note 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 098.00
0.00
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 681.60
154.00
Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.00
62.00
TOTAL DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 782.57 10 524.82
PRODUITS
2008
2007
Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . .
717.57
0.00
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 205.73
558.38
Produits exceptionnels (note 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373.75
0.00
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 485.52
9 966.44
TOTAL DES PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 782.57 10 524.82
<i>Note 1 - Généralitési>
BRINDISI S.A. a été constituée le 13 décembre 2006 pour une durée illimitée sous forme de société anonyme. Son
siège social est établi à Luxembourg.
136497
L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxembourgeoises
ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme
ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur
mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.
Enfin, la société pourra, pour son propre compte, acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement cons-
truire tout bien immobilier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
L'exercice social commence le 1
er
octobre pour se terminer le 30 septembre.
En vertu de l'article n° 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la société est exemptée
de l'obligation d'établir des comptes consolidés.
<i>Note 2 - Principes, règles et méthodes comptablesi>
2.1. Principes généraux
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux
pratiques comptables généralement admises.
2.2. Principales règles d'évaluation
<i>Conversion des devisesi>
La société tient sa comptabilité en euros (EUR), le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette
devise.
<i>Titres de participationsi>
Les parts dans les entreprises liées, les participations et les titres ayant le caractère d'immobilisation financières sont
valorisés individuellement au plus bas de leur prix d'acquisition ou de leur valeur estimée par le Conseil d'Administration,
sans compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles.
Pour déterminer la valeur estimée, le Conseil d'Administration se base sur les états financiers des sociétés à évaluer
et/ou sur d'autres informations et documents disponibles.
<i>Créancesi>
Les créances de l'actif immobilisé et de l'actif circulant sont évaluées à leur valeur nominale. Une correction de valeur
est pratiquée lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale.
<i>Valeurs mobilièresi>
Les valeurs mobilières sont évaluées au plus bas de leur coût d'acquisition ou de leur valeur de marché à la date de
clôture. L'évaluation est faite individuellement et sans compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles.
Le prix d'acquisition des valeurs mobilières cédées est calculé sur base de la méthode du prix moyen pondéré.
<i>Note 3 - Immobilisations financièresi>
2008
2007
Prix d'acquisition, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 300.00
0.00
Mouvements de l'exercice
Augmentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 800.00 63 300.00
Cessions et remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
0.00
Prix d'acquisition, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 100.00 63 300.00
Corrections de valeur, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
0.00
Mouvements de l'exercice
Dotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 098.00
0.00
Reprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
0.00
Corrections de valeur, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 098.00
0.00
Valeur comptable nette, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00 63 300.00
<i>Note 4 - Créancesi>
Créances à moins d'un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 764.11
558.38
Corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
0.00
14 764.11
558.38
136498
<i>Note 5 - Valeurs mobilièresi>
2008
2007
Prix d'acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 477 694.60
0.00
Corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
0.00
Valeur nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 477 694.60
0.00
La valeur du marché des actions s'élève à EUR 1 526 679.04.
<i>Note 6 - Capitaux propresi>
<i>Capital souscriti>
Au 30 septembre 2008, le capital souscrit et entièrement libéré de EUR 31 000.00 est représenté par 310 actions
d'une valeur nominale de EUR 100.00 chacune.
Capital
Résultats Résultats de
souscrit
reportés
l'exercice
Situation au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 000.00
0.00
(9 966.44)
Affectation de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00 (9 966.44)
9 966.44
Bénéfice de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
0.00 (515 485.52)
Situation à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 000.00 (9 966.44) (515 485.52)
<i>Note 7 - Dettesi>
2008
Moins d'un an de 1 à 5 ans
à plus de 5 ans
TOTAL
Dettes envers des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . .
0.00 1 500 000.00
0.00 1 500 000.00
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490 572.67
0.00
0.00
490 572.67
490 572.67 1 500 000.00
0.00 1 990 572.67
2007
Dettes envers des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . .
0.00
0.00
0.00
0.00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 183.25
0.00
0.00
51 183.25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 183.25
0.00
0.00
51 183.25
<i>Note 8 - Résultats exceptionnelsi>
2008 2007
Produits exceptionnels
Produits imputables à des exercices antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.75 0.00
<i>Note 9 - Corrections de valeuri>
2008 2007
sur immobilisations financières (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 098.00 0.00
449 098.00 0.00
BILAN DETAILLE - AU 30/09/2008
(Devise du capital: EUR)
ACTIF
30/09/2008
30/09/2007
C. / III. ACTIF IMMOBILISE / IMMOBILISATIONS FI-
NANCIERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
63 300.00
2410-001, Participation Banchory Investments -100%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Dev. cap. EUR->
21 000.00
21 000.00
EUR 21 000.00
21 000.00 21 000.00
21 000.00
2410-999, Provision moins-value sur participation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Dev. cap.EUR->
-20 999.00
0.00
EUR -20 999.00
-20 999.00
0.00
0.00
2440-001, Prêt à Banchory Investments (Euribor 12
mois + 1%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
428 100.00
42 300,00
EUR 428 100.00
428 100.00 42 300,00
42 300,00
2440-999, Correction de valeur sur prêt à participa-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
-428 099.00
0.00
EUR -428 099.00
-428 099.00
0.00
0.00
D./ III. ACTIF CIRCULANT / INTERETS A RECEVOIR SUR PRETS . . . .
14 764.11
558.38
4712, Intérêts à recevoir sur prêts . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
14 764.11
558.38
136499
EUR 14 764.11
14 764.11
558.38
558.38
D. / VII. ACTIF CIRCULANT / VALEURS MOBILIERES . . . . . . . . . . . . . . 1 477 694.60
0.00
5031, Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR-> 1 477 694.60
0.00
EUR 1 477 694.60 1 477 694.60
0.00
0.00
D. / VIII. ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES, AVOIRS EN
COMPTE CHEQUES POSTAUX, CHEQUES ET ENCAISSE . . . . . . . . . . . .
1 160,04
5 804.86
5100-996, Banque, c/c en EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
1 160,04
5 804.86
EUR 1 160.04
1 160,04
5 804.86
5 804.86
E. COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 499.96
2 553.57
4791, Commissions payées d'avance . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
2 000.00
2 053.61
EUR 2 000.00
2 000.00
2 053.61
2 053.61
4795, Commission domiciliation payée d'avance . . . . En Dev. cap. EUR->
499,96
499,96
EUR 499,96
499,96
499,96
499,96
TOTAL DE L'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 496 120.71
72 216.81
<i>PASSIFi>
30/09/2008
30/09/2007
A./ I. CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 000.00
31 000.00
1013, Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
31 000.00
31 000.00
EUR 31 000.00
31 000.00 31 000.00
31 000.00
A. / V CAPITAUX PROPRES / RESULTATS REPORTES . . . . . . . . . . . . .
-9 966.44
0.00
1150, Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
-9 966.44
0.00
EUR -9 966.44
-9 966.44
0.00
0.00
A. / VI. CAPITAUX PROPRES / RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . .
-515 485.52
-9 966.44
1250, Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
-515 485.52
-9 966.44
EUR -515 485.52
-515 485.52 -9 966.44
-9 966.44
D./ I. DETTES / C/C ACTIONNAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
486 900.00
50 000.00
4512, Compte courant des actionnaires . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
486 900.00
50 000.00
EUR 486 900.00
486 900.00 50 000.00
50 000.00
D./ II. DETTES / DETTES BANCAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000.00
0.00
5240-996, Avances à terme en EUR . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR-> 1 500 000.00
0.00
EUR 1 500 000.00 1 500 000.00
0.00
0.00
D./ III. DETTES / INTERETS A PAYER SUR BANQUES . . . . . . . . . . . . . .
1 913.67
0.00
4761, Intérêts à payer sur avances . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
1 913.67
0.00
EUR 1 913.67
1 913.67
0.00
0.00
D. / IV. DETTES / CHARGES A PAYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 635.00
1 121.25
4678, Frais d'établissement de la décla fiscale à payer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Dev. cap. EUR->
1 495.00
747.50
EUR 1 495.00
1 495.00
747.50
747.50
4680, Frais de publication à payer . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
0.00
373.75
EUR 0.00
0.00
373.75
373.75
4682, Cotisation chambre de comm. à payer . . . . . . En Dev. cap. EUR->
140.00
0.00
EUR 140.00
140.00
0.00
0.00
D. / V. DETTES / IMPOTS ET TAXES A PAYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124.00
62.00
4424-2007, Impôt sur la fortune 2007 à payer . . . . . En Dev. cap. EUR->
62.00
62.00
EUR 62.00
62.00
62.00
62.00
4424-2008, Impôt sur la fortune 2008 à payer . . . . . En Dev. cap. EUR->
62.00
0.00
EUR 62.00
62.00
0.00
0.00
TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 496 120.71
72 216.81
PERTES ET PROFITS DETAILLE - POUR LA PERIODE DU 01/10/2007 AU 30/09/2008
(Devise du capital: EUR)
CHARGES
30/09/2008
30/09/2007
I. CHARGES FINANCIERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 681.60
154.00
6111, Intérêts sur banques à vue . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
683.68
0.00
136500
EUR 683.68
683.68
0.00
0.00
6121, Intérêts sur avances reçues . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
66 332.92
0.00
EUR 66 332.92
66 332.92
0.00
0.00
6140, Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
3 665.00
154.00
EUR 3 665.00
3 665.00
154.00
154.00
II. CHARGES D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 940.97
10 308.82
6211, Frais de constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
0.00
1 386.84
EUR 0.00
0.00
1 386.84
1 386.84
6243, Frais de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
0.00
373.75
EUR 0.00
0.00
373.75
373.75
6249, Frais de domiciliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
1 999.85
1 499.89
EUR 1 999.85
1 999.85
1 499.89
1 499.89
6250, Commission de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
8 053.62
6 160,84
EUR 8 053.62
8 053.62
6 160,84
6 160,84
6262, Frais d'audits et fiscaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
747.50
747.50
EUR 747.50
747.50
747.50
747.50
6290, Cotisation Chambre de Commerce . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
140.00
140.00
EUR 140.00
140.00
140.00
140.00
V. IMPOTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.00
62.00
6346, Impôts s/ la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
62.00
62.00
EUR 62.00
62.00
62.00
62.00
VII. CORRECTIONS DE VALEURS SUR ELEMENT D'ACTIF . . . . . . . . .
449 098.00
0.00
6611, Correct. de valeur s/ participation . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
20 999.00
0.00
EUR 20 999.00
20 999.00
0.00
0.00
6612, Correct. de valeur s/ prêt aux participations
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Dev. cap. EUR->
428 099.00
0.00
EUR 428 099.00
428 099.00
0.00
0.00
TOTAL DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
530 782.57
10 524.82
PRODUITS
30/09/2008
30/09/2007
I. PRODUITS PROVENANT DE L'ACTIF CIRCU-
LANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 205.73
558.38
7122, Intérêts sur prêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
14 205.73
558.38
EUR 14 205.73
14 205.73
558.38
558.38
IV. PLUS-VALUES SUR REALISATIONS D'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
717.57
0.00
7522, Plus-value s/ vente de titres . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
717.57
0.00
EUR 717.57
717.57
0.00
0.00
V. PRODUITS EXCEPTIONNELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373.75
0.00
7782, Produits imputables à des ex. antérieurs . . . . . En Dev. cap. EUR->
373.75
0.00
EUR 373.75
373.75
0.00
0.00
PERTE DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
515 485.52
9.966,44
TOTAL DES PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
530 782.57
10 524.82
<i>Appendix 5i>
BRINDISI S.A. - BILAN DETAILLE - AU 31/10/2008
(Devise du capital: EUR)
<i>ACTIFi>
31/10/2008
30/09/2008
C. / III. ACTIF IMMOBILISE / IMMOBILISATIONS
FINANCIERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
2.00
2410-001, Participation Banchory Investments
-100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
21 000.00
21 000.00
EUR 21 000.00
21 000.00
21 000.00
21 000.00
2410-999, Provision moins-value sur participation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Dev. cap. EUR->
-20 999.00
-20 999.00
EUR -20 999.00
-20 999.00 -20 999.00
-20 999.00
136501
2440-001, Prêt à Banchory Investments (Euribor 12
mois + 1%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap.EUR->
428 100.00
428 100.00
EUR 428 100.00
428 100.00 428 100.00
428 100.00
2440-999, Correction de valeur sur prêt à partici-
pation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
-428 099.00
-428 099.00
EUR -428 099.00
-428 099.00 -428 099.00
-428 099.00
D./ III. ACTIF CIRCULANT / INTERETS A RECEVOIR SUR PRETS . . .
16 381.33
14 764.11
4712, Intérêts à recevoir sur prêts . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
16 381.33
14 764.11
EUR 16 381.33
16 381.33
14 764.11
14 764.11
D. / VII. ACTIF CIRCULANT / VALEURS MOBILIERES . . . . . . . . . . . . . 1 477 694.60
1 477 694.60
5031, Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR-> 1 477 694.60
1 477 694.60
EUR 1 477 694.60 1 477 694.60 1 477 694.60 1 477 694.60
D. / VIII. ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES, AVOIRS EN
COMPTE CHEQUES POSTAUX, CHEQUES ET ENCAISSE . . . . . . . . . . .
1 125.54
1 160.04
5100-996, Banque, c/c en EUR . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
1 125.54
1 160.04
EUR 1 125.54
1 125.54
1 160.04
1 160.04
E. COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 666.64
2 449.96
4791, Commissions payées d'avance . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
1 333.33
2 000.00
EUR 1 333.33
1 333.33
2 000.00
2 000.00
4795, Commission domiciliation payée d'avance . . . En Dev. cap. EUR->
333.31
499,96
EUR 333.31
333.31
499,96
499,96
TOTAL DE L'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 496 870.11
1 496 120.71
<i>PASSIFi>
31/10/2008
30/09/2008
A./ I. CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 000.00
31 000.00
1013, Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
31 000.00
31 000.00
EUR 31 000.00
31 000.00 31 000.00
31 000.00
A. / V CAPITAUX PROPRES / RESULTATS REPORTES . . . . . . . . . . . . .
- 525 451.96
- 9 966.44
1110, Résultat en instance d'affectation . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
- 515 485.52
0.00
EUR - 515 485.52
- 515 485.52
0.00
0.00
1150, Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
-9 966.44
- 9 966.44
EUR -9 966.44
-9 966.44 - 9 966.44
- 9 966.44
A. / VI. CAPITAUX PROPRES / RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . .
- 5 701.89
-515 485.52
1250, Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
- 5 701.89
-515 485.52
EUR - 5 701.89
- 5 701.89
-515
485.52
-515 485.52
D./ I. DETTES / C/C ACTIONNAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
486 900.00
486 900.00
4512, Compte courant des actionnaires . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
486 900.00
486 900.00
EUR 486 900.00
486 900.00 486 900.00
486 900.00
D./ II. DETTES / DETTES BANCAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000.00
1 500 000.00
5240-996, Avances à terme en EUR . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR-> 1 500 000.00
1 500 000.00
EUR 1 500 000.00 1 500 000.00
1 500
000.00 1 500 000.00
D./ III. DETTES / INTERETS A PAYER SUR BANQUES . . . . . . . . . . . . . .
7 415.46
1 913.67
4761, Intérêts à payer sur avances . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
7 415.46
1 913.67
EUR 7 415.46
7 415.46
1 913.67
1 913.67
D. / IV. DETTES / CHARGES A PAYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 522.50
1 635.00
4678, Frais d'établissement de la décla fiscale à payer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Dev. cap. EUR->
2 242.50
1 495.00
EUR 2 242.50
2 242.50
1 495.00
1 495.00
4682, Cotisation chambre de comm. à payer . . . . . . En Dev. cap.EUR->
280.00
140.00
EUR 280.00
280.00
140.00
140.00
D. / V. DETTES / IMPOTS ET TAXES A PAYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186.00
124.00
4424-2007, Impôt sur la fortune 2007 à payer . . . . . En Dev. cap. EUR->
62.00
62.00
136502
EUR 62.00
62.00
62.00
62.00
4424-2008, Impôt sur la fortune 2008 à payer . . . . . En Dev. cap. EUR->
62.00
62.00
EUR 62.00
62.00
62.00
62.00
4424-2009, Impôt sur la fortune 2009 à payer . . . . . En Dev. cap. EUR->
62.00
0.00
EUR 62.00
62.00
0.00
0.00
TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 496 870.11
1 496 120.71
PERTES ET PROFITS DETAILLE - POUR LA PERIODE DU 01/10/2008 AU 31/10/2008
(Devise du capital: EUR)
CHARGES
31/10/2008
30/09/2008
I. CHARGES FINANCIERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 501.79
70 681.60
6111, Intérêts sur banques à vue . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
0.00
683.68
EUR 0.00
0.00
683.68
683.68
6121, Intérêts sur avances reçues . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
5 501.79
66 332.92
EUR 5 501.79
5 501.79 66 332.92
66 332.92
6140, Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
0.00
3 665.00
EUR 0.00
0.00
3 665.00
3 665.00
II. CHARGES D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 755.32
10 940.97
6242, Frais d'enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
34.50
0.00
EUR 34.50
34.50
0.00
0.00
6249, Frais de domiciliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
166.65
1 999.85
EUR 166.65
166.65
1 999.85
1 999.85
6250, Commission de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
666.67
8 053.62
EUR 666.67
666.67
8 053.62
8 053.62
6262, Frais d'audits et fiscaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
747.50
747.50
EUR 747.50
747.50
747.50
747.50
6290, Cotisation Chambre de Commerce . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
140.00
140.00
EUR 140.00
140.00
140.00
140.00
V. IMPOTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.00
62.00
6346, Impôts s/ la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
62.00
62.00
EUR 62.00
62.00
62.00
62.00
VII. CORRECTIONS DE VALEURS SUR ELEMENT D'ACTIF . . . . . . . . .
0.00
449 098.00
6611, Correct. de valeur s/ participation . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
0.00
20 999.00
EUR 0.00
0.00 20 999.00
20 999.00
6612, Correct. de valeur s/ prêt aux participations
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Dev. cap. EUR->
0.00
428 099.00
EUR 0.00
0.00 428 099.00
428 099.00
TOTAL DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 319.11
530 782.57
PRODUITS
31/10/2008
30/09/2008
I. PRODUITS PROVENANT DE L'ACTIF CIRCU-
LANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 617.22
14 205.73
7122, Intérêts sur prêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
1 617.22
14 205.73
EUR 1 617.22
1 617.22 14 205.73
14 205.73
En Dev. cap. EUR->
IV. PLUS-VALUES SUR REALISATIONS D'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
717.57
7522, Plus-value s/ vente de titres . . . . . . . . . . . . . . En Dev. cap. EUR->
0.00
717.57
EUR 0.00
0.00
717.57
717.57
V. PRODUITS EXCEPTIONNELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
373.75
7782, Produits imputables à des ex. antérieurs . . . . . En Dev. cap. EUR->
0.00
373.75
EUR 0.00
0.00
373.75
373.75
PERTE DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 701.89
515 485.52
TOTAL DES PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 319.11
530 782.57
Référence de publication: 2008145292/208/1865.
(080172000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2008.
136503
Jetcom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 49.339.
Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M
e
Jean SECKLER, notaire alors de
résidence à Junglinster, en date du 2 décembre 1994, publié au Mémorial C no 83 du 1
er
mars 1999, modifié par
devant M
e
Jean SECKLER, en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial C no 227 du 1
er
avril 1999. Le capital
a été converti en EUR en date du 17 septembre 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C no 396 du 12 mars
2002, modifiée par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2006, l'avis afférent a été publié au Mémorial C
no 365 du 13 mars 2007.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour JETCOM S.à r.l.
i>Interfiduciaire S.A.
Signature
Référence de publication: 2008145072/1261/20.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04114. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080170396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Avon Capital Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 141.467.
<i>Extrait des résolutions de l'Associé unique de la Société prises en date du 30 septembre 2008i>
En date du 30 septembre 2008, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- de nommer CACEIS Bank Luxembourg, une société anonyme, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistré dans le Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 91985, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 30 septembre
2008 et ce pour une durée indéterminée,
- de prolonger le premier exercice social de la société jusqu'au 31 décembre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2008.
<i>Avon Capital Europe S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008144614/250/21.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02736. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Brasserie 1900 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6460 Echternach, 19, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 101.748.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008144923/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05442. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
136504
GM Italy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 81.319.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17/11/2008.
<i>GM ITALY HOLDING S.A.R.L.
i>Angelo DE BERNARDI
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008144536/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04770. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080169312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
SPE Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 94.402.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 16 juin 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
805 du 31 juillet 2003.
Les comptes au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>SPE FINANCE SàRL
i>Signature
Référence de publication: 2008144962/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02722. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
ING RPFFB Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 71.013.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 95.522.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 27 octobre 2008i>
- La démission de la société Orangefield Trust (Luxembourg) S.A. avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique avec effet immédiat.
- La société IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l. avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg
et enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro RCS B 136.171 est élue par l'associé unique en
tant que gérant de la Société en remplacement du gérant démissionnaire pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 27 octobre 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008144878/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03257. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
136505
Sitalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4438 Soleuvre, 243, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 142.881.
STATUTS
L'an deux mille huit, le dix novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Nicodemo SITA, né à Differdange, le 25 septembre 1973, et son épouse
2.- Madame Maria Carmela SITA, née à Differdange, le 22 octobre 1970,
demeurant ensemble à L-4438 Soleuvre, 243, rue de Differdange tous deux ici représentés par Monsieur Max MAYER,
employé,
demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 10 novembre 2008,
laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentant restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité
limitée familiale, qu'ils déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite
et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "SITALUX S.à
r.l.".
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Commune de Differdange. Il pourra être transféré en tout autre endroit
de la commune, par simple décision du ou des gérant(s).
Art. 3. La société a pour objet le commerce en gros et détail et le négoce d'articles de papeterie, d'emballages de
produits de nettoyage, et de produits alimentaires, ainsi que toutes opérations s'y rattachant directement ou indirecte-
ment.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-
et-un décembre de chaque année.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord du ou des
associés représentant l'intégralité des parts sociales.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs
de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés réunis en assemblée
générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
fondés de pouvoir.
Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l'incapacité d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément
unanime des associés.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur. Mesure transitoire.
La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2008.
136506
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
Parts
1.- Monsieur Nicodemo SITA, prénommée, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Maria Carmela SITA, prénommée, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Toutes les parts ont été entièrement libérées toutes les parts sociales par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution en application de l'article 7 et du point 3 de l'article 6 de la loi
du 29 décembre 1971 sur les sociétés familiales s'élève approximativement à 950,- EUR.
<i>Assemblée généralei>
Et ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1.- Monsieur Nicodemo SITA, prénommé, gérant administratif
2.- Madame Maria Carmela SITA, gérant technique
- L'adresse du siège social est établie à L-4438 Soleuvre, 243, rue de Differdange
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2008, Relation: LAC/2008/45367. — Reçu € 31,25.- (trente-et-un
Euros vingt-cinq Cents).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2008.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2008144691/206/82.
(080170276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Tansen Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 93.663.
<i>Resolution by the Board of Directors of the Company,i>
<i>taken at a meeting in Luxembourg on 15 September 2008i>
Attendance List:
- Peter Engelberg, President
- Gilles Wecker
<i>Resolutioni>
The Board of Directors RESOLVED to move the registered office of the Company from 11, boulevard Royal, L-2449,
Luxembourg, to 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg.
It was further resolved that these minutes be signed by the Chairman and one Board other director.
With no other matters on the agenda the meeting was closed.
Peter Engelberg / Gilles Wecker
<i>Président / -i>
<i>Résolution du Conseil d'Administration de la société,i>
<i>qui a eu lieu au Luxembourg le 15 septembre 2008i>
Liste de présence:
- Peter Engelberg, Président
- Gilles Wecker
136507
<i>Résolutioni>
Le Conseil d'Administration décide d'approuver le transfert du siège social de la société du 11, boulevard Royal, L-2449,
Luxembourg, au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg.
Il a été également résolu que le procès verbal a été signé par le Président et un autre membre du Conseil d'Adminis-
tration.
Aucun autre point n'étant porté à l'agenda, l'assemblée a été clôturée.
Peter Engelberg / Gilles Wecker
<i>Président / -i>
Référence de publication: 2008144815/1369/34.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08447. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080170210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Garage Schiltz Frères S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 100, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 105.750.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 18 novembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008145067/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04697. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Rival Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 107.014.
<i>Resolution by the Board of Directors of the Company,i>
<i>taken at a meeting in Luxembourg on 15 September 2008i>
Attendance List:
- Peter Engelberg, Président
- Gilles Wecker
<i>Resolutioni>
The Board of Directors RESOLVED to move the registered office of the Company from 11, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, to 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
It was further resolved that these minutes be signed by the Chairman and one Board other director.
With no other matters on the agenda the meeting was closed.
Peter Engelberg / Gilles Wecker
<i>Présidenti>
<i>Résolution du Conseil d'Administration de la société,i>
<i>qui a eu lieu au Luxembourg le 15 septembre 2008i>
Liste de présence:
- Peter Engelberg, Président
- Gilles Wecker
<i>Résolutioni>
Le Conseil d'Administration décide d'approuver le transfert du siège social de la société du 11, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Il a été également résolu que le procès verbal a été signé par le Président et un autre membre du Conseil d'Adminis-
tration.
Aucun autre point n'étant porté à l'agenda, l'assemblée a été clôturée.
136508
Peter Engelberg / Gilles Wecker
<i>Président / -i>
Référence de publication: 2008144814/1369/34.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08440. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Rootness S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 89.678.
<i>Resolution by the Board of Directors of the Company,i>
<i>taken at a meeting in Luxembourg on 15 September 2008i>
Attendance List:
- Peter Engelberg, Président
- Gilles Wecker
<i>Resolutioni>
The Board of Directors RESOLVED to move the registered office of the Company from 11, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, to 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
It was further resolved that these minutes be signed by the Chairman and one Board other director.
With no other matters on the agenda the meeting was closed.
Peter Engelberg / Gilles Wecker
<i>Président / -i>
<i>Résolution du Conseil d'Administration de la société,i>
<i>qui a eu lieu au Luxembourg le 15 septembre 2008i>
Liste de présence:
- Peter Engelberg, Président
- Gilles Wecker
<i>Résolutioni>
Le Conseil d'Administration décide d'approuver le transfert du siège social de la société du 11, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L- 2132 Luxembourg.
Il a été également résolu que le procès verbal a été signé par le Président et un autre membre du Conseil d'Adminis-
tration.
Aucun autre point n'étant porté à l'agenda, l'assemblée a été clôturée.
Peter Engelberg / Gilles Wecker
<i>Président / -i>
Référence de publication: 2008144806/1369/34.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08443. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Villefranche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 119.232.
<i>Résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société,i>
<i>qui a eu lieu au Luxembourg le 15 septembre 2008i>
Liste de présence:
- Peter Engelberg (Modem Treuhand SA)
<i>Résolutioni>
L'Assemblée Générale décide d'approuver le transfert du siège social de la société du 11, boulevard Royal, L-2449,
Luxembourg, au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg.
Il a été également résolu que le procès-verbal a été signé par le Président et un autre associé.
Aucun autre point n'étant porté à l'agenda, l'assemblée a été clôturée.
136509
Peter Engelberg.
<i>Resolution of an Extraordinary General Meeting by the Manager(s) of the Company,i>
<i>taken at a meeting in Luxembourg on 15 September 2008i>
Attendance List:
- Peter Engelberg (Modern Treuhand SA)
<i>Resolutioni>
The Manager(s) of the Company RESOLVED to move the registered office of the Company from 11, boulevard Royal,
L-2449, Luxembourg, to 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg.
It was further resolved that these minutes be signed by the Chairman and one other manager.
With no other matters on the agenda the meeting was closed.
Peter Engelberg.
Référence de publication: 2008144817/1369/29.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08542. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080170188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Jolux Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 87.680.
<i>Résolution du Conseil d'Administration de la société,i>
<i>qui a eu lieu au Luxembourg le 15 septembre 2008i>
Liste de présence:
- Peter Engelberg, Président
- Gilles Wecker
<i>Résolutioni>
Le Conseil d'Administration décide d'approuver le transfert du siège social de la société du 11, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Il a été également résolu que le procès-verbal a été signé par le Président et un autre membre du Conseil d'Adminis-
tration.
Aucun autre point n'étant porté à l'agenda, l'assemblée a été clôturée.
Peter Engelberg / Gilles Wecker
<i>Président / -i>
<i>Resolution by the Board of Directors of the Company,i>
<i>taken at a meeting in Luxembourg on 15 September 2008i>
Attendance List:
- Peter Engelberg, Président
- Gilles Wecker
<i>Resolutioni>
The Board of Directors RESOLVED to move the registered office of the Company from 11, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, to 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
It was further resolved that these minutes be signed by the Chairman and one Board other director.
With no other matters on the agenda the meeting was closed.
Peter Engelberg / Gilles Wecker
<i>Président / -i>
Référence de publication: 2008144820/1369/34.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08559. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080170201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
136510
Domus-Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 223, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 117.761.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 18 novembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008145070/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04688. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080170401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Fitness Lounge S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9156 Heiderscheid, 4, Fuussekaul.
R.C.S. Luxembourg B 121.007.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société,i>
<i>en date du 3 octobre 2008 à 10.00 heuresi>
L'assemblée générale accepte la démission à ce jour de Monsieur Henri BRACK de son poste d'administrateur et
administrateur-délégué.
Conformément à l'article 9 des statuts et l'article 60 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale autorise le conseil
d'administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion des affaires de la société ainsi que la repré-
sentation de la société à Monsieur Pedro MARTINS, né à Tondela (P) le 26.12.1982, demeurant à L-9512 Wiltz, 24, route
de Bastogne, qui portera le titre d'administrateur-délégué et qui pourra engager valablement la société par sa signature
conjointe avec la signature d'un autre administrateur.
A l'unanimité sont nommés au poste d'administrateur jusqu'au 8 octobre 2012:
- Madame Lidia MARTINS DE FIGUEIREDO RIBEIRO, née à Tondela (P) le 15.03.1955, demeurant à L-9512 Wiltz,
24, route de Bastogne,
- Monsieur Fernando SIMOES RIBEIRO, né à Casteloes/Tondela (P) le 14.04.1958, demeurant à L-9512 Wiltz, 24,
route de Bastogne.
L'assemblée accepte la démission à ce jour du commissaire aux comptes de la société EWA REVISION S.A.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008144833/832/27.
Enregistré à Diekirch, le 28 octobre 2008, réf. DSO-CV00264. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080170467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.
First Data Luxembourg IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 132.660.
<i>Extrait des résolutions des associés de la société adoptées le 9 septembre 2008i>
Il résulte du dit procès-verbal que:
1. La démission, avec effet au 9 septembre 2008, de Monsieur Philip Wall en tant que gérant A de la Société a été
acceptée.
2. Monsieur Stanley Jay Andersen, né le 7 octobre 1961 au Nebraska, Etats-Unis, avec adresse professionnelle au 6588
Pacific Street, AK-31 Omaha, Etats-Unis d'Amérique a été nommé en tant que gérant A de la Société pour une durée
illimitée avec effet au 9 septembre 2008.
136511
Luxembourg, le 10 novembre 2008.
Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008144203/275/21.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04919. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080169666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
DVD Futur Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 24, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 92.855.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CORFI
63-65, rue de Merl, L-2146 LUXEMBOURG
<i>EXPERTS COMPTABLES
i>Signature
Référence de publication: 2008144204/642/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04468. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080169326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
DVD Futur Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 24, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 92.855.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CORFI
63-65, rue de Merl, L-2146 LUXEMBOURG
<i>EXPERTS COMPTABLES
i>Signature
Référence de publication: 2008144205/642/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04467. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080169321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
DVD Futur Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 24, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 92.855.
Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CORFI
63-65, rue de Merl, L-2146 LUXEMBOURG
<i>EXPERTS COMPTABLES
i>Signature
Référence de publication: 2008144206/642/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04465. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080169318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
136512
Avon Capital Europe S.à r.l.
Banque BCP, S.A.
Beppe S.à r.l.
Brasserie 1900 S.à r.l.
Brindisi S.A.
CB Richard Ellis European Warehousing S.à r.l.
Copefi
Crane International Capital S.à r.l.
Domus-Concept S.à r.l.
DVD Futur Sàrl
DVD Futur Sàrl
DVD Futur Sàrl
First Data Luxembourg IV S.à r.l.
Fitness Lounge S.A.
Garage Schiltz Frères S.A.
GM Italy Holding S.à r.l.
Immobilière Betz & Hettinger
Immoselle G.m.b.H.
ING RPFFB Soparfi A S.à r.l.
Jetcom S.à r.l.
Jolux Invest S.A.
Protrust International S.A.
Rival Management S.A.
Rootness S.A.
Sitalux S.à r.l.
SPE Finance Sàrl
Tansen Investments S.A.
Verger International S.A.
Villefranche S.à r.l.