logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2644

29 octobre 2008

SOMMAIRE

AD Tempus Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

126877

AD Tempus Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

126870

AFD Rivesaltes A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

126906

AFD Saint Martin C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

126901

Apax Europe Maple S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

126866

Arelsa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126880

A-TV Worldwide Marketing S.A.  . . . . . . . .

126906

Bagatelle Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126882

Black & White S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126866

Byte Trust  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126881

Centrum Development S.à r.l.  . . . . . . . . . .

126869

Compagnie Financière Privée  . . . . . . . . . . .

126883

Compt@ssur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126911

Cooper Finance Group  . . . . . . . . . . . . . . . . .

126878

Cooper Investment Group  . . . . . . . . . . . . . .

126879

CPI Asia II Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

126870

Crea-Concept Promotion et Immobilière

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126882

Crea-Concept, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126882

Ferber S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126869

Financière Daunou 17 S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

126870

Garage Rech S.à r.l. et Cie  . . . . . . . . . . . . . .

126877

Gecomat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126880

Global Retail Corporation S. à r.l.  . . . . . . .

126883

H&F Sensor Lux 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

126869

Hyppolite & Caderle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

126879

Hyppolite & Caderle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

126879

Irus Holding Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

126868

IUEOA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126867

Jan de Rijk Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

126912

Jeancel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126869

Luciepressing S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126912

Luxart S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126877

Melb Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126881

Moncrest Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126879

Nastia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126881

Petrotec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126881

PM France Retail Investments S.à r.l.  . . . .

126883

PPG Luxembourg Holdings S.àr.l.  . . . . . . .

126911

P&Pm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126878

Premier I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126909

Prime Properties Investments S.A.  . . . . . .

126901

Pro-Concept Solutions S.àr.l. . . . . . . . . . . . .

126878

Pro-Jardin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126882

Sapphire Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

126880

Shell Finance Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

126896

Temtex Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

126904

Trinity - Gérance Immobilière S.à r.l.  . . . .

126877

Trois Quarts S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126866

UMZ-Umweltmanagement Zens GmbH

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126895

126865

Apax Europe Maple S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.006.

L'adresse professionnelle de Monsieur Stephen Kempen, gérant de catégorie B de la Société, est désormais la suivante:
- 33, Jermyn Street, SW1Y 6DN Londres, Grande-Bretagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008133060/1035/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2008, réf. LSO-CV03119. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080155120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Trois Quarts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6114 Junglinster, 1, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 99.704.

<i>Convention

Entre les soussignés:
1) Monsieur Chun Sang CHAN, serveur, demeurant à L-6114 JUNGLINSTER, 1, route d'Echternach
ci-après dénommé le "Vendeur", d'une part,
et
2) Monsieur Kar Kay Peter YEUNG, cuisinier, demeurant à L-3258 BETTEMBOURG, 37, rue Fernand Mertens
ci-après dénommé l' "Acheteur", d'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
1) Avec effet au 01.07.2005, le Vendeur vend et cède à l'Acheteur, qui accepte, 400 (quatre cents) parts d'une valeur

nominale de EUR 25.- (vingt cinq Euro) de la société à responsabilité limitée TROIS QUARTS SARL, No d'immatriculation
B no 99.704, dont le siège est à L-6114 Junglinster 1, route d'Echternach, ci-après dénommée la "Société".

2) Le prix de vente s'élève à EUR 1.- (un Euro).
3) Cette vente a été faite à la charge de l'Acheteur, qui s'oblige de supporter tous les frais, droits et honoraires auxquels

la présente cession donnera ouverture, de faire signifier à ses frais la présente cession à la Société ou de la faire accepter
par la Société dans un acte notarié et de faire modifier l'article 5 des statuts et les inscriptions afférentes au registre de
commerce.

Faite en trois exemplaires, dont l'un est destiné à être remis au Vendeur, le deuxième à l'Acheteur et le troisième soit

à l'huissier, soit au notaire.

Junglinster, le 22 juin 2005.

Chun Sana CHAN / Kar Kay Peter YEUNG
<i>Le Vendeur / L'Acheteur

Référence de publication: 2008133062/728/30.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT07012. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Black &amp; White S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 48.943.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126866

Junglinster, le 21 octobre 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008133271/231/14.
(080155921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

IUEOA, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2416 Howald, 2, rue de la Redoute.

R.C.S. Luxembourg F 7.745.

STATUTS

(version octobre 2008)

Les membres fondateurs Sven Becker, Sarah Cattani et Ralph Zeimet
élisant domicile à Luxembourg créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la

loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents
statuts:

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination: IUEOA asbl et a son siège social à l'adresse suivante: 2, rue de la

Redoute, L-2416 Howald.

Art. 2. L'association a pour objet de:
- d'informer les citoyens et citoyennes sur le développement durable, via environnemental, sur les mœurs de vie

moderne ainsi que sur la vie culturelle

* créer, publier et diffuser des informations dans le domaine culturel, social, et écologique par des supports médias

divers (internet, publications etc)

* organiser des événements (concerts, festivals, lectures etc)

Art. 3. L'association est constituée de minimum 3 membres.

Art. 4. Les membres fondateurs sont comme suit:
Becker Sven, infographiste, domicilié au 23, rue du Château, L-1329 Luxembourg, de nationalité Luxembourgeoise
Cattani Sarah, journaliste, domiciliée au 2, rue de la Redoute, L-2416 Howald, de nationalité Italo-Suisse
Ralph Zeimet, manager de projet, domicilié au 132, route d'Arlon, L-8008 Strassen, de nationalité Luxembourgeoise

Art. 5. L'admission est ouverte à toute personne qui souhaite adhérer, et se fait par le payement de la cotisation

annuelle. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite
au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de trois mois à compter du jour de l'échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l'association si d'une manière quelconque ils ont porté gravement atteinte

aux intérêts de IUEOA asbl. A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la
décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes, le membre dont
l'exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associé(e)s, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 7a. Les associés et/ou bénévoles s'engagent à ne dévoiler à quiconque une quelconque information confidentielle

dont il aurait acquis la connaissance concernant les activités, projets ou autres données relatives à l'asbl par exemple
savoir technique, méthodes d'organisation, information commerciale.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée à au moins 50,- €.

Art. 9.  L'assemblée  générale  qui  se  compose  de  tous  les  membres  est  convoquée  par  le  conseil  d'administration

régulièrement une fois par an, et extraordinairement chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d'administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant simple lettre

missive ou un email devant mentionner l'ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite, d'un vingtième au moins des membres figurants sur la dernière liste annuelle, doit

être porté à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

126867

Art. 12. L'assemblée générale fixe les directives à suivre et doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts
- nomination et révocation des administrateurs et commissaires aux comptes
- approbation des budgets et comptes
- dissolution de l'association

Art. 13. Elle ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement

indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée
qu'à la majorité de deux tiers. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion,
une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; dans ce
cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associé(e)s ne sont pas présents, la décision sera prise par les

membres fondateurs.

Art. 14. Les délibérations de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre

confiée à la poste ou par mail.

Art. 15. L'association est gérée par un conseil d'administration élu pour une durée de 2 ans par l'assemblée générale.

Art. 16. Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives à lui dévolues

par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'association.

Art. 17. Il représente l'association dans la relation avec des tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à

l'égard de ceux-ci 2 signatures des membres sont nécessaires.

Art. 18. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'appropriation de l'assemblée générale, le rapport d'activité

et les comptes de l'exercice et le budget du prochain exercice.

Art. 19. En cas de liquidation de l'association, les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.

Art. 20. La liste des membres est complétée chaque année par l'indicateur des modifications qui se sont produites et

ce au 31 décembre.

Art. 21. Les ressources de l'IUEOA asbl comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur,
- revenus publicitaires pour couvrir les frais de gestion de l'asbl.

Art. 22. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2008 par les membres fondateurs.

Signatures.

Référence de publication: 2008133229/9478/88.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06139. - Reçu 243,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Irus Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 544.430,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.972.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126868

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008133264/242/13.
(080155862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Centrum Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 237.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 105.723.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008133266/242/13.
(080155873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Jeancel, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-8009 Strassen, 163-165, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 126.964.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008133268/242/13.
(080155885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

H&amp;F Sensor Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 144.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 140.978.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008133269/242/13.
(080155891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Ferber S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4942 Bascharage, 3A, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 25.191.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126869

Luxembourg, le 21/10/2008.

<i>Pour FERBER S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008133298/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04743. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

CPI Asia II Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 135.890.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008133270/242/13.
(080155899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

AD Tempus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 119, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 109.151.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/10/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008133390/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05697. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Financière Daunou 17 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 134.897.

In the year two thousand and eight, the ninth day of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Financière Daunou 17 S.A., a Lu-

xembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 134.897 (the Com-
pany). The Company has been incorporated on 14 December 2007 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
- N° 231 of 29 January 2008. The articles of association of the Company have been amended for the last time on 7 July
2008 pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden, notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
- N°2301 of 20 September 2008.

The Meeting is chaired by Mr Philippe Thiebaud, lawyer, residing in Luxembourg, who appoints as Secretary Ms Mieke

Verstraeten, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting appoints as Scrutineer Mrs. Annick Braquet, private employee, professionally residing in Luxembourg,

(the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

126870

The shareholders, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list

which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders
and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes

and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Submission of the report of the board of directors within the meaning of article 32-3(5) of the Luxembourg Com-

panies Act of 10 August 1915 as amended (the Law), to the general meeting of shareholders of the Company with respect
to the waiver of preferential right of subscription of the existing shareholders in connection with increases of the share
capital of the Company and issuance of instruments convertible or exchangeable into shares by the board of directors
under the delegation of authority to be made by the shareholders under item 3.;

3. Grant of a new authorization to the board of directors to (i) increase the share capital of the Company, whereby

the board of directors is authorized to issue shares and instruments convertible or exchangeable into shares until the
share capital reaches the amount of EUR 341,830,000 (three hundred forty-one million eight hundred thirty thousand
Euro) for a period of five years, and (ii) waive the preferential right of subscription of the shareholders when issuing new
shares and instruments convertible or exchangeable into shares;

4. Increase of the share capital of the Company by a nominal amount of EUR 420,000.00 (four hundred and twenty

thousand Euro), by way of creation and issue of 336,000.00 (three hundred and thirty-six thousand) shares having a par
value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each;

5. Subscription and payment to the share capital increase specified under item 4. above by all shareholders of the

Company by way of a contribution in cash, each share having a subscription price of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five
cents);

6. Subsequent amendment to article 5 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the above changes;

7. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes and grant of authority to

proceed to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company; and

8. Miscellaneous.
II. it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all of the 1,752,000

(one million seven hundred fifty-two thousand) shares having a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents)
each, are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items
on the agenda, here above reproduced, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after exa-
mination of the agenda. The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of
the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the
registration authorities;

III. it appears that the contemplated increase in the capital of the Company is made on a pro rata basis and shall

therefore in no way affect any preferential subscription rights of any current shareholder;

IV. the Meeting has taken unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices; the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting notes that the board of directors of the Company (the Board) proposed to the Meeting to grant to the

Board the authorization to issue ordinary shares of the Company for a period of 5 (five) years as from the date hereof,
including the authorization to limit or waive the preferential subscription rights of the shareholders of the Company when
issuing new ordinary shares, on the following terms and conditions (the Authorization):

"The authorised capital is set at EUR 341,830,000 (three hundred forty-one million eight hundred thirty thousand

Euro) divided into 273,464,000 (two hundred seventy-three million four hundred sixty-four thousand) shares, each having
a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five Cents).

The board of directors is authorised and empowered to increase the current share capital up to the amount of the

authorised capital, in whole or in part from time to time, within a period expiring on 8 October 2013.

In addition, the board of directors is authorised and empowered to issue any instrument convertible or exercisable

into shares, including without limitation, convertible bonds, warrants or convertible preferred equity certificates (the
Instruments), within the limits of the authorized capital.

126871

The board of directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription of shares, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit or reserves
(including any share premium account) of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders
in lieu of dividends. The Board is further authorized to determine the conditions attaching to any subscription of Instru-
ments.

As a consequence, the board of directors is authorised and empowered to:
(a) implement a capital increase by issuing from time to time new shares to be paid up in cash or by way of contribution

of assets in kind, by incorporating reserves or profits carried forward or in any other manner, including the exercise of
warrants, the conversion of convertible bonds and the convertible preferred equity certificates;

(b) fix the place and the date of the issue or the successive issues of the shares, the issue price, with or without a

premium, the date from which the Ordinary Shares shall bear dividend and the terms and conditions of subscription and
payment of the shares;

(c) issue the Instruments and to set the issue price, the interest rate, as well as any other terms and conditions of the

Instruments; and

(d) waive or limit the preferential subscription right of the shareholders when proceeding to the issue of shares or

the issue of Instruments, to the extent required by law."

The  Meeting  is  provided  with  a  copy  of  the  report  issued  by  the  Board  regarding  the  waiver  of  the  preferential

subscription rights of the shareholders (the Report), the Report being made in accordance with article 32-3 (5) of the
law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

In the light of the Report, the Meeting resolves to approve the Authorization, including the authorization granted to

the Board to limit or waive the preferential subscription rights of the shareholders of the Company when issuing new
ordinary shares.

Article 5 of the articles of association shall therefore be amended as set forth in the fifth resolution.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 420,000.00 (four hundred

and twenty thousand Euro) in order to bring the share capital from its current amount of EUR 2,190,000.00 (two million
one hundred ninety thousand Euro) represented by 1,752,000 (one million seven hundred fifty-two thousand) shares
having a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents) each, to an amount of EUR 2,610,000.00 (two million
six hundred and ten thousand Euro) by the creation and issue of 336,000.00 (three hundred and thirty-six thousand)
shares having a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents) each.

<i>Fourth resolution

The  Meeting  resolves  to  accept  and  record  the  following  intervention,  subscription  to  and  full  payment  of  the

336,000.00 (three hundred and thirty-six thousand) newly issued shares of the Company as follows:

<i>Intervention - Subscriptions - Payment

The shareholders of the Company, as mentioned in the table below (the Subscribers), all hereby represented by Philippe

Thiebaud, pre-named, by virtue of powers of attorney given under private seal, declare:

(i) to subscribe to that number of shares set out against their respective names in the table below having each a nominal

value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents) for a subscription price of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents)
each;

(ii) to pay up each their new shares by way of a contribution in cash in the total amount of EUR 420,000.00 (four

hundred and twenty thousand Euro) in accordance with the below table (the Contribution):

SUBSCRIBER

SHARES

CONTRIBUTION

(in EUR)

1) PAI EUROPE V-1 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,099.00

125,123.75

2) PAI EUROPE V-2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,099.00

125,123.75

3) PAI EUROPE V-3 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,227.00

125,283.75

4) PAI EUROPE IV-B FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,575.00

44,468.75

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

336,000.00

420,000.00

(iii) that the shares are subscribed pro rata to their current shareholdings in the Company.
Evidence of the payment under the Contribution has been given to the undersigned notary by means of a blocking

certificate issued by ING on October 9, 2008 confirming the availability of the subscription amount under the Contribution
on the Company's bank account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

The Contribution, in an aggregate amount of EUR 420,000.00 (four hundred and twenty thousand Euro), is to be

allocated entirely to the nominal share capital account of the Company.

126872

<i>Fifth resolution

In order to reflect the resolutions adopted under the second, third and fourth resolution, the Meeting resolves to

amend article 5 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 2,610,000.00 (two million six hundred and ten thousand Euro), represented

by 2,088,000 (two million eighty-eight thousand) shares with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five
Cents) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

The authorised capital is set at EUR 341,830,000 (three hundred forty-one million eight hundred thirty thousand Euro)

divided into 273,464,000 (two hundred seventy-three million four hundred sixty-four thousand) shares, each having a par
value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five Cents).

The board of directors is authorised and empowered to increase the current share capital up to the amount of the

authorised capital, in whole or in part from time to time, within a period expiring on 8 October 2013.

In addition, the board of directors is authorised and empowered to issue any instrument convertible or exercisable

into shares, including without limitation, convertible bonds, warrants or convertible preferred equity certificates (the
Instruments), within the limits of the authorized capital.

The board of directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription of shares, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit or reserves
(including any share premium account) of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders
in lieu of dividends. The Board is further authorized to determine the conditions attaching to any subscription of Instru-
ments.

As a consequence, the board of directors is authorised and empowered to:
(a) implement a capital increase by issuing from time to time new shares to be paid up in cash or by way of contribution

of assets in kind, by incorporating reserves or profits carried forward or in any other manner, including the exercise of
warrants, the conversion of convertible bonds and the convertible preferred equity certificates;

(b) fix the place and the date of the issue or the successive issues of the shares, the issue price, with or without a

premium, the date from which the Ordinary Shares shall bear dividend and the terms and conditions of subscription and
payment of the shares;

(c) issue the Instruments and to set the issue price, the interest rate, as well as any other terms and conditions of the

Instruments; and

(d) waive or limit the preferential subscription right of the shareholders when proceeding to the issue of shares or

the issue of Instruments, to the extent required by law.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law."

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any director of the Company and Mr. Philippe Thiebaud, lawyer at Allen &amp; Overy Luxembourg,
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company
and to see to any formalities in connection therewith.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,700.- (two thousand seven hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuvième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Financière Daunou 17 S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.897 (la Société). La
Société a été constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand Duché
de Luxembourg, en date du 14 décembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 231 du

126873

29 janvier 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois en vertu d'un acte daté
du 7 juillet 2008 de Maître Joëlle Baden, notaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2301
du 20 septembre 2008.

L'Assemblée est présidée par M. Philippe Thiebaud, avocat, avec résidence professionnelle à Luxembourg, qui désigne

en tant que Secrétaire Mme Mieke Verstraeten, avec résidence professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée désigne en tant que Scrutateur Mme Annick Braquet, employée privée, avec résidence professionnelle à

Luxembourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent le Bureau de l'Assemblée).

Les actionnaires représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présences

qui restera annexée aux présentes après avoir été signées par les mandataires des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux présentes

et seront signées par toutes les parties.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi),

présentation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, portant sur la
renonciation aux droits préférentiels de souscription des actionnaires existants dans le cadre de l'augmentation de capital
social de la Société et de l'émission d'instruments convertibles ou échangeables en actions par le conseil d'administration,
en vertu de la délégation de pouvoirs effectuée par les actionnaires, selon le point 3. ci-dessous;

3. Nouvelle autorisation accordée au conseil d'administration afin (i) d'augmenter le capital social de la Société, le

conseil d'administration étant autorisé à émettre des actions et des instruments convertibles ou échangeables en actions
jusqu'à ce que l'augmentation de capital social atteigne le montant de EUR 341.830.000,00 (trois cent quarante et un
millions huit cent trente mille Euros) pour une période de cinq années, et (ii) de renoncer aux droits de souscription
préférentiels des actionnaires lors de l'émission de nouvelles actions et d'instruments convertibles ou échangeables en
actions;

4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 420.000,00 (quatre cent vingt mille Euros), au

moyen de la création et de l'émission de 336.000 (trois cent trente-six mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,25
(un Euro et vingt-cinq cents) chacune;

5. Souscription et libération de l'augmentation de capital social en vertu du point 4. ci-dessus par voie d'apport en

numéraire effectué par chacun des actionnaires, chaque part sociale ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et
vingt-cinq cents);

6. Modification consécutive de l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter les modifications ci-

dessus;

7. Modification du registre des actions de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus et délégation de pouvoir

pour procéder à l'inscription des nouvelles actions émises dans le registre des actions de la Société; et

8. Divers.
II.  qu'il  apparaît  selon  une  liste  de  présences  établie  et  certifiée  par  les  membres  du  Bureau  que  l'intégralité  des

1.752.000 (un million sept cent cinquante-deux mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-
cinq cents) chacune, est dûment représentée à l'Assemblée, qui est par conséquent dûment constituée et apte à délibérer
des points de l'ordre du jour reproduit ci-dessus, les actionnaires représentés à l'Assemblée ayant convenu d'ouvrir
l'Assemblée après examen de l'ordre du jour. La liste de présences signée par l'ensemble des actionnaires représentés à
l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte de même que les procurations, afin
d'être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement;

III. qu'il apparaît que l'augmentation de capital de la Société telle qu'envisagée s'effectuera sur la base de la propor-

tionnalité et n'affectera par conséquent aucunement les droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels;

IV. que l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés se considérant comme dûment convoqués et
déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée note que le conseil d'administration de la Société (le Conseil d'administration) a proposé à l'Assemblée

d'accorder au Conseil d'administration l'autorisation d'émettre de nouvelles actions ordinaires de la Société pendant une
période de 5 (cinq) ans à compter de ce jour, avec autorisation de limiter ou de renoncer aux droit préférentiels de
souscription des actionnaires de la Société lors de l'émission de nouvelles actions ordinaires, selon les conditions et
modalités suivantes (l'Autorisation):

126874

"Le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 341.830.000,00 (trois cent quarante et un millions huit cent trente

mille Euros) représenté par 273.464.000 (deux cent soixante-treize millions quatre cent soixante-quatre mille) actions,
ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté afin d'effectuer toute augmentation du capital social actuel dans la

limite du capital social autorisé, en une seule fois ou par tranches successives, et ce pour une période qui expirera le 8
octobre 2013.

En outre, le conseil d'administration est autorisé et mandaté pour émettre tout instrument convertible ou échangeable

en actions, y inclus et sans limitation, en obligations convertibles, warrants ou convertible preferred equity certificates,
dans les limites du capital autorisé (les Instruments).

En outre, le Conseil d'administration est autorisé à déterminer les conditions relatives à toute souscription d'actions,

et peut décider de procéder à une augmentation de capital partielle ou totale par la conversion de tous bénéfices nets
ou réserves (en ce inclus le compte de prime d'émission) de la Société en capital et par l'attribution d'actions entièrement
libérées aux actionnaires à la place de dividendes. Le Conseil d'administration est également autorisé à déterminer les
conditions relatives à toute souscription aux Instruments.

Par conséquent, le conseil d'administration est autorisé et mandaté afin d'effectuer les opérations suivantes:
(a) réaliser toute augmentation du capital social par l'émission de nouvelles actions payées en numéraires ou au moyen

d'apports en nature, par incorporation de réserves ou de bénéfices reportés, ou de toute autre manière, y inclus par
l'exercice de warrants, par la conversion d'obligations et de convertible preferred equity certificates;

(b) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives d'actions, le prix d'émission, l'existence ou non

d'une prime d'émission, la date à partir de laquelle les Actions Ordinaires engendrent des dividendes, ainsi que les con-
ditions et modalités de souscription et de libération des nouvelles actions;

(c) émettre les Instruments et fixer le prix d'émission, le taux d'intérêts, ainsi que toutes autres conditions et modalités

relatives aux Instruments; et

(d) renoncer à ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions ou d'Ins-

truments, dans les limites déterminées par la loi."

L'Assemblée a reçu une copie du rapport émis par le Conseil d'administration concernant la renonciation aux droits

préférentiels de souscription des actionnaires (le Rapport), le Rapport étant rédigé conformément à l'article 32-3(5) de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Selon le Rapport, l'Assemblée décide d'accepter l'Autorisation, y compris l'autorisation accordé au Conseil d'admi-

nistration  de  limiter  ou  de  renoncer  aux  droits  préférentiels  de  souscription  des  actionnaires  de  la  Société  lors  de
l'émission de nouvelles actions ordinaires.

En conséquence de ce qui précède, l'article 5 des Statuts sera modifié conformément la cinquième résolution.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 420.000,00 (quatre

cent vingt mille Euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 2.190.000,00 (deux
millions cent quatre vingt dix mille Euros) représenté par 1.752.000 (un million sept cent cinquante-deux mille) actions,
ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune, à un montant de EUR 2.610.000,00 (deux
millions six cent dix mille Euros) par la création et l'émission de 336.000,00 (trois cent trente-six mille) nouvelles actions
d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et de prendre acte de l'intervention, la souscription et la libération intégrale suivantes

des 336.000,00 (trois cent trente-six mille) actions nouvellement émises de la Société de la manière suivante:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Les actionnaires de la Société, tels que mentionnés dans le tableau ci-dessous (les Souscripteurs), représentés par

Philippe Thiebaud, prénommé, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé, déclarent:

(i) souscrire au nombre d'actions indiqué dans le tableau ci-dessous en regard de leur nom, la valeur nominale des

actions s'élevant à EUR 1,25 (un Euros et vingt-cinq cents) chacune, et ayant un prix de souscription de EUR 1,25 (un
Euro et vingt-cinq cents) chacune;

(ii) libérer entièrement les nouvelles actions au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de EUR 420.000,00

(quatre cent vingt mille Euros), selon le tableau ci-dessous (l'Apport):

SOUSCRIPTEUR

ACTIONS

APPORT
(en EUR)

1) PAI EUROPE V-1 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.099,00

125.123,75

2) PAI EUROPE V-2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.099,00

125.123,75

3) PAI EUROPE V-3 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.227,00

125.283,75

4) PAI EUROPE IV-B FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.575,00

44.468,75

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

336.000,00

420.000,00

126875

(iii) que leur souscription aux nouvelles actions est proportionnelle à leur actionnariat actuel dans la Société.
Le paiement en vertu de l'Apport a été certifié au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat de blocage émis par

ING le 9 octobre 2008 attestant de la disponibilité sur le compte bancaire de la Société du montant de souscription
correspondant à l'Apport. Le notaire instrumentaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

L'Apport, d'un montant total de 420.000,00 (quatre cent vingt mille Euros), sera attribué entièrement au compte de

capital social nominal de la Société.

<i>Cinquième résolution

Afin de refléter les deuxième, troisième et quatrième résolutions, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts,

qui aura désormais la teneur suivante:

Art.5. Le capital social souscrit est établi à EUR 2.610.000,00 (deux millions six cent dix mille Euros), représenté par

2.088.000 (deux millions quatre-vingt-huit mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq
cents) chacune, correspondant chacune à une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des Statuts.

Le capital social autorisé est établi à EUR 341.830.000,00 (trois cent quarante et un millions huit cent trente mille

Euros), représenté par 273.464.000 (deux cent soixante-treize millions quatre cent soixante-quatre mille) actions, ayant
une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté afin d'effectuer toute augmentation partielle ou totale du capital

social actuel de la Société, dans les limites du montant du capital social autorisé. Cette autorisation est valable pour une
période arrivant à expiration le 8 octobre 2013.

En outre, le Conseil d'administration est autorisé et mandaté afin d'émettre tout instrument convertible ou échangeable

en actions, y inclus et sans limitation, en obligations convertibles, warrants ou convertible preferred equity certificates,
dans les limites du capital autorisé ( les Instruments).

Le Conseil d'administration est autorisé à déterminer les conditions relatives à toute souscription d'actions, et peut

décider de procéder à une augmentation de capital partielle ou totale par la conversion de tous bénéfices nets ou réserves
(en ce inclus le compte de prime d'émission) de la Société en capital, et par l'attribution d'actions entièrement libérées
aux actionnaires à la place de dividendes. Le Conseil d'administration est également autorisé à déterminer les conditions
relatives à toute souscription aux Instruments.

Par conséquent, le conseil d'administration est autorisé et mandaté afin d'effectuer les opérations suivantes:
(a) réaliser toute augmentation du capital social par l'émission de nouvelles actions payées en numéraires ou au moyen

d'apports en nature, par incorporation de réserves ou de bénéfices reportés, ou de toute autre manière, y inclus par
l'exercice de warrants, par la conversion d'obligations et de convertible preferred equity certificates;

(b) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives d'actions, le prix d'émission, l'existence ou non

d'une prime d'émission, la date à partir de laquelle les Actions Ordinaires engendrent des dividendes, ainsi que les con-
ditions et modalités de souscription et de libération des nouvelles actions;

(c) émettre les Instruments et fixer le prix d'émission, le taux d'intérêts, ainsi que toutes autres conditions et modalités

relatives aux Instruments; et

(d) renoncer à ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions ou d'Ins-

truments, dans les limites déterminées par la loi.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans le respect des limites fixées par la loi."

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et

confère pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société et à Philippe Thiebaud, avocat de Allen &amp; Overy
Luxembourg, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des nouvelles actions émises dans le registre
des actions de la Société, et afin d'effectuer toutes les formalités y afférentes.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.700.- (deux mille sept cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle Anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a  été  établi  en  Anglais,  suivi  d'une  version  française.  A  la  requête  de  ces  mêmes  parties  comparantes,  et  en  cas  de
divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé ensemble avec le notaire

l'original du présent acte.

Signé: P. THIEBAUD, M. VERSTRAETEN, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

126876

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 octobre 2008. Relation: LAC/2008/41525. - Reçu deux mille cent euros (0,50%

= 2.100.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

H. HELLINCKX.

Référence de publication: 2008133426/242/363.
(080155865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

AD Tempus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 119, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 109.151.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/10/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008133391/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05698. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Luxart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 131.891.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/10/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008133392/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05699. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Garage Rech S.à r.l. et Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 34, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 21.378.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008133464/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, réf. LSO-CL04173. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080156024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Trinity - Gérance Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 94.937.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126877

Luxembourg, le 20/10/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008133393/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV04994. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

P&amp;Pm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 95.537.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/10/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008133394/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV04996. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Pro-Concept Solutions S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 24A, Dicksstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 124.453.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/10/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008133395/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV04998. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Cooper Finance Group, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 40.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 99.622.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

<i>Pour COOPER FINANCE GROUP
SGG CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2008133398/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05996. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

126878

Hyppolite &amp; Caderle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 86.389.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/10/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008133396/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV05002. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080155799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Hyppolite &amp; Caderle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 86.389.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/10/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés, Sàrl, Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008133397/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV04999. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Cooper Investment Group, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 40.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 99.627.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

<i>Pour COOPER INVESTMENT GROUP
SGG CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2008133399/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05997. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Moncrest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.424.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126879

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008133402/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 17 octobre 2008, réf. DSO-CV00162. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080155771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Gecomat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9573 Wiltz, 38, rue Michel Thilges.

R.C.S. Luxembourg B 106.741.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008133403/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 17 octobre 2008, réf. DSO-CV00167. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080155767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Arelsa Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 95.127.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

<i>Pour ARELSA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008133404/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05991. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Sapphire Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 80.710.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 16 février 2001, publié au Mémorial C n 

o

 800 du

24/09/2001.

Le bilan au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SAPPHIRE SHIPPING S.A.
<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008133463/2820/17.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV04060. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

126880

Petrotec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.650.850,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.109.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008133406/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03482. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080155727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Melb Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 90.295.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/10/2008.

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008133454/792/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04515. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080156073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Byte Trust, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 235, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 56.169.

Les comptes annuels au 30.09.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/10/2008.

STRATEGO INTERNATIONAL SARL
<i>Administrateur
Signature

Référence de publication: 2008133455/792/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04523. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080156074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Nastia, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 88.825.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126881

Luxembourg, le 22/10/2008.

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008133456/792/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04526. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080156075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Bagatelle Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 118.917.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/10/2008.

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008133457/792/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04528. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080156076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Crea-Concept, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Crea-Concept Promotion et Immobilière S.à r.l.).

Siège social: L-8009 Strassen, 51, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 111.513.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-8009 Strassen, le 03 septembre 2008.

Monsieur Maniora Régis
<i>Gérant

Référence de publication: 2008133459/500/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04237. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080156038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Pro-Jardin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5376 Uebersyren, 29, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 117.916.

Le bilan au 31.12.07 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Uebersyren, le 25 juin 2008.

Monsieur Eischen Thomas
<i>Gérant

Référence de publication: 2008133460/500/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04232. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080156039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

126882

PM France Retail Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 134.178.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des associés prises en date du 22 Septembre 2008

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Madame Patricia Schon en tant que Gérant B de la Société avec effet au 22 Septembre 2008;
- De nommer:
* Madame Corinne Muller, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, Luxembourg,

en tant que nouvelle Gérante B de la Société avec effet au 22 Septembre 2008 pour une durée indéterminée

Luxembourg, le 22 Septembre 2008.

Rui Ah Lima.

Référence de publication: 2008133598/9168/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2008, réf. LSO-CV05276. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080155869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

COFIPRI, Compagnie Financière Privée, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 4.228.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008130398/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03570. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080151792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Global Retail Corporation S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 142.190.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the first of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Global Retail Investments Limited, with registered office at TMF Place, Tortola, British Virgin Islands, registered at the

Registrar of Companies of the British Virgin Islands under number B 41.097, (the "Shareholder"), here represented by
Carolin Weirauch, lawyer, residing in Luxembourg.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed

for the purpose of registration.

The appearing person, represented as stated above, has requested the notary to record that:
I. The Shareholder is the sole shareholder of Global Retail Corporation B.V. (the "Company"), a private limited liability

company existing under the laws of The Netherlands Antilles, in process of de-registration at the Trade Register of the
Curaçao Chamber of Commerce with number 56083, with registered office at Pietermaai 123, Curaçao, The Netherlands
Antilles.

II. The issued share capital of the Company is currently fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, entirely paid-in.

III. The Shareholder, represented as mentioned above, has recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

126883

<i>Agenda

1 Acknowledgement of the resolutions taken by the sole shareholder regarding the transfer of the central adminis-

trative seat and the registered office of the Company without any dissolution from Curacao, The Netherlands Antilles,
to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with effect as at 1 October 2008;

2 Transfer of the registered office and the central administrative seat of the Company without dissolution from Cu-

raçao, The Netherlands Antilles, to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as at 1 October 2008.

3 Adoption of the Luxembourg nationality and submission of the Company to Luxembourg laws, adoption of the legal

form of a "société à responsabilité limitée" and change of the Company's name to "Global Retail Corporation S.à r.l."

4 Approval of an interim balance sheet of the Company as at 1 October 2008 including the managing director's report.
5 Complete restatement of the Company's articles of association in order to bring them in conformity with Luxem-

bourg laws,

6 Determination of the address of the registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

7 Appointment of the following persons as managers of the Company for unlimited duration:
* Mrs Polyxeni Kotoula, with professional address at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, born in Athens, Greece,

on 30 November 1973;

* Mr Jorge Perez Lozano, with professional address at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, born in Mannheim,

Germany, on August 17, 1973.

IV. The Shareholder, represented as above mentioned, requested the notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to acknowledge the resolutions of the Shareholder taken on 30 September 2008 in the

Netherlands Antilles which resolved, among others:

* to transfer the central administrative seat and the registered office of the Company without dissolution from Curaçao,

The Netherlands Antilles, to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

* to set the date of effectiveness of the transfer from Curaçao, The Netherlands Antilles to Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg as at 1 October 2008.

Said resolutions of the Shareholder after signature "ne varietur" by the proxyholder and the notary will remain attached

to the present deed.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to transfer the registered office and the central administrative seat of the Company without

any dissolution from Curaçao, The Netherlands Antilles, to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as at
1 October 2008.

The Shareholder resolved that in consequence of such transfer, the Company shall adopt the Luxembourg nationality,

shall be submitted to Luxembourg laws and shall adopt the legal form of a "société à responsabilité limitée".

The Shareholder further resolved that the Company will change its name to "Global Retail Corporation S. à r.l."

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to approve an interim balance sheet of the Company as at 1 October 2008 prepared in

accordance with accounting principles generally accepted in the Netherlands Antilles and which include a report of the
managing director. Pursuant to such interim balance sheet, the value of the Company's assets and liabilities corresponds
at least to the Company's issued share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25) each and the share premium of one million five hundred seventy thousand
Euro (EUR 1,570,000).

Said interim balance sheet, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to proceed with a complete restatement of the Company's articles of association in order

to bring them in conformity with Luxembourg laws. The Shareholder resolved that the articles of association will hen-
ceforth read as follows and will be worded in English to be followed by a French translation whereby the English text
shall prevail in case of divergences between the English and the French text:

Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

126884

The Company will exist under the name of "Global Retail Corporation S. à r.l."

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or

in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well

as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial of financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set

by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 28 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all of which are fully paid
up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed

amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

126885

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or

class B Managers (the "Class B Managers").

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or

proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to

whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'

written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers

holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means

of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

126886

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which
the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number

of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may,
as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

Chapter IV. - Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to

the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general
meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25)

shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

126887

Art. 20. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in

a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 21. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

Art. 22. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 23. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be a
majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 24. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial Year, Financial Statements, Distribution of Profits

Art. 25. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 26. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 27. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

126888

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 28. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 29. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolved to fix the address of the registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The Shareholder resolved to appoint the following persons as managers of the Company for unlimited duration:
* Mrs Polyxeni Kotoula, with professional address at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, born in Athens, Greece,

on 30 November 1973;

* Mr Jorge Perez Lozano, with professional address at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, born in Mannheim,

Germany, on August 17, 1973.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at ten thousand three hundred euro (EUR 10,300.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le premier octobre.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Global Retail Investments Limited, ayant son siège social à TMF Place, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée

au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro B 41.097, (l'"Actionnaire"), représentée par Carolin
Weirauch, avocate, demeurant au Luxembourg.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, sera annexée aux présentes pour

être enregistrée.

Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, a demandé au notaire d'enregistrer que:
I. L'Associé est le seul associé de Global Retail Corporation B.V. (la "Société"), une société à responsabilité limitée

existant sous les lois des Antilles Néerlandaises, dans le processus de désenregistrement au Registre du Commerce de
la Chambre de Commerce de Curaçao sous le numéro 56083, avec siège social à Pietermaai 123, Curaçao, Antilles
Néerlandaises.

II. Le capital social émis de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté

par cinq cents (500) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, entièrement libéré.

III. L'Associé, représenté ci-dessus, a reconnu être totalement informé des résolutions devant être prises sur la base

de l'agenda suivant:

126889

<i>Agenda

1 Approbation des résolutions prises par le seul associé relatives au transfert de l'administration centrale et du siège

social de la Société, sans dissolution, de Curacao, Antilles Néerlandaises, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
avec effet au 1 

er

 octobre 2008;

2 Transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société, sans dissolution, de Curaçao, Antilles Néer-

landaises, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1 

er

 octobre 2008;

3 Adoption de la nationalité luxembourgeoise et soumission de la Société aux lois luxembourgeoises, adoption de la

forme légale d'une "société à responsabilité limitée" et changement du nom de la Société en "Global Retail Corporation
S.à r.l."

4 Approbation d'un bilan intérimaire de la Société au 1 

er

 octobre 2008 incluant le rapport du gérant.

5 Refonte complète des statuts de la Société dans le but de les mettre en conformité avec les lois luxembourgeoises.
6 Détermination de l'adresse du siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
7 Nomination des personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée illimitée:
* Mme Polyxeni Kotoula, dont l'adresse professionnelle est 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, née à Athènes, Grèce, le 30 novembre 1973;

* Mr Jorge Perez Lozano, dont l'adresse professionnelle est 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, né à Mannheim, Allemagne, le 17 Août 1973;

IV. L'Associé, représenté comme mentionné ci-dessus, a demandé au notaire d'enregistrer les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé d'approuver les résolutions de l'Associé prises le 30 septembre 2008 dans les Antilles Néerlandaises

qui décident, entre autres:

* de transférer l'administration centrale et le siège social de la Société, sans dissolution, de Curaçao, Antilles Néer-

landaises, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

* de fixer la date d'effectivité du transfert de Curaçao, Antilles Néerlandaises, à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg, au 1 

er

 octobre 2008.

Ces résolutions de l'Associé après signature ne varietur par le comparant et le notaire resteront jointes au présent

acte.

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé de transférer le siège social et le principal établissement de la Société, sans dissolution, de Curaçao,

Antilles Néerlandaises, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sans dissolution, avec effet au 1 

er

 octobre 2008.

L'Associé a décidé qu'en conséquence d'un tel transfert, la Société adopte la nationalité luxembourgeoise, est soumise

aux lois luxembourgeoises et adopte la forme légale d'une "société à responsabilité limitée".

L'Associé a également décidé que la Société changera son nom en "Global Retail Corporation S. à r.l."

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé d'approuver un bilan intérimaire de la Société au 1 

er

 octobre 2008 préparé conformément aux

principes comptables généralement acceptés dans les Antilles Néerlandaises et qui inclue un rapport du gérant. Confor-
mément à un tel bilan, la valeur des biens et des dettes de la Société correspond au moins au capital social émis de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500) divisé en cinq cents (500) actions de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et à la prime
d'émission d'un million cinq cent soixante-dix mille euros (EUR 1.570.000).

Le bilan intérimaire prémentionné, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, restera

annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

<i>Quatrième résolution

L'Associé a conclu de procéder à une refonte totale des statuts de la Société dans le but de les mettre en conformité

avec les lois luxembourgeoises. L'Associé a conclu que les statuts seront dorénavant lus comme suit et seront rédigés
en anglais pour être suivis par une traduction française, la version anglaise faisant foi en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la "Société") régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les "Lois"), et par les présents statuts (les "Statuts").

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination "Global Retail Corporation S. à r.l."

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

126890

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par

décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social

sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement  le  siège  social  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales.  Ces  mesures
provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
les Gérants.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et

entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés

sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier

ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à

ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime

utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de

majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 28 des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts Sociales

Art. 5. Capital Emis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) divisé en cinq

cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte
nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné

ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession

n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article
1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement

adoptées par les associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou

plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement

similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérants, Commissaires aux Comptes

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés

(les "Gérants").

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

126891

Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants

peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") ou

Gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B").

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la

compétence des Gérants.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des

mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe

de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne

sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie
B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes

s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le "Président"). Il peut également nommer un

secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
de Gérance (le "Secrétaire").

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera

un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra

être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera
requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par

tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est

présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie
B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B
sont présents.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout

autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire

(s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,

pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

126892

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une

rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction

de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre
un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lors-

que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas

échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de
toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce
cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable
de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes
susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 17. Commissaires aux Comptes. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes

consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa
situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être
contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) aux compte(s) ou réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront, le cas échéant, nommés par

les Associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent
être  révoqués  à  tout  moment,  avec  ou  sans  motif,  par  une  résolution  des  associés  sauf  dans  les  cas  où  le  réviseur
d'entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

Chapitre IV. Des associés

Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si

la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des
associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Art. 19. Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les

résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou
plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter
ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze
(15)  jours  calendaires  suivant  la  réception  du  texte  de  la  résolution  proposée,  d'exprimer  leur  vote  par  écrit  en  le
retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à
l'adoption de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social

de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que
des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 20. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi

se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des

126893

Gérants, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du

jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale
d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été

dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 21. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte

écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

Art. 22. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée

par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale
des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les associés participant à l'assemblée générale des as-

sociés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 23. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de

la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par
écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront à la majorité simple, indépen-
damment du nombre de parts sociales représentées.

Lors  de  toute  assemblée  générale  des  associés,  convoquée  conformément  aux  Statuts  ou  aux  Lois,  en  vue  de  la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la majorité en nombre des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Art. 24. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents

et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées

générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

Chapitre V. Exercice Social, Comptes Annuels, Distribution des Bénéfices

Art. 25. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et s'achève le dernier jour de décembre

de chaque année.

Art. 26. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les

Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.

Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours
calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 27. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la "Réserve Légale"), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils

peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à
nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés,
chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants

peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi
que la date de paiement de tels acomptes.

126894

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 28. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-

sédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être

une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par
les règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi Applicable

Art. 29. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Cinquième résolution

L'Associé a décidé de fixer l'adresse du siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

<i>Sixième résolution

L'Associé a décidé de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée illimitée:
* Mme Polyxeni Kotoula, dont l'adresse professionnelle est 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, née à Athènes, Grèce, le 30 novembre 1973;

* M. Jorge Perez Lozano, dont l'adresse professionnelle est 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, né à Mannheim, Allemagne, le 17 août 1973.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont

estimés à dix mille trois cents euros (EUR 10.300,-).

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Weirauch et M. Schaeffer.
Enregistré  à  Luxembourg  A.C.,  le  6  octobre  2008,  LAC/2008/40471.  -  Reçu  sept  mille  neuf  cent  quatorze  euros

soixante et onze cents (EUR 0,50% = 7.914,71).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008131149/5770/666.
(080153116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2008.

UMZ-Umweltmanagement Zens GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6832 Betzdorf, Déponie Sigre.

R.C.S. Luxembourg B 44.047.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UMZ-UMWELTMANAGEMENT ZENS GMBH
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2008131765/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03678. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

126895

Shell Finance Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 79.812.

In the year two thousand and eight, on the twelfth of September.
Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

The private limited liability company "Shell Luxembourgeoise", with registered office at 7, rue de l'Industrie, L-8069

Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed dated March 31st, 1920, inscribed in the Trade
and Companies' Register Luxembourg, section B, under the number 7.479 (the Single Shareholder),

here represented by Mr. Hans SEVENANTS, Head of Legal Belgian Shell NV and Shell Luxembourgeoise, residing in

Kiezelstraat 2A, 3350 Linter, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the private limited liability company "Shell Finance

Luxembourg" with registered office at 7, rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, inscribed in
the Trade and Companies' Register Luxembourg, section B, under the number 79,812, incorporated pursuant to a deed
of the notary Frank BADEN, then residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg, on December 14th, 2000,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 590 of the 31st of July 2001, (the Company),
and whose articles of association (the Articles) have amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary on January 31st, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 993 of the 22nd
of April 2008.

The Single Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. the Single Shareholder holds all the 133,861 shares of a nominal value of USD 1,210 each in the share capital of the

Company amounting to USD 161,971,810 and the Single Shareholder exercises the powers of the general meeting of the
shareholder in accordance with article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

II. the Single Shareholder declares to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

<i>Agenda:

1. Waiver of the convening notice.
2. Increase of the issued share capital of the Company by 29,150,110.- USD, so as to raise it from its present amount

of 161,971,810.- USD to 191,121,920.- USD.

3. Issue of 24,091 new shares, so as to raise the actual number of shares from 133,861 shares, each with a nominal

value of 1,210.- USD, to 157,952 shares.

4. Acceptance of the subscription to 24,091 new shares by B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch

(PAM LB), acceptance of the full payment for such shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities
of PAM LB constituting an entire branch of activity and having an aggregate value of 4,400,390,458.- USD, with a total
share premium on such shares of 4,371,240,348.- USD, allocation of the newly issued shares to PAM LB in consideration
for such contribution and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

5. Amendment of the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association so as to reflect the resolutions

to be adopted under items 2. to 4 of the agenda.

6. Amendment of the share register of the Company to reflect the above changes.
7. Miscellaneous.

<i>First resolution

Representing the entire share capital of the Company, the Single Shareholder waives the convening notices, considers

itself as duly convened and declares to have full knowledge of the purpose of the present meeting, which has been
communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The single shareholder has resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of twenty-nine

million one hundred and fifty thousand one hundred and ten US Dollars (29,150,110.- USD) so as to raise it from its
present amount of one hundred and sixty-one million nine hundred and seventy-one thousand eight hundred and ten US
Dollars (161,971,810.-USD) to an amount of one hundred and ninety-one million one hundred and twenty one thousand
nine hundred and twenty US Dollars (191,121,920.-USD).

126896

<i>Third resolution

The single shareholder has resolved to issue twenty-four thousand and ninety-one (24,091) new shares so as to raise

the number of shares from one hundred and thirty-three thousand eight hundred and sixty-one (133,861) shares, each
with a nominal value of one thousand two hundred and ten US Dollars (1,210.- USD), to one hundred and fifty-seven
thousand nine hundred and fifty-two (157,952) shares, each with a nominal value of one thousand two hundred and ten
US Dollars (1,210.- USD), those shares having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends
as from the day of adoption of the present resolution.

<i>Subscription and allotment

There now appeared Mr. Hans SEVENANTS, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of

"B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch", with registered office at 46a, boulevard John-F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, inscribed in the Trade and Companies' Register Luxembourg, section
B, under the number 129.270, by virtue of a proxy given in Luxembourg under private seal, which proxy, after having
been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be
recorded with it.

The person appearing has declared to subscribe in the name and on behalf of the said company, represented by its

Luxembourg branch, to the newly issued shares of the Company as follows:

Name of subscriber, Number of shares subscribed
"B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch", 24,091
The said subscriber has declared through his duly appointed attorney-in-fact to make payment in full, including the

share premium, for all such new shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of PAM LB
constituting an entire branch of activity (the Assets and Liabilities).

The Assets and Liabilities thus contributed represent a net contribution in kind in an aggregate amount of four billion

four hundred million three hundred and ninety thousand four hundred and fifty-eight US Dollars (4,400,390,458.- USD)
is to be allocated as follows:

(i) an amount of twenty-nine million one hundred and fifty thousand one hundred and ten US Dollars (29,150,110.-

USD) to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) an aggregate amount of four billion three hundred and seventy-one million two hundred and forty thousand three

hundred and forty-eight US Dollars (4,371,240,348.- USD) to the premium reserve of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Assets and Liabilities to the Company is evidenced by a certificate

dated 10th September 2008, issued by the management of B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch
that:

(1)"the Assets and Liabilities contributed to the Company are shown on the attached pro forma balance sheet as per

12th September 2008 (the Balance Sheet);

(2) based on generally accepted accountancy principles the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the

Company per the Balance Sheet is valued at least at 4,400,390,458.- USD and since the Balance Sheet date no material
changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;

(3) the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by B.V. Petroleum Assurantie Maat-

schappij Luxembourg Branch and they are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting
their transferability or reducing their value; and

(4) all formalities to transfer the legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been

or will be accomplished by the managers of B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch."

A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The subscriber, acting through his attorney in fact, has stated that there exist no impediments to the free transferability

of the Assets and Liabilities to the Company without any restriction or limitation and that instructions have been given
to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Assets and
Liabilities to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of the Assets and Liabilities has been given to the undersigned Notary.

<i>Fourth resolution

The Single Shareholder has resolved to accept the subscription of twenty-four thousand and ninety-one (24,091) new

shares by "B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch", with registered seat office at 46a, boulevard
John-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to accept payment in full of each of these shares
by a contribution consisting in the Assets and Liabilities and to allocate the newly issued shares to the contributor,
represented by its Luxembourg branch in consideration for such contribution.

The Single Shareholder has acknowledged the certificate dated 10th September, 2008 issued by the management of

"B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij" which confirms inter alia that "B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Lux-
embourg Branch" is organized from a technical point of view so to function as an autonomous business from its head-
office, "B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij", a copy of this certificate, after having been signed "ne varietur" by the

126897

proxy-holder of the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the articles

of association of the Company, which shall have the following wording:

"The capital is set at one hundred and ninety-one million one hundred and twenty one thousand nine hundred and

twenty US Dollars (191,121,920.-USD), divided into one hundred and fifty-seven thousand nine hundred and fifty-two
(157,952) shares of a nominal value of one thousand two hundred ten US Dollars (1,210.- USD) each."

<i>Sixth resolution

The shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

empowers and authorizes any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the
above changes in the share register of the Company.

<i>Statement

Insofar as the contribution in kind results in "B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch", the Lux-

embourg branch of a company which has its place of effective management and statutory seat in a Member State of the
European Union, contributing all its assets and liabilities, constituting an entire branch of activity to the Company which
has its place of effective management and statutory seat in a Member State of the European Union, the latter refers to
Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for a capital tax exemption in such case.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately six thousand and eight hundred
Euros.

For the purposes of the registration the total amount of the capital increase and the share premium is evaluated at

12,000.- EUR.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing person,
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing person, are known to the notary by his first and last name, civil status

and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, am zwölften September.
vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Shell Luxembourgeoise", mit Sitz in 7, rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange,

(Großherzogtum Luxemburg), gegründet durch notarielle Urkunde vom 31. März 1920, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 7.479,

hier vertreten durch Herrn Hans SEVENANTS, Leiter der Rechtsabteilung der Belgian Shell NV und Shell Luxem-

bourgeoise,  wohnhaft  in  Kiezelstraat  2A,  3350  Linter,  (Belgien),  auf  Grund  einer  ihm,  in  Luxemburg  privatschriftlich
erteilten Vollmacht.

Nachdem der Bevollmächtigte und der unterzeichnete Notar die Vollmacht "ne varietur" unterschrieben haben, ver-

bleibt sie der vorliegende Urkunde beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung "Shell Finance Luxembourg", mit Sitz in 7, rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange, (Großherzogtum Luxemburg),
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 79.812, gemäß Urkunde
des Notars Frank BADEN, mit damaligen Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 14. Dezember 2000
gegründet, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 590 vom 31. Juli 2001, (die
Gesellschaft), und deren Satzung zuletzt gemäß Urkunde des urterzeichneten Notars am 31. Januar 2008 geändert wurde,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 993 vom 22. April 2008.

Die alleinige Gesellschafterin ersucht den unterzeichneten Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die alleinige Gesellschafterin hält alle 133,861 Anteile mit einem jeweiligen Nennwert von USD 1.210,- des Gesell-

schaftsvermögens,  das  sich  auf  USD  161.971.810,-  beläuft,  und  die  alleinige  Gesellschafterin  übt  die  Befugnisse  der
Generalversammlung der Anteilseigner nach Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften, in geänderter Fassung, aus.

126898

II. Die alleinige Gesellschafterin erklärt, dass sie umfassend Kenntnis von den nach folgender Tagesordnung zu fassenden

Beschlüssen hat:

<i>Tagesordnung:

1. Verzicht auf Ladung.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von USD 29.150.110,-, um es von seinem jetzigen Betrag von

USD 161.971.810,-auf USD 191.121.920,- zubringen.

3. Ausgabe von 24.091 neuen Anteilen, um die Zahl der gegenwärtigen 133.861 Anteile, jeder mit einem Nennwert

von USD 1.210,- auf 157.952 Anteile zu erhöhen.

4. Annahme der Zeichnung von 24.091 neuen Anteilen durch die Luxemburger Zweigstelle der "B.V. Petroleum As-

surantie  Maatschappij  Luxembourg  Branch"  (PAM  LB),  Annahme  der  vollen  Einzahlung  dieser  Anteile  durch  eine
Sacheinlage in Form von sämtlichen Aktiva und Passiva der PAM LB, eine Gesamtbetriebstelle mit einem Gesamtwert
von USD 4.400.390.458,- inklusive eines Aufgelds von insgesamt USD 4.371.240.348,- und Zuweisung der neuen Anteile
an PAM LB, als Gegenwert für diese Sacheinlage und Anerkennung der Wirksamkeit der Kapitalerhöhung.

5. Neufassung des ersten Absatzes von Artikels 6 der Satzung, um die Beschlüsse, welche unter den Punkten 2) bis 3)

gefasst werden, wiederzugeben.

6. Infolge der vorgenannten Beschlüsse, Abänderung des Anteilsregister der Gesellschaft.
7. Verschiedenes.

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin, die das gesamte Gesellschaftskapital hält, verzichtet auf Ladung und betrachtet sich als

ordnungsgemäß geladen und erklärt umfassende Kenntnis von dem Zweck dieser Versammlung zu haben, der ihr vorab
mitgeteilt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von neunundzwanzig Millionen

einhundertfünfzigtausendeinhundertzehn US Dollar (USD 29.150.110,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag
von  einhunderteinundsechzig  Millionen  neunhunderteinundsiebzigtausendachthundertzehn  US  Dollar  (USD
161.971.810,-)  auf  den  Betrag  von  einhunderteinundneunzig  Millionen  einhunderteinundzwanzigtausendneunhundert-
zwanzig US Dollar (USD 191.121.920,-) zu bringen.

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin hat die Ausgabe von vierundzwanzigtausendeinundneunzig (24.091) neuen Anteilen be-

schlossen, um die Zahl der gegenwärtigen einhundertdreiunddreißigtausendachthunderteinundsechzig (133.861) Anteile,
jeder mit einem Nennwert von eintausendzweihundertzehn US Dollar (USD 1.210,-), auf einhundertsiebenundfünfzig-
tausendneunhundertzweiundfunfzig (157.952) Anteile zu erhöhen, jeder mit einem Nennwert von eintausendzweihun-
dertzehn US Dollar (USD 1.210,-), diese Anteile haben die gleichen Rechte und Privilegien wie die ausgegebenen Anteile
und berechtigen zu Dividenden ab dem Tag der Annahme dieses Beschlusses.

<i>Zeichnung und Ausgabe

Daraufhin ist erschienen Herr Hans SEVENANTS, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßiger Be-

vollmächtigter der Luxemburger Zweigstelle "B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch", mit Sitz in
46a, boulevard John-F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg), eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 129.270, auf Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg,
die vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde, und der gegenwärtigen
Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Der Erschienene erklärt im Namen und zugunsten dieser Gesellschaft, vertreten durch ihre Luxemburger Zweigstelle,

die neuen Anteile der Gesellschaft wie folgt zu zeichnen:

Name des Zeichners, Anzahl der gezeichneten Anteile
"B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch", 24.091
Der besagte Zeichner hat durch seinen rechtmäßig bestellten Bevollmächtigten erklärt, diese Anteile, inklusive eines

Aufgelds, durch Einbringung einer Sacheinlage ir: Form von sämtlichen Aktiva und Passiva der Luxemburger Zweigstelle
welche einer Gesamtbetriebstelle entsprechen, ohne jegliche Einschränkung, voll einzuzahlen (die Aktiva und Passiva).

Die Aktiva und Passiva, die durch eine Sacheinlage eingebracht wird, haben einen Gesamtwert von vier Milliarden

vierhundert Millionen dreihundertneunzigtausendvierhundertachtundfünfzig US Dollar (USD 4.400.390.458,-) und wer-
den wie folg zugewiesen:

1. ein Betrag von neunundzwanzig Millionen einhundertfünfzig-tausendeinhundertzehn US Dollar (USD 29.150.110,-)

dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen und

2. der Gesamtbetrag von vier Milliarden dreihunderteinundsiebzig Millionen zweihundertvierzigtausenddreihunder-

tachtundvierzig US Dollar (USD 4.371.240.348,-) dem Posten "Aufgeld" zugewiesen.

126899

Die Bewertung der Aktiva und Passiva, die durch eine Sacheinlage eingebracht werden wird durch ein Gutachten vom

10. September 2008 von den Mitgliedern des Verwaltungsrates der B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg
Branch bescheinigt, das:

(1) "die in die Gesellschaft eingebrachten Aktiva und Passiva sind in der beigefugten vorläufigen Bilanz zum 12. Sep-

tember 2008 (die Bilanz) angegeben;

(2) aufgrund allgemein anerkannter Bilanzierungsgrundsätze ist der Nettowert der in die Gesellschaft eingebrachten

Aktiva und Passiva nach der Bilanz mit wenigstens USD 4.400.390.458,- zu bewerten und seit dem Bilanzstichtag geschahen
keine wesentlichen Änderungen, die die Einlage in die Gesellschaft vermindert hätten;

(3) die in die Gesellschaft eingebrachten Aktiva und Passiva können von B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Lu-

xembourg  Branch  frei  übertragen  werden  und  unterliegen  keiner  Beschränkung  und  sind  weder  Gegenstand  einer
Verpfandung oder einer dinglichen Belastung, die ihre Übertragbarkeit beeinträchtigt oder ihren Wert mindert; und

(4) alle Formalien für die Übertragung des Eigentums der in die Gesellschaft eingebrachten Aktiva und Passiva sind

oder werden von den Verwaltungsratsmitgliedern von B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch er-
füllt."

Eine Kopie der genannten Dokumente bleibt, nachdem sie von dem Bevollmächtigten im Namen der erschienenen

Parteien und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um
mit derselben hinterlegt zu werden.

Der Zeichner, handelnd durch seinen Bevollmächtigten, hat erklärt, dass kein Grund vorliegt, der die freie Übertragung

der Aktiva und Passiva, ohne Einschränkung, an die Gesellschaft verhindern könnte, und dass ordnungsgemäße Anwei-
sungen zur Bekanntmachung, Eintragung und der weiteren Formalien, die notwendig sind, um die Aktiva und Passiva an
die Gesellschaft zu übertragen, erteilt wurden.

Der Eigentumsnachweis des Zeichners der Aktiva und Passiva wurde dem amtierenden Notar erbracht.

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin hat die Annahme der Zeichnung der vierundzwanzigtausendeinundneunzig (24.091) neuen

Anteile durch die "B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch", mit Sitz in 46a, boulevard John-F. Ken-
nedy, L-1855 Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg), mittels voller Einzahlung dieser Anteile durch die Einbringung
einer Sacheinlage in Form von Aktiva und Passiva, und die Zuweisung der neu ausgegebenen Anteile an den Einleger,
vertreten durch seine Luxemburger Zweigstelle, als Gegenwert für diese Sacheinlage beschlossen.

Die alleinige Gesellschafterin hat die am 10. September 2008, durch die Geschäftsführung der "B.V. Petroleum Assu-

rantie Maatschappij", ausgestellte Bescheinigung anerkannt, welche unter anderem bestätigt, dass die "B.V. Petroleum
Assurantie Maatschappij Luxembourg Branch" vom technischen Sichtpunkt ausgesehen, so organisiert ist, um eigenständig
von ihrem Sitz aus zu funktionieren, eine Kopie dieser Bescheinigung, vom Bevollmächtigten der erschienen Partei und
dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben
hinterlegt zu werden.

<i>Fünfter Beschluss

Infolge der vorgenannten Beschlüsse haben die Gesellschafter beschlossen, den ersten Absatz von Artikel 6 der Satzung

der Gesellschaft abzuändern, der folgenden Wortlaut erhalten wird:

"Das  Gesellschaftskapital  ist  auf  einhunderteinundneunzig  Millionen  einhunderteinundzwanzigtausendneunhundert-

zwanzig US Dollar (USD 191.121.920,-) festgesetzt, eingeteilt in einhundertsiebenundfünfzig-tausendneunhundertzwei-
undfünfzig (157.952) Gesellschaftsanteile, jeder mit einem Nennwert von eintausendzweihundertzehn US Dollar (USD
1.210,-)."

<i>Sechster Beschluss

Infolge der vorgenannten Beschlüsse beschließen die alleinigen Gesellschafter das Anteilsregister der Gesellschaft zu

ändern und ermächtigt jeden Geschäftsführer, durch seine/ihrer Einzelunterschrift und für Rechnung der Gesellschaft, die
neu ausgegebenen Anteile in das Gesellschaftsregister einzutragen.

<i>Erklärung

Sowie aus der Einbringung der Sacheinlage hervorgeht, dass "B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij Luxembourg

Branch", die Luxemburger Zweigstelle einer Gesellschaft mit Hauptverwaltungssitz und Gesellschaftssitz in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, seine sämtlichen Aktiva und Passiva, welcher einer Gesamtbetriebstelle entsprechen,
in die Gesellschaft einbringt, nimmt Letztere Bezug auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher in
diesem Fall eine Steuerbefreiung vorsieht.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr sechstausendachthundert
Euro.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird der Gesamtbetrag der Kapitalerhöhung und des Aufgelds auf 12.000,-

Euro abgeschätzt.

126900

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen

Person, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben
erschienenen Person, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die englische
Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem unterzeichneten Notar nach Vor- und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, hat dieser zusammen mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: SEVENANTS - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 septembre 2008. Relation GRE/2008/3791. — Reçu Douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 15 octobre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008131934/231/295.
(080154290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Prime Properties Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.389.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Noëlle PICCIONE. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 28 mars 2008.

C. BONVALET / C. PISVIN
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008132063/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04553. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

AFD Saint Martin C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 112.940.

In the year two thousand and eight, on the twenty third of September.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ArcIndustrial France Developments I S.à r.l a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 6C, parc d'Activités Syrdall, L-5365, Munsbach, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 112.938 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Alain THILL, private employee, residing professionally at 3, route de Luxembourg, L-6130,

Junglinster,

by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities,

The appearer has requested the undersigned notary to record the following:
I. That it is the Sole Shareholder of AFD Saint Martin C S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company (société

à responsabilité limitée), having its registered office at 6C, parc d'Activités Syrdall in L-5365, Munsbach, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 112.940, incorporated pursuant to a deed of Maître
André SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, on December 19, 2005, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Number 597 of March 22, 2006.

The articles have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Jean SECKLER, prenamed, on

August 26, 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

126901

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 46,375 (forty six thousand three hundred seventy

five euro) in order to bring the share capital from its former amount of EUR 780,750 (seven hundred eighty thousand
seven hundred fifty euro) to EUR 827,125 (eight hundred twenty seven thousand one hundred twenty five euro), by way
of the issue of 371 (three hundred seventy one) new shares with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro)
each, together with a share premium of EUR 111 (one hundred eleven euro).

2. Subscription and payment to the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted

under item 1.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any employee of Management &amp; Accounting Services S.à r.l. to proceed on
behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 46,375

(forty six thousand three hundred seventy five euro) in order to bring the share capital from its former amount of EUR
780,750 (seven hundred eighty thousand seven hundred fifty euro) to EUR 827,125 (eight hundred twenty seven thousand
one hundred twenty five euro), by way of the issue of 371 (three hundred seventy one) new shares with a par value of
EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each, together with a share premium of EUR 111 (one hundred eleven euro).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital of the Company in the

amount of EUR 46,375 (forty six thousand three hundred seventy five euro) and it fully pays it up by a contribution in
cash in an aggregate amount of EUR 46,486 (forty six thousand four hundred eighty six euro) which is evidenced to the
notary by a certificate of blockage and which shall be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 46,375 (forty six thousand three hundred seventy five euro) is to be allocated to the nominal

share capital account of the Company, and

(ii) an amount of EUR 111 (one hundred eleven euro) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:

ArcIndustrial France Developments I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,617 shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,617 shares

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it

shall henceforth read as follows:

"5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 827.125 (eight hundred twenty seven thousand one hundred

twenty five euro), represented by 6.617 (six thousand six hundred seventeen) shares in registered form with a par value
of EUR 125 (one hundred twenty- five euros) each, all subscribed and fully paid up."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers

and authorizes any manager of the Company and any employee of Management &amp; Accounting Services S.à.r.l. to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at one thousand five hundred euro.

Whereof the present notarial deed is drawn in Junglinster, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

126902

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Arc Industrial France Developments I S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6C, parc d'Activités Syrdall, L-5365, Munsbach, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.938,

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci,

La comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Qu'elle est l'Associée Unique de AFD Saint Martin C S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 6C, parc d'Activités Syrdall à L-5365, Munsbach, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.940, constituée suivant un acte du notaire André
SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre, 2005, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Numéro 597 du 22 mars 2006.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean

SECKLER, prénommé, le 26 août 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 46.375 (quarante six mille trois cent soixante

quinze euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 780.750 (sept cent quatre vingt mille sept
cent cinquante euros) à EUR 827.125 (huit cent vingt sept mille cent vingt cinq euros) par l'émission de 371 (trois cent
soixante et onze) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros)
chacune, avec une prime d'émission de EUR 111 (cent onze euros).

2. Souscription et paiement de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital spécifiée au point 1.
4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société et à tout employé de Management &amp; Accounting Services S.à.r.l. de procéder au nom de la
Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

5. Divers.
III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de EUR

46.375 (quarante six mille trois cent soixante quinze euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR
780.750 (sept cent quatre vingt mille sept cent cinquante euros) à EUR 827.125 (huit cent vingt sept mille cent vingt cinq
euros) par l'émission de 371 (trois cent soixante et onze) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, avec une prime d'émission de EUR 111 (cent onze euros).

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération intégrale de l'augmentation du capital

social comme suit:

<i>Souscription - Libération

L'Associée Unique déclare souscrire à l'augmentation de capital de la Société d'un montant de EUR 46.375 (quarante

six mille trois cent soixante quinze euros) et de la payer par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 46.486
(quarante six mille trois cent soixante quinze euros) documenté au notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté
de la manière suivante:

(i) un montant de EUR 46.375 (quarante six mille trois cent soixante quinze euros) sera affecté au compte capital

nominal de la Société,

(ii) un montant de EUR 111 (cent onze euros) sera affecté au compte prime d'émission de la Société.
Le montant de l'augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au

notaire instrumentant.

L'Assemblée décide d'acter que l'actionnariat de la Société suite à l'augmentation de capital est comme suit:

ArcIndustrial France Developments I S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.617 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.617 parts sociales

126903

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte qu'il

aura la teneur suivante:

"5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 827.125 (huit cent vingt sept mille cent vingt cinq euros) représenté

par 6.617 (six mille six cent dix-sept) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-
cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement, libérées."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-

dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de Management &amp; Accounting
Services S.à.r.l. de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le
registre des parts sociales de la Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi

en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent

acte avec nous, Notaire.

Signé: THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 septembre 2008, Relation GRE/2008/3848. — Reçu deux cent trente-deux euros

et quarante-trois cents.

0,5%: 232,43 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 16 octobre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008131937/231/163.
(080154277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Temtex Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 129.581.

Im Jahre zweitausendacht, am vierundzwanzigsten September,
Vor dem unterzeichneten Notar Karine REUTER, mit Amtssitz in Redange/Attert.

Sind die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft TEMTEX MANAGEMENT SA, mit Sitz in L-1371 LUXEMBURG, 223 Val

Sainte Croix zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen vor dem unterzeichneten Notar Karine REUTER,

am 2.Juli 2007,

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 24.August 2008, Nummer 1.798, Seite 86.262.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Josef Dobelke, geboren am 28. Oktober 1936, wohnhaft Eschen-

weg 2, D-53177 Bonn. Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Erwin Reimund Blug, geboren am 03Juli 1952, wohnhaft
Wiesenstrasse 29, D-66636 Tholey.

Zum  Stimmzähler  wird  ernannt  Frau  Anke  Doberstein,  geboren  am  13.  Juni  1967,  wohnhaft  Levelingstrasse  19,

D-54293 Trier.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar

zu Protokoll genommen werden:

a) Aus der beigefügten Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung

zugegen oder rechtlich vertreten sind;

b) Die Generalversammlung ist, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmässig zusammenge-

setzt und kann somit gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden;

c) Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1.- Sitzverlegung von 223, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, nach L-54444 Schengen,5,rue Baachergaass:

126904

2. Abänderung von Artikel 2 Absatz 2 der Statuten im ihm folgenden Inhalt zu geben:
«Le siège social est établi dans la Commune de Schengen»
3.- Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissars
4.- Ernennung des neuen Rechnungskommissars, der neuen Verwaltungsratsmitgliedern sowie des Präsidenten des

Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende trägt daraufhin die Gründe vor, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversammlung

diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Anschliessend nimmt die Generalversammlung einstimmig über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von 223, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, nach L-5444

Schengen, 5, rue Baachergaass.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des ersten Beschlusses wird der zweite Abschnitt von Artikel 2 der Statuten abgeändert und hat fortan fol-

genden Wortlaut:

«Le siège social est établi dans la Commune de Schengen»

<i>Dritter Beschluss

Die  Versammlung  beschließt  als  Rechnungskommissar  die  REVILUX  S.A.,  societe  anonyme,  223  Val  Sainte  Croix,

L-1371 Luxembourg, mit Wirkung vom heutigen Tage abzuberufen und erteilt derselben Entlastung.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt als neuen Rechnungskommissar die Gesellschaft Fiduciaire DomoLux Sprunck

Theobald &amp; Partenaires, Experts Comptables, Société Civile (Matricule No 20067001894), eingetragen im Handelsregister
Luxemburg unter der Nummer E 3.253, mit Sitz in L-5444 Schengen, 5, rue Baachergaass zu ernennen.

Die Ernennung erfolgt auf unbestimmte Dauer.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Demission der Verwaltungsratsmitglieder, nämlich von:
Herrn Jean FABER, expert-comptable, geschäftsansässig in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt
Herrn Didier KIRSCH, geschäftsansässig in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt
Frau Marie-Helene MOSCHINI, geschäftsansässig in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt
Die Generalversammlung erteilt ihnen Entlastung.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung ernennt mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit zu neuen Verwaltungsratsmit-

gliedern:

Herrn Josef Dobelke, geboren am 28.Oktober 1936 in Bonn, numéro de matricule 1936 10 28 573, wohnhaft Eschen-

weg 2, D-53177 Bonn.;

-  Herrn  Erwin  Reimund  Blug,  geboren  am  3.  Juli  1952  in  Lindscheid  (  Deutschland),  wohnhaft  Wiesenstrasse  29,

D-66636 Tholey,

- Frau Anke Doberstein, geboren am 13. Juni 1967 in Hille ( Deutschland), numéro de matricule 1967 06 13 642,

wohnhaft Levelingstrasse 19, D-54293 Trier,

Das Verwaltungsratsmitglied Erwin Reimund Blug wird zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Herr Erwin

BLUG kann die Gesellschaft unter allen Umständen - einschliesslich aller Bankgeschäften - durch seine alleinige Unters-
chrift rechtskräftig vertreten und verpflichten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg-Stadt,
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll

unterschrieben.

Signé: Dobelke, Blug, Doberstein, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, le 25 septembre 2008. Relation: RED/2008/1145. - Reçu douze euros 12,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Redange/Attert, le 2 octobre 2008.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2008131947/7851/78.
(080154441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

126905

A-TV Worldwide Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.996.

<i>Extract of the Annual General Meeting of the Shareholders on April 21st, 2008

The resignation of the company EFFIGI S.à r.l. is accepted. Mrs Cynthia SCHWICKERATH, private employee, pro-

fessionally residing 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg born on July 30th, 1974 is appointed as new Director in
its replacement. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2011.

For true copy

Suit la traduction française de ce qui précède:

La démission de la société EFFIGI S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit Luxembourgeois avec siège social

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est acceptée. Mademoiselle Cynthia SCHWICKERATH est nommée com-
me nouvel Administrateur en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2011.

Mademoiselle Cynthia SCHWICKERATH réside professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

Certifié sincère et conforme
<i>A-TV WORLDWIDE MARKETING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2008132064/795/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02630. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

AFD Rivesaltes A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 114.005.

In the year two thousand and eight, on the twenty third of September.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ArcIndustrial France Developments I S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 112.938 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Alain THILL, private employee, residing professionally at 3, route de Luxembourg, L-6130

Junglinster,

Which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities,

The appearer has requested the undersigned notary to record the following:
I. That it is the Sole Shareholder of AFD Rivesaltes A S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company (société

à responsabilité limitée), having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall in L-5365 Munsbach, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.005, incorporated pursuant to a deed of Maître
André SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, on January 25, 2006, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations Number 860 of May 2, 2006.

The articles have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Jean SECKLER, prenamed,

dated August 26, 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 278.875 (two hundred seventy eight thousand

eight hundred seventy five euro) in order to bring the share capital from its former amount of EUR 1,831,000 (one million
eight hundred thirty one thousand euro) to EUR 2.109.875 (two million one hundred nine thousand eight hundred seventy
five euro), by way of the issue of 2.231 (two thousand two hundred thirty one) new shares with a par value of EUR 125
(one hundred twenty-five euro) each, together with a share premium of EUR 40 (forty euro).

2. Subscription and payment to the share capital increase specified in item 1. above.

126906

3. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted

under item 1.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any employee of Management &amp; Accounting Services S.à r.l. to proceed on
behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

278.875 (two hundred seventy eight thousand eight hundred seventy five euro) in order to bring the share capital from
its former amount of EUR 1,831,000 (one million eight hundred thirty one thousand euro) to EUR 2,109,875 (two million
one hundred nine thousand eight hundred seventy five euro), by way of the issue of 2,231 (two thousand two hundred
thirty one) new shares with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each, together with a share premium
of EUR 40 (forty euro).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription - payment

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital of the Company in the

amount of EUR 278,875 (two hundred seventy eight thousand eight hundred seventy five euro) and it fully pays it up by
a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 278,915 (two hundred seventy eight thousand nine hundred fifteen
euro) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 278,875 (two hundred seventy eight thousand eight hundred seventy five euro) is to be allocated

to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) an amount of EUR 40 (forty euro) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:

Shares

ArcIndustrial France Developments I S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,879

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,879

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it

shall henceforth read as follows:

"5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 2.109.875 (two million one hundred nine thousand eight hundred

seventy five euro), represented by 16.879 (sixteen thousand eight hundred seventy nine) shares in registered form with
a par value of EUR 125.- (one hundred twenty- five euros) each, all subscribed and fully paid up."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers

and authorizes any manager of the Company and any employee of Management &amp; Accounting Services S.à.r.l. to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at three thousand one hundred and fifty euro.

Whereof the present notarial deed is drawn in Junglinster, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

126907

ArcIndustrial France Developments I S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6C, parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.938,

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

La comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Qu'elle est l'Associée Unique de AFD Rivesaltes A S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 6C, parc d'Activités Syrdall à L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.005, constituée suivant un acte du notaire André SCHWACHTGEN,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Numéro 860 du 2 mai 2006.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean

SECKLER, prénommé, le 26 aout 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 278.875 (deux cent soixante dix huit mille huit

cent soixante quinze euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.831.000 (un million huit cent
trente et un mille euros) à EUR 2.109.875 (deux millions cent neuf mille huit cent soixante quinze euros) par l'émission
de 2.231 (deux mille deux cent trente et un) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR
125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, avec une prime d'émission de EUR 40 (quarante euros).

2. Souscription et paiement de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital spécifiée au point 1.
4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société et à tout employé de Management &amp; Accounting Services S.à.r.l. de procéder au nom de la
Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

5. Divers.
III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de EUR

278.875 (deux cent soixante dix huit mille huit cent soixante quinze euros) afin de porter le capital social de son montant
actuel de EUR 1.831.000 (un million huit cent trente et un mille euros) à EUR 2.109.875 (deux millions cent neuf mille
huit cent soixante quinze euros) par l'émission de 2.231 (deux mille deux cent trente et un) nouvelles parts sociales de
la Société, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, avec une prime d'émission de EUR 40
(quarante euros).

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération intégrale de l'augmentation du capital

social comme suit:

<i>Souscription - libération

L'Associée Unique déclare souscrire à l'augmentation de capital de la Société d'un montant de EUR 278.875 (deux

cent soixante dix huit mille huit cent soixante quinze euros) et de la payer par un apport en numéraire d'un montant total
de EUR 278.915 (deux cent soixante dix huit mille neuf cent quinze euros) documenté au notaire par un certificat de
blocage et qui sera affecté de la manière suivante:

(i) un montant de EUR 278.875 (deux cent soixante dix huit mille huit cent soixante quinze euros) sera affecté au

compte capital nominal de la Société,

(ii) un montant de EUR 40 (quarante euros) sera affecté au compte prime d'émission de la Société.
Le montant de l'augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au

notaire instrumentant.

L'Assemblée décide d'acter que l'actionnariat de la Société suite à l'augmentation de capital est comme suit:

Parts sociales

ArcIndustrial France Developments I S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.879

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.879

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte qu'il

aura la teneur suivante:

126908

"5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 2.109.875 (deux millions cent neuf mille huit cent soixante quinze

euros) représenté par 16.879 (seize mille huit cent soixante dix neuf) parts sociales sous forme nominative d'une valeur
nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-

dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de Management &amp; Accounting
Services S.à.r.l. de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le
registre des parts sociales de la Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à trois mille cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi

en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent

acte avec nous, Notaire.

Signé: THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 septembre 2008, Relation GRE/2008/3846. — Reçu Mille trois cent quatre-vingt-

quatorze euros et cinquante-huit cents

0,5%: 1.394,58 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 octobre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008131939/231/165.
(080154268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Premier I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 87.919.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth day of September,
Before Us Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Stichting Premier I B, a foundation incorporated and governed by the laws of the Netherlands, having its registered

office at Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam

hereby represented by Mr Frédéric Lahaye, employee, residing in Arlon.
by virtue of a proxy given under private seal in Amsterdam on September 23rd, 2008
Said  proxy  after  having  been  initialed  "ne  varietur"  by  the  proxy-holder  and  the  undersigned  notary  shall  remain

attached to the present deed.

The appearing party, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested

the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing party is the sole shareholder of Premier I S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B-87.919 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-
Joseph  Wagner,  notary  residing  in  Belvaux,  on  2  July  2002,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, N° 1123 on 24 July 2002. The articles of incorporation have been amended for the last time on 17 July 2002
pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N° 1213 on 16 August 2002.

II.- The Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into thirty-one (31) shares

with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

III.-  The  appearing  party,  as  sole  shareholder  of  the  Company,  declares  to  have  full  knowledge  of  the  articles  of

incorporation and the financial standing of the Company.

126909

IV.- The appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liqui-

dation and dissolution of the Company.

V.- The appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company. The dissolution

of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes
all liabilities of the Company in their current state.

VI.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate

up to the date of the dissolution of the Company.

VII.- The shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.
VIII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former

registered office of the Company, which is at 1, allée Sheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by its surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-six septembre.
Par-devant Nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Stichting Premier I B, une fondation régie par les lois hollandaises ayant son siège social au Locatellikade 1, Parnassus-

toren, 1076 AZ Amsterdam ici représentée aux fins des présentes par Mr Frédéric Lahaye, employé, demeurant à Arlon.

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Amsterdam le 23 septembre 2008.
Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis

le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est l'actionnaire unique de Premier I S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 1, allée Sheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-87.919 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par
Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Belvaux, le 2 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, N° 1123 du 24 juillet 2002. Les statuts ont été modifié la dernières fois le 17 juillet 2002 suivant acte
reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, N° 1213 du 16 août 2002.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), représenté par trente

et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euro (EUR 1000,-) chacune.

III.- La comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et

de la situation financière de la Société.

IV.- La comparante en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la

dissolution immédiates de la Société.

V.- La comparante déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société. La dissolution de la Société est

ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements
sociaux de la Société dans leur état actuel.

VI.- Par suite de cette liquidation, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.
VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la

Société, 1, allée Sheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant

par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. LAHAYE, P. DECKER.

126910

Enregistré à Luxembourg A.C, le 2 octobre 2008. Relation: LAC/2008/39918. — Reçu € 12.- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008132797/206/90.
(080155696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2008.

PPG Luxembourg Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 97.150.

EXTRAIT

Il résulte des décisions des associés de la Société tenue le 17 septembre 2008:
- La démission avec effet au 31 août 2008 de Steven Pohl de son mandat de gérant de catégorie A,
- La nomination avec effet au 17 septembre 2008 pour une durée indéterminée de Scott D. Beamer en tant que gérant

de catégorie A, né le 17 mars 1971 à Pennsylvania, U.S.A, ayant son adresse professionnelle à 32, route de Gilly, 1180
Rolle, Switzerland.

De plus il résultait des décisions des associés de la Société tenue le 10 juillet 2008:
- La démission avec effet au 12 juillet 2008 de Michael McGarry de son mandat de gérant de catégorie A,
- La nomination avec effet au 12 juillet 2008 pour une durée indéterminée de Pierre-Marie de Leener en tant que

gérant de catégorie A, né le 29 août 1957 à Anvers, Belgique, ayant son adresse professionnelle à Javastraat 2D, 2585
AM, La Haye, Pays-Bas.

Veuillez en conséquence noter que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:
- Pierre-Marie de Leener, gérant de catégorie A;
- Scott D. Beamer, gérant de catégorie A
- Stewart Kam-Cheong, gérant de catégorie B.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2008133047/1337/30.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU07039. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Compt@ssur, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6942 Niederanven, 38, Domaine Mielstrachen.

R.C.S. Luxembourg B 112.385.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente septembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Edwin Renneboog, comptable, demeurant à L-6942 Niederanven, 38, Domaine Mielstrachen.
Lequel comparant a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. COMPT@SSUR (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-6942 Niederanven, 38,

Domaine Mielstrachen inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro
112.385 que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 506 du 9 mars 2006

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) divisé en cent

(100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

III. L'Associé unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

126911

IV. L'Associé unique déclare être devenu propriétaire de l'ensemble des parts sociales de la Société et, en tant qu'as-

socié unique, représentant l'intégralité du capital social, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. L'Associé unique déclare que l'ensemble des dettes de la Société a été réglé et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs

de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa
dissolution;

VI. Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour;
VII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège de la société savoir L-6942 Nie-

deranven, 38, Domaine Mielstrachen

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant préqualifié a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. RENNEBOOG, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2008. Relation: LAC/2008/39932. — Reçu € 12.- (douze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008132799/206/36.
(080155694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Jan de Rijk Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1360 Luxembourg, Luxair Cargocenter.

R.C.S. Luxembourg B 43.917.

Veuillez trouver ci-joint le changement d'adresse de la société Jan de Rijk Luxembourg S.à.r.l à dater de ce jour.
Ancienne adresse:
Jan de Rijk Luxembourg S.à.r.l, Luxair Cargo Center Room A-101, L-1110 Luxembourg
Nouvelle adresse:
Jan de Rijk Luxembourg S.à.r.l, Luxair Cargo Center Block J-2080, L-1360 Luxembourg
Matricule:
1993 2404 403

Luxembourg le, 21 octobre 2008.

Jan de Rijk Luxembourg

Référence de publication: 2008133484/4356/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2008, réf. LSO-CV06708. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080156089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Luciepressing S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 125.576.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Fiduciaire Giloanne S.A.
18a, rue de Mondorf, L-5750 Frisange
Signature

Référence de publication: 2008133467/1217/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV03858. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080155938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

126912


Document Outline

AD Tempus Holding S.à r.l.

AD Tempus Holding S.à r.l.

AFD Rivesaltes A S.à r.l.

AFD Saint Martin C S.à r.l.

Apax Europe Maple S.à.r.l.

Arelsa Holding S.A.

A-TV Worldwide Marketing S.A.

Bagatelle Invest S.A.

Black &amp; White S.àr.l.

Byte Trust

Centrum Development S.à r.l.

Compagnie Financière Privée

Compt@ssur

Cooper Finance Group

Cooper Investment Group

CPI Asia II Holdings S.à r.l.

Crea-Concept Promotion et Immobilière S.à r.l.

Crea-Concept, S.à r.l.

Ferber S.à r.l.

Financière Daunou 17 S.A.

Garage Rech S.à r.l. et Cie

Gecomat S.A.

Global Retail Corporation S. à r.l.

H&amp;F Sensor Lux 2 S.à r.l.

Hyppolite &amp; Caderle S.A.

Hyppolite &amp; Caderle S.A.

Irus Holding Luxembourg S.à r.l.

IUEOA

Jan de Rijk Luxembourg S.à.r.l.

Jeancel

Luciepressing S.à.r.l.

Luxart S.à r.l.

Melb Holdings S.A.

Moncrest Sàrl

Nastia

Petrotec S.à r.l.

PM France Retail Investments S.à r.l.

PPG Luxembourg Holdings S.àr.l.

P&amp;Pm S.A.

Premier I S.A.

Prime Properties Investments S.A.

Pro-Concept Solutions S.àr.l.

Pro-Jardin S.à r.l.

Sapphire Shipping S.A.

Shell Finance Luxembourg

Temtex Management S.A.

Trinity - Gérance Immobilière S.à r.l.

Trois Quarts S.à r.l.

UMZ-Umweltmanagement Zens GmbH