This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2520
15 octobre 2008
SOMMAIRE
Abowijs International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
120925
Acta Priv S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120925
Admiral Participations (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120941
Alcentra Mezzanine No. 2 S.à r.l. . . . . . . . .
120959
Alianza Iberian Private Equity (Luxem-
bourg-One) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120960
A.S.M. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
120917
Bale Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120960
Böhrs + Böhrs Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
120918
Brain & More S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120914
Bugs S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120924
Callisto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120927
CaraTime S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120957
Careba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120916
Charterhouse Capri II . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120916
Chrysley Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
120914
City Apart S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120930
Colarg Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
120915
Colony HR Holding (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . .
120956
Cortec Papersystems S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
120929
East West Photo-Graphic SA . . . . . . . . . . .
120957
ECC (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
120923
Edelvys Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120924
E.L.P. European Licence Partners (Hol-
dings) S.àr.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120917
Etesian Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
120960
European Power Systems S.A. . . . . . . . . . .
120930
FBS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
120922
Financière Daunou 15 S.A. . . . . . . . . . . . . . .
120920
Florea Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120916
Fund Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120928
Gohar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120927
Haus- und Grundinvest S.A. . . . . . . . . . . . . .
120915
Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l. . . . .
120929
Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l. . . . .
120927
Hopetoun Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
120928
Huber Lux Financing Co. S.à r.l. . . . . . . . . .
120919
Icare Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120919
IDI Emerging Markets SA . . . . . . . . . . . . . . .
120926
Knollwood S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120926
Lomair Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120923
Luxflower SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120926
Macquarie Investment Management S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120920
MEIF II Luxembourg Communications S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120922
MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . .
120921
MGI Fisogest S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120956
MGI Fisogest S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120931
Miracema S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120921
Ned Lease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120923
OAK Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120914
Paddylux Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120957
Palamon Collection Holdco S.à r.l. . . . . . . .
120921
PCLease S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120918
Plénitude S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120918
Prelor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120958
Procobel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120915
Reech AiM Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120928
Sammartini S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120940
S.C. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120925
Seal Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120926
Surface Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120922
Torre Mayor Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120929
Transco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120928
Ulysses Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120917
Vargas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120931
Vignes et Terroirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120927
Vins et Domaines Finance S.A. . . . . . . . . . .
120920
Weena S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120919
X-Time S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120929
Zorin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120958
120913
OAK Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 127.418.
Constituée par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 mars 2007, acte publié
au Mémorial C no 1253 du 25 juin 2007.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OAK Investment S.A.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008125984/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09606. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080146722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Chrysley Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 127.804.
Constituée par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en
date du 4 avril 2007, acte publié au Mémorial C no 1327 du 2 juillet 2007.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CHRYSLEY INVESTMENTS S.A.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008125979/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09583. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Brain & More S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 85.625.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 08 septembre 2008i>
Les mandats des Administrateurs, à savoir, Monsieur Jean-Claude BINTZ, demeurant au 20, rue des Sangliers à L-7344
Steinsel, Monsieur Ghislain LUDWIG, demeurant au 15, rue des Prunelles à L-2353 Luxembourg et Monsieur Frank
ZEIMET, demeurant au 7, rue de la Résistance à L-5651 Mondorf-les-Bains, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée générale
annuelle de 2012.
Le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Jean-Marc Faber étant venu échéance, celui-ci est donc remplacé
par la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, est
reconduit jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
BRAIN & MORE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008126328/780/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09647. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120914
Procobel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 15.214.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2008i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l.,
ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Sabrina COLLETTE, avec
adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008126274/506/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09345. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Haus- und Grundinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 43.373.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Juli 2008i>
Der bisherige Gesellschaftssitz 26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg wird mit Wirkung vom 01. August 2008 verlegt
nach
62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg
Luxemburg, den 31. Juli 2008.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
Référence de publication: 2008126129/756/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07521. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Colarg Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 107.799.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2008.
<i>Pour Colarg Partners S.à.r.l.
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008126131/1005/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2008, réf. LSO-CV00245. - Reçu 36,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120915
Charterhouse Capri II, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 600.000,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 114.355.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31/09/2008.
<i>Pour Charterhouse Capri II S.A.
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008126136/1005/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2008, réf. LSO-CV00232. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080146362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Careba, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-5618 Mondorf-les-Bains, rue Théodore Flammang.
R.C.S. Luxembourg B 23.699.
<i>Verbesserung des Auszugsi>
<i>des Beschlusses der außerordentlichen Gesellschaftsversammlung vom 1. Januar 2002i>
Herrn Christian Arend, Geschäftsführer der Gesellschaft, wurde am 1. Januar 2002 auf unbestimmte Dauer ernannt.
Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Band C.
Careba
Unterschrift
Référence de publication: 2008126100/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU08756. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Florea Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 29.369.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Monsieur John PROSSER, demeurant 4, Brighton Place, Fox-
rock, DUBLIN 18 (Irlande) et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528, LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social
au 18a, boulevard de la Foire, L-1528, LUXEMBOURG.
L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528, LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Denise VERVAET, avec
adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528, LUXEMBOURG.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008126403/506/22.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2008, réf. LSO-CV00302. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120916
A.S.M. Investments S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 34.024.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l.,
ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Sabrina COLLETTE, avec
adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008126405/506/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09273. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
E.L.P. European Licence Partners (Holdings) S.àr.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 49.310.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/10/2008.
<i>Pour E.L.P. European Licence Partners (Holdings) S.àr.l
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2008125879/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07705. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Ulysses Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.300.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 132.623.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 11 septembre 2008 que Ulysses Participation S.à r.l. a
transféré 23.311.380 parts ordinaires à:
- SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2008.
ULYSSES FINANCE S.A R.L.
Signatures
Référence de publication: 2008126088/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2008, réf. LSO-CV00183. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120917
Böhrs + Böhrs Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 137.162.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. September 2008i>
Die Versammlung bestätigt den Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds Herrn Günter Thiel mit sofortiger Wirkung.
Zum neuen Verwaltungsratsmitglied bestellt die Versammlung Frau Edith Maerten, geb. 16.03.1957 in Wochern,
wohnhaft in 6, An der Schlaed, L-6160 Bourglinster die das Amt annimmt und bis zur ordentlichen Generalversammlung
des Jahres 2013 fortführt.
Leudelange, den 25. September 2008.
<i>Für die Versammlung
i>Unterschrift
Référence de publication: 2008126094/756/17.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09570. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080146932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
PCLease S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 72.509.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CORFI
63-65, rue de Merl, L-2146, LUXEMBOURG
<i>Experts Comptables
i>Signature
Référence de publication: 2008126075/642/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09435. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Plénitude S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 40.727.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 17 juillet 2008i>
L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Umberto TRABALDO TOGNA, demeurant au 6, Ch. Calandrini, CH-1231 Conches/Ge,
- Monsieur Massimo TRABALDO TOGNA, demeurant au 26, Alberto da Giussano, I-20145 Milan,
- Monsieur Patrick ROCHAS, Président du Conseil d'administration, demeurant au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530,
Luxembourg.
L'assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes la société MAZARS dont le siège social est
au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de
l'assemblée générale à tenir en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Patrick ROCHAS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008126369/636/22.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU01213. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120918
Icare Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 111.000.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2008i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Monsieur Guy DE CLERCQ, demeurant Cuzay, F-86120
ROIFFE et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEM-
BOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18a, boulevard
de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Denise VERVAET, avec
adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008126407/506/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09275. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Weena S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.492.
Par résolutions signées en date du 18 août 2008, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat des gérants suivants:
- Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126399/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08206. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Huber Lux Financing Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 114.314.
Par résolutions signées en date du 9 septembre 2008, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Peggy
Murphy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe
B, avec effet au 1
er
août 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2008.
Référence de publication: 2008126397/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08217. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120919
Vins et Domaines Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 110.876.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2008i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Romy CASTEL, demeurant 308, rue de Suisse,
CH-1298, CELIGNY, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528,
LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528, LUXEMBOURG.
L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528, LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Denise VERVAET, avec
adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528, LUXEMBOURG.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008126408/506/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09282. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Macquarie Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 108.283.
Par résolutions prises en date du 1
er
août 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Ian Learmonth, avec adresse professionnelle au L29, 1, Ropemaker Street, EC2Y 9HD
Londres, Royaume-Uni de son mandat de gérant, avec effet immédiat
- nomination de Philipp Graf, avec adresse professionnelle au One Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume-
Uni, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126391/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08276. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Financière Daunou 15 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 125.436.
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 septembre 2008, les actionnaires ont décidé de
nommer Benoît Chéron, avec adresse au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, au mandat d'administrateur,
avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126390/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08278. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120920
Palamon Collection Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.554.875,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 124.971.
Par résolution signée en date du 2 septembre 2008, les associés ont décidé de nommer Ennio Valerio Boccardi, avec
adresse professionnelle au 33, Cleveland House, King Street, SW1Y 6RJ Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126392/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07284. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080146911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 117.627.
Par résolutions prises en date du 8 septembre 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Klaus Thalheimer, avec adresse au 15, Am Kirchberg, 60431 Francfort, Allemagne,
de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 4 août 2008
- Nomination de Hilko Schomerus, avec adresse professionnelle au 75, Neue Mainzer Strasse, 60311 Francfort, Alle-
magne, au mandat de gérant de classe B avec effet au 8 septembre 2008 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126380/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08299. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Miracema S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 50.351.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 20 juin 2008i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l.,
ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Sabrina COLLETTE, avec
adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008126410/506/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09283. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120921
Surface Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 36.727.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2008i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l.,
ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Sabrina COLLETTE, avec
adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008126412/506/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09285. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
FBS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 317.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 72.772.
Par résolution prise en date du 3 janvier 2008, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Sandrine Van
Waveren, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant avec
effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126395/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07290. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
MEIF II Luxembourg Communications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 137.826.
Par résolutions prises en date du 8 septembre 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Klaus Thalheimer, avec adresse au 15, Am Kirchberg, 60431 Francfort, Allemagne,
de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 4 août 2008
- Nomination de Hilko Schomerus, avec adresse professionnelle au 75, Neue Mainzer Strasse, 60311 Francfort, Alle-
magne, au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126379/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08304. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120922
ECC (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 87.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.778.
Par résolutions signées en date du 31 juillet 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Mark Vincent Andrew Healey, avec adresse professionnelle à Templar House, Don
Road, JE1 2TR St Helier, Jersey, de son mandat de gérant, avec effet au 28 mai 2008
- nomination de Thomas Amy, avec adresse professionnelle à Templar House, Don Road, JE1 2TR St Helier, Jersey,
au mandat de gérant, avec effet au 28 mai 2008 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126382/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08295. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080146858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Lomair Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 96.767.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l.,
ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Sabrina COLLETTE, avec
adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008126416/506/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09292. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Ned Lease, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 24, Kiricheneck.
R.C.S. Luxembourg B 106.124.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le 1
er
mars 2008
01 L'intégralité du capital social est représentée.
02 L'assemblée Générale décide de transférer le siège social de route de Stavelot, 124, L-9991 WEISWAMPACH à
24, Kiricheneck, L-9990 WEISWAMPACH.
Frank Van Iersel / Dimitri Chaniotakis
<i>Gérant techniquei> / <i>Gérant techniquei>
Référence de publication: 2008126454/1611/15.
Enregistré à Diekirch, le 29 août 2008, réf. DSO-CT00250. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080146488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120923
Edelvys Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 83.791.
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2008, les actionnaires ont pris à l'unanimité la décision
de transférer le siège social de L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.àr.l., Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008126469/7262/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09155. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080146948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Bugs S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 99.929.
<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2008i>
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird von DREI auf VIER erhöht.
2. Das Mitglied des Verwaltungsrates Herr Raphael Heinold wird mit sofortiger Wirkung ersetzt durch Herrn Christian
Greiner, wohnhaft in Obere Kreuzgasse 24, D-90402 Nürnberg. Die Dauer des Mandats des neu ernannten Verwal-
tungsratsmitgliedes endet mit der jährlichen Gesellschafterversammlung, welche im Jahre 2011 stattfinden wird.
Als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates wird mit sofortiger Wirkung Herr Peter Oncken, wohnhaft in Hohenlo-
hestr. 8, D-90491 Nürnberg ernannt. Die Dauer des Mandats des neu ernannten Verwaltungsratsmitgliedes endet mit
der jährlichen Gesellschafterversammlung, welche im Jahre 2011 stattfinden wird.
3. Weiterhin bestätigt die Gesellschafterversammlung die bestehenden Mandate als Verwaltungsratsmitglieder von
Herrn Jürgen Zienterra, wohnhaft in Trier (D) und Herrn Markus Struzyna, wohnhaft in Trier (D). Die Mandate von
Herrn Jürgen Zienterra und Herrn Markus Struzyna erlöschen mit der in der Satzung vorgesehenen ordentlichen (jähr-
lichen) Generalversammlung, welche im Jahr 2011 stattfinden wird.
4. Gem. den Bestimmungen der in gegenwärtiger Form abgeänderten Satzung und des Gesetzes, bestätigt die Gesell-
schafterversammlung die Ermächtigung des Verwaltungsrates die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der
Gesellschaft einem oder mehreren seiner Mitglieder zu übertragen oder an jede andere durch den Verwaltungsrat bes-
timmte Person, unbeschadet den nachfolgenden Entscheidungen, welche von der oder den Personen, welche mit der
täglichen Geschäftsführung beauftragt sind (délégué(s) à la gestion journalière) nur in Verbindung mit der Unterschrift
eines Verwaltungsratsmitgliedes getroffen werden können:
1. Kreditaufnahme bei Geldinstituten
2. Abschluß von Verträgen, welche die Firma mehr als 12 Monate binden, einschließlich Mietverträge, Personalverträge,
Versicherungen, etc.
3. Kauf und Verkauf von Gegenständen, die den jeweiligen Einzelwert von 10.000,- EUR (in Worten: ZEHNTAUSEND
EURO) überschreiten.
4. Einstellung und Entlassung von Geschäftsführern und leitenden Angestellten.
5. Einstellung und Entlassung von Angestellten mit wesentlicher Verantwortung.
5. Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 01. April 2008 an die Adresse 16, Esplanade de la Moselle in L-6637
Wasserbillig verlegt.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
Bugs S.A., Société anonyme
Unterschrift
Référence de publication: 2008126452/7857/39.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09746. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
120924
S.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8808 Arsdorf, 30, rue du Lac.
R.C.S. Luxembourg B 125.657.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 3 octobre 2008.
Fiduciaire COFIGEST S.A.R.L.
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN
Isabelle PHILIPIN
Référence de publication: 2008126474/2631/15.
Enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2008, réf. DSO-CU00270. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(080147030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Abowijs International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 31.922.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2008i>
L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l.,
ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Sabrina COLLETTE, avec
adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008126413/506/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09288. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Acta Priv S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 59.923.
RECTIFICATIF
Les documents de clôture de l'année 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Ces documents de clôture de l'année 2007 remplacent les documents déposés le 08.08.2008 au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le n
o
L080117055.04.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ACTA PRIV S.A.
i>ARENDT CONSULT S.A R.L., MERSCH
Signature
Référence de publication: 2008126550/8537/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07906. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
120925
Luxflower SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 24, Op der Haart.
R.C.S. Luxembourg B 93.798.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature
Référence de publication: 2008126527/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2008, réf. DSO-CU00274. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(080146659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
IDI Emerging Markets SA, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 139.111.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par le Directoire de la Société en date du 7 juillet 2008 au siège social de la Sociétéi>
Le Directoire a notamment pris la résolution suivante:
«Peter Bieliczky est nommé président du Directoire»
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Peter BIELICZKY
<i>Président du Directoirei>
Référence de publication: 2008126528/9432/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00742. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Seal Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 98.019.
Le bilan au 31 août 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03/10/08.
Signature.
Référence de publication: 2008126518/318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09263. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Knollwood S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 127.133.
Le bilan au 9 avril 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126536/6341/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00907. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
120926
Callisto S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 93.740.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03/10/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126508/318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09021. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080147279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Gohar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 107.922.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour compte de GOHAR Sàrl
i>Fiduplan S.A.
Signature
Référence de publication: 2008126511/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00675. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 41.203.406,40.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 79.934.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126609/7832/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2008, réf. LSO-CV01375. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Vignes et Terroirs, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 130.299.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2008126591/636/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00748. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
120927
Transco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle «Um Monkeler».
R.C.S. Luxembourg B 25.082.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008126590/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00761. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080147349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Hopetoun Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 90.453.
Le bilan au 31 juillet 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29.09.08.
Bart Zech.
Référence de publication: 2008126589/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00813. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Fund Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 86.828.
Le bilan consolidé au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FUND PARTNERS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008126584/526/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV01016. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Reech AiM Group, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 116.129.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2008.
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société à responsabilité limitée
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008126618/6684/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01886. - Reçu 111,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
120928
X-Time S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 83.005.
Le bilan au 31.07.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06.10.08.
Signature.
Référence de publication: 2008126600/9125/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00744. - Reçu 42,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080147416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 41.203.406,40.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 79.934.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008126610/7832/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2008, réf. LSO-CV01375. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Torre Mayor Finance, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 94.077.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06.10.2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008126608/2271/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00828. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Cortec Papersystems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 78.897.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2008.
FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008126679/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09317. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
120929
European Power Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 59.522.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joëlle BADEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008126895/7241/11.
(080147592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
City Apart S.C.I., Société Civile (en liquidation).
Siège social: L-2317 Howald, 21B, rue Général Patton.
R.C.S. Luxembourg E 3.056.
DISSOLUTION
L'an deux mille huit, le dix-neuf septembre;
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg;
Ont comparu:
1.- Monsieur Arndt VON REICHENBACH, employé privé, né à Sulingen (Allemagne), le 14 mars 1969 (no matricule
19690314714), demeurant à L-2636, Luxembourg, 14, rue Léon Thyes;
et
2.- son épouse Madame Marlène METGÉ, employée privée, née à Lavaur/Tarn (France), le 16 novembre 1974 (no
matricule 19741116386), demeurant à L-2423, Luxembourg, 49, rue de Pont-Remy;
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
a.- Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société civile immobilière CITY APART S.C.I. No matricule
20057002418) avec siège social à L-2317, Howald, 21b, rue General Patton;
constituée suivant acte, reçu par le notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, daté du 12 décembre 2005, publié
au Mémorial C de 2006, numéro 572, page 27.439;
Que les parts de la société civile appartiennent pour la moitié à Monsieur Arndt VON REICHENBACH, et pour l'autre
moitié à Madame Marlène METGÉ;
b.- Que d'un commun accord les prédits associés de la société civile immobilière «CITY APART S.C.I.» ont décidé la
dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs de la
société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation;
c- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-2636, Luxembourg,
14, rue Léon Thyes;
d.- Cet exposé fait, les comparants déclarent et constatent que la société civile immobilière «CITY APART S.C.I.» est
dissoute de plein droit et qu'eux, comparants, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les parts sociales
de la société, sont investis de tout l'actif et passif de cette société, dont la liquidation se trouve ainsi définitivement clôturée.
e.- Après la dissolution de ladite société, l'actif et le passif de la société sera attribué pour 50% à Monsieur Arndt VON
REICHENBACH, prédit, et pour 50% à Madame Marlène METGÉ, prédite;
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, date qu'en tête des présentes;
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec nous notaire le présent acte, lequel certifie l'état civil des comparants d'après
les cartes d'identité.
Signé: Von Reichenbach, Metgé, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette, le 24 septembre 2008, Relation: EAC/2008/12051. — Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 29 septembre 2008.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2008126675/209/43.
(080147861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
120930
MGI Fisogest S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 20.114.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 octobre 2008.
FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008126671/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09314. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080147614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Vargas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.954.
STATUTS
L'an deux mille huit, le seize septembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 65.906,
ici représentée par Monsieur Grégory Guissard, Juriste, résidant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg, (le Mandataire) en vertu d'une procuration donnée sous seing privée le 11 septembre 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit
les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Forme et Dénomination.
1.1 Il est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la Loi), et par les présents
statuts (les Statuts).
1.2 La Société existe sous la dénomination de «VARGAS S.A.».
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra
pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.
Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
2.2 II pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-
tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.
2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)
de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.
120931
Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
4.2 La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
4.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
4.4 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.
4.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
4.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.
Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)
actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une
action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de
l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi.
6.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.
6.3 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.
Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.
Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.
7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-
blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de
la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois de
juin, à 15 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.
7.4 L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des
circonstances exceptionnelles le requièrent.
7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
120932
7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 8. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de
l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.
8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée
Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.
8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.
8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment
convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration
composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Ac-
tionnaire Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas
besoin d'être actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux
catégories d'administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).
9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Actionnaire Unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'As-
semblée Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois
un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).
9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-
nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et
peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.
10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au
lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un
autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont
présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.
10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.
Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.
10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence
téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.
120933
10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise
par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et
d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts
à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du
Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.
12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution
de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux
administrateurs de la Société ou celle de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes
ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Admi-
nistration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature
conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.
Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.
14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé
d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.
14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire
de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.
Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi,
par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six ans et
il est rééligible.
15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,
leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.
Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
la même année.
Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.
17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer
des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.
17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et
doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.
120934
Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à
la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et
qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée
Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi.
Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2009. La première Assemblée Générale
annuelle se tiendra en 2010.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée, représentée
comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les trois cent dix (310) actions représentant la totalité du capital social de la
Société.
Toutes ces actions sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en nu-
méraire, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en constate
expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de
la Loi.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de deux mille cinq
cent euros (EUR 2.500,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social sou-
scrit, prend les résolutions suivantes:
1. le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
(i) Madame Stéphanie COLLEAUX, née à Dinant (Belgique), le 2 décembre 1977, avec adresse professionnelle au 412
F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
(ii) Madame Betty PRUDHOMME, née à Arlon (Belgique), le 30 janvier 1960, avec adresse professionnelle au 412 F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
(iii) Monsieur Grégory GUISSARD, né à Braine-l'Alleud (Belgique), le 1
er
août 1980, avec adresse professionnelle au
412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
3. FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230 est nommé commissaire de la Société.
4. le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire de la Société en 2014; et
5. le siège social de la société est fixé à L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la comparante, le présent
acte est établi en français, suivi d'une version anglaise. A la requête de ce même mandataire et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version française prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and eight on the sixteenth of September.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared
120935
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., a public limited liability company duly organized under the laws of Lux-
embourg, having its registered office at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, and registered with Trade and
Companies Register of Luxembourg under number B 65.906,
hereby represented by Mr Gregory Guissard, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal dated September, 11th, 2008 (the Proxyholder).
The said proxy, after having been signed «ne varietur» by the Proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated above, requested the notary to state as follows the articles of incorporation
of a public limited liability company ("société anonyme") which is hereby incorporated:
Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be
governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).
1.2 The Company will exist under the name of "VARGAS S.A.".
1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of
directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole
Director.
2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or
are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted
in the manner required for amendments of the Articles.
Art. 4. Corporate objects.
4.1 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
4.2 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability
company, as well as the administration, management, control and development of such participations.
4.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a
portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
4.4 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.
4.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
4.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as ail transactions and directly
or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of three hundred ten
(310) ordinary shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
120936
of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form,
at the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject
to the restrictions foreseen by Law.
6.2 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title
of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.
7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In
these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.
7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company
(the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the third Tuesday of the month of June, at 3.00 pm. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional
circumstances so require.
7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of
communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partic-
ipating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
Art. 8. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
8.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General
Meetings, unless otherwise provided herein.
8.2 Each share is entitled to one vote.
8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in
original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.
8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves
as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 9. Management.
9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors
composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole
Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s)
of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors
(A Directors and B Directors).
9.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General
Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall
be eligible for reappointment.
120937
9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board.
10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and
may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who
need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well
as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.
10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person
delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circum-
stances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,
or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event
that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 12. Delegation of powers. The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes
of performing specific functions at every level within the Company.
Art. 13. Binding signatures.
13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two
members of the Board or sole signature of the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature
of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the
limits of such power.
13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A
Director together with any B Director.
Art. 14. Conflict of interests.
14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.
14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of
the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
120938
Art. 15. Statutory Auditor(s).
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,
where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their
remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.
Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January of each year and shall
terminate on the 31st of December of the same year.
Art. 17. Allocation of profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.
17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may
alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such
places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Law.
Art. 18. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by
the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuner-
ation of the liquidator(s).
Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.
Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory provisionsi>
The first business year begins on this day and ends on the 31st of December 2009.
The first annual General Meeting will be held in 2010.
<i>Subscriptioni>
The Articles of the Company having thus been established, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prenamed,
represented as stated above, hereby declares to subscribe to the three hundred ten (310) shares representing the total
share capital of the Company.
All these shares are paid up by the Sole Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash,
so that the amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) paid by the Sole Shareholder is from now on at the free
disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.
<i>Statement - costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and
expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply
with the provisions of article 27 of the Law.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at two thousand five hundred (EUR
2,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The Sole Shareholder, prenamed, represented as stated above, representing the entire of the subscribed capital, passed
the following resolutions:
1. the number of directors is set at 3 (three) and the number of auditors at 1 (one);
2. the following persons are appointed as directors:
(i) Mrs. Stéphanie COLLEAUX, born in Dinant (Belgique), on December 02, 1977, with professional address at 412 F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
(ii) Mrs. Betty PRUDHOMME, born in Arlon (Belgique), on January 01, 1960, with professional address at 412 F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg;
(iii) M. Gregory GUISSARD, born in Braine-l'Alleud (Belgique), on August 01, 1980, with professional address at 412
F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
120939
3. that FIN-CONTROLE S.A., a public limited company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with reg-
istered office at L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register, under the number B 42.230, be appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company;
4. that the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the
annual General Meeting of the Company of the year 2014; and
5. that the address of the registered office of the Company is at L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version. At the request of the
same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French versions, the French version
will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with the notary the
present deed.
Signé: Gregory GUISSARD et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2008. LAC / 2008 / 37801. - Reçu à 0,50 %: cent cinquante-cinq euros
(€ 155,-).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Franck SCHNEIDER.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2008.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2008126702/7241/508.
(080147551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Sammartini S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 138.206.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth day of July.
Before us M
e
Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
GENERALI REAL ESTATE FUND, a société d'investissement à capital variable, incorporated and existing under the
laws of Luxembourg, having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register section B under number 121362, here represented by Ilaria DRESCHER,
residing professionally at 6D, route de Trèves - L-2633 Senningerberg, by virtue of a power of attorney, given under
private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the person appearing and by the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, acting as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of SAM-
MARTINI S. à r.l., a société à responsabilité limitée, a private limited liability company, incorporated and existing under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138206 (the "Company"), incor-
porated pursuant to a deed of notary Jean-Joseph Wagner residing in Sanem on April 23, 2008, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
1302 of May 28, 2008 has required the undersigned notary to state its
resolutions as follows:
<i>Resolutionsi>
The Sole Shareholder decides to transfer the registered office of the Company from 6D, route de Trèves, L-2633
Senningerberg to 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and to amend first sentence of article 5 of the Company's articles
of incorporation as follows:
" Art. 5. first sentence. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg."
The Sole Shareholder decides that the above resolutions shall be effective as from July 31, 2008.
Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
120940
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said person signed together with the notary, the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-quatre juillet,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
GENERALI REAL ESTATE FUND, une société d'investissement à capital variable, constituée et existant selon le droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, enregistrée auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 121.362, ici représentée par Ilaria DRESCHER,
demeurant professionnellement au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.
Ladite procuration, après signature ne varietur par la personne comparante et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité de seul associé (P «Associé Unique»)
de SAMMARTINI S. à r.l. constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6D,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 138206 (la «Société»), constituée suivant acte reçu du notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à
Sanem en date du 23 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1302 du 28 mai 2008
a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 5 des statuts de la
Société comme suit:
« Art. 5. première phrase. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»
L'Associé Unique décide que les résolutions précédentes sont prises avec effet au 31 juillet 2008.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil
et résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ilaria Drescher, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 31 juillet 2008. LAC/2008 /31960. — Reçu € 12,- ( douze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 octobre 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008126667/202/71.
(080147787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Admiral Participations (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 141.953.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the third day of September.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Admiral Europe Holding Ltd., a company incorporated and existing under the laws of Malta, having its registered office
at 85, St. John Street, Valetta VLT1165 Malta, registered under registration number C 450 10,
duly represented by Ms Verena Zimmermann, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 1 September 2008;
120941
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, represented as stated above, requested the undersigned notary to document the deed of in-
corporation of a société à responsabilité limitée, which it wishes to incorporate and the articles of incorporation of which
shall be as follows:
A. Name - duration - purpose - registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owner of the shares and/or anyone who may be a shareholder
in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Admiral Participations
(Luxembourg) S.àr.l." (the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of incorporation.
Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
The Company's purpose is furthermore to hold and administer participating interests held directly or indirectly in
other entities (including but not limited to companies and partnerships), which shall in turn hold participating interests
in credit institutions, financial institutions and providers of ancillary services.
3.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds
a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,
the Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.
4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - shares - register of shareholders - ownership and transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting of twelve
thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.
5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of incorporation.
5.3 Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality
of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in
the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such preferential
120942
subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a
registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting
of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential
subscription right of the existing shareholder(s). Such resolution shall be adopted in the manner required for an amend-
ment of these articles of incorporation.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by
him/her/it in the Company's share capital.
6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed
shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.6 The Company's shares are in registered form.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of incorporation as well
as any security rights granted on shares.
7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-
holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the
shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders rep-
resenting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.
8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company's corporate bodies.
9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of incorporation, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of incor-
poration is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".
9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of incorporation.
9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of
holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
120943
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of incorporation regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the
municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.
10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of incorporation, resolutions of the shareholders are
validly passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital
on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a
second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the
portion of capital represented.
11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
11.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,
facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
11.7 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of incorporation. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
120944
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of incorporation, a reference to the
"board of managers" used in these articles of incorporation is to be construed as being a reference to the "sole manager".
14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of incorporation to the share-
holder(s).
14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Then appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
For the avoidance of any doubts, the daily management does not include Significant Decisions as defined in Article 20
below.
14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone
or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a
chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.
Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-
holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.
16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph.
17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours
at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of incorporation.
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers. In the event that class A managers and class B managers have been appointed, at
least one class A manager and one class B manager need to be present or represented at a meeting of the board of
managers
18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting
of the board of managers. In the event that class A managers and class B managers have been appointed, the approval
requires the votes of at least one class A manager and one class B manager. The chairman shall not have a casting vote.
18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
120945
18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.
18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of
the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.
Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the
board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.
Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties concerning Significant Decisions
by the joint signatures of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures or by the sole signature
of any person(s) (not being a member of the board of managers) to whom such signatory power shall be delegated by
the board of managers or by one class A manager and one class B manager. For all other decisions not falling under the
scope of the Significant Decisions, the Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to
whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to
the rules and the limits of such delegation.
Significant Decisions means decisions concerning
a. the exercise of voting rights in direct and/or indirect subsidiaries of the Company;
b. the decisions in respect of profit distributions in the Company and/or its subsidiaries;
c. the incurrence of debt in excess of one hundred thousand Euro (EUR 100,000);
d. the assumption of suretyships, guarantees or other obligations in respect of the liabilities of third parties in excess
of fifty thousand Euro (EUR 50,000) or falling outside the ordinary scope of business of the Company;
e. any decisions having material impact on the Company's direct and/or indirect subsidiaries;
f. the commencement of new business activities, partial or complete discontinuation of business activities undertaken
in the past;
g. the acquisition of shares in other corporations or of interests and partnerships and/or disposal of shares and/or
interests in direct and/or indirect subsidiaries;
h. the incorporation or liquidation of subsidiaries;
i. the acquisition, disposal or encumbrance of the whole business or a substantial part of the business of the Company;
j. the conclusion, alteration or termination of contracts or conducting of transaction requiring prior or subsequent
notification to an authority and/or the approval of the authority;
k. the commencement of any material litigation or arbitration proceedings other than in the ordinary course of business
or for the purpose of collecting book or trade debts owing to the Company;
l. the alteration of the articles of incorporation of any direct and/or indirect subsidiary, in particular, but not limited
to the alteration of the business year and capital increases or decreases;
m. the appointment or removal of any managing director of any direct and/or indirect subsidiary;
n. all measures in a direct and/or indirect subsidiary which would also in the Company constitute a Significant Decision;
o. all other transactions or measures falling outside the ordinary scope of the business of the Company or having been
specified by the Company in General Meeting as constituting a Significant Decision.
120946
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and
shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.
21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of incorporation relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the
law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.
F. Financial year - profits - interim dividends
Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on
thirty-first December of the same year.
Art. 23. Profits.
23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the
remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of incorporation.
Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,
under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of incorporation and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions haven been satisfied.
24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)
or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
H. Governing law
Art. 26. Governing law. These articles of incorporation shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with
the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31
December 2009.
120947
2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
Admiral Europe Holding Ltd., aforementioned, declares to subscribe to all the twelve thousand five hundred (12,500)
shares and paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) in subscription for the said twelve thousand five hundred
(12,500) shares.
All the shares are entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is
as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be two thousand five hundred euro (EUR
2,500).
<i>General meeting of shareholdersi>
The incorporating shareholder, representing the Company's entire share capital and considering itself as duly convened,
immediately passed the following resolutions.
1. The number of members of the board of managers is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed for an unlimited period of time as members of the board of managers of the
Company:
<i>As class A manager:i>
a) Ms Wendy Friedman Dulman, born on 16 November 1968 in Ohio, United States of America, with private address
at 48, Annandale Drive, Chappaqua, NY 10514, United States of America.
<i>As class B managers:i>
b) Mr Alexis Kamarowsky, born on 10 April 1947 in Strang (now called Bad Rothenfelde), Germany, with professional
address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
c) Mr Michael Robert Kidd, born on 18 April 1960 in Basingstoke, County of Hampshire, United Kingdom, with private
address at 28, rue Puert, L-5433 Niederdonven, Grand-Duchy of Luxembourg.
3. The address of the Company's registered office is set at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same prox-
yholder and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
the notary this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes
Im Jahre zweitausend und acht, den dritten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joëlle Baden, Zivilrechtsnotar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
Ist erschienen:
Admiral Europe Holding Ltd., eine gemäß dem Recht von Malta gegründete und existirende Gesellschaft mit einge-
tragenem Sitz in 85, St. John Street, Valetta VLT1165 Malta, eingetragen unter Registernummer C 450 10,
ordnungsgemäß vertreten durch Frau Verena Zimmermann, Rechtsanwältin, mit Adresse in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 1. September 2008;
Nachdem die Vollmacht durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wur-
de, bleibt diese gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Solch erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société à
responsabilité limitée aufzunehmen, welche sie gründen möchten und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten
soll:
A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz
Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen dem derzeitigen Inhaber der Anteile und/oder jeder anderen Person, die
künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma "Admiral
Participations (Luxembourg) S.à r.l." (die "Gesellschaft").
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
120948
Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher
in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 3. Zweck.
3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus
Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
Der Gesellschafts Zweck erstreckt sich außerdem auf das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen, die direkt
oder indirekt in anderen Körperschaften (die Gesellschaften und Personenkapitalgesellschaften umfassen, aber nicht da-
rauf beschränkt sind) gehalten werden, die ihrerseits Beteiligungen in Kreditinstitutionen, Finanzinstitutionen und
Anbietern von Nebendienstleistungen halten.
3.2 Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-
gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmens Gruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von
Verbindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmens Gruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und
- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in
welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.
3.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. In-
nerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:
- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-
papiers oder Schuidpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;
- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland beteiligen; und
- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes
beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
4.3 Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch
einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.
B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-
schäftsanteilen
Art. 5. Stammkapital.
5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus zwölftau-
sendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.
5.2 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-
schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden
Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den
Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäfts-
anteile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugs-
recht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines
an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung an-
kündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um
über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehen-
120949
den Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise
gefasst werden wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig
(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.
6.3 Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl
der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.
6.4 Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend
den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.
6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-
gekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend
herabgesetzt.
6.6 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.
Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-
schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.
7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung
mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.
Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1 Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-
schafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.
8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-
sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.
8.3 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter
Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.
8.4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles
in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesell-
schafterverzeichnis eintragen kann.
8.5 Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen und
diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Do-
kument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.
C. Gesellschafterversammlung
Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1 Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-
terversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
"Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.
120950
9.3 Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich
verliehenen Befugnisse.
9.4 Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,
statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.
Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die
satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.
10.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-
sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.
10.3 Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit
der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.
10.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.
Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1 In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-
denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.
11.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3 Quorum und Stimmabgabe
11.3.1 Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2 Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-
schafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.
11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,
Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.
11.5 Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Vi-
deokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesellschafter
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören
und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend
ist.
11.6 Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-
formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.
11.7 Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden
müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.
120951
Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag
durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.
Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie
von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.
13.2 Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse
aufnehmen und unterzeichnen.
13.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen
oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein
müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat"
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.
14.2 Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.
14.3 Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts
können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird festgehalten, dass die Führung des Tagesge-
schäfts der Gesellschaft nicht Wesentliche Entscheidungen im Sinne von Artikel 20 umfasst.
14.4 Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede
Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.
Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten
des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.
Art. 16 Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit
festlegt.
16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen
werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.
16.3 Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer
kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.
Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1 Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner
Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
17.2 Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung
anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.
120952
Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1 Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner Ab-
wesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen
18.2 Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
an der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Falls Geschäftsführer der Klasse A und der Klasse B ernannt wurden, muss
mindestens ein Geschäftsführer der Klasse A und ein Geschäftsführer der Klasse B an der Sitzung anwesend oder ver-
treten sein.
18.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder
vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben. Falls Geschäftsführer der Klasse A
und der Klasse B ernannt wurden, erfordern Beschlüsse mindestens die Stimmen eines Geschäftsführers der Klasse A
und eines Geschäftsführers der Klasse B.
18.4 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein
anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
18.5 Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-
okonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
abgehalten wurde.
18.6 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in
einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.
18.7 Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt
oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat
und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inte-
ressenskonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden. Dieser Artikel 18.7 ist nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.
Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung
des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.
19.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden
sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten bezüglich Wesentlichen Entscheidungen durch
die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Klasse A und einem Geschäftsführer der Klasse B oder durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) (jedoch nicht durch ein Mitglied des
Geschäftsführerrates) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder durch
einen Geschäftsführer der Klasse A und einen Geschäftsführer der Klasse B übertragen worden ist. Für jegliche Ent-
scheidungen, die nicht in den Bereich der Wesentlichen Entscheidungen fallen, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber
durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung des
Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.
Unter Wesentliche Entscheidungen fallen Entscheidungen bezüglich
a. der Ausübung von Stimmrechten in direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
b. Entscheidungen über Gewinnverteilungen innerhalb der Gesellschaft und/oder ihrer Tochtergesellschaften;
c. der Übernahme von Schulden in einem Betrag von über einhunderttausend Euro (EUR 100.000);
120953
d. der Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder anderen Verpflichtungen bezüglich Verbindlichkeiten von Dritten
in Höhe von mehr als fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) oder von Verbindlichkeiten, die nicht in den ordentlichen Ge-
schäftsbereich der Gesellschaft fallen;
e. jeglicher Entscheidungen, die einen wesentlichen Einfluss auf die direkten und/oder indirekten Tochtergesellschaften
der Gesellschaft haben;
f. der Aufnahme von neuen Geschäftstätigkeiten und der teilweisen oder vollständigen Einstellung von früheren Ge-
schäftstätigkeiten;
g. des Erwerbes von Aktien oder Geschäftsanteilen in anderen Gesellschaften oder von Anteilen an Handelsgesell-
schaften und/oder der Veräußerung von Aktien oder Geschäftsanteilen und/oder Anteilen in direkten und/oder indirekten
Tochtergesellschaften;
h. der Gründung oder Auflösung von Tochtergesellschaften;
i. des Erwerbes, der Veräußerung oder der Belastung der gesamten Geschäftstätigkeit oder eines wesentlichen Teils
der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft;
j. des Abschlusses, der Änderung oder der Beendigung von Verträgen oder der Durchführung einer Transaktion, die
eine vorherige oder nachfolgende Benachrichtigung einer Behörde und/oder eine Genehmigung durch die Behörde er-
fordert;
k. des Beginns eines wesentlichen Gerichtsverfahrens oder schiedsgerichtlichen Prozesses, der nicht in die ordentliche
Geschäftstätigkeit fällt und der nicht im Rahmen einer Beitreibung von Buch- oder Gewerbeschulden zu Gunsten der
Gesellschaft geführt wird;
l. der Änderung der Satzung einer direkten und/oder indirekten Tochtergesellschaft, vor allem, jedoch nicht aus-
schließlich bezüglich der Änderung des Geschäftsjahres sowie Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen;
m. der Ernennung oder der Abberufung eines jeden Geschäftsführers einer direkten und/oder indirekten Tochterge-
sellschaft;
n. aller Maßnahmen in einer direkten und/oder indirekten Tochtergesellschaft, die auch in der Gesellschaft eine We-
sentliche Entscheidung darstellen;
o. all anderer Transaktionen oder Maßnahmen, die nicht in den ordentlichen Geschäftsbereich der Gesellschaft fallen
oder die durch die Gesellschaft in einer Hauptversammlung als Wesentliche Entscheidung bestimmt worden sind;
E. Aufsicht
Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder
mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.
21.2 Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und
ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.
21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung
abberufen werden.
21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte
der Gesellschaft.
21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten
der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.
21.6 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher
aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.
21.7 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.
F. Geschäftsjahr - gewinne - Zwischendividenden
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-
unddreißigsten Dezember desselben Jahres.
120954
Art. 23. Gewinne.
23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.
23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage
zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.
23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt
werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.
23.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen wird die Gesellschafterversammlung beschließen, wie der verbleibende Rest
des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden
soll.
Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.
24.1 Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Voraus-
setzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.
24.2 Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.
H. Anwendbares recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-
burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2009.
2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Admiral Europe Holding Ltd., vorgenannt, eklärt hiermit alle zwölftausend fünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen zu
zeichnen und zahlte zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) gegen Zeichnung von besagten zwölftausend fünfhundert
(12.500) Geschäftsanteilen.
Alle Geschäftsanteile sind ganz in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR
12.500) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Auslageni>
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang
mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Die Gründungsgesellschafterin, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentiert und die sich selbst als ord-
nungsgemäß geladen erachten, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst.
I. Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf drei (3) festgesetzt.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer
ernannt:
<i>Als Geschäftsführer der Klasse A:i>
a) Frau Wendy Friedman Dulman, geboren am 16. November 1968 in Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika, mit
privater Anschrift in 48, Annandale Drive, Chappaqua, NY 105149, Vereinigte Staaten von Amerika.
120955
<i>Als Geschäftsführer der Kategorie B:i>
b) Herr Alexis Kamarowsky, geboren am 10. April 1947 in Strang (jetzt Bad Rothenfelde), Deutschland, mit beruflicher
Anschrift in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
c) Herr Michael Robert Kidd, geboren am 18. April 1960 in Basingstoke, County of Hampshire, Vereinigtes Königreich,
mit privater Anschrift in 28, rue Puert, L-5433 Niederdonven, Großherzogtum Luxemburg.
3. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage des
Bevollmächtigten der erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf
Anfrage desselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
soll die englische Fassung vorrangig sein.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, hat dieser gegewärtige Urkunde
zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: V. ZIMMERMANN und J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A. C, le 5 septembre 2008. LAC / 2008 / 36224. — Reçu soixante-deux euros cinquante
cents € 62,50.
<i>Le Receveuri>
(signé): SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr im Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations erteilt.
Luxemburg, den 30. September 2008.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2008126709/7241/818.
(080147540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
MGI Fisogest S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 20.114.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 octobre 2008.
FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008126664/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09312. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
Colony HR Holding (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 110.245.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2006 de Fairmont Raffles Holdings International ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26.09.08.
Signatures.
Référence de publication: 2008126653/5564/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09546. - Reçu 82,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080147651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2008.
120956
CaraTime S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 139.577.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le gérant unique de la Société en date du 30 juillet 2008i>
Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 septembre 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008126449/631/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09473. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080146383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
East West Photo-Graphic SA, Société Anonyme,
(anc. Paddylux Soparfi S.A.).
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 112.883.
L'an deux mille huit, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
S'est réuni l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PADDYLUX SOPARFI S.A., avant son siège
social à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade (matr. 2005 2230 285),
constituée sous la dénomination ILUX REAL ESTATE SOPARFI S.A. aux termes d'un acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 2 décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C n°656 du 30 mars
2006, ayant changé sa dénomination suivant acte du notaire Urbain THOLL, de résidence à Mersch en date du 9 novembre
2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C n°2434 du 29 décembre 2006, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 112.883.
L'assemblée est présidée par Monsieur Yvan CRAB, commerçant, demeurant à H-2643 Nagybörzsöny, Ganàdpuszta,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Gary HESS, employé privé, demeurant à Niederfeulen.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Guillaume Marth, demeurant à Holler.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignées sur
une liste de présences, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Il résulte de la liste de présence que toutes les trois mille (3.000) actions représentant l'intégralité du capital social
sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points à l'ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Révocation et nomination d'administrateurs;
- Changement de l'objet social de la société et adaptation afférente du premier alinéa de l'article 4 alinéas 1 et 2 des
statuts;
- Changement du nom de la société adaptation afférente de l'article 1
er
alinéas des statuts;
L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) L'assemblée générale décide de révoquer la société anonyme EAST WEST VENTURE CAPITAL S.A., ayant son
siège social à L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce, de son poste d'administrateur de la société et de nommer en
son remplacement comme administrateur Monsieur Jan CRAB, photographe, demeurant à B-3360 Bierbeek, Konigin
Albertlaan 27, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
120957
2) L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et de modifier en conséquence les alinéas 1
er
et 2 de
l'article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
La société a pour objet la création et l'exploitation d'un atelier de photographie, la vente de matériel de photo au
détail, la cinématographie ainsi que le reportage-photo commercial et de presse.
La société pourra, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales,
financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
La société pourra s'intéresser par voie de souscriptions, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute
société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes
opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Ensuite le conseil d'administration de la susdite société s'est réuni et a décidé de nommer Monsieur Jan CRAB, prén-
ommé, comme administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.
3) L'assemblée décide de changer le nom de la société et de modifier en conséquence l'article 1
er
des statuts qui aura
dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de EAST WEST PHOTO-GRAPHIC
SA.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ cinq cents (500.- €) euros.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état et
demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.
Signé: Y. CRAB, G. HESS, G. MARTH, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 30 juillet 2008. DIE/2008/6992. - Reçu douze euros. EUR 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 19 septembre 2008.
Pierre PROBST.
Référence de publication: 2008122008/4917/64.
(080141449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2008.
Prelor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4350 Esch-sur-Alzette, 2A, rue Wurth-Paquet.
R.C.S. Luxembourg B 47.888.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/09/2008.
<i>Pour Prelor S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2008123341/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06659. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080142928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
Zorin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.507.
L'an deux mille huit, le onze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme «ZORIN S.A.» (la «Société»), ayant
son siège social au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
120958
date du 9 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 11 décembre 2007,
numéro 2867 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.507.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Philippe MORALES, avocat, demeurant à Luxembourg, qui dé-
signe comme secrétaire Maître Cécile HESTIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc RAVELLI, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que l'actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions
qu'il détient, sont indiqués sur une liste de présence signée par le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que par
les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration de l'actionnaire
représenté restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, l'actionnaire présent ou représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution et liquidation de la Société.
2. Nomination de Maître Philippe MORALES en tant que seul liquidateur de la Société.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
Après avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer Maître Philippe MORALES, prénommé, en tant que seul liquidateur de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. MORALES, C. HESTIN, M. RAVELLI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 septembre 2008. Relation: EAC/2008/11702. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 24 septembre 2008.
Jean-Joseph Wagner.
Référence de publication: 2008124056/239/51.
(080144356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.
Alcentra Mezzanine No. 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 107.704.
Le bilan au 30 juin 2008 et les informations y relatives ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
120959
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008125303/1649/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09344. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080145954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.
Etesian Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 109.477.
Constituée par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 12 juillet 2005, acte publié au Mémorial C no 1309 du 1
er
décembre 2005.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Etesian Investments S.à r.l.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008125373/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07896. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080145636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2008.
Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-One) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 93.372.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 août 2008i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 août 2008 que:
- Le siège social est transféré à partir du 15 août 2008 au 43, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2008.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008126010/7857/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2008, réf. LSO-CV00597. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Bale Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 80.982.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/10/2008.
<i>Pour BALE HOLDING SA
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2008125874/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07716. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080146501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
120960
Abowijs International S.A.
Acta Priv S.A.
Admiral Participations (Luxembourg) S.à r.l.
Alcentra Mezzanine No. 2 S.à r.l.
Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-One) S.A.
A.S.M. Investments S.A.
Bale Holding SA
Böhrs + Böhrs Invest S.A.
Brain & More S.A.
Bugs S.A.
Callisto S.A.
CaraTime S.à r.l.
Careba
Charterhouse Capri II
Chrysley Investments S.A.
City Apart S.C.I.
Colarg Partners S.à r.l.
Colony HR Holding (Lux) S.à r.l.
Cortec Papersystems S.à r.l.
East West Photo-Graphic SA
ECC (Luxembourg) S.à r.l.
Edelvys Holding S.A.
E.L.P. European Licence Partners (Holdings) S.àr.l
Etesian Investments S.à r.l.
European Power Systems S.A.
FBS Luxembourg S.à r.l.
Financière Daunou 15 S.A.
Florea Invest S.A.
Fund Partners
Gohar S.à r.l.
Haus- und Grundinvest S.A.
Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l.
Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l.
Hopetoun Holdings S.à r.l.
Huber Lux Financing Co. S.à r.l.
Icare Finance S.A.
IDI Emerging Markets SA
Knollwood S.à r.l.
Lomair Holding S.A.
Luxflower SA
Macquarie Investment Management S.à r.l.
MEIF II Luxembourg Communications S.à r.l.
MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l.
MGI Fisogest S.àr.l.
MGI Fisogest S.àr.l.
Miracema S.A.
Ned Lease
OAK Investment S.A.
Paddylux Soparfi S.A.
Palamon Collection Holdco S.à r.l.
PCLease S.A.
Plénitude S.A.
Prelor S.à r.l.
Procobel S.A.
Reech AiM Group
Sammartini S.à r.l.
S.C. S.A.
Seal Investments S.A.
Surface Holding S.A.
Torre Mayor Finance
Transco S.A.
Ulysses Finance S.à r.l.
Vargas S.A.
Vignes et Terroirs
Vins et Domaines Finance S.A.
Weena S.à r.l.
X-Time S.A.
Zorin S.A.