logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2475

9 octobre 2008

SOMMAIRE

AMP Capital Investors (FDF European In-

frastructure No. 3) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

118773

Aqua Valley Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

118761

Aralia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118757

Aromes et Senteurs sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

118781

Atlas Capital Group Holding S.A. . . . . . . . .

118761

Bamaco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118762

Bedwyn Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

118755

Belper Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

118754

Berlage 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118771

Bescot Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

118756

Bexhill Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

118762

Bleasby Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

118757

Blue Holding Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

118766

Cemex Capital Investments S.à r.l.  . . . . . .

118766

Centaurium Management . . . . . . . . . . . . . . .

118763

Chiquis SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118765

Cofino Crans S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118771

Ecomundo Group International s.à r.l.  . . .

118762

Elsa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118769

E-Solutions International Holding S.A.  . . .

118756

E.S.T.I.M. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118754

EuroInvest Financing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

118769

Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118770

Financière Saint Merri Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118759

Fruitbrokers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118764

Fruitbrokers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118765

Goodrich XCH Luxembourg B.V.  . . . . . . .

118767

Guitay Distribution S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

118767

HH Luxembourg 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

118760

HSBC Securities Services (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118767

HSBC Securities Services (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118754

HSBC Trinkaus Lingohr  . . . . . . . . . . . . . . . .

118763

IPSE Dixit Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

118772

JB Construction S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118780

JP/LX BC Stereo I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

118758

Kauri Capital 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118770

Kauri Capital 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118760

Kauri Capital 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118770

LFS Multi-Family Office S.A.  . . . . . . . . . . . .

118773

Mai Luxembourg SE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118781

Messageries du Livre S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

118762

Messageries Paul Kraus S.à r.l.  . . . . . . . . . .

118768

Moon International Luxembourg S.A. . . . .

118759

Nerisa Beheer B.V. / S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

118758

Nido Notting Hill S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

118765

Norla Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118761

OHL Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118771

Oras S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118763

Pafint Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118781

Polaris Architects S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

118769

Quixline.com S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118759

REA Group European Production Center

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118758

Rowlands Temporaire-RTT Lux S.A. . . . . .

118800

Russbrough S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118766

Saint Merri Overseas S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

118757

SCI Cessimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118771

SEDIC S.A. (Société Européenne pour le

Développement de l'Industrie et du Com-
merce, Société Anonyme)  . . . . . . . . . . . . .

118755

S.G.S. Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118768

Shawsa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118755

Talmec Natur S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118760

Talmec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118760

Transports et Garage Presse S.à r.l.  . . . . .

118764

VP Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118764

Zefiro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118756

118753

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 28.531.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Ciaran Mc Kay

Référence de publication: 2008123703/41/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08074. - Reçu 60,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080143949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Belper Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.509.

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 01.08.2008 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg)

S.A. et Chefa Limited les 1,250,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Chefa Limited domicilié à 77 Lemesou Avenue, ELIA HOUSE, 2121 Nicosia, Cyprus détient 1,250,000 parts sociales

d'une valeur nominale de EUR 0.01 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Belper Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008123585/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08134. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

E.S.T.I.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 117.928.

<i>Cession de parts

La soussignée, la société BUSINESS BUILDINGS COMPANY INC, ayant son siège social 16192 Coastal Highway à

DE-19958 Lewes - Delaware (U.S.A.), inscrite au Secretary of the State File sous le Numéro 3437536.

transfère à Mr Philippe GENTY, directeur commercial domicilié 4, rue Landi à F-88600 Dompierre (France).
le nombre de 24 parts sociales de la S.à r.l. E.S.T.I.M., avec siège social 47, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg,

numéro R.C.S. Luxembourg B. 117.928 au capital de 12.400 EUR.

Le soussigné, Bernard COLIN, agissant en sa qualité de gérant de la société E.S.T.I.M. Sàrl, déclare accepter la présente

cession de parts au nom et pour le compte de la-dite société.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2008.

BUSINESS BUILDINGS COMPANY INC
<i>Le vendeur
Philippe GENTY / Bernard COLIN
<i>L'acheteur / Gérant

Référence de publication: 2008123459/1969/22.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06728. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

118754

SEDIC S.A. (Société Européenne pour le Développement de l'Industrie et du Commerce, Société Ano-

nyme).

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 25.954.

Le bilan au 31 décembre 1997 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008123390/1031/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU04895. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080143251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Shawsa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 124.600.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Constituée par acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 février 2007,

publié au Mémorial C numéro 735 du 27 avril 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 124.600.

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire décidant la clôture de liquidation reçu par Maître Blanche

MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 septembre 2008,

enregistré à Esch/Al. A.C., le 18 septembre 2008, relation: EAC/2008/11855,
- que l'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
- que l'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq

ans à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2008.

Pour extrait
BLANCHE MOUTRIER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2008123798/272/22.
(080143652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Bedwyn Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.503.

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 01.08.2008 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg)

S.A. et Armotage Trading Limited les 1,250,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Armotage Trading Limited domicilié à 77 Lemesou Avenue, ELIA HOUSE, 2121 Nicosia, Cyprus détient 1,250,000

parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0.01 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Bedwyn Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008123581/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08137. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

118755

Bescot Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.505.

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 01.08.2008 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg)

S.A. et Quaraz Limited les 1,250,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Quaraz Limited domicilié à 77 Lemesou Avenue, ELIA HOUSE, 2121 Nicosia, Cyprus détient 1,250,000 parts sociales

d'une valeur nominale de EUR 0.01 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Bescot Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008123579/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08130. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080143592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Zefiro S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.059.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 26 juin 2008,

enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008, LAC/2008/26481 que l'assemblée a décidé de clôturer la liquidation et a
pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relatif aux sociétés commerciales et conformément à
l'article 9 de ladite loi.

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social, au 26,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

- et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas

présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

<i>Pour la société
Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008123786/211/22.
(080143992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

E-Solutions International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 77.808.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/9/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123299/777/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06976. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

118756

Bleasby Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.507.

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 01.08.2008 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg)

S.A. et Wyedene Holdings Limited les 1,250,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Wyedene Holdings Limited domicilié à Kosti Palama 5, 2/201, 1096 Nicosia, Cyprus détient 1,250,000 parts sociales

d'une valeur nominale de EUR 0.01 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Bleasby Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg)S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008123578/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08120. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080143595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Saint Merri Overseas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 123.248.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2008123969/206/13.
(080144150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Aralia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 92.484.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 1 

<i>er

<i>septembre à 15.00 heures

<i>Délibérations

Après délibérations, l'Assemblée, à l'unanimité décide:
1. L'Assemblée révoque la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE REVISION EXPERTISE COMPTABLE, CON-

SEIL Sàrl de son poste de commissaire aux comptes de la société.

2. L'Assemblée nomme à compter de ce jour M. Philippe GIBELLO demeurant 3, rue Turique, F-54000 Nancy au poste

de commissaire aux comptes de la société en remplacement de son prédécesseur. La durée du mandat est fixée à UN
(1) an.

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008123801/8948/22.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09143. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118757

REA Group European Production Center, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 140.539.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue par devant le notaire

Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 9 septembre 2008, enregistré à Luxembourg A.C., le 11 sep-
tembre 2008, LAC/2008/36904:

Que Monsieur Simon BAKER, managing director, né le 6 décembre 1966 à Londres (Royaume-Uni), demeurant à Unit

7, 102-104, Jolimont Road, East Melbourne, Vic 3002, Australie, a été révoqué de sa fonction d'administrateur avec effet
immédiat.

Que Monsieur Alain FONTAINE, head of IT, né le 6 octobre 1974 à Ettelbruck (Luxembourg), demeurant à 18B, route

d'Elvange, L-5495 Wintrange (Luxembourg) a été nommé nouvel administrateur.

Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2013.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivré à la demande de la société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008124018/220/22.
(080144220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

JP/LX BC Stereo I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 139.388.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2008123977/206/13.
(080143781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Nerisa Beheer B.V. / S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,00.

Siège de direction effectif: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.055.

L'Associé  Joannes  Gerhardus  Hermanus  Maria  NIESSEN,  né  le  02  décembre  1963  à  Rotterdam,  aux  Pays-Bas,  et

possédant 40 parts sociales, est domicilié, à compter de septembre 2008, à l'adresse suivante:

4 Chemin de la Fontaine
1291 Commugny,
Suisse
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Nerisa Beheer B.V./S.à r.l.
Jacob Mudde
<i>Gérant

Référence de publication: 2008124019/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08114. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118758

Financière Saint Merri Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 122.926.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2008123970/206/13.
(080144141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Quixline.com S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 75.566.

EXTRAIT

<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 août 2008

1. Les actionnaires décident de reconduire le mandat de Kitz S.A., comme administrateur de la société pour une période

de 5 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2012;

2. Les actionnaires décident de reconduire le mandat de Monsieur Marc Schintgen, comme administrateur de la société

pour une période de 5 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2012;

3. Les actionnaires décident de reconduire le mandat de Monsieur Michal Wittmann, comme administrateur de la

société pour une période de 5 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année
2012;

4. Les actionnaires décident de reconduire le mandat du commissaire aux comptes, Alpha Expert S.A., pour une période

de 5 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 19/9/08.

Signature.

Référence de publication: 2008124031/777/22.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06987. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Moon International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 66.836.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le

<i>26 juillet 2007 à 10.00 heures

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Madame Elise Lethuillier et Monsieur Reinald Loutsch en

tant qu'Administrateurs et de H.R.T. Révision S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an,
leur mandat prenant fin à l'Assemblée statuant sur les Comptes de l'année 2007.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2008124085/817/19.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05001. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118759

Kauri Capital 4, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.817.100,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 122.757.

L'associé unique, dans ses résolutions du 17 septembre 2008, a renouvelé le mandat de ses gérants:
- Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 3-5, place

Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

- Manuel HACK, maître ès sciences économiques, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

<i>Pour KAURI CAPITAL 4, Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2008124077/833/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU07153. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080143696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Talmec Natur S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Talmec S.à r.l.).

Siège social: L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 121.787.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Emile SCHLESSER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008124042/227/13.
(080143868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

HH Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 124.035.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 17. Juni 2008

- Die Gesellschaft verlegt ihren Sitz von 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg nach 6, place de Nancy, L-2212

Luxembourg.

- Frau Corinne Muller mit Berufsanschrift in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, tritt von ihrer Tätigkeit als

Geschäftsführer zurück.

- Als neue Geschäftsführer werden ernannt:
1. Frau Jennifer Beyer, mit Berufsanschrift in 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
2. Herr Patrick Römer, mit Berufsanschrift in 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

<i>Pour la société
PKF Weber &amp; Bontemps
Unterschriften

Référence de publication: 2008124097/592/22.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07696. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118760

Norla Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 36.620.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme Norla Holdings SA qui s'est

tenue en date du 23 juillet 2008 que:

1. Mademoiselle Eléonore PAULY, avec adresse professionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, a été

nommée comme Administrateur de la société avec effet à ce jour, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra
en 2010 en remplacement de Monsieur Filipe CAPINHA - HELIODORO démissionnaire.

2. Madame Catherine MANRY, avec adresse professionnelle au 36/38, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, a été nommée

comme Administrateur additionnel de la société avec effet à ce jour, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra
en 2010.

Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2008124100/309/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU06082. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Atlas Capital Group Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 78.314.

Le conseil d'administration du 5 mars 2008 a pris acte du décès de Monsieur Patrick STEVENSON.

Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2008124043/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08585. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Aqua Valley Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 129.117.

<i>Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 10 janvier 2008

- La démission du Commissaire aux Comptes Fiduciaire Benoy Consulting Sàrl a été acceptée;
- En remplacement du Commissaire démissionnaire, l'Assemblée a nommé Aquilegia Sàrl, une société ayant son siège

social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes; et ce jusqu'à l'As-
semblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008124098/1629/19.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06549. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118761

Bexhill Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.506.

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 01.08.2008 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg)

S.A. et Ryxan Limited les 1.250.000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Ryxan Limited domicilié à 77 Lemesou Avenue, ELIA HOUSE, 2121 Nicosia, Cyprus détient 1.250.000 parts sociales

d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Bexhill Holdings S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2008124107/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08123. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080143725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Ecomundo Group International s.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Bamaco S.à r.l.).

Siège social: L-8390 Nospelt, 8, rue Leck.

R.C.S. Luxembourg B 90.521.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 09 septembre 2008 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Capellen, le 24 septembre 2008.

Camille MINES
<i>Notaire

Référence de publication: 2008124048/225/13.
(080144029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Messageries du Livre S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2411 Luxembourg, 5, rue Frédérique Guillaume Raiffeisen.

R.C.S. Luxembourg B 53.763.

Messageries Paul Kraus, porteur des parts à 100 % de la s.à r.l. Messageries du Livre, représentée par Monsieur Jérôme

Trigano, a pris la décision suivante lors de l'assemblée générale ordinaire du 10.09.2008:

1. Monsieur Peter Wüst ne fait plus partie du conseil de gérance avec effet au 10.07.2008.
2. Monsieur Kaspar Niklaus est nommé nouveau membre du conseil de gérance avec effet au 10.09.2008.
3. Le nouveau conseil de gérance se compose des personnes suivantes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:
Monsieur Jacques Funck, président 79, rue des Champs, L-8053 Bertrange
Monsieur Markus Voegeli, Bergstrasse 23, CH-8700 Küsnacht
Monsieur Kaspar Niklaus, Rundihale 1, CH-8707 Uetikon am See
Monsieur Christian Schock, Mülistatt 6, CH-8955 Oetwill a.d. Limmat
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Jérôme Trigano
<i>Directeur général

Référence de publication: 2008124116/1539/22.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2008, réf. LSO-CU05593. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118762

Centaurium Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.304.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 juillet 2008

L'Assemblée a décidé de reconduire le mandat d'administrateur de
Monsieur Theo Uffing, ayant son adresse professionnelle au 162, Jan van Rijswijcklaan, B- 2020 Anvers, Belgique,
Monsieur Claude Zimmer, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg,
Monsieur Hans Pieterman, ayant son adresse professionnelle au 99, Voie Julia, F- 06220 Vallauris, France,
Monsieur Sibrand van Roijen, ayant son adresse professionnelle au 22-24, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg,
ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes de
Audiex S.A., ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124113/4175/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04365. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

HSBC Trinkaus Lingohr, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 141.002.

Les statuts coordonnés de la société au 15 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 22 septembre 2008.

Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008124047/243/13.
(080143788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Oras S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 55.892.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 juin 2008

Sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de

2014, les mandats de:

Madame Sylvie THEISEN et Dr. Albert GNÄGI en tant qu'administrateurs et administrateurs-délégués et Madame

Eliane IRTHUM en tant qu'administrateur de la société

FIDUCIAIRE FRH SARL (anciennement FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES SARL), Strassen en tant que

Commissaire aux Comptes.

Pour extrait sincère et conforme
<i>ORAS S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008124108/788/19.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06304. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118763

VP Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 730.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 43, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.936.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique prenant effet le 22 septembre 2008 que:
M. Borger Borgerson a été renvoyé de ses fonctions de gérant. En remplacement, la personne suivante a été nommée

gérant avec effet immédiat pour une durée indéterminée:

- M. Torben Henning Nielsen, Deputy Chairman &amp; Governor, né le 2 novembre 1947, à Fanefjord, Danmark, demeurant

professionnellement au Banque Centrale de Danemark, Havnegade 5, DK-1093 Copenhague, Denmark.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Jan BÖING
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008124126/275/19.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07786. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Transports et Garage Presse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 15.484.

Messageries Paul Kraus, porteur des parts à 100 % de la s.à r.l. Transports et Garage Presse, représentée par Monsieur

Jérôme Trigano, a pris la décision suivante lors de l'assemblée générale ordinaire du 10.09.2008:

1. Monsieur Peter Wüst ne fait plus partie du conseil de gérance avec effet au 10.07.2008.
2. Monsieur Kaspar Niklaus est nommé nouveau membre du conseil de gérance avec effet au 10.09.2008.
3. Le nouveau conseil de gérance se compose des personnes suivantes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:
Monsieur Jacques Funck, président, 79, rue des Champs, L-8053 Bertrange
Monsieur Markus Voegeli, Bergstrasse 23, CH-8700 Küsnacht
Monsieur Kaspar Niklaus, Rundihale 1, CH-8707 Uetikon am See
Monsieur Christian Schock, Mülistatt 6, CH-8955 Oetwill a.d. Limmat
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Jérôme Trigano
<i>Directeur général

Référence de publication: 2008124117/1538/22.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2008, réf. LSO-CU05595. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Fruitbrokers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 44.385.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/9/08.

Signature.

Référence de publication: 2008124307/777/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02838. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

118764

Fruitbrokers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 44.385.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/9/08.

Signature.

Référence de publication: 2008124308/777/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02836. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Chiquis SA, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 135.896.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents des son/ses administrateur(s):

Mr Doeke van der Molen, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, a été

nommé en date du 1 

er

 août 2008 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec

effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2013.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Administrateur Unique
Par Doeke van der Molen
<i>Représentant Permanent

Référence de publication: 2008124137/710/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07489. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Nido Notting Hill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 121.188.

<i>Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 31 juillet 2008 que BRE/Europe 5N S.à r.l. a transféré les

500 (cinq cents) parts qu'elle détenait dans la Société à:

- Nido Holding Hill JV S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois de Luxembourg,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 140.873, ayant son siège social
au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Depuis cette date, les parts de la Société sont réparties comme suit:

Nido Holding Hill JV S.à r.l.

500 (cinq cents) parts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

<i>NIDO NOTTING HILL S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008124125/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08574. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118765

Blue Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.250.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.915.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société du 11 août 2008 + rectificatif

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 11 août 2008, Mr Alois Johann Bauer a transféré la totalité de ses parts

détenues dans la Société de la manière suivante:

- 150,000 parts sociales de catégorie B, à Donau Reserve GmbH, enregistrée auprès du registre de commerce et des

sociétés de Passau (Allemagne) sous le numéro de registre HRB 7219, ayant son siège social au Dr.-Emil-Brichta-Strasse
3a, 94036, Passau, Allemagne avec effet au 1 

er

 août 2008

Suite à un changement d'adresse de Donau Management GmbH &amp; Co. KG, il y lieu de modifier les données de celui-

ci comme suit. Donau Management GmbH &amp; Co. KG a son siège social au Dr.-Emil-Brichta-Strasse 3a, 94036, Passau,
Allemagne.

Luxembourg, le 15 septembre 2008.

Jean-Michel Clinquart
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008124142/9168/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08334. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Russbrough S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 98.406.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents des son/ses administrateur(s):

Mr Doeke van der Molen, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, a été

nommé en date du 1 

er

 août 2008 en tant que représentant permanent de TCG Gestion S.A. avec effet immédiat, son

mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2009.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Luxembourg Corporation Company SA / TCG Gestion SA
<i>Administrateur / Administrateur
Par Doeke van der Molen / Par Doeke van der Molen
<i>Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2008124140/710/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07496. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Cemex Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 115.907.340,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 96.895.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124311/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07785. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

118766

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 28.531.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 30 juin 2008 a adopté les résolutions suivantes:
1. L'assemblée a ré-élu comme administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle

de 2009.

- Monsieur Germain Birgen, (résidant au Luxembourg),
- Monsieur Nigel Howard Fielding, (résidant au Luxembourg),
- Monsieur Timothy Howell, (résidant en Grande Bretagne),
- Madame Christiane Hella Marliani, (résidant en Allemagne),
- Monsieur Michael Peter May, (résidant à Luxembourg),
- Monsieur John Christopher Wilcockson, (résidant à Luxembourg)
2. L'assemblée a ré-élu KPMG Audit à la fonction de réviseur d'entreprises pour une période d'un an se terminant à

l'assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Pour HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Ciaran Mc Kay

Référence de publication: 2008124148/41/23.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08075. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Goodrich XCH Luxembourg B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 83.442.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008123962/220/12.
(080144229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Guitay Distribution S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 113.335.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de son/ses administrateur(s):

Mr Doeke van der Molen, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été

nommé en date du 1 

er

 août 2008 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec

effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2011.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Administrateur
Par Doeke van der Molen
<i>Représentant Permanent

Référence de publication: 2008124133/710/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07500. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118767

S.G.S. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 113.747.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 22 août 2008

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société S.G.S. INVEST S.A tenue le 22 août

2008, que

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 8-10,

rue Monnet, L-2180 Luxembourg

2. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marco CAMERONI, de son poste de Président et Administrateur

et de Mme Marie Louise SCHMIT de son poste d'Administrateur, avec effet immédiat.

3. L'Assemblée nomme:
- M 

e

 Aloyse MAY, né à Strasbourg (France) le 16 juillet 1954 et demeurant professionnellement au 41, av. de la Liberté

à L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- M. Gianmarco BERGERRE, né le 21 mai 1962 à La Hestre (Belgique), demeurant professionnellement au 8-10, rue

Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, Administrateur;

avec effet à dater de la présente Assemblée.
Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2008124037/5387/27.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04885. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Messageries Paul Kraus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.000.000,00.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 73.774.

Valora Holding Austria AG, porteur des parts à 100% de la s.à r.l. Messageries Paul Kraus, représentée par Monsieur

Markus Voegeli, a pris la décision suivante lors de l'assemblée générale ordinaire du 10.09.2008:

1. Monsieur Peter Wüst ne fait plus partie du conseil de gérance avec effet au 10.07.2008.
2. Monsieur Kaspar Niklaus est nommé nouveau membre du conseil de gérance avec effet au 10.09.2008.
3. Le nouveau conseil de gérance se compose des personnes suivantes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:
Monsieur Jacques Funck, président
79, rue des Champs, L-8053 Bertrange
Monsieur Markus Voegeli
Bergstrasse 23, CH-8700 Küsnacht
Monsieur Kaspar Niklaus
Rundihale 1, CH-8707 Uetikon am See
Monsieur Christian Schock
Mülistatt 6, CH-8955 Oetwill a.d. Limmat
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2008.

Jérôme Trigano
<i>Directeur général

Référence de publication: 2008124118/1529/27.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2008, réf. LSO-CU05586. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118768

EuroInvest Financing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R.C.S. Luxembourg B 94.083.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 24 juin 2008

<i>- Conseil d'administration:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu les membres suivants du conseil d'administration:
1) Monsieur Ziad Rawashdeh, administrateur de sociétés, demeurant à Grand-Saconnex, Genève, Suisse, 14, Chemin

des Massettes, président du conseil d'administration,

2) Monsieur Abbas Jafarian, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, Grande-Bretagne, 53 Cavendisch House,

21 Wellington Road, administrateur,

3) Madame Lucy Dupong, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie, adminis-

trateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année

2009, statuant sur les comptes de l'exercice 2008.

<i>- Commissaire:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu comme commissaire la société Dupont, Koevoets &amp; Co, réviseurs d'en-

treprises, avec siège social à Bruxelles, Belgique.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2009,

statuant sur les comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 10 septembre 2008.

<i>Pour EuroInvest Financing S.A.
Par mandat
Lucy DUPONG

Référence de publication: 2008124120/259/29.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04872. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Elsa S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 56.510.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008123929/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03953. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Polaris Architects S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 38, rue Arthur Herchen.

R.C.S. Luxembourg B 105.989.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008124324/824/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03911. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

118769

Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 84.426.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008124316/1091/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08629. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Kauri Capital 5, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 324.900,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 123.781.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 17 septembre 2008, a renouvelé le mandat de ses gérants:
- Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 3-5, place

Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

- Manuel HACK, maître ès sciences économiques, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

<i>Pour KAURI CAPITAL 5, Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2008124078/833/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU07154. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Kauri Capital 3, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.538.325,00.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 119.753.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 17 septembre 2008, a renouvelé le mandat de ses gérants:
- Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 3-5, place

Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

- Manuel HACK, maître ès sciences économiques, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

<i>Pour KAURI CAPITAL 3, Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2008124076/833/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU07152. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118770

Cofino Crans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 88.002.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008124424/724/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08470. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

OHL Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 83.066.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008124411/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08471. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Berlage 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.879.

L'adresse professionnelle de Monsieur Sibrand van Roijen est dorénavant au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

L'adresse professionnelle de Monsieur Claude Zimmer est dorénavant au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Lu-

xembourg.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124114/4175/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05214. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

SCI Cessimo, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 70, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg E 1.199.

ACTE RECTIFICATIF

L'an deux mille huit, le onze août.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. - Madame Simone KERGEN, associée gérante APL, demeurant à L-1328 Luxembourg, 46, rue de Charlemagne,
2.- La société à responsabilité limitée «SIMPAT S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-8093 Bertrange, 2, rue

Charles Schwall, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 129328, con-
stituée suivant acte notarié du 27 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1710 du
13 août 2007,

118771

ici représentée par son gérant unique savoir Monsieur Patrick ATTEN, employé privé, demeurant professionnellement

à Bertrange,

les comparants sub 1.- et 2.- agissant en leur qualité d'associés de la société civile immobilière « SCI CESSIMO » (ci-

après dénommée «la Société»), ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 70, rue de Cessange.

Lesquels comparants ont déclaré vouloir rectifier le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire documenté

par le notaire soussigné en date du 29 juin 2007 (numéro 457/07 de son répertoire), en raison de l'erreur matérielle
figurant à la page 2 dudit acte à laquelle il est erronément indiqué que «suite à cet acte de cession, le capital social de la
société AUTO-PARTS S.à r.l. est réparti comme sait:».

Ce paragraphe est rectifié comme suit:
«Suite à cet acte de cession, le capital social de la société SCI CESSIMO est réparti comme suit:

Madame Simone KERGEN: cinquante-et-une parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

SIMPAT S.à r.l.: quarante-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. KERGEN, P. ATTEN et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2008. LAC/2008/33933. - Reçu douze euros, € 12,-.

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande aux fins de publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008123921/7241/38.
(080143983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

IPSE Dixit Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.346.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 5 mai 2008

<i>Résolutions

L'assemblée  ratifie la  cooptation de  M.  Jonathan Lepage  et  de Monsieur  Sébastien Schaack  décidée par le  conseil

d'administration lors de ses réunions respectivement du 31 janvier 2008 et du 16 avril 2008.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2008 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Jonathan Lepage, né le 27 août 1975 à Namur (Belgique), demeurant professionnellement au 19-21, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur et président;
Sébastien Schaack, né le 22 juillet 1978 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 19-21, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Mme Elisiana Pedone, née le 30 avril 1982 à Trani (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008123782/24/29.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08616. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

118772

LFS Multi-Family Office S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 115.083.

EXTRAIT

Il résulte d'un courrier adressé à la société en date du 31 juillet 2008 que:
- M. Laurent MULLER a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet immédiat.
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008124406/717/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07778. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 141.798.

In the year two thousand eight, on the twelfth of September
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 2) S.à r.l., a company incorporated and organized under the

laws of Luxembourg, with registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, which registration with the
Luxembourg Trade and Companies Register is pending,

here represented Barbara Malaniuk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September

12th, 2008 in Luxembourg;

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration au-
thorities.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - registered office - object - duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name

AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 3) S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by
the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter
the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

118773

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company.  It  may  also  give  guarantees  and  grant  securities  in  favour  of  third  parties  to  secure  its  obligations  or  the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets. For the avoidance of doubt, the Company
shall not carry out any regulated activities of the financial sector.

3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against currency
exchange and interest rate risks as well as other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twenty thousand British pounds (GBP 20,000) represented by twenty

thousand (20,000) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the

general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law

and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - representation

Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of

118774

managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there is more than one manager, by any two managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of

any two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

118775

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2008.

<i>Subscription-payment

Thereupon, AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 2) S.à r.l., prenamed and represented as stated

here-above, declare to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all twenty
thousand (20,000) shares by contribution in cash, so that the amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000)
is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

For the tax registration purposes, the share capital is estimated at EUR 25.094.- (exchange rate (median price) on

September 11th, 2008: GBP 1.- = EUR 1,2547).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR one thousand five hundred euro (1.500.- €).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Phil Garling, manager, born on 8 October 1953 in Sydney (Australia), with professional address at Level 13, AMP

Centre, 50 Bridge Street Sydney NSW 2000, Australia;

- Mr. Rob Gregor, manager, born on 29 May 1969 in Griffith (Australia), with professional address at 4th floor Berkeley

Square House Berkeley Square London W1J 6BX United Kingdom; and

- Mr. Bart Zech, manager, born on 5 September 1969 in Putten (the Netherlands), with professional address at 12-14,

rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

118776

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le douze septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 2) S.à r.l., une société constituée et régie selon le droit

luxembourgois, ayant son siège social au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg en cours d'immatriculation auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg,

ici représentée par Barbara Malaniuk, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

le 12 septembre 2008 à Luxembourg.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le représentant de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - siège social - objet social - durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AMP Capital Investors

(FDF European Infrastructure No. 3) S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les
Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des

succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou  de  créances.  La Société  pourra  prêter  des  fonds, y  compris ceux résultant  des  emprunts  et/ou  des  émissions
d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou
de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs. En tout état de cause, la Société ne devra
pas effectuer une activité réglementée du secteur financier.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

118777

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à vingt mille livres sterling (GBP 20.000), représenté par à vingt mille (20.000) parts sociales

sous forme nominative d'une valeur d'un livre sterling (GBP 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des parts sociales sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où

il pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat.
Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas
nécessairement un/des associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par le gérant, ou s'il y a plusieurs gérants, par deux gérants de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

118778

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de

deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-

118779

ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est

fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2008.

<i>Souscription - libération

AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 2) S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir

souscrit à l'intégralité du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les vingt mille (20.000) parts sociales
par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt mille livres (GBP 20.000) est à la disposition de la Société, ce
qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à EUR 25.094.- (taux de change (median price) du 11

septembre 2008: GBP 1,- = EUR 1,2547).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500.-
€).

<i>Décision de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérantes de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Phil Garling, gérant, né le 8 octobre 1953 à Sydney (Australie), avec adresse professionnelle au 13 

ème

 niveau,

AMP Centre, 50 Bridge Street Sydney NSW 2000, Australie;

- M. Rob Gregor, gérant, né le 29 mai 1969 à Griffith (Australie), avec adresse professionnelle au 4 

ème

 étage, Berkeley

Square House Berkeley Square Londres W1J 6BX Angleterre; et

- M. Bart Zech, gérant, né le 5 septembre 1969 à Putten (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 12-14, rue Léon

Thyes L-2636 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la société compa-

rante, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la société comparante, ledit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: B. Malaniuk et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg AC, le 18 septembre 2008. LAC/2008/37942. - Reçu cent vingt-cinq euros soixante cents

Eur 0,5% = 125,60

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008124194/5770/415.
(080144546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

JB Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 128.848.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

118780

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008124348/824/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03909. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Pafint Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 40.359.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.09.08.

Signature.

Référence de publication: 2008124372/9125/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05134. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080144536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Aromes et Senteurs sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 98.599.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 30 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008124294/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05203. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Mai Luxembourg SE, Société Européenne.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 42.206.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of the month of September.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Mai Luxembourg SE, (the "Company"), a société

européenne having its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg registered with the Luxem-
bourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 42.206, incorporated as a société anonyme by deed of
Maître Reginald Neuman, notary then residing in Luxembourg, dated 4th December 1992 published in the Mémorial C
(Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 70 of 12th February 1993 converted to a société à res-
ponsabilité limitée by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 7th September 1999 published
in the Mémorial number 887 of the 24th November 1999 and converted to a société anonyme by deed of Maître Blanche
Moutrier, prenamed, on 27th May 2008 published in the Mémorial number 1187 of 16th May 2008. The Company has
been converted into a société européenne by deed of Maître Blanche Moutrier, prenamed, on 24th June 2008 published
in the Mémorial number 1657 of the 5th July 2008.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of Maître Blanche Moutrier,

prenamed, on 24th June 2008 published in the Mémorial number 1657 of the 5th July 2008.

The meeting was presided by Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

e

 Mariya Gadzhalova, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as

secretary and scrutineer.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by

the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached to this
document to be filed with the registration authorities.

118781

2. It appears from said attendance list that all one hundred twenty thousand and one (120.001) shares in issue are

represented at the present general meeting.

3. All shareholders represented declared having had full knowledge of the agenda of the meeting and waive their rights

to prior notice so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

4. On 7th July 2008 the board of directors of the Company resolved to propose to the shareholders of the Company

to transfer the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the United Kingdom.

5. All formalities with respect to the transfer of the registered office of the Company from the Grand Duchy of

Luxembourg to the United Kingdom as provided for by articles 101-2 a 101-9 of the law of 10th August 1915 on com-
mercial companies, as amended (the "Law") and by article 8 of the Council Regulation (EC) N 

o

 2157/2001 of 8 th October

2001 on the Statute for a European company (the "Regulation"), have been complied with, in particular:

a) the board has drawn up a transfer proposal which was published in the Memorial number 1760 published on 17th

July 2008, i.e. at least two months prior to the holding of the present extraordinary general meeting of the shareholders
of the Company;

b) the board has drawn up a board report on the proposed transfer of registered office from the Grand Duchy of

Luxembourg to the United Kingdom in accordance with article 101-4 of the Law and article 8 (3) of the Regulation;

c) the board report and the transfer proposal were available for consultation to the creditors and the shareholders

and the shareholders and the creditors have been duly informed of their right to consult the board report and the transfer
proposal at the registered office of the Company one month prior to the present general meeting;

d) the creditors were duly informed of their right to apply for security to the Tribunal d'Arrondissement de et a

Luxembourg sitting in commercial matters within a two-month period starting on the date of publication of the transfer
proposal in the Memorial;

e) the Company has no employees and no bondholders so that the requirements relating thereto are not applicable.
6. The agenda of the meeting was as follows:
A. Presentation and approval of the transfer proposal as published in the Memorial number 1760 published on 17th

July 2008 and the board report on the transfer of the registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the
United Kingdom.

B. Approval of the change of nationality and approval of the transfer of the registered office of the Company from 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Ludgate House, 245 Blackfriars Road,
London SE1 9UY, United Kingdom.

C. Approval and adoption of new articles of association of the Company compliant with English law, the proxyholder

being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate.

D. Acceptance of the resignation of Mr Jack Groesbeek, Mr Paul de Haan and Mr Dennis Bosje as directors of the

Company with effect from 17th September 2008 and appointment of the following persons as additional directors of the
Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company approving the accounts for the financial
year which shall end 31st December 2008:

- Mrs Anne Claire Siddell, company secretary, born on 17th May 1954 in Pinner, United Kingdom, residing at 10 Hearn

Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, United Kingdom;

- Mr Andrew Frank Crow, chartered accountant, born on 12th July 1957 in Bromley, United Kingdom, residing at 61

Palace Road, Tulse Hill, London, SW2 3LB, United Kingdom;

- Mr Peter Ian Wrankmore, chartered accountant, born on 10th April 1969 in Eastleigh, United Kingdom, residing at

5 Park Road, Bishops Waltham, Southampton, S032 1BQ, United Kingdom; and

- Mr Nicolas Michael Perkins, international tax manager, born on 16th September 1969 in Bridgend, United Kingdom,

residing at Flat 1, 46 Islington Park Street, London, N1 IPX, United Kingdom.

E. Acceptance of the resignation of Mrs Valerie Fisson as statutory auditor of the Company with effect from 17th

September 2008.

Thereafter the meeting unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The transfer proposal relating to the transfer of the registered office of the Company from 17, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United
Kingdom as published in the Memorial number 1760 of 17th July 2008 and the board report thereon were presented to
the meeting.

Thereafter the general meeting carefully considered the terms thereof and resolved to approve such transfer proposal

subject to any amendments which appeared necessary as provided for in the following resolutions.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to change the nationality of the Company from Luxembourg to English and to transfer

the registered office of the Company from 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
to Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United Kingdom, with effect from the date hereof.

118782

<i>Third resolution

The general meeting noted the proposed articles of association as set out in the transfer proposal published in the

Memorial number 1760 of 17th July and noted that the new articles of association of the Company to be adopted by it
further to the transfer of the Company's registered office to the United Kingdom approved hereabove shall comply with
English law.

Therefore, the general meeting resolved to adopt new articles of association of the Company as follows:

"STATUTES

OF

MAI LUXEMBOURG SE ("the Company")

Interpretation

1. IN THESE STATUTES:
The following words and expressions have the following meanings:
1.1 "Acts" means the Companies Acts 1985 and 2006 including any statutory modification or re-enactment thereof

for the time being in force.

"address" in relation to an electronic communication includes any number or address used for the purposes of such

communication.

"administrative organ" means the body responsible for the management of the Company, and in these Statutes such

term is used interchangeably with, and should be construed synonymously with, the term "members", meaning the mem-
bers or any of them acting as the administrative organ of the Company. In addition, a reference in the Acts to the board
of directors or the directors shall be construed as a reference to the administrative organ or the members, respectively.

"auditors" means the auditors of the Company.
"clear days" in relation to the period of a notice means that period excluding the day when the notice is given or

deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect.

"electronic communication" means the same as in the Electronic Communications Act 2000.
"executed" includes any mode of execution.
"member" means, except where the context otherwise required, a member of the administration organ of the Com-

pany, as such term is used in the Rules and "members" shall be construed accordingly.

"office" means the registered office of the Company.
"Rules" shall collectively mean Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European

Company (SE), Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European Company
with  regard  to  the  involvement  of  employees  and  The  European  Public  Limited-Liability  Company  Regulations  2004
(Statutory Instrument 2004 No. 2326).

"secretary" means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the secretary

of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary.

"shareholder" in relation to shares means the shareholder whose name is entered in the register of shareholders as

the holder of the shares.

"Statutes" means the statutes of the Company, wherein are set forth, as required by the Rules, the rules for the

operation of the Company.

"uncertificated" in relation to a share means that, by virtue of legislation (other than section 778 of the Companies

Act 2006) permitting title to shares to be evidenced and transferred without a certificate, title to that share is evidenced
and may be transferred without a certificate.

"the United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland.
l. 2 Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Statutes bear the same meaning

as in the Acts or in the Rules as the case may be but excluding any statutory modification thereof not in force when these
Statutes become binding on the Company.

l. 3 Powers of delegation shall not be restrictively construed but the widest interpretation shall be given to them.
1.4 No power of delegation shall be limited by the existence or, except where expressly provided by the terms of

delegation, the exercise of that or any other powers of delegation.

1. 5 Except where expressly provided by the terms of delegation, the delegation of a power shall not exclude the

concurrent exercise of that power by any other body or person who is for the time being authorised to exercise it under
the Statutes or under another delegation of the power.

1. 6 References to a document being executed include references to its being executed under hand or under seal or

by any other method.

1. 7 Unless the context otherwise requires, any reference to "writing" or "written" shall include any method of re-

producing words or text in a legible and non-transitory form and for the avoidance of doubt shall include email.

118783

.l. 8 Save where specifically required or indicated otherwise words importing one gender shall be treated as importing

any gender, words importing individuals shall be treated as importing corporations and vice versa, words importing the
singular shall be treated as importing the plural and vice versa, and words importing the whole shall be treated as including
a reference to any part thereof.

1. 9 Clause and paragraph headings are inserted for ease of reference only and shall not affect construction.

Name and registered office

2. The Company's name is MAI LUXEMBOURG SE.

3. The Company's registered office is situated at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United

Kingdom.

Share capital

4. The subscribed capital of the Company shall amount to EURO 120,001 and shall be divided into 120,001 par value

shares with a nominal value of EURO 1.00 each.

5. Subject to the provisions of the Acts and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any share

may be issued with such rights or restrictions as the Company may by ordinary resolution determine.

6. Subject to the provisions of the Acts, shares may be issued which are to be redeemed or are to be liable to be

redeemed at the option of the Company or the shareholders on such terms and in such manner as may be provided by
these Statutes.

7. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust and

(except as otherwise provided by these Statutes or by law) the Company shall not be bound by or recognise any interest
in any share except an absolute right to the entirety thereof in the holder.

8. The liability of the Company's shareholders is limited.

No share certificates

9. None of the Company's shareholders shall be entitled to receive any share certificate(s) in respect of any shares in

the Company and the register of shareholders of the Company shall be conclusive evidence of a shareholder's title to
any shares of the Company.

Transfer of shares

10. The instrument of transfer of a share may be in any usual form or in any other form which the members may

approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and, unless the share is fully paid, by or on behalf of the
transferee.

11. The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered.

Transmission of shares

12. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a

corporation may, upon such evidence being produced as the members may properly require, elect either to become the
shareholder or to have some person nominated by him registered as the transferee. If he elects to become the share-
holder, he shall give notice to the Company to that effect. If he elects to have another person registered, he shall execute
an instrument of transfer of the share to that person. All provisions in the Statutes relating to the transfer of shares shall
apply to the notice or instrument of transfer as if it were an instrument of transfer executed by the shareholder and the
merger or consolidation of the shareholder had no occurred.

13. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a

corporation shall have the rights to which he would be entitled if he were the shareholder, except that he shall not, before
being registered as the shareholder, be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company or at
any separate meeting of the shareholders of any class of shares in the Company.

Alteration of share capital

14. The Company may by ordinary resolution:
(a) increase its share capital by new shares of such amount as the resolution prescribes;
(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
(c) subject to the provisions of the Acts, sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount and the

resolution may determine that, as between the shares resulting from the sub-division, any of them may have any preference
or advantage as compared with the others; and

(d) cancel shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any

person and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled.

15. Subject to the provisions of the Acts, the Company may by special resolution reduce its share capital, any capital

redemption reserve and any share premium account in any way.

118784

Purchase of own shares

16. Subject to the provisions of the Acts, the Company may purchase its own shares (including any redeemable shares).

General meetings

17. The Company shall hold a general meeting at least once every calendar year within six months of the end of its

financial year.

18. All general meetings other than annual general meetings shall be called general meetings.

19. The members may call general meetings and, on the requisition of shareholders pursuant to the provisions of the

Acts, shall forthwith proceed to convene a general meeting for a date not later than eights weeks after receipt of the
requisition.

Notice of general meetings

20. An annual general meeting shall be called by at least twenty-one clear days' notice. All other general meetings shall

be called by at least fourteen clear days' notice but a general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed:

(a) in the case of an annual general meeting, by all the shareholders entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of any other meeting by a majority in number of the shareholders having a right to attend and vote

being a majority together holding not less than ninety-five per cent in nominal value of the shares giving that right.

21. The notice shall specify the time and place of the meeting and the general nature of the business to be transacted

and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such.

22. Subject to the provisions of the Statutes and to any restrictions imposed on any shares, the notice shall be given

to all the shareholders and to the auditors.

23. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person

entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

24. Where for any purpose an ordinary resolution of the Company is required, a special resolution shall also be

effective.

Proceedings at general meetings

25. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. One person entitled to vote upon the

business to be transacted, being a shareholder or a proxy for a shareholder or a duly authority representative of a
corporation, shall be a quorum.

26. The shareholders present and entitled to vote at any general meeting shall choose one of their number to preside

as chairman of such meeting.

27. A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of hands unless before, or on the declaration

of the result of, the show of hands a poll is duly demanded by the chairman or any member present, in person or by
proxy, or duly authorised representative, and entitled to vote.

28. In the case of an equality of votes the chairman shall be entitled to a casting vote in addition to any other vote he

may have.

Votes of shareholders

29. Subject to any rights or restrictions attached to any shares every shareholder shall have one vote for every share

of which he is the shareholder.

30. Votes may be cast in person or by proxy.

31. A vote given or poll demanded by proxy or by the duly authorised representative of a corporation shall be valid

notwithstanding the previous determination of the authority of the person voting or demanding a poll unless notice of
the determination was received by the Company at the office or at such other place at which the instrument of proxy
was duly deposited or, where the appointment of the proxy was contained in an electronic communication, at the address
at which such appointment was duly received before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which
the vote is given or the poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or
adjourned meeting) the time appointed for taking the poll.

Numbers of members

32. Unless otherwise determined by ordinary resolution, the number of members shall not be subject to any maximum

but shall be not less than two.

Power of members

33. The Company shall operate under a one-tier system as prescribed by the Rules. Subject to the provisions of the

Rules, the Acts, the Statutes and to any directions given by special resolution, the business of the Company shall be

118785

managed by the members who may exercise all the powers of the Company and the following transactions shall require
an express decision of the administrative organ;

(a) the appointment of any person to be and fulfil the role (as defined by the members) of (i) President; (ii) Vice-

President; (iii) Controller; and (iv) Treasurer for the Company;

(b) the disposal of the whole of the Company's undertaking or property or a substantial part thereof; and
(c) the acquisition of the whole or any substantial part of the undertaking, assets or business of any other company or

any firm or person or the entry into of any joint venture or partnership with any other person.

34. No alteration of the Statutes and no such direction shall invalidate any prior act of the members which would have

been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given. The powers given by this Statute 34
shall not be limited by any special power given the members by the Statutes and a meeting of members at which a quorum
is present may exercise all powers exercisable by the members.

35. The members may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for

such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his
powers.

36. The members shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not to divulge any information

which they have concerning the Company the disclosure of which might be prejudicial to the Company's interests, except
where such disclosure is required or permitted under law or is in the public interest.

Appointment and removal of members

37. Members previously appointed by shareholders' resolution shall continue as members for the duration of the terms

specified in those shareholders' resolutions unless removed earlier by an ordinary resolution of the Company. All mem-
bers shall be appointed (for a term of one year) either:

(i) by an ordinary resolution of the Company; or
(ii) by a decision of the members,
and may be removed prior to the expiration of the term of their appointment by ordinary resolution of the Company.

A member who is appointed by a decision of the members must retire at the next following annual general meeting.

38. A member whose term of appointment shall expire shall be eligible for reappointment once or more than once

but always such that any new appointment shall be for a term of one year and subject to such appointment (and any
subsequent removal prior to the expiration of the term of their appointment) being made by an ordinary resolution of
the Company.

Disqualification and removal of members

39. The office of a member shall be vacated if:
(a) he ceases to be a member by virtue of any provision of the Acts or he becomes prohibited by law from being a

member; or

(b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(c) he is, or may be, suffering from mental disorder and either:
(i) he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act

1983 or, in Scotland, an application for admission under the Mental Health (Scotland) Act 1960; or

(ii) an order is made by a court having jurisdiction (whether in the United Kingdom or elsewhere) in matters concerning

mental disorder for his detention or for the apportionment of a receiver, curator bonis or other person to exercise
powers with respect to his property or affairs; or

(d) he resigns his office by notice to the Company.

Remuneration of members

40. The members shall be entitled to a remuneration and the reimbursement of their expenses as the Company by

ordinary resolution determines.

Proceedings of members

41. Subject to the provisions of the Statutes, the members may regulate their proceedings as they think fit. A member

may, and the secretary at the request of a member shall, call a meeting of the members and in any event shall do so at
least every three months to discuss the progress and foreseeable development of the Company's business. Notice of a
meeting of the members shall be deemed to be properly given to a member if it is given to him personally or by word of
mouth or sent in writing or by electronic communication to him at his last known address or any other address given by
him to the Company for this purpose. Any member may waive notice of a meeting and any such waiver may be retro-
spective. Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes. In this case of an equality of votes, the
chairman shall have a second or casting vote.

42. The quorum for the transaction of the business of the members may be fixed by the members and unless so fixed

at any other number shall be two.

118786

43. The continuing members or a sole continuing member may act notwithstanding any vacancies in their number, but,

if the number of members is less than the number fixed as the quorum, the continuing members of member may act only
for the purpose of calling a general meeting.

44. The members shall appoint one of their number to be chairman of the administrative organ and may at any time

remove him from that office. Unless he is unwilling to do so, the member so appointed shall preside at every meeting of
members at which he is present. If there is no member holding that office, or if the member holding it is unwilling to
preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the members present may appoint
one of their number to be chairman of the meeting.

45. All acts done by a meeting of members, or of a committee of members, or by a person acting as a member shall,

notwithstanding that it be afterwards discovered that there was a defect in the appointment of any member or that any
of them were disqualified from holding office, or had vacated office, or were entitled not to vote, be as valid as if every
such person had been duly appointed and was qualified and had continued to be a member and had been entitled to vote.

46. A resolution in writing signed by all the members entitled to receive notice of a meeting of members or of a

committee of members shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of members or (as the case
may be) a committee of members duly convened and held and may consist of several documents in the like form each
signed by one or more members.

47. The contemporaneous connection of a number of the members not less than the quorum, regardless of the physical

location, by any means of electronic communication shall be deemed to constitute a properly held meeting of the members
so long as the following conditions are met:

(a) throughout the meeting each of the members taking part must be able to:
(i) hear each of the other members taking part; and
(ii) subject as mentioned below, send and receive communications simultaneously to and from all of the other members

taking part;

(b) at the beginning and at the conclusion of the meeting the chairman shall ask all of those who have been a party to

the proceedings to acknowledge their presence and to confirm that they have attended throughout the meeting.

Such a meeting shall be deemed to take place where it is convened to be held or (if no member is present in that

place) where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of
the meeting is located. The word "meeting" in the Statutes shall be construed accordingly.

The meeting shall have been validly conducted notwithstanding that a member may have been accidentally disconnected

during the meeting, so long as a quorum of members was connected at all times. A minute of the proceedings shall be
sufficient evidence to the observance of the necessary formalities if certified by a member who was party to them.

48. Subject to such disclosure as is required by the Acts and the Statutes, a member shall be entitled to vote at any

meeting of members or of a committee of members on, and be counted in the quorum present at a meeting in relation
to, any resolution concerning a matter in which he has, directly or indirectly, an interest or duty which is material and
which conflicts or may conflict with the interest of the Company.

49. Each member is entitled to require the administrative organ to provide to him all information submitted to the

administrative organ.

Secretary

50. Subject to the provisions of the Acts, the secretary shall be appointed by the members for such term, at such

remuneration and upon such conditions as they may think fit, and any secretary so appointed may be removed by them.

51. Two or more joint secretaries, each of whom shall have full authority to act alone and independently of each other,

may be appointed pursuant to the provisions of Statute 50.

Minutes

52. The members shall cause minutes to be made in books kept for the purpose:
(a) of all appointments of officers made by the members; and
(b) of all proceedings at meetings of the Company, of the shareholders of any class of shares in the Company, and of

the members, and of committees of members, including the names of the members present at each such meeting.

Notices

53. Any notice to be given to or by any person pursuant to the Statutes (other than a notice calling a meeting of the

members) shall be in writing or shall be given using electronic communications to an address for the time being notified
for that purpose to the person giving the notice.

54. The Company may give any notice to a shareholder either personally or by sending it by post in a prepaid envelope

addressed to the shareholder at his registered address or by leaving it at the address or by giving it using electronic
communications to an address for the time being notified to the Company by the shareholder.

118787

55. A shareholder present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company or of the shareholders of

any class of shares in the Company shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the
purposes for which it was called.

56. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share which, before

his name is entered in the register of shareholders, has been duly given to a person from whom he derives his title.

57. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted shall be conclusive evidence

that the notice was given. Proof that a notice contained in an electronic communication was sent in accordance with
guidance issued by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators shall be conclusive evidence that the notice
was given. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after the envelope containing it was posted
or, in the case of a notice contained in an electronic communication, at the expiration of 48 hours after the time it was
sent.

Procedure for declaring dividends

58. The Company may by ordinary resolution declare dividends, and the members may decide to pay interim dividends.

59. A dividend must not be declared by ordinary resolution unless the members have made a recommendation as to

its amount. Such dividend must not exceed the amount recommended by the members.

60. No dividend may be declared or paid unless;
(a) it appears to the members that the profits available for distribution justify the payment; and
(b) it is in accordance with shareholders' respective rights.

61. Unless the ordinary resolution of the Company or members' decision to declare or pay a dividend, or the terms

on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholders' holding of shares on
the date of the resolution or decision to declare or pay it.

62. If the Company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying

deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrears.

63. The members may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available

for distribution justify the payment.

64. If the members act in good faith they do not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights

for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.

Calculation of dividends

65. Except as otherwise provided by these Statutes or the rights attached to shares, all dividends must be:
(a) declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid; and
(b) apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the

period in respect of which the dividend is paid.

66. If any share is issued on terms providing that it ranks for dividend as from a particular date, the share ranks for

dividend accordingly.

67. For the purpose of calculating dividends, no account is to be taken of any amount which has been paid up on a

share in advance of the due date for payment of that amount.

Payment of dividends and other distributions

68. Where a dividend or other sum is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following

means:

(a) transfer to a bank account specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members

decide;

(b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution

recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address
specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide;

(c) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient

has specified in writing or by such other means as the members decide; or

(d) any other means of payment (including by the allotment or transfer of further shares in accordance with these

Statutes) as the members agree with the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide.

69. In these Statutes "distribution recipient" means, in the respect of a share in respect of which a dividend or other

sum is payable:

(a) the holder of the share; or
(b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or

118788

(c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law,

the transmittee.

Deductions from distributions in respect of sums owed to the company

70. If a share is party paid for any part of the share's nominal value and any premium at which it has been issued, the

members may deduct from any dividend or other sum payable in respect of the share any sum of money which is payable
to the Company in respect of that share.

71. Money so deducted must be used to pay any of the sums payable in respect of that share.

72. The Company must notify the distribution recipient in writing of:
(a) the fact and amount of any such deduction;
(b) any non-payment of a dividend or other sum payable in respect of a share resulting from any such deduction; and
(c) how the money deducted has been applied.

No interest on distributions

73. The Company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise

provided by:

(a) the terms on which the share was issued; or
(b) the provisions of another agreement between the holder of that share and the Company.

Unclaimed distributions

74. All dividends or other sums which are:
(a) payable in respect of shares; and
(b) unclaimed after having been declared or become payable,
must be invested or otherwise made use of by the members for the benefit of the Company until claimed.

75. The payment of such dividend or other sum into a separate account does not make the Company a trustee in

respect of it.

76. If:
(a) twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment; and
(b) the distribution recipient has not claimed it,
the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other sum and it ceases to remain owing by the

Company.

Non-cash distributions

77. Subject to the terms of issue of the share in question, the Company may, by ordinary resolution on the recom-

mendation of the members, decide to pay all or part of a dividend or other sum payable in respect of a share by transferring
non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).

78. If the shares in respect of which such a non-cash distribution is paid are uncertificated, any shares in the Company

which are issued as a noncash distribution in respect of them must be uncertificated.

79. For the purpose of paying a non-cash distribution, the members may make whatever arrangement they think fit,

including:

(a) fixing the value of any assets;
(b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
(c) vesting any assets in trustees.

Waiver of distributions

80. Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other sum payable in respect of a share by

giving the Company notice in writing to that effect, but if:

(a) the share has more than one holder; or
(b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy or one of more joint

holders, or otherwise,

the notice is not effective unless it is expressed to be given and signed, by all the holders or persons otherwise entitled

to the share.

Winding up

81. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the Company and any

other sanction required by the Acts, divide among the shareholders in specie the whole or any part of the assets of the
Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the
shareholders or different classes of shareholders. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part

118789

of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the shareholders as he with the like sanction determines, but
no shareholder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

Indemnity

82. Subject to the provisions of the Acts but without prejudice to any indemnity to which a member may otherwise

be entitled, every member or other officer of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against
any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour
or in which he is acquitted or in connection with any application in which relief is granted to him by the court from liability
for negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the affairs of the Company.

83. Without prejudice to the provisions of Statute 82 and subject to what the Company by ordinary resolution of the

shareholders determines, the members may exercise all the powers of the Company to purchase and maintain insurance
for or for the benefit of any person who is or was a member, other officer or employee or auditor of the Company, or
any body which is or was the holding company or subsidiary undertaking of the Company, or in which the Company or
such holding company or subsidiary undertaking has or had any interest (whether direct or indirect) or with which the
Company or such holding company or subsidiary undertaking is or was in any way allied or associated against any liability
incurred by such person in respect of any act or omission in the actual or purported execution or discharge of his duties
or in the exercise or purported exercise of his powers or otherwise in relation to his duties, powers or officers in relation
to the relevant body or fund.

Exclusion of Table A

84. Neither the regulations in Table A in the First Schedule to the Companies Act 1948 nor those in Table A in the

schedule to the Companies (Table A to F) Regulations 1985 as amended from time to time shall apply to the Company.

Objects

85. The Company's objects are to carry on the business of a general commercial company; to subscribe for, take,

purchase, or otherwise acquire, hold, sell, deal with and dispose of, place and underwrite shares, stocks, debentures,
debenture stocks, bonds, obligations or securities issues or guaranteed by any other company constituted or carrying on
business in any part of the world, and debentures, debenture stocks, bonds obligations or securities issued or guaranteed
by any government or authority, municipal, local or otherwise, in any part of the world; to carry on any other trade or
business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the objects specified
in this Statute 85 or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the property,
assets or rights of the Company and to do all such things as are incidental or conducive to the above objects or any of
them."

<i>Fourth resolution

The general meeting acknowledged and accepted the resignation of Mr Jack Groesbeek, Mr Paul de Haan and Mr

Dennis Bosje as directors of the Company with effect from 17th September 2008 and resolved to appoint the following
persons as additional directors of the Company until the annual meeting of the shareholders of the Company approving
the accounts for the financial year which shall end 31st December 2008:

- Mrs Anne Claire Siddell, company secretary, born on 17th May 1954 in Pinner, United Kingdom, residing at 10 Hearn

Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, United Kingdom;

- Mr Andrew Frank Crow, chartered accountant, born on 12th July 1957 in Bromley, United Kingdom, residing at 61

Palace Road, Tulse Hill, London, SW2 3LB, United Kingdom;

- Mr Peter Ian Wrankmore, chartered accountant, born on 10th April 1969 in Eastleigh, United Kingdom, residing at

5 Park Road, Bishops Waltham, Southampton, S032 1BQ, United Kingdom; and

- Mr Nicolas Michael Perkins, international tax manager, born on 16th September 1969 in Bridgend, United Kingdom,

residing at Flat 1, 46 Islington Park Street, London, N1 1PX, United Kingdom.

<i>Fifth resolution

The general meeting acknowledged and accepted the resignation of Mrs Valérie Fisson as statutory auditor of the

Company with effect from 17th September 2008.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the transfer of its registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the United Kingdom are estimated
at €3,100,-.

There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg on the day beforementioned
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

118790

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-septième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Mai Luxembourg SE, (la «Société»), une société

européenne avec siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 42.206, constituée sous forme d'une
société anonyme par acte de Maître Reginald Neuman, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, le 4 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 70
du 12 février 1993, convertie en une société à responsabilité limitée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence  à  Luxembourg,  en  date  du  7  septembre  1999,  publié  au  Mémorial  numéro  887  du  24  novembre  1999  et
convertie en une société anonyme par acte de Maître Blanche Moutrier, prénommée, le 7 mai 2008 publié au Mémorial
numéro 1187 du 16 mai 2008. La Société a été convertie en une société européenne par acte de Maître Blanche Moutrier,
prénommée, le 24 juin 2008 publié au Mémorial numéro 1657 du 5 juillet 2008.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Blanche Moutrier, prénommée, le

24 juin 2008 publié au Mémorial numéro 1657 du 5 juillet 2008.

L'assemblée a été présidée par Monsieur Paul de Haan, comptable, résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-

bourg.

Maître  Mariya  Gadzhalova,  maître  en  droit,  résidant  à  Luxembourg,  Grand-Duché  du  Luxembourg,  a  été  désigné

comme secrétaire et comme scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée par

le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste restera annexée au présent acte pour
être soumise aux formalités d'enregistrement.

2. Il ressort de ladite liste que toutes les cent vingt mille et une (120.001) actions émises par la Société sont représentées

à la présente assemblée générale.

3. Tous les actionnaires représentés déclarent avoir eu une connaissance complète de l'ordre du jour de l'assemblée

et renoncer à leur droit à une convocation préalable de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les
points portés à l'ordre du jour.

4. Le 7 juillet 2008 le conseil d'administration de la Société a décidé de proposer aux actionnaires de la Société de

transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers le Royaume-Uni.

5. Toutes les formalités relatives au transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers le

Royaume-Uni telles que prévues par les articles 101-2 à 101-9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la «Loi») et par l'article 8 du Règlement CE 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif
au statut de la société européenne (le «Règlement») ont été respectées, notamment:

a) le conseil a établi un projet de transfert qui a été publié au Mémorial numéro 1760 du 17 juillet 2008, c'est-à-dire

au moins deux mois avant la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires de la Société;

b) le conseil a établi un rapport du conseil d'administration sur le transfert proposé du siège social du Grand-Duché

de Luxembourg vers le Royaume-Uni conformément à l'article 101-4 de la Loi et à l'article 8(3) du Règlement;

c) le rapport du conseil d'administration et le projet de transfert étaient disponibles à la consultation par les créanciers

et les actionnaires et les actionnaires et les créanciers ont été dûment informés de leur droit de consulter le rapport du
conseil d'administration et le projet de transfert au siège social de Société un mois avant la présente assemblée générale;

d) les créanciers ont été dûment informés de leur droit de demander au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

siégeant en matière commerciale la constitution de sûretés pendant une période de deux mois à partir de la date de
publication du projet de transfert au Mémorial;

e) la Société n'a pas d'employés ni d'obligataires de sorte que les conditions y relatives ne sont pas applicables.
6. Que l'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:
A. Présentation et approbation du projet de transfert tel que publié au Mémorial numéro 1760 du 17 juillet 2008 et

du rapport du conseil d'administration concernant le transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers le
Royaume-Uni.

B. Approbation du changement de nationalité et approbation du transfert du siège social de la société du 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1
9UY, Royaume-Uni.

C. Approbation et adoption de nouveaux statuts de la Société conformes au droit anglais, le mandataire étant ex-

pressément autorisé et ayant le pouvoir de procéder et de donner son accord aux modifications qui lui sembleront
appropriées.

D. Acceptation de la démission de M. Jack Groesbeek, M. Paul de Haan et M. Dennis Bosje en tant que administrateurs

de la Société avec effet au 17 septembre 2008 et nomination des personnes suivantes en tant que administrateurs sup-

118791

plémentaires de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes
annuels de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008:

- Mme Anne Claire Siddell, secrétaire de société, née le 17 mai 1954 à Pinner, Royaume Uni, demeurant au 10 Hearn

Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, Royaume Uni;

- M. Andrew Frank Crow, expert comptable, né le 12 juillet 1957 à Bromley, Royaume Uni, demeurant au 61 Palace

Road, Tulse Hill, Londres, SW2 3LB, Royaume Uni;

- M. Peter Ian Wrankmore, expert comptable, né le 10 avril 1969 à Eastleigh, Royaume Uni, demeurant au 5 Park Road,

Bishops Waltham, Southampton, S032 1BQ, Royaume Uni; et

- M. Nicolas Michael Perkins, directeur fiscalité internationale, né le 16 septembre 1969 à Bridgend, Royaume Uni,

demeurant au Appartement 1, 46 Islington Park Street, Londres, N1 1PX, Royaume Uni.

E. Acceptation de la démission de Mme Valérie Fisson en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet

au 17 septembre 2008.

Suite à quoi, l'assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le projet de transfert concernant le transfert du siège social de la Société du 17, boulevard Prince Henri, L-1724

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1 9UY, Royaume-Uni,
tel que publié au Mémorial numéro 1730 du 17 juillet 2008 et du rapport du conseil d'administration y relatif ont été
présentés à l'assemblée.

Ensuite l'assemblée a attentivement examiné leurs termes et a décidé d'approuver le projet de transfert sous réserve

de toutes modifications nécessaires telles que prévues dans les résolutions suivantes.

<i>Seconde résolution

L'assemblée générale a décidé de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en anglaise et de transférer

le siège social de la Société du 17, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Ludgate
House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1 9UY, Royaume-Uni, avec effet à partir de la date du présent acte.

<i>Troisième résolution

L'assemblée a pris note des statuts proposés tels que figurant au projet de transfert publié au Mémorial 1730 du 17

juillet 2008 et a pris note que les statuts de la Société devant être adoptés suite au transfert du siège social de la Société
vers le Royaume-Uni approuvé ci-dessus doivent être conformes au droit anglais.

Par conséquent, l'assemblée a décidé d'adopter des nouveaux statuts de la Société comme suit:

"STATUTES

OF

MAI LUXEMBOURG SE ("the Company")

Interprétation

1. IN THESE STATUTES:
The following words and expressions have the following meanings:
1.1 "Acts" means the Companies Acts 1985 and 2006 including any statutory modification or re-enactment thereof

for the time being in force.

"address" in relation to an electronic communication includes any number or address used for the purposes of such

communication.

"administrative organ" means the body responsible for the management of the Company, and in these Statutes such

term is used interchangeably with, and should be construed synonymously with, the term "members", meaning the mem-
bers or any of them acting as the administrative organ of the Company. In addition, a reference in the Acts to the board
of directors or the directors shall be construed as a reference to the administrative organ or the members, respectively.

"auditors" means the auditors of the Company.
"clear days" in relation to the period of a notice means that period excluding the day when the notice is given or

deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect.

"electronic communication" means the same as in the Electronic Communications Act 2000.
"executed" includes any mode of execution.
"member" means, except where the context otherwise required, a member of the administration organ of the Com-

pany, as such term is used in the Rules and "members" shall be construed accordingly.

"office" means the registered office of the Company.
"Rules" shall collectively mean Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European

Company (SE), Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European Company
with  regard  to  the  involvement  of  employees  and  The  European  Public  Limited-Liability  Company  Regulations  2004
(Statutory Instrument 2004 No. 2326).

118792

"secretary" means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the secretary

of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary.

"shareholder" in relation to shares means the shareholder whose name is entered in the register of shareholders as

the holder of the shares.

"Statutes" means the statutes of the Company, wherein are set forth, as required by the Rules, the rules for the

operation of the Company.

"uncertificated" in relation to a share means that, by virtue of legislation (other than section 778 of the Companies

Act 2006) permitting title to shares to be evidenced and transferred without a certificate, title to that share is evidenced
and may be transferred without a certificate.

"the United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland.
1.2 Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Statutes bear the same meaning

as in the Acts or in the Rules as the case may be but excluding any statutory modification thereof not in force when these
Statutes become binding on the Company.

1.3 Powers of delegation shall not be restrictively construed but the widest interpretation shall be given to them.
1.4 No power of delegation shall be limited by the existence or, except where expressly provided by the terms of

delegation, the exercise of that or any other powers of delegation.

1.5 Except where expressly provided by the terms of delegation, the delegation of a power shall not exclude the

concurrent exercise of that power by any other body or person who is for the time being authorised to exercise it under
the Statutes or under another delegation of the power.

1.6 References to a document being executed include references to its being executed under hand or under seal or

by any other method.

1.7 Unless the context otherwise requires, any reference to "writing" or "written" shall include any method of repro-

ducing words or text in a legible and non-transitory form and for the avoidance of doubt shall include email.

1.8 Save where specifically required or indicated otherwise words importing one gender shall be treated as importing

any gender, words importing individuals shall be treated as importing corporations and vice versa, words importing the
singular shall be treated as importing the plural and vice versa, and words importing the whole shall be treated as including
a reference to any part thereof.

1.9 Clause and paragraph headings are inserted for ease of reference only and shall not affect construction.

Name and registered office

2. The Company's name is MAI LUXEMBOURG SE.

3. The Company's registered office is situated at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, United

Kingdom.

Share capital

4. The subscribed capital of the Company shall amount to EURO 120,001 and shall be divided into 120,001 par value

shares with a nominal value of EURO 1.00 each.

5. Subject to the provisions of the Acts and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any share

may be issued with such rights or restrictions as the Company may by ordinary resolution determine.

6. Subject to the provisions of the Acts, shares may be issued which are to be redeemed or are to be liable to be

redeemed at the option of the Company or the shareholders on such terms and in such manner as may be provided by
these Statutes.

7. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust and

(except as otherwise provided by these Statutes or by law) the Company shall not be bound by or recognise any interest
in any share except an absolute right to the entirety thereof in the holder.

8. The liability of the Company's shareholders is limited.

No share certificates

9. None of the Company's shareholders shall be entitled to receive any share certificate(s) in respect of any shares in

the Company and the register of shareholders of the Company shall be conclusive evidence of a shareholder's title to
any shares of the Company.

Transfer of shares

10. The instrument of transfer of a share may be in any usual form or in any other form which the members may

approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and, unless the share is fully paid, by or on behalf of the
transferee.

11. The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered.

118793

Transmission of shares

12. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a

corporation may, upon such evidence being produced as the members may properly require, elect either to become the
shareholder or to have some person nominated by him registered as the transferee. If he elects to become the share-
holder, he shall give notice to the Company to that effect. If he elects to have another person registered, he shall execute
an instrument of transfer of the share to that person. All provisions in the Statutes relating to the transfer of shares shall
apply to the notice or instrument of transfer as if it were an instrument of transfer executed by the shareholder and the
merger or consolidation of the shareholder had no occurred.

13. A person becoming entitled to a share in consequence of the merger or consolidation of any shareholder being a

corporation shall have the rights to which he would be entitled if he were the shareholder, except that he shall not, before
being registered as the shareholder, be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company or at
any separate meeting of the shareholders of any class of shares in the Company.

Alteration of share capital

14. The Company may by ordinary resolution:
(a) increase its share capital by new shares of such amount as the resolution prescribes;
(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
(c) subject to the provisions of the Acts, sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount and the

resolution may determine that, as between the shares resulting from the sub-division, any of them may have any preference
or advantage as compared with the others; and

(d) cancel shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any

person and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled.

15. Subject to the provisions of the Acts, the Company may by special resolution reduce its share capital, any capital

redemption reserve and any share premium account in any way.

Purchase of own shares

16. Subject to the provisions of the Acts, the Company may purchase its own shares (including any redeemable shares).

General meetings

17. The Company shall hold a general meeting at least once every calendar year within six months of the end of its

financial year.

18. All general meetings other than annual general meetings shall be called general meetings.

19. The members may call general meetings and, on the requisition of shareholders pursuant to the provisions of the

Acts, shall forthwith proceed to convene a general meeting for a date not later than eights weeks after receipt of the
requisition.

Notice of general meetings

20. An annual general meeting shall be called by at least twenty-one clear days' notice. All other general meetings shall

be called by at least fourteen clear days' notice but a general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed:

(a) in the case of an annual general meeting, by all the shareholders entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of any other meeting by a majority in number of the shareholders having a right to attend and vote

being a majority together holding not less than ninety-five per cent in nominal value of the shares giving that right.

21. The notice shall specify the time and place of the meeting and the general nature of the business to be transacted

and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such.

22. Subject to the provisions of the Statutes and to any restrictions imposed on any shares, the notice shall be given

to all the shareholders and to the auditors.

23. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person

entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

24. Where for any purpose an ordinary resolution of the Company is required, a special resolution shall also be

effective.

Proceedings at general meetings

25. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. One person entitled to vote upon the

business to be transacted, being a shareholder or a proxy for a shareholder or a duly authority representative of a
corporation, shall be a quorum.

26. The shareholders present and entitled to vote at any general meeting shall choose one of their number to preside

as chairman of such meeting.

118794

27. A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of hands unless before, or on the declaration

of the result of, the show of hands a poll is duly demanded by the chairman or any member present, in person or by
proxy, or duly authorised representative, and entitled to vote.

28. In the case of an equality of votes the chairman shall be entitled to a casting vote in addition to any other vote he

may have.

Votes of shareholders

29. Subject to any rights or restrictions attached to any shares every shareholder shall have one vote for every share

of which he is the shareholder.

30. Votes may be cast in person or by proxy.

31. A vote given or poll demanded by proxy or by the duly authorised representative of a corporation shall be valid

notwithstanding the previous determination of the authority of the person voting or demanding a poll unless notice of
the determination was received by the Company at the office or at such other place at which the instrument of proxy
was duly deposited or, where the appointment of the proxy was contained in an electronic communication, at the address
at which such appointment was duly received before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which
the vote is given or the poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or
adjourned meeting) the time appointed for taking the poll.

Numbers of members

32. Unless otherwise determined by ordinary resolution, the number of members shall not be subject to any maximum

but shall be not less than two.

Power of members

33. The Company shall operate under a one-tier system as prescribed by the Rules. Subject to the provisions of the

Rules, the Acts, the Statutes and to any directions given by special resolution, the business of the Company shall be
managed by the members who may exercise all the powers of the Company and the following transactions shall require
an express decision of the administrative organ;

(a) the appointment of any person to be and fulfil the role (as defined by the members) of (i) President; (ii) Vice-

President; (iii) Controller; and (iv) Treasurer for the Company;

(b) the disposal of the whole of the Company's undertaking or property or a substantial part thereof; and
(c) the acquisition of the whole or any substantial part of the undertaking, assets or business of any other company or

any firm or person or the entry into of any joint venture or partnership with any other person.

34. No alteration of the Statutes and no such direction shall invalidate any prior act of the members which would have

been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given. The powers given by this Statute 34
shall not be limited by any special power given the members by the Statutes and a meeting of members at which a quorum
is present may exercise all powers exercisable by the members.

35. The members may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for

such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his
powers.

36. The members shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not to divulge any information

which they have concerning the Company the disclosure of which might be prejudicial to the Company's interests, except
where such disclosure is required or permitted under law or is in the public interest.

Appointment and removal of members

37. Members previously appointed by shareholders' resolution shall continue as members for the duration of the terms

specified in those shareholders' resolutions unless removed earlier by an ordinary resolution of the Company. All mem-
bers shall be appointed (for a term of one year) either:

(i) by an ordinary resolution of the Company; or
(ii) by a decision of the members,
and may be removed prior to the expiration of the term of their appointment by ordinary resolution of the Company.

A member who is appointed by a decision of the members must retire at the next following annual general meeting.

38. A member whose term of appointment shall expire shall be eligible for reappointment once or more than once

but always such that any new appointment shall be for a term of one year and subject to such appointment (and any
subsequent removal prior to the expiration of the term of their appointment) being made by an ordinary resolution of
the Company.

Disqualification and removal of members

39. The office of a member shall be vacated if:

118795

(a) he ceases to be a member by virtue of any provision of the Acts or he becomes prohibited by law from being a

member; or

(b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(c) he is, or may be, suffering from mental disorder and either:
(i) he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act

1983 or, in Scotland, an application for admission under the Mental Health (Scotland) Act 1960; or

(ii) an order is made by a court having jurisdiction (whether in the United Kingdom or elsewhere) in matters concerning

mental disorder for his detention or for the apportionment of a receiver, curator bonis or other person to exercise
powers with respect to his property or affairs; or

(d) he resigns his office by notice to the Company.

Remuneration of members

40. The members shall be entitled to a remuneration and the reimbursement of their expenses as the Company by

ordinary resolution determines.

Proceedings of members

41. Subject to the provisions of the Statutes, the members may regulate their proceedings as they think fit. A member

may, and the secretary at the request of a member shall, call a meeting of the members and in any event shall do so at
least every three months to discuss the progress and foreseeable development of the Company's business. Notice of a
meeting of the members shall be deemed to be properly given to a member if it is given to him personally or by word of
mouth or sent in writing or by electronic communication to him at his last known address or any other address given by
him to the Company for this purpose. Any member may waive notice of a meeting and any such waiver may be retro-
spective. Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes. In this case of an equality of votes, the
chairman shall have a second or casting vote.

42. The quorum for the transaction of the business of the members may be fixed by the members and unless so fixed

at any other number shall be two.

43. The continuing members or a sole continuing member may act notwithstanding any vacancies in their number, but,

if the number of members is less than the number fixed as the quorum, the continuing members of member may act only
for the purpose of calling a general meeting.

44. The members shall appoint one of their number to be chairman of the administrative organ and may at any time

remove him from that office. Unless he is unwilling to do so, the member so appointed shall preside at every meeting of
members at which he is present. If there is no member holding that office, or if the member holding it is unwilling to
preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the members present may appoint
one of their number to be chairman of the meeting.

45. All acts done by a meeting of members, or of a committee of members, or by a person acting as a member shall,

notwithstanding that it be afterwards discovered that there was a defect in the appointment of any member or that any
of them were disqualified from holding office, or had vacated office, or were entitled not to vote, be as valid as if every
such person had been duly appointed and was qualified and had continued to be a member and had been entitled to vote.

46. A resolution in writing signed by all the members entitled to receive notice of a meeting of members or of a

committee of members shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of members or (as the case
may be) a committee of members duly convened and held and may consist of several documents in the like form each
signed by one or more members.

47. The contemporaneous connection of a number of the members not less than the quorum, regardless of the physical

location, by any means of electronic communication shall be deemed to constitute a properly held meeting of the members
so long as the following conditions are met:

(a) throughout the meeting each of the members taking part must be able to:
(i) hear each of the other members taking part; and
(ii) subject as mentioned below, send and receive communications simultaneously to and from all of the other members

taking part;

(b) at the beginning and at the conclusion of the meeting the chairman shall ask all of those who have been a party to

the proceedings to acknowledge their presence and to confirm that they have attended throughout the meeting.

Such a meeting shall be deemed to take place where it is convened to be held or (if no member is present in that

place) where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of
the meeting is located. The word "meeting" in the Statutes shall be construed accordingly.

The meeting shall have been validly conducted notwithstanding that a member may have been accidentally disconnected

during the meeting, so long as a quorum of members was connected at all times. A minute of the proceedings shall be
sufficient evidence to the observance of the necessary formalities if certified by a member who was party to them.

118796

48. Subject to such disclosure as is required by the Acts and the Statutes, a member shall be entitled to vote at any

meeting of members or of a committee of members on, and be counted in the quorum present at a meeting in relation
to, any resolution concerning a matter in which he has, directly or indirectly, an interest or duty which is material and
which conflicts or may conflict with the interest of the Company.

49. Each member is entitled to require the administrative organ to provide to him all information submitted to the

administrative organ.

Secretary

50. Subject to the provisions of the Acts, the secretary shall be appointed by the members for such term, at such

remuneration and upon such conditions as they may think fit, and any secretary so appointed may be removed by them.

51. Two or more joint secretaries, each of whom shall have full authority to act alone and independently of each other,

may be appointed pursuant to the provisions of Statute 50.

Minutes

52. The members shall cause minutes to be made in books kept for the purpose:
(a) of all appointments of officers made by the members; and
(b) of all proceedings at meetings of the Company, of the shareholders of any class of shares in the Company, and of

the members, and of committees of members, including the names of the members present at each such meeting.

Notices

53. Any notice to be given to or by any person pursuant to the Statutes (other than a notice calling a meeting of the

members) shall be in writing or shall be given using electronic communications to an address for the time being notified
for that purpose to the person giving the notice.

54. The Company may give any notice to a shareholder either personally or by sending it by post in a prepaid envelope

addressed to the shareholder at his registered address or by leaving it at the address or by giving it using electronic
communications to an address for the time being notified to the Company by the shareholder.

55. A shareholder present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company or of the shareholders of

any class of shares in the Company shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the
purposes for which it was called.

56. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share which, before

his name is entered in the register of shareholders, has been duly given to a person from whom he derives his title.

57. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted shall be conclusive evidence

that the notice was given. Proof that a notice contained in an electronic communication was sent in accordance with
guidance issued by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators shall be conclusive evidence that the notice
was given. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after the envelope containing it was posted
or, in the case of a notice contained in an electronic communication, at the expiration of 48 hours after the time it was
sent.

Procedure for declaring dividends

58. The Company may by ordinary resolution declare dividends, and the members may decide to pay interim dividends.

59. A dividend must not be declared by ordinary resolution unless the members have made a recommendation as to

its amount. Such dividend must not exceed the amount recommended by the members.

60. No dividend may be declared or paid unless;
(a) it appears to the members that the profits available for distribution justify the payment; and
(b) it is in accordance with shareholders' respective rights.

61. Unless the ordinary resolution of the Company or members' decision to declare or pay a dividend, or the terms

on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholders' holding of shares on
the date of the resolution or decision to declare or pay it.

62. If the Company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying

deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrears.

63. The members may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available

for distribution justify the payment.

64. If the members act in good faith they do not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights

for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.

Calculation of dividends

65. Except as otherwise provided by these Statutes or the rights attached to shares, all dividends must be:

118797

(a) declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid; and
(b) apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the

period in respect of which the dividend is paid.

66. If any share is issued on terms providing that it ranks for dividend as from a particular date, the share ranks for

dividend accordingly.

67. For the purpose of calculating dividends, no account is to be taken of any amount which has been paid up on a

share in advance of the due date for payment of that amount.

Payment of dividends and other distributions

68. Where a dividend or other sum is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following

means:

(a) transfer to a bank account specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members

decide;

(b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution

recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address
specified by the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide;

(c) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient

has specified in writing or by such other means as the members decide; or

(d) any other means of payment (including by the allotment or transfer of further shares in accordance with these

Statutes) as the members agree with the distribution recipient in writing or by such other means as the members decide.

69. In these Statutes "distribution recipient" means, in the respect of a share in respect of which a dividend or other

sum is payable:

(a) the holder of the share; or
(b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or
(c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law,

the transmittee.

Deductions from distributions in respect of sums owed to the company

70. If a share is party paid for any part of the share's nominal value and any premium at which it has been issued, the

members may deduct from any dividend or other sum payable in respect of the share any sum of money which is payable
to the Company in respect of that share.

71. Money so deducted must be used to pay any of the sums payable in respect of that share.

72. The Company must notify the distribution recipient in writing of:
(a) the fact and amount of any such deduction;
(b) any non-payment of a dividend or other sum payable in respect of a share resulting from any such deduction; and
(c) how the money deducted has been applied.

No interest on distributions

73. The Company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise

provided by:

(a) the terms on which the share was issued; or
(b) the provisions of another agreement between the holder of that share and the Company.

Unclaimed distributions

74. All dividends or other sums which are:
(a) payable in respect of shares; and
(b) unclaimed after having been declared or become payable,
must be invested or otherwise made use of by the members for the benefit of the Company until claimed.

75. The payment of such dividend or other sum into a separate account does not make the Company a trustee in

respect of it.

76. If:
(a) twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment; and
(b) the distribution recipient has not claimed it,
the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other sum and it ceases to remain owing by the

Company.

118798

Non-cash distributions

77. Subject to the terms of issue of the share in question, the Company may, by ordinary resolution on the recom-

mendation of the members, decide to pay all or part of a dividend or other sum payable in respect of a share by transferring
non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).

78. If the shares in respect of which such a non-cash distribution is paid are uncertificated, any shares in the Company

which are issued as a noncash distribution in respect of them must be uncertificated.

79. For the purpose of paying a non-cash distribution, the members may make whatever arrangement they think fit,

including:

(a) fixing the value of any assets;
(b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
(c) vesting any assets in trustees.

Waiver of distributions

80. Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other sum payable in respect of a share by

giving the Company notice in writing to that effect, but if:

(a) the share has more than one holder; or
(b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy or one of more joint

holders, or otherwise,

the notice is not effective unless it is expressed to be given and signed, by all the holders or persons otherwise entitled

to the share.

Winding up

81. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the Company and any

other sanction required by the Acts, divide among the shareholders in specie the whole or any part of the assets of the
Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the
shareholders or different classes of shareholders. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part
of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the shareholders as he with the like sanction determines, but
no shareholder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

Indemnity

82. Subject to the provisions of the Acts but without prejudice to any indemnity to which a member may otherwise

be entitled, every member or other officer of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against
any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour
or in which he is acquitted or in connection with any application in which relief is granted to him by the court from liability
for negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the affairs of the Company.

83. Without prejudice to the provisions of Statute 82 and subject to what the Company by ordinary resolution of the

shareholders determines, the members may exercise all the powers of the Company to purchase and maintain insurance
for or for the benefit of any person who is or was a member, other officer or employee or auditor of the Company, or
any body which is or was the holding company or subsidiary undertaking of the Company, or in which the Company or
such holding company or subsidiary undertaking has or had any interest (whether direct or indirect) or with which the
Company or such holding company or subsidiary undertaking is or was in any way allied or associated against any liability
incurred by such person in respect of any act or omission in the actual or purported execution or discharge of his duties
or in the exercise or purported exercise of his powers or otherwise in relation to his duties, powers or officers in relation
to the relevant body or fund.

Exclusion of Table A

84. Neither the regulations in Table A in the First Schedule to the Companies Act 1948 nor those in Table A in the

schedule to the Companies (Table A to F) Regulations 1985 as amended from time to time shall apply to the Company.

Objects

85. The Company's objects are to carry on the business of a general commercial company; to subscribe for, take,

purchase, or otherwise acquire, hold, sell, deal with and dispose of, place and underwrite shares, stocks, debentures,
debenture stocks, bonds, obligations or securities issues or guaranteed by any other company constituted or carrying on
business in any part of the world, and debentures, debenture stocks, bonds obligations or securities issued or guaranteed
by any government or authority, municipal, local or otherwise, in any part of the world; to carry on any other trade or
business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the objects specified
in this Statute 85 or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the property,
assets or rights of the Company and to do all such things as are incidental or conducive to the above objects or any of
them."

118799

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a constaté et accepté la démission de M. Jack Groesbeek, M. Paul de Haan et M. Dennis Bosje

en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 17 septembre 2008 a décidé de nommer les personnes suivantes
en tant qu'administrateurs supplémentaires de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la
Société qui statuera sur les comptes annuels de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008:

- Mme Anne Claire Siddell, secrétaire de société, née le 17 mai 1954 à Pinner, Royaume Uni, demeurant au 10 Hearn

Close, Manor Road, Penn, Bucks, HP10 8JT, Royaume Uni;

- M. Andrew Frank Crow, expert comptable, né le 12 juillet 1957 à Bromley, Royaume Uni, demeurant au 61 Palace

Road, Tulse Hill, Londres, SW2 3LB, Royaume Uni;

- M. Peter Ian Wrankmore, expert comptable, né le 10 avril 1969 à Eastlelgh, Royaume Uni, demeurant au 5 Park Road,

Bishops Waltham, Southampton, S032 1BQ, Royaume Uni; et

- M. Nicolas Michael Perkins, directeur fiscalité internationale, né le 16 septembre 1969 à Bridgend, Royaume Uni,

demeurant au Appartement 1, 46 Islington Park Street, Londres, N1 1PX, Royaume Uni.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale a constaté et accepté la démission de Mme Valérie Fisson en tant que commissaire aux comptes

de la Société avec effet au 17 septembre 2008.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison du transfert du siège social du Grand Duché de Luxembourg vers le Royaume-Uni sont évalués à € 3.100.-.

Aucun point ne restant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en

langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. de Haan, M. Gadzhalova, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 18 SEP, 2008 Relation: EAC/2008/11859. - Reçu douze euros 12,-€.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008124176/272/1025.
(080144828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Rowlands Temporaire-RTT Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 51.158.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 juin 2008

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé la démission, avec effet au 13 mai 2008, des personnes

suivantes de leur fonction d'administrateur:

1. M. Peter VALKS, demeurant à NL-1214 LN Hilversum, Lijsterbeslann: administrateur de la Société;
2. M. Peter RINKES, demeurant à NL-1019 JT Amsterdam, Fred Petterbaan, 27: administrateur de la Société;
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a nommé les administrateurs suivants pour une période prenant

fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en 2012:

1. M. Jacobus Wim van den BROEK, domicilié à NL-1405 GZ Bussum, Graaf Wichmanlaan, 39: administrateur de la

Société;

2. M. Cornelius Christianus VERBRAAK, domicilié à B-3090 Overijse, Metsijsdreef, 2: administrateur de la Société;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008123571/280/21.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07483. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

118800


Document Outline

AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 3) S.à r.l.

Aqua Valley Solutions S.A.

Aralia S.A.

Aromes et Senteurs sàrl

Atlas Capital Group Holding S.A.

Bamaco S.à r.l.

Bedwyn Holding S. à r. l.

Belper Holding S. à r. l.

Berlage 4

Bescot Holding S. à r. l.

Bexhill Holding S. à r. l.

Bleasby Holding S. à r. l.

Blue Holding Luxembourg S.à r.l.

Cemex Capital Investments S.à r.l.

Centaurium Management

Chiquis SA

Cofino Crans S.A.

Ecomundo Group International s.à r.l.

Elsa S.A.

E-Solutions International Holding S.A.

E.S.T.I.M. S.à r.l.

EuroInvest Financing S.A.

Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.à r.l.

Financière Saint Merri Investments S.A.

Fruitbrokers S.A.

Fruitbrokers S.A.

Goodrich XCH Luxembourg B.V.

Guitay Distribution S.A.

HH Luxembourg 2 S.à r.l.

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

HSBC Trinkaus Lingohr

IPSE Dixit Holding S.A.

JB Construction S.A.

JP/LX BC Stereo I S.à r.l.

Kauri Capital 3

Kauri Capital 4

Kauri Capital 5

LFS Multi-Family Office S.A.

Mai Luxembourg SE

Messageries du Livre S.à.r.l.

Messageries Paul Kraus S.à r.l.

Moon International Luxembourg S.A.

Nerisa Beheer B.V. / S.àr.l.

Nido Notting Hill S.à r.l.

Norla Holdings S.A.

OHL Finance S.à r.l.

Oras S.A.

Pafint Holding S.A.

Polaris Architects S.à r.l.

Quixline.com S.A.

REA Group European Production Center

Rowlands Temporaire-RTT Lux S.A.

Russbrough S.A.

Saint Merri Overseas S.A.

SCI Cessimo

SEDIC S.A. (Société Européenne pour le Développement de l'Industrie et du Commerce, Société Anonyme)

S.G.S. Invest S.A.

Shawsa S.A.

Talmec Natur S.à r.l.

Talmec S.à r.l.

Transports et Garage Presse S.à r.l.

VP Lux S.à r.l.

Zefiro S.A.