logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2220

11 septembre 2008

SOMMAIRE

Ad'Net S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106518

Adorf S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106532

Airpark S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106523

Aqua Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106540

Barthels Hof S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106520

Boucherie Krack S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

106518

COLT Lux Group Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

106537

Cono - Consultatio Nobilitatis S.à r.l.  . . . .

106559

Duraflex Luxembourg S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

106514

East Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106558

Elektro R.Velz A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106559

ENTREPRISE DE TRANSPORTS COR-

DELLA Cosimino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106537

EUROMARKET, Alimentation en gros  . . .

106541

European Logistics Income Venture SCA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106550

European Retail Income Venture S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106524

Faune Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106544

Fosbel Global Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106517

Genes Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

106540

Gotic House S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106532

Green European Venture Capital S.A.  . . .

106550

Gulfstream Marine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

106517

HaMer Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106529

Hegeling Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106558

Héron S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106559

HSBCPI Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

106559

Internet Activities S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

106560

Jasper Broker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106541

Kyritz Ueckermunde S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

106532

Lagon 120 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106516

La Modenese S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106520

Les Rossignols S.A. 1850  . . . . . . . . . . . . . . . .

106541

LSF Japan Hotel Investments II S.à r.l.  . . .

106542

Marcell Equity S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106517

Marlow S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106528

Mauna International S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

106549

Micropolis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106523

Monetics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106557

MSPE Metro Investors Lux S.à r.l.  . . . . . . .

106518

Nido Notting Hill S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

106546

ODE International Publishers Holding S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106545

Panthera/Funding Lux 1 S. à r.l.  . . . . . . . . .

106521

Piwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106536

Possneck S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106531

Prenzlau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106523

Pro-Move S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106517

Puzzle Sub S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106537

Quality Electronics Design SA . . . . . . . . . . .

106558

Quedlinburg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106529

Rhyton Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106544

Richemont Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

106547

Rivoli 144 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106519

Russian Credit Cards No. 1 S.A.  . . . . . . . . .

106516

Siagep S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106558

Sopinor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106520

Space Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106545

Telco Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106533

Toiture Ludwig S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106514

Tulipe International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

106560

UK Holdco 2 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106546

Wax S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106519

Wax S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106519

Weinheim Estates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106529

Woodford S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106549

Wrei S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106541

106513

Duraflex Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 133.604.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

SGG Corporate Services S.A.
412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008110922/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11600. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Toiture Ludwig S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6684 Mertert, 7, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 141.068.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den zweiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg),

IST ERSCHIENEN:

Herr Walter LUDWIG, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54413 Rascheid, Schulstrasse 13.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "TOITURE LUDWIG S.à r.l."

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Ausführung von Zimmereiarbeiten und alles was damit verbunden ist.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder

denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN

HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche integral durch Herrn
Walter LUDWIG, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54413 Rascheid, Schulstrasse 13, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€

12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690

des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

106514

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-

gen  bezüglich  der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  ein.  Sie  sind  jedoch  für  die  ordnungsgemässe  Ausführung  ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.

Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr neun hundert Euro (€ 900.-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Walter LUDWIG, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54413 Rascheid, Schulstrasse 13.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und

verpflichtet.

106515

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6684 Mertert, 7, rue du Parc.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. LUDWIG, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 25 août 2008, Relation: ECH/2008/1151. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents

12.500.- à 0,5% = 62,50.- €.

<i>Le Receveur

 (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Echternach, den 26. August 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008110856/201/105.

(080128991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Russian Credit Cards No. 1 S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 119.941.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/08/2008.

SGG Corporate Services S.A.
412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg
<i>Un mandataire
Signature

Référence de publication: 2008110923/1005/17.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09877. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Lagon 120 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 115.055.

La Société LAGON 120 SA a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de la société GL CONSULTING SA, représentée par son administrateur-délégué,

Mr Jean GREFF, avec siège social à L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce du
Luxembourg sous le numéro B 84.282, de son poste d'administrateur.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée nomme la société INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY SA, représentée par son administrateur

unique, Mr Jean GREFF, avec siège social à L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération, inscrite au Registre de Com-
merce du Luxembourg sous le numéro B 139.578, au poste d'administrateur et qui terminera le mandat de l'administrateur
démissionnaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106516

Dudelange, le 16/07/2008.

Mr Jean GREFF / Mme Chantal SIMON / Mlle Aurélie BOULEAU
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2008111596/3139/25.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09636. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Marcell Equity S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 121.636.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008110924/1005/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT10092. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Gulfstream Marine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 122.487.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008110925/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11374. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Pro-Move S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 123.716.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour PRO-MOVE S.àr.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110926/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10616. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Fosbel Global Services, Société Anonyme.

Capital social: USD 40.300,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 109.718.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106517

Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2008110950/1005/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11635. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Ad'Net S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 21A, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 67.532.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour AD'NET S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110927/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10610. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Boucherie Krack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 24, rue Joseph Junck.

R.C.S. Luxembourg B 50.010.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour BOUCHERIE KRACK S.àr.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110928/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10605. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

MSPE Metro Investors Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.076.950,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 120.467.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 juillet 2008

Il résulte de la décision de l'associé unique que:
- Monsieur Pratish Shantilal PATEL, né le 18 juillet 1968 à New York, Etats-Unis, avec adresse professionnelle au 1585

Broadway, New York 10036, Etats-Unis, a été nommé en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 30
juillet 2008;

- Monsieur Martijn BOSCH, né le 28 octobre 1976 à Hengelo, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 6, route de

Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, a été nommé en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet au
30 juillet 2008 pour une période indéfinie.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106518

Luxembourg, le 30 juillet 2008.

<i>Pour MSPE Metro Investors Lux S. à r. l.
SGG Corporate Services S.A.
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2008111617/1005/24.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT10132. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Wax S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1D, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 45.353.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour WAX S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110929/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09735. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Wax S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1D, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 45.353.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour WAX S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110930/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09738. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Rivoli 144 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 115.906.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique en date du 7 août 2008

L'Associé Unique a décidé de prendre les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission avec effet au 7 août 2008:
* Mrs Catherine Koch, gérant B
* Mr Luca Gallinelli, gérant B
- de nommer comme nouveaux gérants B de la société, avec effet au 7 août 2008 pour une durée illimitée;
* Mr Vincenzo Arnò, ayant pour adresse professionnelle 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
* Mr Kemba Raphaël Tshilumba, ayant pour adresse professionnelle 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 33, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106519

Luxembourg, le 18 août 2008.

<i>Pour Rivoli 144 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008111645/1005/24.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10589. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Sopinor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3220 Bettembourg, 55, rue Auguste Collart.

R.C.S. Luxembourg B 86.593.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour SOPINOR S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110931/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09741. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

La Modenese S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 125-129, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 54.130.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour LA MODENESE S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110932/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT07038. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Barthels Hof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.067.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour Barthels Hof S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110934/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT10871. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

106520

Panthera/Funding Lux 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 140.296.

In the year two thousand and eight, on the eighth day of August.
Before Us, Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Panthera/Funding Cayman Limited, an exempted company incorporated and existing under the laws of the Cayman

Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 211395 having its registered
office at c/o Stuarts Corporate Services Ltd, P.O. Box 25.10, 36A Dr. Roy's Drive, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands,

represented by Mrs Claudia Rouckert, private employee with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030

Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on August 7th, 2008.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party is the sole partner of Panthera/Funding Lux 1 S.à.r.l., existing under the laws of Luxembourg and

having its registered office at L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, registered with the Luxembourg trade and com-
panies register under number B 140.296, incorporated pursuant to a notarial deed on July 3rd, 2008, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the "Company")

The by-laws of the Company have been amended pursuant to a notarial deed on July 24, 2008, not yet published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolves to cancel the par value of the shares and to change the currency of the share capital that is

currently expressed in Euro (EUR) into Pounds Sterling (GBP) at the exchange rate of 1.- EUR = 0,79205 GBP as of
August  6th,  2008  and  thereby  to  change  the  share  capital  from  twelve  thousand  five  hundred  Euro  (EUR  12.500,-),
represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares with a par value of one Euro (EUR 1,-) each into nine
thousand nine hundred point sixty-three Pounds Sterling (GBP 9.900,63), represented by twelve thousand five hundred
(12.500) shares without par value.

<i>Second resolution

The sole partner resolves to increase the share capital by two thousand five hundred ninety-nine point thirty-seven

Pounds Sterling (GBP 2.599,37) in order to raise it from the present amount of nine thousand nine hundred point sixty-
three Pounds Sterling (GBP 9.900,63) to twelve thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 12.500,-) without issue of
new shares.

The increase of capital is fully paid up in cash by the sole partner, so that the amount of two thousand five hundred

ninety-nine point thirty-seven Pounds Sterling (GBP 2.599,37) is at the disposal of the Company, as has been proved to
the undersigned notary.

<i>Third resolution

The sole partner resolves to set the par value of the twelve thousand five hundred (12.500) shares at one Pound

Sterling (GBP 1,-) each.

<i>Fourth resolution

Following the above resolutions, the sole partner resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of

incorporation so that it shall henceforth read as follows:

« Art. 5. first paragraph. The company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Pounds Sterling

(GBP 12.500,-) divided into twelve thousand five hundred (12.500) shares of one Pound Sterling (GBP 1, -) each.»

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 1.500,-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

106521

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le huit août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Panthera/Funding Cayman Limited, une société créée et existant sous les lois des Iles Cayman, immatriculée auprès

du Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro 211395, ayant son siège social à c/o Stuarts Corporate
Services Ltd, P.O. Box 2510, 36A Dr. Roy's Drive, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,

représentée par Madame Claudia Rouckert, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard,

L-4030 Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée en date du 7 août 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante est l'associée unique de Panthera/Funding Lux 1 S.à.r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg sous le numéro B 140.296, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 juillet
2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (la «Société»)

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 juillet 2008, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales et de convertir la devise du capital social

actuellement exprimé en Euro (EUR) en Livres Sterling (GBP) au taux d'échange de référence du 6 août 2008, à savoir
1,- EUR = 0,79205 GBP, et de convertir ainsi le capital de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) en neuf mille neuf cent virgule
soixante-trois Livres Sterling (GBP 9.900,63), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans désigna-
tion de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf virgule

trente-sept Livres Sterling (GBP 2.599,37) pour le porter de son montant actuel de neuf mille neuf cent virgule soixante-
trois Livres Sterling (GBP 9.900,63) à douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500,-) sans émission de parts sociales
nouvelles.

L'augmentation de capital est entièrement libérée par apport en numéraire par l'associée unique, de sorte que le

montant de deux mille cinq cent quatre-vingt dix-neuf virgule trente-sept Livres Sterling (GBP 2.599,37) se trouve à la
libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de fixer la valeur nominale des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales à une Livre

Sterling (GBP 1,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions prises ci-avant, l'associée unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 5

des statuts comme suit:

« Art. 5. premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500,-)

représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales avec une valeur de une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune».

<i>Estimation des Frais

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la

Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.500,-.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an figurant tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présente

acte est rédigé en langue anglaise suivie d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire par le notaire.

Signé: Rouckert, Kesseler.

106522

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 août 2008. Relation: EAC/2008/10835. - Reçu seize euros quarante et un

cents, 3.281,83 à 0,5% = 16,41 EUR.

<i>Le Receveur (signé): N. Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26 août 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008110971/219/117.
(080128922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Airpark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.746.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour AIRPARK S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110935/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT10866. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Micropolis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.750.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour MICROPOLIS S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110936/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10621. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Prenzlau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.752.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour PRENZLAU S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110939/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10633. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

106523

European Retail Income Venture S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 109.566.

In the year two thousand eight, on the first day of August,
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEAR:

Mrs Sandra Elsholz, employee, with professional address at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
acting in her capacity as a special proxyholder of EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., a société en com-

mandite par actions governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg, incorporated on 14 July 2005 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial C") number 1339 of 7 December 2005, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 109.566, and whose articles of incor-
poration (the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 17 January
2008, published in the Mémorial C number 647 of 14 March 2008 (the "Company"), by virtue of the authority conferred
on her, by resolutions adopted by the board of directors of EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A. (the "Board of Direc-
tors"), a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue de
la Chapelle, L-1325 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 109.637, acting as general partner of the Company (the "General Partner"), on 11 June 2008, an excerpt of
which resolutions, signed ne varietur by the appearer and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record the following dec-

larations and statements:

I. The subscribed capital of the Company is set at twelve million one hundred thirty thousand seven hundred thirty

five Euro and fifty Cents (EUR 12,130,735.50), represented by eighty-four thousand one hundred fifty-four (84,154) Class
A Shares and eight million three thousand three (8,003,003) Class B Shares each of a par value of one Euro and fifty Cents
(EUR 1.50) and each fully paid in.

II. Pursuant to article 6 of the Articles, the authorised capital of the Company has been set at one hundred thirty-seven

million nine hundred thousand seven hundred sixty-four Euro and fifty Cents (EUR 137,900,764.50) to be used in order
to issue new shares or to increase the nominal value of the shares and pursuant to the same article 6, the General Partner
of the Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company, and to amend the articles of
association of the Company to reflect such a capital increase.

III. The Board of Directors of the General Partner, by resolution adopted on 11 June 2008, and in accordance with

the authority granted to them pursuant to article 6 of the Articles, decided, subject to the confirmation by any one
director of the General Partner of the receipt of the relevant subscription moneis, which confirmation occurred on 18
July 2008, an increase of the Company's issued share capital by an amount of eighty-two thousand two hundred eighty-
five Euro and fifty Cents (EUR 82,285.5) in order to raise the issued share capital to the amount of twelve million two
hundred thirteen thousand twenty one Euro (EUR 12,213,021) by the issuance of two hundred thirty (230) new Class A
Shares with a par value of one Euro and fifty Cents (EUR 1.50) and a share premium of one hundred eighty Euro point
one six five two one seven four (EUR 180.1652174) per each new Class A Share, having the same rights and privileges
as the existing Class A Shares and fifty-four thousand six hundred twenty-seven (54,627) new Class B Shares with a par
value of one Euro and fifty Cents (EUR 1.50) and a share premium of one hundred eighty Euro point seven nine four
seven eight one (EUR 180.794781) per each new Class B Share, having the same rights and privileges as the existing Class
B Shares.

IV. The Board of Directors of the General Partner, by resolution taken on 11 June 2008, approved, in accordance with

the preferential right of subscription of the shareholders of the Company:

1. the subscription of the two hundred thirty (230) new Class A Shares, together with a total share premium of an

amount of forty-one thousand four hundred thirty-eight Euro (EUR 41,438.-) by EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A., a
société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with
registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, and

2. the subscription of the fifty-four thousand six hundred twenty-seven (54,627) new Class B Shares, together with a

total share premium of an amount of nine million eight hundred seventy-six thousand two hundred seventy-six Euro and
fifty Cents (EUR 9,876,276.50), as follows:

MUTAVIE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic of France,

with registered office in F-79088 Niort Cedex 9 France, subscribed to two thousand eight hundred sixty-five (2,865) Class
B Shares, together with a total share premium of an amount of five hundred seventeen thousand nine hundred seventy-
seven Euro five Cents (EUR 517,977.05);

106524

CARDIF ASSURANCE VIE, a société anonyme incorporated in accordance with and governed by French laws, with

registered office at 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris, France, subscribed to seven thousand six hundred fourty
(7,640) Class B Shares, together with a total share premium of an amount of one million three hundred eighty-one
thousand two hundred seventy-two Euro thirteen Cents (EUR 1,381,272.13);

OP LIFE ASSURANCE, a limited company incorporated in accordance with and governed by the laws of Finland, with

registered office at Teollisuuskatu 1a A 00510, Helsinki, Finland, subscribed to one thousand nine hundred ten (1,910)
Class B Shares, together with a total share premium of an amount of three hundred fourty-five thousand three hundred
eighteen Euro three Cents (EUR 345,318.03);

GERBERA S.A. a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of Grand Duchy of

Luxembourg, with registered office at 48, rue de Bragance L-1255 Luxembourg, subscribed to three thousand eight
hundred twenty (3,820) Class B Shares, together with a total share premium of an amount of six hundred ninety thousand
six hundred thirty-six Euro six Cents (EUR 690,636.06);

SCI VENDÔME COMMERCES, a société civile immobilière à capital variable incorporated in accordance with and

governed by French laws, with registered office at Coeur Défense Tour B, La Défense 4, 100, esplanade du Général de
Gaulle, F-92932 Paris La Defense Cedex, France, subscribed to five thousand seven hundred thirty (5,730) Class B Shares,
together with a total share premium of an amount of one million thirty-five thousand nine hundred fifty-four Euro nine
Cents (EUR 1,035,954.09);

AXA RE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic of France,

with registered office at 39, rue du Colisée, 75008 Paris - France, subscribed to one thousand nine hundred ten (1,910)
Class B Shares, together with a total share premium of an amount of three hundred fourty-five thousand three hundred
eighteen Euro three Cents (EUR 345,318.03);

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS, a company incorporated with and governed by the laws of Norway, with reg-

istered office at Filipstad Brygge n 

o

 1, Oslo, Norway, subscribed to four thousand seven hundred seventy-five (4,775)

Class B Shares, together with a total share premium of an amount of eight hundred sixty-three thousand two hundred
ninety-five Euro eight Cents (EUR 863,295.08);

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID (BPF Bouw), a company incorporated with and

governed by the laws of the Netherlands, with registered office at La Guardiaweg 4, 1043 DG Amsterdam, The Neth-
erlands, subscribed to nine thousand five hundred fifty (9,550) Class B Shares, together with a total share premium of an
amount of one million seven hundred twenty-six thousand five hundred ninety Euro sixteen Cents (EUR 1,726,590.16);

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES, a company incorporated with and governed

by the laws of the Netherlands, with registered office at Huizermaatweg 550, 1270 AB Huizen, The Netherlands, sub-
scribed to two thousand eight hundred sixty-five (2,865) Class B Shares, together with a total share premium of an amount
of five hundred seventeen thousand nine hundred seventy-seven Euro five Cents (EUR 517,977.05);

PENSIOENSTICHTING TRANSPORT, a company incorporated with and governed by the laws of the Netherlands,

with registered office at Hoofdorp, The Netherlands, subscribed to one thousand four hundred thirty-three (1,433) Class
B Shares, together with a total share premium of an amount of two hundred fifty-nine thousand seventy-eight Euro ninety-
two Cents (EUR 259,078.92);

ILMARINEN MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, a company incorporated in accordance with and gov-

erned by the laws of Finland, with registered office at Porkkalankatu 1, Helsinki, Finland, Fin-00018 llmarinen, Finland,
subscribed to four thousand seven hundred seventy-five (4,775) Class B Shares, together with a total share premium of
an amount of eight hundred sixty-three thousand two hundred ninety-five Euro eight Cents (EUR 863,295.08);

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, a company incorporated in accordance with and governed by the laws

of France, with registered office at rue de Lille n 

o

 56, F-75007 Paris, France, subscribed to three thousand eight hundred

twenty (3,820) Class B Shares, together with a total share premium of an amount of six hundred ninety thousand six
hundred thirty-six Euro six Cents (EUR 690,636.06);

STICHTING PENSIOENFONDS AHOLD, a company incorporated with and governed by the laws of the Netherlands,

with  registered  office  at  Provincialeweg  11,  1506  MA  Zaadam,  The  Netherlands,  subscribed  to  two  thousand  three
hundred eighty-eight (2,388) Class B Shares, together with a total share premium of an amount of four hundred thirty-
one thousand seven hundred thirty-seven Euro ninety-four Cents (EUR 431,737.94);

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD, a company incorporated with and governed by the laws of Israel, with registered

office at 7, Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, Israel, subscribed to one thousand one hundred fourty-six (1,146) Class
B Shares, together with a total share premium of an amount of two hundred seven thousand one hundred ninety Euro
eighty-two Cents (EUR 207,190.82).

V. All these new Class A and Class B shares were entirely subscribed by the aforesaid subscribers and fully paid up,

together with the share premium, by contribution in cash to the Company on 18 July 2008, so that the total amount of
ten million Euro (EUR 10,000,000.-) representing the aggregate amount of the above mentioned capital increase and
comprising the payment of a share premium in an amount of nine million nine hundred seventeen thousand seven hundred
fourteen Euro and fifty Cents (EUR 9,917,714.50) was on 18 July 2008 at the free disposal of the Company, as was
evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.

106525

VI. As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 18 July 2008,

paragraph one of article 5 of the articles of association is therefore amended and shall read as follows:

"5.1. The subscribed capital is fixed at EUR 12,213,021.- (twelve million two hundred thirteen thousand twenty one

Euro), represented by 84,384 (eighty-four thousand three hundred eighty-four) shares of Unlimited Shareholder ("actions
de commandité", herein defined as "Class A Shares") and 8,057,630 (eight million fifty-seven thousand six hundred thirty)
shares of Limited Shareholder ("actions de commanditaires", herein defined as "Class B Shares"; together, with the Class
A Shares, herein as the "Shares"), with a par value of EUR 1.50 (one Euro and fifty Cents) each. The holders of Shares
are hereafter referred to as the "Shareholders"."

Furthermore, consequently to the above mentionned capital increase and the increased performed on 17 January 2008,

both within the framework of the authorised capital clause, the amount of the authorised share capital as set out in the
article 6.1. of the Articles was decreased to one hundred thirty-seven million eight hundred eighteen thousand four
hundred seventy-nine Euro (EUR 137,818,479.-) so that article 6.1 of the Articles is amended accordingly and now reads
as follows:

"6.1 The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of EUR 137,818,479.- (one hundred

thirty-seven million eight hundred eighteen thousand four hundred seventy-nine Euros) to be used in order to issue new
Shares or to increase the nominal value of the Shares."

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately fifty-six thousand five hundred Euro (EUR 56,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le premier août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Sandra Elsholz, employée privée, avec adresse professionnelle à 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire spécial de EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., une société en com-

mandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle,
L-1325 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 14 juillet 2005 publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 1339 du 7 décembre 2005 et immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.566 et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 17 janvier 2008 publié au Mémorial C numéro 647 du 14
mars 2008 (la "Société"), en vertu du pouvoir qui lui a été donné par les résolutions adoptées par le conseil d'administration
de EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A. (le "Conseil d'Administration"), une société anonyme régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.637 en qualité d'associé commandité gérant de la
Société (l'"Associé Commandité") le 11 juin 2008, un extrait desdites résolutions, après avoir été signé ne varietur par
le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et

constatations suivantes:

I. La Société a un capital souscrit de douze millions cent trente mille sept cent trente-cinq euros et cinquante cents

(EUR 12.130.735,50) divisé en quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-quatre (84.154) actions de Catégorie A et huit
millions trois mille trois (8.003.003) actions de catégorie B, les actions ayant une valeur nominale de un euro et cinquante
cents (EUR 1,50) chacune, ces actions étant entièrement libérées.

II. En vertu de l'article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à cent trente-sept millions

neuf cent mille sept cent soixante quatre euros et cinquante cents (EUR 137.900.764,50.-) pouvant être utilisé pour
émettre de nouvelles actions ou pour augmenter la valeur nominale des actions et qu'en vertu du même article 6, l'Associé
Commandité de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations de capital et à modifier les statuts de la Société
de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.

III. Le Conseil d'Administration de l'Associé Commandité, par résolutions adoptées le 11 juin 2008 et en conformité

avec les pouvoirs leur étant conférés en vertu de l'article 6 des Statuts, ont décidé sous réserve de la confirmation par
l'un des administrateurs de l'Associé Commandité de la réception des fonds de souscription, laquelle confirmation est
intervenue le 18 juillet 2008, une augmentation du capital social souscrit à concurrence d'un montant de quatre-vingt-

106526

deux mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante cents (EUR 82.285,50) en vue de porter le capital social souscrit
à montant de douze millions deux cent treize mille deux cent vingt et un euros (EUR 12.213.021) par la création et
l'émission de deux cent trente (230) nouvelles actions de Catégorie A d'une valeur nominale de un euro et cinquante
cents  (EUR  1,50)  avec  une  prime  d'émission  de  cent  quatre-vingts  euros  virgule  un  six  cinq  deux  un  sept  quatre
(180,1652174) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de Catégorie A existantes et cinquante-
quatre mille six cent vingt-sept (54.627) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de un euro et cinquante
cents (EUR 1,50) avec un prime d'émission de cent quatre-vingt euros virgule sept neuf quatre sept huit un (180,794781)
chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de Catégorie B existantes.

IV. Le Conseil d'Administration de l'Associé Commandité, par résolutions adoptées le 11 juin 2008, ont approuvé,

conformément au droit de souscription préférentiel des associés de la Société:

1. la souscription des deux cent trente (230) nouvelles actions de Catégorie A, avec une prime d'émission totale de

quarante et un mille quatre cent trente huit euros (EUR 41.438,-) par EUROPEAN RETAIL VENTURE S.A., une société
anonyme constituée selon et régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325
Luxembourg; et

2. la souscription des cinquante-quatre mille six cent vingt-sept (54.627) nouvelles actions de Catégorie B, avec une

prime  d'émission  totale d'un montant  de  neuf  millions  huit  cent soixante-seize mille  deux  cent soixante-seize euros
cinquante cents (EUR 9.876.276,50), comme suit:

MUTAVIE S.A., une société anonyme constituée selon et régie par le droit français, ayant son siège social à F-79088

Niort Cedex 9, France: deux mille huit cent soixante-cinq (2.865) Actions de Catégorie B, avec une prime d'émission
totale de cinq cent dix-sept mille neuf cent soixante-dix-sept euros cinq cents (EUR 517.977,05);

CARDIF ASSURANCE VIE, une société anonyme constituée selon et régie par le droit français, ayant son siège social

au 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris, a souscrit sept mille six cent quarante (7.640) Actions de Catégorie B, avec
une prime d'émission totale de un million trois cent quatre-vingt-un mille deux cent soixante-douze euros et treize cents
(EUR 1.381.272,13);

OP LIFE ASSURANCE, une limited company constituée selon et régie par le droit finlandais, ayant son siège social au

Teollisuuskatu 1a A 00510, Helsinki, Finlande, a souscrit mille neuf cent dix (1.910) Actions de Catégorie B, avec une
prime d'émission totale de trois cent quarante-cinq mille trois cent dix-huit euros trois cents (EUR 345.318,03);

GERBERA S.A., une société anonyme constituée selon et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au

48, rue de Bragance L-1255 Luxembourg, a souscrit trois mille huit cent vingt (3.820) Actions de Catégorie B, avec une
prime d'émission totale de six cent quatre-vingt-dix mille six cent trente-six euros et six cents (EUR 690.636,06);

SCI VENDOME COMMERCES, une société civile immobilière à capital variable constituée selon et régie par le droit

français, ayant son siège social au Coeur Défense, Tour B, La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris
La Défense Cedex France, a souscrit cinq mille sept cent trente (5.730) Actions de Catégorie B, avec une prime d'émission
totale de un million trente-cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros neuf cents (EUR 1.035.954,09);

AXA RE S.A., une société anonyme constituée selon et régie par le droit français, ayant son siège social à 39, rue du

Colisée, 75008 Paris - France, a souscrit mille neuf cent dix (1.910) Actions de Catégorie B, avec une prime d'émission
totale de trois cent quarante-cinq mille trois cent dix-huit euros et trois cents (EUR 345.318,03);

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS, une société constituée selon et régie par le droit norvégien, ayant son siège

social à Filipstad Brygge no1, Oslo, Norvège, a souscrit quatre mille sept cent soixante-quinze (4.775) Actions de Catégorie
B, avec une prime d'émission totale de huit cent soixante-trois mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et huit cents
(EUR 863.295,08);

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID (BPF BOUW), une société constituée selon et régie

par le droit néerlandais, ayant son siège social au La Guardiaweg 4, 1043 DG Amsterdam, Pays-Bas, a souscrit neuf mille
cinq cent cinquante (9.550) Actions de Catégorie B, avec une prime d'émission totale de un million sept cent vingt-six
mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et seize cents (EUR 1.726.590,16);

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES, une société constituée selon et régie par le

droit néerlandais, ayant son siège social au Huizermaatweg 550, 1270 AB Huizen, Pays-Bas, a souscrit deux mille huit cent
soixante-cinq (2.865) Actions de Catégorie B, avec une prime d'émission totale de cinq cent dix-sept mille neuf cent
soixante-dix-sept euros et cinq cents (EUR 517.977,05);

PENSIOENSTICHTING TRANSPORT, une société constituée selon et régie par le droit néerlandais, ayant son siège

social à Hoofdorp, Pays-Bas, a souscrit mille quatre cent trente-trois (1.433) Actions de Catégorie B, avec une prime
d'émission totale de deux cent cinquante-neuf mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-douze cents (EUR 259.078,92);

ILMARINEN MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, une société constituée selon et régie par le droit fin-

landais, ayant son siège social au Porkkalankatu 1, Helsinki, Finlande, Fin-00018 Ilmarinen, Finlande, a souscrit quatre mille
sept cent soixante-quinze (4.775) Actions de Catégorie B, avec une prime d'émission totale de huit cent soixante-trois
mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et huit cents (EUR 863.295,08);

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, une société constituée selon et régie par le droit français, ayant son

siège social au rue de Lille n o 56, F-75007 Paris, France, a souscrit trois mille huit cent vingt (3.820) Actions de Catégorie

106527

B,  avec  une  prime  d'émission  totale  de  six  cent  quatre-vingt-dix  mille  six  cent  trente-six  euros  et  six  cents  (EUR
690.636,06);

STICHTING PENSIOENFONDS AHOLD, une société constituée selon et régie par le droit néerlandais, ayant son

siège social au Provincialeweg 11, 1506 MA Zaadam, Pays-Bas, a souscrit deux mille trois cent quatre-vingt-huit (2.388)
Actions de Catégorie B, avec une prime d'émission totale de quatre cent trente et un mille sept cent trente-sept euros
quatre-vingt-quatorze cents (EUR 431.737,94);

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD, une société constituée selon et régie par le droit israélien, ayant son siège social

au 7, Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, Israël, a souscrit mille cent quarante-six (1.146) Actions de Catégorie B, avec
une prime d'émission totale de deux cent sept mille cent quatre-vingt-dix euros quatre-vingt-deux cents (EUR 207.190,82),

V. Toutes les nouvelles actions de Catégorie A et de Catégorie B ont été entièrement souscrites par les souscripteurs

susnommés et libérées intégralement, ensemble avec une prime d'émission, par des versements en numéraire à la Société
le 18 juillet 2008, de sorte que la somme de dix millions d'euros (EUR 10.000.000,-) représentant le montant total de la
susdite augmentation du capital social et incluant le paiement d'une prime d'émission pour un montant de neuf millions
neuf cent dix-sept mille sept cent quatorze euros et cinquante cents (EUR 9.917.714,50) se trouvait le 18 juillet 2008 à
la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives
de libération.

VI. Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet au 18 juillet 2008, le premier alinéa

de l'article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

"5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 12.213.021 (douze millions deux cent treize mille vingt et

un euros) représenté par 84.384 (quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-quatre) actions d'Actionnaire Com-
mandité (ci-après "Actions de Classe A") et par 8.057.630 (huit millions cinquante-sept mille six cent trente) actions
d'Actionnaire Commanditaire (ci-après "Actions de Classe B", ensemble avec les Actions de Classe A, repris ci-après
comme les "Actions"), d'une valeur nominale de EUR 1,50 (un euro et cinquante cents) chacune. Les détenteurs d'Actions
sont repris ci-après comme les "Actionnaires"."

De plus, en conséquence de l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus et de l'augmentation effectuée le 17 janvier

2008, toute deux dans la limite de la clause de capital autorisé, le montant du capital autorisé tel qu'il figure à l'article 6.1
des Statuts a été réduit à 137.818.479,- EUR (cent trente-sept millions huit cent dix-huit mille quatre cent soixante-dix-
neuf euros) de sorte que l'article 6.1 des Statuts est modifié et doit être lu comme suit:

"La Société a un capital non émis mais autorisé d'un montant de 137.818.479,- EUR (cent trente-sept millions huit cent

dix-huit mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) devant être utilisé afin d'émettre de nouvelle Actions ou d'augmenter
la valeur nominale des Actions."

<i>Frais

Les frais incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de cinquante six mille cinq cents euros (EUR 56.500).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Elsholz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2008. LAC/2008/32623. — Reçu à 0,50%: cinquante mille euros (EUR 50.000,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008111106/220/279.
(080129178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Marlow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.753.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106528

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour MARLOW S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110940/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT10862. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Quedlinburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.748.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour QUEDLINBURG S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110941/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10634. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Weinheim Estates, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.082.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour WEINHEIM ESTATES
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110942/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10635. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

HaMer Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.296.

In the year two thousand eight, on the sixth day of June.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ

07302, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., hereafter the "sole member",

duly  represented  by  Mr  Guy  HORNICK,  "maître  en  sciences  économiques",  with  professional  address  in  L-1653

Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

by virtue of a proxy dated June 4, 2008.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed for the purpose of registration,

Acting as sole member of "HaMer Holding S.à r.l." (the "Company"), a "société à responsabilité limitée", which has its

registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-

106529

panies Register under number B 112.296, which has been incorporated by a notarial deed on October 5, 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 425 of February 27, 2006. The articles of incorporation have

been modified at last by a deed of the undersigned notary residing in Luxembourg, on May 27th, 2008, not yet published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

The sole member represented as above stated, requests the undersigned notary to document the following:

<i>First resolution

The sole member resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of EUR 29,475 (twenty-nine

thousand four hundred seventy-five Euro) to raise it from EUR 560,000 (five hundred sixty thousand Euro) to EUR 589,475
(five hundred eighty-nine thousand four hundred seventy-five Euro) by the creation and issue of 1,179 (one thousand one
hundred seventy-nine) new corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and with a total share
premium of EUR 30,524.31 (thirty thousand five hundred twenty-four Euro thirty-one cents), benefiting of the same rights
and advantages as the presently issued corporate units.

The sole member decides to waive its preferential subscription rights and decides to admit to the subscription of the

1,179 (one thousand one hundred and seventy-nine) new corporate units POLISH ENTERPRISE FUND VI, L.P.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI GP, LTD, with registered office in Ugland House, South Church

Street, George Town, Grand Cayman, The Cayman Islands, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND VI,
L.P., duly represented by Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, with professional address in L-1653 Luxembourg,
2, avenue Charles de Gaulle, by virtue of a proxy dated June 4, 2008, declares to subscribe the 1,179 (one thousand one
hundred and seventy-nine) newly issued corporate units, with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each with a
total share premium amounting to EUR 30,524.31 (thirty thousand five hundred twenty-four Euro thirty-one cents) and
to fully pay them up by a contribution in cash, so that the amount of EUR 59,999.31 (fifty-nine thousand nine hundred
ninety-nine Euro thirty-one cents) is as of today at the free disposal of the Company, evidence thereof having been
submitted to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The members resolve to amend article FIVE (5) of the Company's Articles of Incorporation, which shall forthwith read

as follows:

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 589,475 (five hundred eighty-nine thousand four hundred

and seventy-five Euro) divided into 23,579 (twenty-three thousand five hundred and seventy-nine) corporate units with
a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately two thousand Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing proxy holder and in
case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing proxy holder, known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le six juin.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, ayant son siège social à 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302,

agissant en tant que general partner de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., ci-après l' "associé unique",

ici représentées par Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à

L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 4 juin 2008.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associée unique de "HaMer Holding S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 112.296, constituée suivant acte notarié en date du 5
octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 425 du 27 février 2006. Les statuts ont été

106530

modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mai 2008, pas encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

L'associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 29.475 (vingt-

neuf mille quatre cent soixante-quinze euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 560.000 (cinq cent soixante
mille euros) à EUR 589.475 (cinq cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante-quinze euros), par la création et
l'émission de 1.179 (mille cent soixante-dix-neuf) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune, assortie d'une prime d'émission de EUR 30.524,31 (trente mille cinq cent vingt-quatre euros trente
et un cents), et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales déjà existantes.

L'associé unique décide de renoncer à ses droits de souscription préférentiels et décide d'admettre la souscription

aux 1.179 (mille cent soixante-dix-neuf) nouvelles parts sociales POLISH ENTERPRISE FUND VI, L.P.

<i>Intervention, Souscription, Libération

Ensuite a comparu POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI GP, LTD, ayant siège social à Ugland House, South Church

Street, George Town, Grand Cayman, The Cayman Islands, agissant en tant que general partner de POLISH ENTERPRISE
FUND VI, L.P., représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à
L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, qui déclare souscrire les 1.179 (mille cent soixante-dix-neuf) parts
sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, assorties d'une prime d'émission
totale de EUR 30.524,31 (trente mille cinq cent vingt-quatre euros trente et un cents) et les libérer intégralement par un
apport en numéraire, de sorte que le montant de EUR 59.999,31 (cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
euros trente et un cents) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au
notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article CINQ (5) des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 589.475 (cinq cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante-quinze euros)

représenté par 23.579 (vingt-trois mille cinq cent soixante-dix-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune."

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à deux mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la

partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et
qu'à la demande du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. HORNICK, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2008. Relation: LAC/2008/23598. — Reçu trois cent euros (300.-€).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 27 juin 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008111118/211/117.
(080128646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Possneck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.755.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106531

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour POSSNECK S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110943/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10639. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Kyritz Ueckermunde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.751.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour KYRITZ UECKERMUNDE S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110944/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT10877. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Adorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.754.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour ADORF S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110945/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT10880. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Gotic House S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.747.

Les comptes annuels au 30/09/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour GOTIC HOUSE S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110946/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT10873. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

106532

Telco Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.268.990,87.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 99.920.

In the year two thousand and eight, on the tenth day of July.
Before us M 

e

 Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. PERMIRA EUROPE III L.P.1, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey)

Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey
under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED
whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here represented
by Raymond Thill, clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Guernsey, on July 10, 2008,

2. PERMIRA EUROPE III L.P.2, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey)

Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey
under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED
whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here represented
by Raymond Thill, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Guernsey, on July 10, 2008,

3. PERMIRA EUROPE III GMBH &amp; Co. KG, a German limited partnership registered with the commercial register at

the lower court of Munich under registration number HRA 82707 pursuant to the provisions of the German Commercial
Code (Handelsgesetzbuch) acting by its managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership
registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA
EUROPE III G.P. Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel
Islands, here represented by Raymond Thill, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Guernsey, on July 10,
2008,

4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, acting by its administrator PERMIRA EUROPE III G.P. Limited

whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here represented
by Raymond Thill, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Guernsey, on July 10, 2008,

5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, acting by its nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED whose registered office

is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here represented by Raymond Thill, pre-
named, by virtue of a power of attorney given in Guernsey, on July 10, 2008,

6. DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR, a German partnership, acting by its managing partners, with busi-

ness  address  at  c/o  Walter  Sigle  Rechtsanwälte,  Kernerstraße  50,  70182  Stuttgart,  Germany,  here  represented  by
Raymond Thill, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg and Stuttgart, on July 10, 2008,

7. DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS ZWEI GbR, a German partnership, acting by its managing partners, with

business address at c/o Walter Sigle Rechtsanwälte, Kernerstraße 50, 70182 Stuttgart, Germany, here represented by
Raymond Thill, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg and Stuttgart, on July 10, 2008,

8. DUG MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR, a German partnership, acting by its managing partner, with business

address at Langer Grund 8, 16348 Wandlitz, Germany, here represented by Raymond Thill, prenamed, by virtue of a
power of attorney given in Luxembourg, on July 10, 2008.

9. SGBT EUROPEAN CITIUS INVESTMENTS S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, registered

with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number B 105.772, having its registered office at
15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, here represented by Raymond Thill, prenamed, by virtue of a power of
attorney given in Luxembourg, on July 10, 2008.

Which said proxies, after signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, representing more than three quarter of the corporate capital, have requested the undersigned

notary to enact the following:

- the prenamed are the shareholders of "TELCO HOLDING" a société à responsabilité limitée, with registered office

at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the trade and companies' register of Luxembourg under
section B number B 99.920, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, then notary residing in
Luxembourg, dated March 18, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 519 dated
May 18, 2004 (the "Company"). The articles of incorporation have been amended several times and for the last time
pursuant to a deed of the notary, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated July 8, 2008, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- the Company's share capital is set at one million seven hundred fifty-nine thousand four hundred seventy two euro

and thirty-three cent (EUR 1,759,472.33-) represented by one hundred seventy five million nine hundred forty seven

106533

thousand two hundred thirty three (175,947,233) ordinary Class A shares having a par value of one cent of euro (EUR
0.01) each.

- the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to redeem and cancel 49,048,146 ordinary Class A each having a par value of one cent of euro (EUR 0.01)

held by SGBT European Citius Investments S.A. and subsequent acknowledgement of the cancellation of such shares by
all of the shareholders pursuant to which SGBT European Citius Investments S.A. ceases to be a shareholder of the
Company;

2. Following the redemption of the shares in the Company, reimbursement of one hundred eighty-five million five

hundred seventy-five thousand two hundred forty-three euro and ninety-nine cent (EUR 185,575,243.99) to SGBT Eu-
ropean Citius Investments S.A.;

3. Decrease of the share capital of the Company as the result of the cancellation of the shares referred to in item 1

by  an  aggregate  amount  of  four  hundred  ninety  thousand  four  hundred  eighty  one  euro  and  forty-six  cent  (EUR
490,481.46) so as to bring the capital from its current amount of one million seven hundred fifty nine thousand four
hundred seventy-two euro and thirty-three cent (EUR 1,759,472.33) to one million two hundred sixty-eight thousand
nine hundred ninety euro and eighty-seven cent (EUR 1,268,990.87);

4. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.
After this had been set forth, the above named shareholders of the Company, representing the entire capital of the

Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide unanimously to decrease the share capital of the Company by an aggregate amount of four

hundred ninety thousand four hundred eighty one euro and forty-six cent (EUR 490,481.46) by way of redemption and
cancellation of forty nine million forty eight thousand one hundred forty-six (49,048,146) Class A shares each having a
par value of one cent of euro (EUR 0.01) currently held by SGBT European Citius Investments S.A. and that as a result
of the redemption and cancellation of such shares SGBT European Citius Investments S.A. ceases to be a shareholder of
the Company.

<i>Second resolution

Following the redemption of its shares in the Company, reimbursement of one hundred eighty five million five hundred

seventy five thousand two hundred forty-three euro and ninety-nine cent (EUR 185,575,243.99) to SGBT European Citius
Investments S.A.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows:

Art 5. § 1. The Company's share capital is set at one million two hundred sixty-eight thousand nine hundred ninety

euro and eighty-seven cent (EUR 1,268,990.87) represented by one hundred twenty-six million eight hundred ninety-nine
thousand eighty-seven (126,899,087) ordinary Class A shares having a par value of one cent of euro (EUR 0.01) each, all
fully paid-up and subscribed."

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at two thousand five hundred (2,500.-) euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the attorney of the appearing person, known to the notary by first and surname, civil

status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le dixième jour de juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. PERMIRA EUROPE III L.P.1, une limited partnership enregistrée à Guernesey conformément au Limited Partnerships

(Guernsey) Law, 1995, représentée par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., une limited partnership
enregistrée à Guernesey conformément au Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, représentée par son general
partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED ayant son siège social Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey,

106534

Channel Islands, ici représentée par Raymond Thill, clerc, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
à Guernesey, en date du 10 juillet 2008,

2. PERMIRA EUROPE III L.P.2, une limited partnership enregistrée à Guernesey selon le Limited Partnerships (Guern-

sey) Law, 1995, représentée par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., une limited partnership enregistrée
à Guernesey conformément au Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, représentée par son general partner PER-
MIRA EUROPE III G.P. LIMITED ayant son siège social Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel
Islands, ici représentée par Raymond Thill, précité, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, en date du 10 juillet
2008,

3. PERMIRA EUROPE III GMBH &amp; Co. KG, une limited partnership allemande enregistrée au registre de commerce

du tribunal de Munich sous le numéro HRA 82707 suivant les dispositions du code de commerce allemand (Handelsge-
setzbuch),  représentée  par  son  managing  limited  partner  PERMIRA  EUROPE  III  G.P.  L.P.,  une  limited  partnership
enregistrée à Guernesey conformément au Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, représentée par son general
partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED ayant son siège social Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey,
Channel Islands, ici représentée par Raymond Thill, précité, en vertu d'une procuration donnée à Guernsey, en date du
10 juillet 2008,

4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, représentée par son administrateur PERMIRA EUROPE III G.P.

LIMITED ayant son siège social Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, ici représentée
par Raymond Thill, précité, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, en date du 10 juillet 2008,

5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, représentée par son fiduciaire PERMIRA NOMINEES LIMITED ayant son siège

social Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, ici représentée par Raymond Thill, précité,
en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, en date du 10 juillet 2008,

6. DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR, une partnership allemande, représentée par ses managing partners,

avec adresse professionnelle c/o Walter Sigle Rechtsanwälte, Kernerstraße 50, 70182 Stuttgart, Allemagne, ici représentée
par Raymond Thill, précité, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg et Stuttgart, en date du 10 juillet 2008.

7. DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS ZWEI GbR, une partnership allemande, représentée par ses managing

partners, avec adresse professionnelle c/o Walter Sigle Rechtsanwälte, Kernerstraße 50, 70182 Stuttgart, Allemagne, ici
représentée par Raymond Thill, précité, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg et Stuttgart, en date du 10
juillet 2008.

8. DUG MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR, une partnership allemande, représentée par son managing partner,

avec adresse professionnelle Langer Grund 8, 16348 Wandlitz, Allemagne, ici représentée par Raymond Thill, précité, en
vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, en date du 10 juillet 2008.

9. SGBT EUROPEAN CITIUS INVESTMENTS S.A., une société anonyme, ayant son siège social 15, avenue Emile

Reuter, L-2420 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.772,
ici représentée par Raymond Thill, précité, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, en date du 10 juillet 2008.

Les procurations signées «ne varietur» par les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants, représentant plus des trois quarts du capital social, ont requis le notaire soussigné d'acter que:
les prénommés sont tous associés de «TELCO HOLDING» une société à responsabilité limitée, ayant son siège social

sis 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 99.920, constituée suivant acte de Maître André Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg, en
date du 18 mars 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 519 daté du 18 mai 2004 (la
«Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois dont la dernière modification a été faite par Maître
Martine Schaeffer, notaire, résident à Luxembourg, en date du 8 juillet 2008 et non encore publiée au Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations.

Le capital social de la Société est fixé à un million sept cent cinquante-neuf mille quatre cent soixante-douze euros et

trente-trois centimes (EUR 1.759.472,33) divisé en cent soixante-quinze millions neuf cent quarante-sept mille deux cent
trente-trois (175.947.233) parts sociales de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01.-) chacune.

L'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de racheter et d'annuler quarante neuf millions quarante-huit mille cent quarante-six (49.048.146) parts

sociales de classe A ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) détenues par SGBT European Citius
Investments S.A. et d'approuver la subséquente annulation de ces parts sociales par tous les associés, suite à laquelle
SGBT European Citius Investments S.A. cessera d'être un associé de la Société;

2. En conséquence du rachat des parts sociales de la Société, décision de rembourser cent quatre-vingt-cinq millions

cinq cent soixante-quinze mille deux cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (EUR 185.575.243,99)
à SGBT European Citius Investments S.A.;

3. Réduction du capital social de la Société, résultant de l'annulation des parts sociales citées dans le premier point de

l'ordre du jour pour un montant total de quatre cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre vingt un euros et quarante-
six centimes (EUR 490.481,46) afin de réduire le capital social d'un million sept cent cinquante-neuf mille quatre cent

106535

soixante-douze euros et trente-trois centimes (EUR 1.759.472,33) à un montant d'un million deux cent soixante-huit
mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-sept centimes (EUR 1.268.990,87).

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, re-

quièrent désormais le notaire instrumentant de prendre acte des décisions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident à l'unanimité de réduire le capital social de la Société d'un montant total de quatre cent quatre-

vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quarante-six centimes (EUR 490.481,46) par le rachat et l'annulation
de quarante-neuf millions quarante-huit mille cent quarante-six (49.048.146) parts sociales de classe A détenues par SGBT
European Citius Investments S.A. et, en conséquence du rachat et de l'annulation desdites parts sociales, SGBT European
Citius Investments S.A. cessera d'être un associé de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence du rachat des parts sociales de la Société, les associés décident de rembourser cent quatre-vingt-cinq

millions  cinq  cent  soixante-quinze  mille  deux  cent  quarante-trois  euros  et  quatre-vingt-dix-neuf  centimes  (EUR
185.575.243,99) à SGBT European Citius Investments S.A.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la précédente résolution, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts est modifié et aura la

teneur comme suit:

« Art 5. § 1. Le capital social de la Société est fixé à un million deux cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix

euros et quatre-vingt-sept centimes (EUR 1.268.990,87) divisé en cent vingt-six millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf
mille quatre-vingt-sept (126.899.087) parts sociales de classe A, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées et souscrites.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte, s'élèvent approximativement à deux mille cinq cents (2.500,-) euros.

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, lesdits

comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2008, LAC/2008/29546. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008111089/5770/210.
(080129095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Piwa, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 39, rue Felix de Blochhausen.

R.C.S. Luxembourg B 21.082.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour PIWA
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110947/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2008, réf. LSO-CT09733. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

106536

ENTREPRISE DE TRANSPORTS CORDELLA Cosimino, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 93.592.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour ENTREPRISE DE TRANSPORTS CORDELLA Cosimino
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110948/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04349. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Puzzle Sub S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 130.555.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008110949/1005/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11637. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

COLT Lux Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.940.

In the year two thousand and eight, on the seventh day of the month of July,
Before M 

e

 Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared COLT Lux Holding, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg (the "RCS") under number B 116 042, being the sole shareholder of "COLT
Lux Group Holding, S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 2A, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the RCS under number B 115 940, incorporated by deed of the
undersigned notary on 27th April 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial")
number 1294 of 5th July 2006, as amended several times and for the last time on 4th July 2006 by deed of the undersigned
notary published in the Mémorial number 1779 of 22 September 2006;

Represented by Ms Esmee Chengapen, company secretarial manager, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy.
The appearing party declared and requested the notary to state that:
1. The entire issued share capital represented by forty thousand five hundred (40,500) shares is held by the sole

shareholder.

2. The sole shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this

extraordinary decision of the sole shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items on the agenda.

3. The agenda of the meeting is as follows:
A. Amendment of article 2 (Object) of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
"The objects of the Company are, in Luxembourg and abroad:
- the provision of telecommunications services of all kinds including, but not limited to, transmission of electronic

information on a telecommunications network and the storage of electronic information;

- either for itself, or for third parties it shall be able to examine, build, manage and run telecommunications networks

of any kind, private or official, from Luxembourg or abroad;

106537

- the provision of value added services by means of the exploitation of communications -software, owned or licensed

from others, and entering into activities or agreements to enable, protect or benefit from the software's capabilities;

- the development, exploitation and ownership of any such intellectual property as is required for the effective ex-

ploitation of its business activities and the activities of any company in which it has a participation, whether direct or
indirect;

- it may buy, sell, hire, and in a general manner run all processes or equipments necessary for carrying out it's corporate

objects, all equipments, licenses, processes, factories, laboratories, studios, trade houses relating directly or indirectly to
it;

- any activity, including research and development activity relating directly or indirectly to the objects mentioned

hereabove, and to any similar or connected or likely to promote its development, including all such activities deemed to
be preparatory to or necessary for the provision of such services.

The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, and the holding of immovable property or real estate interests, in any form whatsoever and
wherever situate, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities or immovable property interests of any kind, the
possession, the administration, the development, exploitation by rental or lease and the management of its portfolio and
of immovable property interests.

The Company may borrow funds from and grant any assistance, loan, advance, warranty and guarantee, to the benefit

or for the companies in which it holds direct or indirect participations or interests, or any company being directly or
indirectly part of group of companies to which the Company belongs. It may also, within the former or otherwise, grant
any guarantees, securities or pledge on its goods, securities and real estate in such conditions as it may determine.";

B. Acknowledgment of the resignation of Mrs. Alex GUYATT, Mr. Marc WATHELET, Mr. Christian DEKEYSER and

Mrs.  Rita  THIES  from  their  mandates  as  managers  of  the  Company;  appointment  as  new  managers  to  the  board  of
managers of the Company for an undetermined period of time with such signature powers as set forth in the articles as
follows:

- Mr Tony BATES;
- Mr Richard H. BLAUSTEIN;
- Mr Gary BUTTERS
- Mrs Tanuja RANDERY
- Mr Francois Eloy
After deliberation it was unanimously resolved as follows:

<i>First resolution

It is resolved to amend article 2 (Object) of the articles of incorporation of the Company as set out in the agenda.

<i>Second resolution

It is resolved to appoint the following persons as managers to the board of managers of the Company with such

signature powers as set forth in the articles for an unlimited period of time:

- Mr Tony BATES, company director, born on 24 May 1956 in Newcastle-under-Lyme, United Kingdom, residing at

11 Sheldon Square, Paddington, London W2 6DQ;

- Mr Richard H. BLAUSTEIN, managing director, born on 28 June 1951in Neuilly s/ Seine, France, residing at 6, bou-

levard Andre Maurois, Paris, 75116, France;

- Mr Gary BUTTERS, company director, born on 18 November 1957 in Glasgow, Scotland, residing at 59 Boss House,

Boss Street, London SE1 2PS;

- Mr Tanuja RANDERY, managing director, born on 12 September 1966 in Calcutta, India, residing at av. des Erables

20, Rhode Saint Genese 1640, Belgium;

- Mr Francois Eloy, managing director, born on 14 July 1959 in Roubaix, France, residing at 26, rue Jean Edeline, F-92500

Rueil-Malmaison, France.

There being no further item on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at 1,500.- Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

106538

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le septième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu COLT Lux Holding, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (le "RCS") sous le numéro B 116 042, étant l'associé unique de "COLT Lux Group Holding, S.à r.l." (la
"Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,
inscrite auprès du RCS sous le numéro B 115 940, constituée le 27 avril 2006 par acte du notaire soussigné, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1294 du 5 juillet 2006, tel que modifié plusieurs
fois et pour la dernière fois le 4 juillet 2006 par acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 1779 du 22
septembre 2006,

représentée par Mme Esmee Chengapen, company secretarial manager, résidant à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. La totalité du capital social représentée par quarante mille cinq cents parts sociales (40,500) est détenu par l'associé

unique.

2. L'associé unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales sont représentées

à cette décision extraordinaire de l'associé unique de sorte que toutes les décisions peuvent être valablement prises sur
tous les points de l'ordre du jour.

3. Les points sur lesquels les résolutions doivent être passées sont les suivants:
A. Modification de l'article 2 (Objet) des statuts de la Société comme suit:
"La Société a pour objets au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger:
- la fourniture de services de télécommunications de toutes espèces, y compris, mais sans limitation, la transmission

d'informations électroniques sur un réseau de télécommunication et le stockage d'informations électroniques;

- elle pourra soit pour elle-même, soit pour compte de tiers, étudier, construire, gérer et exploiter des réseaux de

télécommunications de toutes espèces, privés ou officiels, luxembourgeois ou étrangers;

- la fourniture de services haut de gamme par le biais de l'exploitation de logiciels de communication, exploités en

propriété ou sous licence, ainsi que l'exercice d'activités ou la conclusion d'accords permettant de réaliser, de protéger
ou de tirer avantage du potentiel de ces logiciels;

- le développement, l'exploitation et la détention de toute propriété intellectuelle telle qu'elle peut être requise dans

le cadre d'une exploitation efficace de ses activités et des activités de toute société dans laquelle elle détient une parti-
cipation directe ou indirecte.

- elle pourra acheter, vendre, louer et d'une manière générale exploiter tous procédés ou appareils réalisant son objet

social, tous matériels, licences, procédés, usines, laboratoires, studios, maisons de commerce se rapportant directement
ou indirectement à celui-ci;

- toutes activités, y compris des activités de recherche et de développement, se rapportant directement ou indirec-

tement aux objets ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en promouvoir le développement,
y compris toutes activités jugées préparatoires ou nécessaires à la fourniture de ces services.

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, et la détention, exclusivement pour ses propres besoins, de propriétés immobilières, de toutes
espèces et quelle qu'en soit la situation, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que le
transfert  par  vente,  échange  ou  autrement  de  titres,  emprunts  obligataires,  bons  été  d'autres  valeurs  mobilières  ou
immobilières de toute sorte, la possession, l'administration, le développement, l'exploitation par bail à court ou à long
terme et la gérance de son portefeuille et des valeurs mobilières.

La Société peut emprunter et pourra accorder toute assistance, prêt, avance, garantie et sûreté à, au bénéfice ou pour

les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou un intérêt direct ou indirect ou toutes sociétés faisant partie,
directement ou indirectement, du même groupe de sociétés que la Société. Elle pourra également, dans le cadre de ce
qui précède ou autrement, accorder toutes sûretés, nantissements et gages sur ses biens, valeurs mobilières et immobi-
lières aux conditions et modalités qu'elle déterminera.";

B. Constat de la démission de Mme Alex GUYATT, M. Marc WATHELET, M. Christian DEKEYSER and Mme Rita

THIES en tant que gérants de la Société; nominations en tant que nouveaux gérants du conseil de gérance de la Société
pour une durée indéterminée ayant les pouvoirs de signature tels que rédigés dans les statuts:

- M. Tony BATES;
- M. Richard H. BLAUSTEIN;
- M. Gary BUTTERS;
- Mme. Tanuja RANDERY;
- M. Francois Eloy.

106539

Après délibération, il a été décidé à l'unanimité comme suit:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l'article 2 (Objet) des statuts de la Société tel que rédigé dans l'ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de nommer comme gérants au conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée ayant les

pouvoirs de signature tels que rédigés dans les statuts:

- M. Tony BATES, company director, né le 24 mai 1956 à Newcastle-under-Lyme, Royaume-Uni, résidant à 11 Sheldon

Square, Paddington, London W2 6DQ;

- M. Richard H. BLAUSTEIN, managing director, né le 28 juin 1951 à Neuilly s/ Seine, France, résidant à 6, boulevard

Andre Maurois, Paris, 75116, France;

- M. Gary BUTTERS, company director, né le 18 novembre 1957 à Glasgow, Ecosse, résidant à 59 Boss House, Boss

Street, London SE1 2PS;

- Mme. Tanuja RANDERY, managing director, née le 12 septembre 1966 à Calcutta, Inde, résidant à Av. des Erables

20, Rhode Saint Genese 1640, Belgique;

- M. Francois Eloy managing director, né le 14 juillet 1959 à Roubaix, France, résidant à 26, rue Jean Edeline, F-92500

Rueil-Malmaison, France.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée fut clôturée.

<i>Coûts

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

sont estimés à 1.500.- Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais a constaté qu'à la demande de la partie comparante, le présent

procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même personne comparante, en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: E. CHENGAPEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 09 juillet 2008, Relation: LAC/2008/28222. — Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 29 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008111131/211/173.
(080128520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Genes Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 101.569.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008110951/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12332. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Aqua Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 101.534.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

106540

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008110952/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11345. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Wrei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 35.310.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008110953/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11358. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Les Rossignols S.A. 1850, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 54.830.

Constituée par-devant M 

e

 Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date

du 26 avril 1996, acte publié au Mémorial C no 384 du 9 août 1996.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LES ROSSIGNOLS S.A. 1850
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008110958/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10457. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Jasper Broker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 94.995.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008110954/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11366. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

EUROMARKET, Alimentation en gros, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 140, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 7.605.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106541

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour EUROMARKET, Alimentation en gros
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110955/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10618. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

LSF Japan Hotel Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.278.375,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 117.888.

In the year two thousand and eight, on the fifth of August.
Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) Lone Star Capital Investments S. à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper,

L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91 796, repre-
sented by Mr Philippe Detournay, here represented by Ms. Josiane Meissener, private employee, with professional address
in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 4 August 2008,

AND
2) RISING SUN II HOLDING Ltd, a limited company incorporated under the laws of Bermuda, with registered office

at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, represented by Dennis HOWARTH, here represented
by Ms Josiane Meissener, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given in Princeton, on 4 August 2008,

(the Shareholders).
Which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties

and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent

the entire share capital of LSF Japan Hotel Investments II S. à r.l. (the Company), a company established under the laws
of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 117.888, incorporated
pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen and M 

e

 Schaeffer dated 11 July 2006, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 1756 of 20 September 2006, amended several times and for the

last time by a deed of Maître Martine Schaeffer dated 25 January 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Association N 

o

 635 of 13 March 2006.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,048,750 by an amount of

EUR 1,229,625 to an amount of EUR 2,278,375 by the issuance of 9,837 new ordinary shares with a par value of EUR125
each and to pay a share premium of EUR 43.17; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions unan-

imously:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,048,750

(one million forty-eight thousand seven hundred and fifty euro) represented by 8,389 (eight thousand three hundred and
eighty-nine) ordinary shares and 1 (one) preferred share with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five
euro) by an amount of EUR 1,229,625 (one million two hundred and twenty-nine thousand six hundred and twenty-five
euro) to an amount of EUR 2,278,375 (two million two hundred and seventy-eight thousand three hundred and seventy-
five euro) by way of the issuance of 9,837 (nine thousand eight hundred and thirty-seven) new ordinary shares having a
nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, and to pay a share premium of EUR 43.17 (forty-
three euro and seventeen cent).

Rising Sun II Holding Ltd expressly waives its right to subscribe to any of the newly issued shares.

106542

All the 9,837 (nine thousand eight hundred and thirty-seven) new ordinary shares to be issued have been fully sub-

scribed and paid up in cash and the share premium has been paid by Lone Star Capital Investments S. à r.l. so that the
amount  of  EUR  1,229,668.17  (one  million  two  hundred  and  twenty-nine  thousand  six  hundred  sixty-eight  euro  and
seventeen cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.

As a consequence of the share capital increase, Lone Star Capital Investments S. à r.l. holds 18,226 (eighteen thousand

two hundred and twenty-six) ordinary shares and Rising Sun II Holding Ltd holds 1 (one) preferred share.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of

the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at 2,278,375 (two million two hundred and seventy-eight

thousand three hundred and seventy-five euro), represented by 18,226 (eighteen thousand two hundred and twenty-six)
ordinary shares and 1 (one) preferred share having a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each."

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinq août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) Lone Star Capital Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91 796, représentée
par Philippe Detournay, ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée privée, ayant son adresse professionnelle
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 4 août 2008,

ET
2) RISING SUN II HOLDING Ltd, une société établie sous le droit des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon

House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes, représentée par Dennis HOWARTH, ici représentée par Mme
Josiane Meissener, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
à Princeton, le 4 août 2008,

(les Associés).
Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire agissant pour le compte des parties

comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF Japan Hotel Investments II S. à r.l. (la Société), une société de
droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
117.888, constituée selon acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen et Maître Martine Schaeffer du 11 juillet 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 1756 du 20 septembre 2006, modifié plusieurs fois et

pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer du 25 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N 

o

 635 du 13 mars 2008.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de EUR 1.048.750 par un montant de EUR 1.229.625

à un montant de EUR 2.278.375 par voie d'émission de 9.837 nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale
de EUR 125 chacune, et le paiement d'une prime d'émission de EUR43,17; et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 1,048,750

(un million quarante-huit mille sept cent cinquante euros) représenté par 8,389 (huit mille trois cent quatre-vingt-neuf)
parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq
euros) chacune par le biais d'une augmentation de EUR 1.229.625 (un million deux cent vingt-neuf mille six cent vingt-

106543

cinq euros) à un montant de EUR 2.278.375 (deux millions deux cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante-quinze
euros) par voie d'émission de 9.837 (neuf mille huit cent trente-sept) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur
nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et de payer une prime d'émission d'un montant de EUR 43.17
(quarante-trois euros et dix-sept cents).

Rising Sun II Holding Ltd renonce expressément à son droit de souscrire aux parts sociales nouvellement émises.
Toutes les 9.837 (neuf mille huit cent trente-sept) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement

souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par Lone Star Capital Investments S. à r.l., de sorte
que la somme de EUR 1,229,668.17 (un million deux cent vingt-neuf mille six cent soixante-huit euro et dix-sept cents)
est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, Lone Star Capital Investments S. à r.l. détient 18.226 (dix-huit mille deux cent

vingt-six) parts sociales ordinaires et Rising Sun II Holding Ltd détient 1 (une) part sociale préférentielle.

<i>Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'associé unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société,

dont la version française aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR2.278.375 (deux millions deux cent soixante-dix-huit

mille trois cent soixante-quinze euros) représenté par 18.226 (dix-huit mille deux cent vingt-six) parts sociales ordinaires
et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 août 2008. LAC/2008/33366. — Reçu six mille cent quarante-huit euros trente-

quatre cents Eur 0,50% = 6.148,34.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008111091/5770/134.
(080129140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Rhyton Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 66.650.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Rhyton Holding S.A.
Signature

Référence de publication: 2008110956/565/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03867. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Faune Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 62.514.

Constituée par-devant M 

e

 Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 23 décembre 1997, acte publié

au Mémorial C n° 242 du 15 avril 1998, modifiée pour la dernière fois par acte sous seing privé en date du 18
septembre 2001, publié par extrait au Mémorial C n° 647 du 25 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

106544

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FAUNE HOLDING S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008110962/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10473. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Space Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 105.550.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 décembre 2007

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2007:

<i>Signataire catégorie A:

Monsieur Sergio BENOCCI, Président, demeurant au 25, via Puccinotti, I-50129 Florence, Italie;

<i>Signataires catégorie B:

- Monsieur John SEIL, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-

bourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2007:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111527/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11233. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

ODE International Publishers Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.946.

Constituée par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 29 décembre 2006, acte publié au Mémorial C no 532 du 4 avril 2007.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ODE INTERNATIONAL PUBLISHERS HOLDING S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008110963/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10475. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

106545

Nido Notting Hill S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. UK Holdco 2 S. à r.l.).

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 121.188.

In the year two thousand and eight, on the twenty-third day of July.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

BRE/Europe 5NQ S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg trade
and companies register,

here represented by Ms Emilie VIARD, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given

on 22 July 2008, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of UK Holdco 2 S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies register under section B number 121188, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,
then residing in Mersch, on 26 October 2006, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number
2356 of 18 December 2006.

The appearing party representing the entire share capital then took the following resolution:

<i>Sole Resolution

The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company from "UK Holdco 2 S.à r.l." to "Nido Notting Hill

S.à r.l.".

As a consequence, the Sole Shareholder resolved to amend article 4 of the Company's articles of association which

shall now read as follows:

Art. 4. The Company will assume the name of Nido Notting Hill S.à r.l.".

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-troisième jour du mois de juillet,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

BRE/Europe 5NQ S.à r.l, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, pas encore enregistrée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Emilie VIARD, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

à Luxembourg, le 22 juillet 2008.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, en sa qualité d'associé unique (l'«Associé Unique») de UK Holdco 2 S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130212, constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, alors de
résidence à Mersch, en date du 26 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
2356 du 18 décembre 2006 (la «Société»).

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, prend la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Associé Unique a décidé de changer la dénomination de la Société de "UK Holdco 2 S.à r.l." en "Nido Notting Hill

S.à r.l.".

En conséquence l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 4 qui aura désormais la teneur suivante:

106546

« Art. 4. La Société prend la dénomination de Nido Notting Hill S.à r.l.».

<i>Estimation des frais

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. VIARD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juillet 2008, Relation: LAC/2008/31350. — Reçu douze euros (12 €).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008110974/242/70.
(080128935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Richemont Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.202.

In the year two thousand and eight, on the twenty-first day of the month of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

there appeared M 

e

 Mathilde Lattard, maître en droit, residing in Luxembourg, as proxy holder on behalf of Ichor

Investments S.A., a société anonyme, with registered office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg registered
with the registry of trade and companies under number B 70.290 pursuant to a proxy dated July 21, 2008, being the sole
shareholder of "Richemont Investments SA" (the "Corporation"), a société anonyme having its registered office at 35,
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the registry of trade and companies under number B 71.202
incorporated on 6 August 1999 by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 3 November 1999, Number C-816. The articles of incorporation of
the Corporation (the "Articles") have been amended for the last time on 20 December 2002 by deed of M 

e

 Jospeh

Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 26 March
2003, Number C-323.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The sole shareholder holds all the shares in issue in the Corporation, so that the decisions can validly be taken on

all items of the agenda.

2. The items on which a resolution is to be passed are as follows:
A. Change of the currency in which the Corporation's share capital is expressed from EUR to Pounds Sterling at the

Euro foreign exchange reference rates Euro /Pounds Sterling as published by the European Central Bank as at 16 July
2008 being one Euro for 0.79395 Pounds Sterling so that the Corporation's share capital is fixed at six hundred thirty
five million one hundred sixty thousand Pounds Sterling (£635,160,000) divided into sixty three million five hundred and
sixteen thousand (63,516,000) shares of no par value. Allocation of the balance of the existing capital to paid-in surplus,
if any.

B. Amendment of paragraph 1 of article 5 of the Articles in order to reflect the currency change resolved upon item

A above.

After the foregoing has been approved the following resolutions were duly taken:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to convert the currency in which the Corporation's share capital is expressed from

EUR to Pounds Sterling at the Euro foreign exchange reference rates Euro /Pounds Sterling as published by the European
Central Bank as at 16 July 2008 being one Euro for 0.79395 Pounds Sterling so that the Corporation's share capital is
fixed at six hundred thirty five million one hundred sixty thousand Pounds Sterling (£635,160,000) divided into sixty three
million five hundred and sixteen thousand (63,516,000) shares of no par value.

The sole shareholder decides to confer all powers to the board of directors to proceed to the essential book entries

and to convert all the books and documents of the company from EUR into GBP and to proceed to the exchange of the
EIGHTY MILLION (80,000,000) shares of no par value against SIXTY-THREE MILLION FIVE HUNDRED AND SIXTEEN
THOUSAND (63,516,000) shares of no par value.

106547

<i>Second resolution

As a result of the preceding conversion of the capital, the sole shareholder resolved to amend the first paragraph of

article 5 of the Articles so as to read as follows:

"The subscribed capital of the Corporation is set at six hundred thirty-five million one hundred sixty thousand Pounds

Sterling (£635,160,000.-) divided into sixty-three million five hundred and sixteen thousand (63,516,000) shares of no par
value."

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at EUR 1,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the proxy holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt et unième jour du mois de juillet,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu M 

e

 Mathilde Lattard, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en tant que mandataire pour le compte

de Ichor Investments S.A., une société anonyme ayant son siège social au 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 70.290, en vertu d'une procuration datée du 21 juillet
2008, étant l'actionnaire unique de «Richemont Investments S.A.» (la «Société»), une société anonyme ayant son siège
social au 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
B 71.202, constituée le 6 août 1999 suivant acte reçu de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro C-816 du 3 novembre 1999. Les statuts de la Société
(les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois en date du 20 décembre 2002 suivant acte reçu de M 

e

 Joseph

Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro C-323
du 26 mars 2003.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'actionnaire unique détient toutes les actions émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent être

valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:
A. Changement de la devise dans laquelle le capital social de la Société est exprimée de l'Euro en Livre Sterling au taux

de change de référence Euro / Livre Sterling tel que publié par la Banque Centrale Européenne en date du 16 juillet 2008,
étant d'un Euro pour 0,79395 Livres Sterling de sorte que le capital social de la Société est fixé à six cent trente cinq
millions  cent  soixante  mille  Livres  Sterling  (£635.160.000)  divisé  en  soixante-trois  millions  cinq  cent  seize  mille
(63.516.000) actions sans valeur nominale. Affectation du solde du capital existant à la réserve extraordinaire, le cas
échéant.

B. Modification du paragraphe 1 

er

 de l'article 5 des Statuts afin de refléter le changement de devise décidé au point

A.

Après approbation de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique a décidé de convertir la devise dans laquelle le capital social de la Société est exprimée de l'Euro

en Livre Sterling au taux de change de référence Euro / Livre Sterling tel que publié par la Banque Centrale Européenne
en date du 16 juillet 2008, étant d'un Euro pour 0,79395 Livres Sterling de sorte que le capital social de la Société est fixé
à six cent trente cinq millions cent soixante mille Livres Sterling (£635.160.000) divisé en soixante-trois millions cinq cent
seize mille (63.516.000) actions sans valeur nominale.

L'actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration de procéder aux écritures comp-

tables qui s'imposent, pour convertir tous les livres et documents de la société de EUR en GBP et pour procéder à
l'échange des QUATRE-VINGT MILLIONS (80.000.000) actions sans désignation de valeur nominale contre SOIXANTE-
TROIS MILLIONS CINQ CENT SEIZE MILLE (63.516.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la conversion de capital qui précède, l'actionnaire unique a décidé de modifier le premier paragraphe

de l'article 5 des Statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à six cent trente cinq millions cent soixante mille Livres Sterling (£635.160.000)

divisé en soixante-trois millions cinq cent seize mille (63.516.000) actions sans valeur nominale.»

106548

<i>Dépenses

Les coûts, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à

EUR 1.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante,
en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présente acte.
Signé: M. LATTARD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juillet 2008. Relation: LAC/2008/31315. - Reçu douze euros (12€).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008110975/242/109.
(080128954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Woodford S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 122.775.

EXTRAIT

En date du 18 août 2008, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Monsieur Jorrit Crompvoets, avec adresse professionnelle au «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg», est élu

nouveau gérant de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

- Monsieur Frank Walenta, avec adresse professionnelle au «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg», est élu nouveau

gérant de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 août 2008.

Pour extrait conforme
Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
Frank Walenta

Référence de publication: 2008111529/724/21.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT10981. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Mauna International S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.587.

Constituée par-devant M 

e

 André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg), en date du 31 décembre 2003, acte publié au Mémorial C no 252 du 3 mars 2004.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Mauna International S.àr.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008110988/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10478. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

106549

Green European Venture Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 77.091.

Constituée par-devant Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de

Luxembourg), en date du 21 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n° 909 du 23 décembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GREEN EUROPEAN VENTURE CAPITAL S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008110989/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10481. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

European Logistics Income Venture SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 102.749.

In the year two thousand eight, on the first day of August,
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEAR:

Mrs Sandra Elsholz, employee, with professional address at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, acting as the

representative of European Logistics, (before named LOG), a société anonyme, having its registered office at 7, rue de la
Chapelle L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 102.727 and incorporated and existing under the Luxembourg law pursuant to a notarial
deed dated on 13 July 2004, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1125 dated 9
November 2004, page 53954 (the "General Partner"), acting in its capacity as the general partner of the company, Euro-
pean Logistics Income Venture SCA, a société en commandite par actions, having its registered office 7, rue de la Chapelle,
L-1325 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 102.749
(the "Company"), pursuant to resolutions of the General Partner taken on 3 July 2008, an excerpt of which, initialled ne
varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The appearer, acting in her said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
1. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed, dated 13 July 2004 and its articles (the "Articles")

have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1128 dated 10 November
2004, page 54117.

2. The Articles have been amended pursuant to:
- a general meeting of the shareholders dated 24 November 2004 deciding, among others, to change the name of the

Company from LOG 1 SCA into European Logistics Income Venture SCA, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations under number 431 dated 10 May 2005, page 20649;

- a notarial rectifying deed dated 14 February 2005 enacting the amendment of article 9.1 of the Articles following the

change of name of the General Partner from LOG into European Logistics, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations under number 834 dated 1 September 2005, page 39994;

- a notarial deed dated 15 February 2005, enacting an increase of the share capital of the Company from one million

two Euros (€ 1,000,002.-) to an amount of one million one hundred thirty thousand four Euros (€ 1,130,004.-), published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 774 dated 3 August 2005, page 37140;

- a notarial deed dated 11 May 2005, enacting an increase of the share capital of the Company from one million one

hundred thirty thousand four Euros (€ 1,130,004.-) to an amount of one million four hundred seventy six thousand six
hundred six Euros (€ 1,476,606.-), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 975
dated 3 October 2005, page 46757;

- a notarial deed dated 18 January 2006, enacting an increase of the share capital of the Company from one million

four hundred seventy six thousand six hundred six Euros (€ 1,476,606.-) to an amount of one million five hundred seventy-
one thousand six hundred seven Euros (€ 1,571,607.-), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under number 840, dated 27 April 2006, page 40306;

106550

- a notarial deed dated 27 March 2006, enacting an increase of the share capital of the Company from one million five

hundred seventy-one thousand six hundred seven Euros (€ 1,571,607.-) to an amount of one million six hundred twenty
three thousand six hundred nine Euros (€ 1,623,609.-), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under number 1311, dated 6 July 2006, page 62888;

- a notarial deed dated 11 May 2006, enacting an increase of the share capital of the Company from one million six

hundred twenty three thousand six hundred nine Euros (€ 1,623,609.-) to an amount of one million eight hundred sixty
five thousand one hundred nine Euros (€ 1,865,109.-), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under number 1446, dated 27 July 2006, page 69390;

- a notarial deed dated 10 November 2006, enacting an increase of the share capital of the Company from one million

eight hundred sixty five thousand one hundred nine Euros (€ 1,865,109.-) to an amount of two million four hundred thirty
thousand two hundred ten Euros (€ 2,430,210.-), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 423, dated 21 March 2007, page 20258;

- a notarial deed dated 14 February 2007, enacting an increase of the share capital of the Company from two million

four hundred thirty thousand two hundred ten Euros (€ 2,430,210.-) to an amount of two million four hundred seventy-
six thousand two hundred sixteen Euros fifty cents (€ 2,476,216.50), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number 824, dated 9 May 2007, page 39516;

- a notarial deed dated 18 April 2007, enacting an increase of the share capital of the Company from an amount of

two million four hundred seventy-six thousand two hundred sixteen Euros fifty cents (€ 2,476,216.50) to an amount of
two million eight hundred seventy-five thousand four hundred fifty-five Euros (€ 2,875,455.-), published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1373, dated 5 July 2007, page 65866;

- a notarial deed dated 28 June 2007, amending certain provisions of the Articles published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations under number 1988, dated 14 September 2007, page 95388;

- a notarial deed dated 17 October 2007, enacting an increase of the share capital of the Company from an amount

of two million eight hundred seventy-five thousand four hundred fifty-five Euros (€ 2,875,455.-) to an amount of three
million four hundred thirty-five thousand four hundred fifty-seven Euros fifty cents (€ 3,435,457.50), published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2667, dated 21 November 2007, page 127977; and

- a notarial deed dated 27 June 2008, enacting an increase of the share capital of the Company from an amount of

three million four hundred thirty-five thousand four hundred fifty-seven Euros fifty cents (€ 3,435,457.50) to an amount
of four million two hundred forty-one thousand nine hundred sixty-two Euros fifty cents (€ 4,241,962.50), not yet pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

3. The share capital was then fixed at four million two hundred forty-one thousand nine hundred sixty-two Euros fifty

cents (€ 4,241,962.50), represented by:

- forty-six thousand three hundred sixty-three (46,363) shares of Unlimited Shareholder (herein referred to as "actions

de commandité" or "Class A shares"); and

-  two  million  seven  hundred  eighty-one  thousand  six  hundred  twelve  (2,781,612)  shares  of  Limited  Shareholders

(herein referred to as "actions de commanditaire" or "Class B Shares"); (together with the Class B Shares, the "Shares").

Each Share has a par value of one Euro fifty cents (€ 1.50).
4. Pursuant to article 6 of the Articles, the Company, for the purposes of the effective performance of the obligations

resulting from the agreement possibly entered into or to be entered into between the Shareholders, has an un-issued
but authorised capital of a maximum amount of ninety-eight million six hundred thirty-three thousand four hundred
ninety-two Euros fifty cents (€ 98,633,492.50) to be used in order to issue new Shares or to increase the nominal value
of the Shares and is subject to the specific limits and conditions set out under article 6 of the Articles.

5. The increase of the share capital by way of authorised capital, shall be realised within the strict limits defined in the

article 6 of the Articles, which are as following:

"6.2 The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Shares or the increase of the nominal

value of the existing Shares in exchange of contribution in cash made by the existing Shareholders in execution of the
capital calls made by the General Partner in compliance with any agreement possibly entered into from time to time
between, amongst others, the Shareholders and the Company.

6.3 Until 28 June 2012 at the latest, and in compliance with any agreement possibly entered into from time to time

between, amongst others, the Shareholders and the Company, the General Partner is authorised to increase, from time
to time, the capital, within the limits of the authorised capital, by the issue or not of Shares to the existing Shareholders
or to any other person as approved by the Shareholders in compliance with any applicable provision of the Law.

6.4 These new Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined by the General

Partner within the strict limits stated in any agreement possibly entered into from time to time between, amongst others,
the Shareholders and the Company.

6.5 In particular, the General Partner may decide to issue the new Shares subject to the constitution of a share premium,

the amount and the allocation of which will be freely decided by the General Partner.

106551

6.6 The General Partner may also determine the date of the issue and the number of new Shares having to be eventually

subscribed and issued. It may proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a preferential right
to subscribe to the new shares under issuance.

6.7 The rights attached to the new Shares will be strictly similar to the rights attached to the existing respective class

of Shares.

6.8 The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for new Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

6.9 The General Partner shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of

capital and the issue of new Shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary
documents evidencing the decision of the General Partner, the above power of attorney, the subscription and the paying
up of the new Shares.

6.10 Upon cash increase of the share capital of the Company by the General Partner within the limits of the authorised

share capital, the amount of the authorised capital specified in article 6.1 of the Articles shall be deemed to be decreased
by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in articles 5 and 6 of the Articles
will be amended accordingly pursuant to the notarial deed enacting the increase of share capital under article 6 of the
Articles."

6. In the resolutions of the General Partner of the Company taken on 3 July 2008, the General Partner of the Company

resolved in compliance with article 6 of the Articles to increase the share capital of the Company by way of authorised
capital, with an amount of one million five hundred eighty-two thousand Euros fifty cents (€1,582,000.50) subject to the
payment of a global share premium for an amount of fourteen million two hundred thirty-eight thousand four Euros fifty
cents (€ 14,238,004.50) allocated to an available reserve item of the balance sheet, pursuant to articles 5 and 6 of the
Articles in order to raise it from the amount of four million two hundred forty-one thousand nine hundred sixty-two
Euros fifty cents (€ 4,241,962.50) to five million eight hundred twenty-three thousand nine hundred sixty-three Euros (€
5,823,963.-), by creating and issuing one million fifty-four thousand six hundred sixty-seven (1,054,667) new Class B Shares
(the "New Class B Shares") with a par value of one Euro fifty cents (€ 1.50) each, having the same rights and obligations
as the existing Class B Shares.

7. The General Partner has further decided to have the increase of the share capital enacted by a Luxembourg notary

and to grant:

- Christel Di Marco, employee, residing in Luxembourg; and /or
- Sylvie Reisen, employee, residing in Belgium; and /or
- Sandra Elsholz, employee, residing professionally in Luxembourg;
a power of attorney to have the increase of the subscribed capital of the Company and the consequential amendments

to the Articles recorded in a deed of notary.

8. The New Class B Shares were fully subscribed by the existing Class B Shareholders exercising their respective

preferential right of subscription i.e.:

1) AXA RE, a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic of France,

having its registered office at 39, rue du Colisée, F-75008 Paris (France), registered with the Paris Register of Commerce
under number 542 066 394 RCS, subscribed eighty-seven thousand eight hundred eighty-nine (87,889) New Class B
Shares for an amount of one hundred thirty-one thousand eight hundred thirty-three Euros fifty cents (€ 131,833.50),
subject  to  a  share  premium  of  one  million  one  hundred  eighty-six  thousand  five  hundred  one  Euros  fifty  cents  (€
1,186,501.50), for a total amount of one million three hundred eighteen thousand three hundred and thirty-five Euros (€
1,318,335.-);

2) SCI VENDOME ACTIVITE, a société civile à capital variable incorporated in accordance with and governed by the

laws of the Republic of France, having its registered office at Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, 100, Esplanade du
Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex, (France) (registered under number 414 874 313 in Nanterre), sub-
scribed eighty-seven thousand eight hundred eighty-nine (87,889) New Class B Shares for an amount of one hundred
thirty-one thousand eight hundred thirty-three Euros fifty cents (€ 131,833.50), subject to a share premium of one million
one hundred eighty-six thousand five hundred one Euros fifty cents (€ 1,186,501.50), for a total amount of one million
three hundred eighteen thousand three hundred and thirty-five Euros (€ 1,318,335.-);

3) AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, a company incorporated in accordance with

and governed by the laws of Spain with registered office at Calle Monsenor Palmer n 

o

 1, Palma de Mallorca (Spain),

subscribed ninety-nine thousand six hundred seven (99,607) New Class B Shares for an amount of one hundred forty-
nine thousand four hundred ten Euros fifty cents (€ 149,410.5), subject to a share premium of one million three hundred
forty-four thousand six hundred ninety-four Euros fifty cents (€ 1,344,694.5), for a total amount of one million four
hundred ninety-four thousand one hundred five Euros (€ 1,494,105.-);

4) AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS S.A., a company incorporated in accordance with and governed

by the laws of Portugal with registered office at rua Goncalo Sampaio 39 Ap. 4076,4002-001 Porto, Portugal, subscribed
seventeen thousand five hundred seventy-eight (17,578) New Class B Shares for an amount of twenty-six thousand three
hundred sixty-seven Euros (€ 26,367.-), subject to a share premium of two hundred thirty-seven thousand three hundred

106552

three  Euros  (€  237,303.-),  for  a  total  amount  of  two  hundred  sixty-three  thousand  six  hundred  seventy  Euros  (€
263,670.-);

5) MUTAVIE S.A., a société anonyme, incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic of

France, having its registered office at 9, rue des Iris, F-79000 Bessines (France), subscribed one hundred seventy-five
thousand seven hundred seventy-eight (175,778) New Class B Shares for an amount of two hundred sixty three thousand
six hundred sixty-seven Euros (€ 263,667.-), subject to a share premium of two million three hundred seventy-three
thousand three Euros (€ 2,373,003.-) for a total amount of two million six hundred thirty-six thousand six hundred seventy
Euros (€ 2,636,670.-);

6) CARDIF ASSURANCE VIE S.A., a société anonyme, incorporated in accordance with and governed by the laws of

the Republic of France, having its registered office at 5, avenue Kléber, F-75016 Paris (France), subscribed one hundred
seventeen thousand one hundred eighty-five (117,185) New Class B Shares for an amount of one hundred seventy-five
thousand seven hundred seventy-seven Euros fifty cents (€ 175,777.50), subject to a share premium of one million five
hundred eighty-one thousand nine hundred ninety-seven Euros fifty cents (€ 1,581,997.50) for a total amount of one
million seven hundred fifty-seven thousand seven hundred seventy-five Euros (€ 1,757,775.-);

7) SOGECAP S.A., a société anonyme, incorporated in accordance with and governed by the laws of the Republic of

France, having its registered office at 50, avenue du Général de Gaulle, F-92093 Paris La Défense Cedex, France, subscribed
one hundred seventeen thousand one hundred eighty-five (117,185) New Class B Shares for an amount of one hundred
seventy-five thousand seven hundred seventy-seven Euros fifty cents (€ 175,777.50), subject to a share premium of one
million five hundred eighty-one thousand nine hundred ninety-seven Euros fifty cents (€ 1,581,997.50) for a total amount
of one million seven hundred fifty-seven thousand seven hundred seventy-five Euros (€ 1,757,775.-);

8) EUROPEAN LOGISTICS FEEDER SCA, a société en commandite par actions, incorporated in accordance with and

governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129 820, subscribed three
hundred fifty-one thousand five hundred fifty-six (351,556) New Class B Shares for an amount of five hundred twenty-
seven thousand three hundred thirty-four Euros (€ 527,334.-), subject to a share premium of four million seven hundred
forty-six thousand six Euros (€ 4,746,006.-) for a total amount of five million two hundred seventy-three thousand three
hundred forty Euros (€ 5,273,340.-).

9. The New Class B Shares were fully paid up together with a share premium through contributions in cash as evidenced

by the bank certificate issued by Dexia-Banque Internationale à Luxembourg on 23 July 2008, so that the Company had
at its free disposal the amount of fifteen million eight hundred twenty thousand five Euros (€ 15,820,005.-).

10. The justifying documents of the subscription and of the payment of the New Class B Shares have been produced

to the undersigned notary, who expressly acknowledges receipt. Therefore, the capital increase is effective as of 23 July
2008 at which the New Class B Shares were fully paid up.

11. As a consequence of such increase of the share capital of the Company article 5.1 of the Articles is amended and

now reads as follows:

"5.1 The share capital is fixed at five million eight hundred twenty-three thousand nine hundred sixty-three Euros (€

5,823,963.-) represented by:

- forty-six thousand three hundred sixty-three (46,363) shares of Unlimited Shareholder (herein referred to as "actions

de commandité" or "Class A shares"); and

- three million eight hundred thirty-six thousand two hundred seventy-nine (3,836,279) shares of Limited Shareholders

(herein referred to as "actions de commanditaire" or "Class B Shares");

(the Class A Shares together with the Class B Shares, are referred to as the "Shares"), with a par value of one Euro

fifty cents (€ 1.50) each.

12. As a consequence of the present increase of the share capital of the Company by way of the authorised capital

clause, article 6.1 of the Articles is amended and now reads as follows:

"6.1 For the purposes of the effective performance of the obligations resulting from any agreement possibly entered

into from time to time between, amongst others, the Shareholders and the Company, the Company has an un-issued but
authorised capital of a maximum amount of ninety-seven million fifty-one thousand four hundred ninety-two Euros (€
97,051,492.-) to be used in order to issue new Shares or to increase the nominal value of the Shares."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at eighty six thousand euros (EUR 86,000).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

106553

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le premier août,
Par devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Sandra Elsholz, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de European Logistics, (anciennement dénommée LOG), société anonyme,
ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.727 et constituée et existant selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'un acte notarié en date du 13 juillet 2004, et publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1125 du 9 novembre 2004, page 53954 (le "Gérant Commandité"),
agissant en sa qualité de gérant commandité de European Logistics Income Venture SCA, une société en commandite par
actions, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.749 (la "Société"), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré
aux termes des résolutions prises par le Gérant Commandité le 3 juillet 2008, dont un extrait restera, après avoir été
paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de
l'enregistrement.

La comparante, qui agit ès qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1. La Société a été constituée en vertu d'un acte notarié en date du 13 juillet 2004 et ses statuts (les "Statuts") ont été

publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1128 du 10 novembre 2004, page 54117.

2. Les Statuts ont été modifiés à plusieurs reprises en vertu:
- d'une assemblée générale des actionnaires tenue le 24 novembre 2004 décidant notamment de changer la dénomi-

nation de la Société de LOG 1 SCA en European Logistics Income Venture SCA, publiée au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 431 du 10 mai 2005, page 20649;

- d'un acte rectificatif notarié en date du 14 février 2005 constatant la modification de l'article 9.1 des Statuts suite au

changement de dénomination du Gérant Commandité de LOG en European Logistics, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 834 du 1er septembre 2005, page 39994;

- d'un acte notarié du 15 février 2005 constatant l'augmentation du capital social de la Société d'un million et deux

Euros (1.000.002,- €) à un million cent trente mille et quatre Euros (1.130.004,- €), publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 774 du 3 août 2005, page 37140;

- d'un acte notarié du 11 mai 2005 constatant l'augmentation du capital social de la Société d'un million cent trente

mille et quatre Euros (1.130.004,- €) à un million quatre cent soixante-seize mille six cent six Euros (1.476.606,- €) publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 975 du 3 octobre 2005, page 46757-;

- d'un acte notarié du 18 janvier 2006 constatant l'augmentation du capital social de la Société d'un million quatre cent

soixante-seize mille six cent six Euros (1.476.606,- €) à un million cinq cent soixante et onze mille six cent sept Euros
(1.571.607,- €), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 840 du 27 avril 2006, page
40306;

- d'un acte notarié du 27 mars 2006 constatant l'augmentation du capital social de la Société d'un million cinq cent

soixante et onze mille six cent sept Euros (1.571.607,- €) à un million six cent vingt-trois mille six cent neuf Euros
(1.623.609,- €), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1311 du 6 juillet 2006, page
62888;

- d'un acte notarié du 11 mai 2006 constatant l'augmentation du capital social de la Société d'un million six cent vingt-

trois mille six cent neuf Euros (1.623.609,- €) à un million huit cent soixante-cinq mille cent neuf Euros (1.865.109,- €),
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1446 du 27 juillet 2006, page 69390;

- d'un acte notarié du 10 novembre 2006 constatant l'augmentation du capital social de la Société d'un million huit

cent soixante-cinq mille cent neuf Euros (1.865.109,- €) à deux millions quatre cent trente mille deux cent dix Euros
(2.430.210,- €), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 423, en date du 21 mars 2007,
page 20258;

- d'un acte notarié du 14 février 2007 constatant l'augmentation du capital social de la Société de deux millions quatre

cent trente mille deux cent dix Euros (2.430.210,- €) à deux millions quatre cent soixante-seize mille deux cent seize
Euros cinquante centimes (2.476.216,50 €), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
824, en date du 9 mai 2007, page 39516;

- d'un acte notarié du 18 avril 2007 constatant l'augmentation du capital social de la Société de deux millions quatre

cent soixante-seize mille deux cent seize Euros cinquante centimes (2.476.216,50 €) à deux millions huit cent soixante-
quinze mille quatre cent cinquante cinq Euros (2.875.455,- €), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 1373, en date du 5 juillet 2007, page 65866;

- d'un acte notarié du 28 juin 2007, modifiant certaines dispositions des Statuts publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations sous le numéro 1988, en date du 14 septembre 2007, page 95388;

106554

- d'un acte notarié du 17 octobre 2007 constatant l'augmentation du capital social de la Société de deux millions huit

cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante cinq Euros (2.875.455,- €) à trois millions quatre cent trente-cinq mille
quatre cent cinquante-sept Euros cinquante centimes (3.435.457,50 €), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 2667, en date du 21 novembre 2007, page 127977; et

- d'un acte notarié du 27 juin 2008 constatant l'augmentation du capital social de la Société de trois millions quatre

cent trente-cinq mille quatre cent cinquante-sept Euros cinquante centimes (3.435.457,50 €) à quatre millions deux cent
quarante et un mille deux cent soixante-deux Euros cinquante centimes (4.241.962,50 €), non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

3. Le capital social de la Société était alors fixé à quatre millions deux cent quarante et un mille neuf cent soixante-

deux Euros cinquante centimes (4.241.962,50 €) représenté par:

- quarante six mille trois cent soixante trois (46.363) actions d'Actionnaire Commandité (ci-après les "actions de

commandité" ou "Actions de Classe A"); et

- deux millions sept cent quatre-vingt-un mille six cent douze (2.781.612) actions d'Actionnaire Commanditaire (ci-

après les "actions de commanditaire" ou "Actions de Classe B"); (ensemble avec les Actions de Classe B, les "Actions").

Chaque Action a une valeur nominale d'un Euro cinquante centimes (1,50 €).
4. Conformément à l'article 6 des Statuts, la Société, afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant

des dispositions de la convention intervenue ou à intervenir probablement entre les Actionnaires, disposera d'un capital
autorisé d'un montant maximum de quatre-vingt-dix-huit millions six cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-
douze Euros cinquante centimes (98.633.492,50 €) pour émettre de nouvelles Actions ou augmenter la valeur nominale
des Actions et sera soumise aux limites et conditions définies à l'article 6 des Statuts.

5. L'augmentation du capital social de la Société par voie de capital autorisé, doit être réalisée dans le strict respect

des limites et conditions définies à l'article 6 des Statuts, qui sont les suivantes:

"6.2 Ce capital autorisé a pour seul objectif de permettre l'émission d'Actions nouvelles ou l'augmentation de la valeur

nominale des Actions existantes en contrepartie et rémunération d'apports en numéraire effectués par les Actionnaires
existants en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant Commandité aura procédé conformément à toute con-
vention pouvant intervenir à tout moment entre, parmi d'autres, les Actionnaires et la Société.

6.3 Jusqu'au 28 juin 2012 au plus tard, et conformément aux engagements pris par le Gérant Commandité dans toute

convention pouvant intervenir à tout moment entre, parmi d'autres, les Actionnaires et la Société, le Gérant Commandité
pourra augmenter à tout moment le capital social dans les limites du capital autorisé, par émission de nouvelles Actions
ou augmentation de la valeur nominale des Actions existantes aux Actionnaires actuels ou à toutes autres personnes
approuvées par les Actionnaires conformément aux dispositions applicables de la Loi.

6.4 Ces nouvelles Actions pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminés par le Gérant Commandité,

tout en restant dans la stricte observance des conditions précisées par toute convention pouvant intervenir à tout moment
entre, parmi d'autres, les Actionnaires et la Société.

6.5 Le Gérant Commandité peut décider en particulier d'émettre les nouvelles Actions avec prime d'émission. Le

montant et l'affectation de cette prime d'émission seront déterminés à la discrétion du Gérant Commandité.

6.6 Le Gérant Commandité déterminera également la date d'émission et le nombre d'Actions devant être, le cas

échéant, souscrites et émises. Il pourra procéder à cette augmentation sans délivrer aux Actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription sur les nouvelles parts à émettre.

6.7 Les droits attachés aux Actions nouvelles seront identiques à ceux attachés respectivement aux classes d'Actions

déjà émises.

6.8 Le Gérant Commandité pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter des souscri-

ptions et la réception des paiements pour les Actions nouvelles représentant tout ou partie des montants augmentés du
capital social.

6.9 Le Gérant Commandité désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux

fins de constater authentiquement l'émission des Actions nouvelles et l'augmentation du capital, sur présentation des
pièces justificatives de la décision du Gérant Commandité, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les sou-
scriptions et libérations des Actions nouvelles.

6.10 Lors de chaque augmentation du capital social de la Société effectuée par le Gérant Commandité dans les limites

du capital autorisé, le montant du capital autorisé précisé à l'article 6.1 des Statuts sera considéré comme diminué du
montant correspondant à cette augmentation. En conséquence, les montants précisés aux articles 5 et 6 des Statuts seront
ainsi modifiés en vertu d'un acte notarié constatant l'augmentation de capital en vertu de l'article 6 des Statuts de la
Société."

6. Dans les résolutions prises le 3 juillet 2008 par le Gérant Commandité de la Société, celui-ci a décidé, conformément

à l'article 6 des Statuts, d'augmenter le capital social de la société par voie du capital autorisé, à concurrence d'un million
cinq cent quatre-vingt-deux mille Euros cinquante centimes (1.582.000,50 €), moyennant le paiement d'une prime d'émis-
sion  globale  d'un  montant  de  quatorze  millions  deux  cent  trente-huit  mille  quatre  Euros  cinquante  centimes
(14.238.004,50 €) qui restera allouée à un compte de réserves disponibles du bilan, conformément aux articles 5 et 6 des
Statuts, pour porter ainsi le capital social du montant de quatre millions deux cent quarante et un mille neuf cent soixante-

106555

deux Euros cinquante centimes (4.241.962,50 €)) à cinq millions huit cent vingt-trois mille neuf cent soixante-trois Euros
(5.823.963,- €), par la création et l'émission d'un million cinquante-quatre mille six cent soixante-sept (1.054.667) nou-
velles Actions de Classe B (les "Nouvelles Actions B") d'une valeur nominale d'un Euro cinquante centimes (1,50 €)
chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les Actions de Classe B existantes.

7. Le Gérant Commandité a également décidé de faire acter l'augmentation de capital social par un notaire luxem-

bourgeois et de donner pouvoir à:

- Christel Di Marco, employée privée, résidant à Luxembourg; et/ou
- Sylvie Reisen, employée privée résidant en Belgique; et/ou
- Sandra Elsholz, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg;
afin de faire enregistrer par acte notarié l'augmentation de capital souscrit de la Société et les modifications des Statuts

en découlant.

8. Les Nouvelles Actions de Classe B ont été entièrement souscrites par les Actionnaires existants de Classe B exerçant

leur droit de souscription préférentielle respectif comme suit:

1) AXA RE, une société anonyme constituée et régie par le droit français, ayant son siège social au 39, rue du Colisée,

F-75008 Paris (France), immatriculée auprès du Registre de Commerce de Paris sous le numéro 542 066 394 RCS, a
souscrit quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-neuf (87.889) Nouvelles Actions de Classe B pour un montant de
cent trente et un mille huit cent trente-trois Euros cinquante centimes (131.833,50 €), moyennant une prime d'émission
d'un montant d'un million cent quatre-vingt-six mille cinq cent un Euros cinquante centimes (1.186.501,50 €), pour une
somme totale d'un million trois cent dix-huit mille trois cent trente-cinq Euros (1.318.335,- €);

2) SCI VENDOME ACTIVITE, société civile à capital variable constituée et régie par le droit français, ayant son siège

social au Cœur Défense, Tour B, La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex
(France), (immatriculée auprès du registre des Sociétés à Nanterre sous le numéro 414 874 313) a souscrit quatre-vingt-
sept mille huit cent quatre-vingt-neuf (87.889) Nouvelles Actions de Classe B pour un montant de cent trente et un mille
huit cent trente-trois Euros cinquante centimes (131.833,50 €), moyennant une prime d'émission d'un montant d'un
million cent quatre-vingt-six mille cinq cent un Euros cinquante centimes (1.186.501,50 €), pour une somme totale d'un
million trois cent dix-huit mille trois cent trente-cinq Euros (1.318.335,- €);

3) AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, une société constituée et gouvernée confor-

mément au droit espagnol ayant son siège social à Calle Monsenor Palmer n 

o

 1, Palma de Mallorca (Espagne), a souscrit

quatre-vingt-dix-neuf mille six cent sept (99.607) Nouvelles Actions de Classe B pour un montant de cent quarante neuf
mille quatre cent dix Euros cinquante centimes (149.410,50 €), moyennant une prime d'émission d'un montant d'un million
trois cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze Euros cinquante centimes (1.344.694,50 €), pour une
somme totale d'un million quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cent cinq Euros (1.494.105,- €);

4) AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS S.A., une société constituée et gouvernée conformément au droit

portugais ayant son siège social à rua Goncalo Sampaio 39 Ap. 4076,4002-001 Porto, Portugal, a souscrit dix-sept mille
cinq cent soixante-dix-huit (17.578) Nouvelles Actions de Classe B pour un montant de vingt-six mille trois cent soixante-
sept Euros (26.367,- €), moyennant une prime d'émission d'un montant de deux cent trente-sept mille trois cent trois
Euros (237.303,- €), pour une somme totale de deux cent soixante trois mille six cent soixante-dix Euros (263.670,- €);

5) MUTAVIE S.A., une société anonyme constituée et régie par le droit français, ayant son siège social au 9, rue des

Iris, F-79000 Bessines (France), a souscrit cent soixante-quinze mille sept cent soixante-dix huit (175.778) Nouvelles
Actions  de  Classe  B  pour  un  montant  de  deux  cent  soixante-trois  mille  six  cent  soixante-sept  Euros  (263.667,-  €),
moyennant une prime d'émission d'un montant de deux millions trois cent soixante-treize mille trois Euros (2.373.003,-
€), pour une somme totale de deux millions six cent trente-six mille six cent soixante-dix Euros (2.636.670,- €);

6) CARDIF ASSURANCE VIE S.A., une société anonyme constituée et régie par le droit français, ayant son siège social

au 5, avenue Kléber, F-75016 Paris (France), a souscrit cent dix-sept mille cent quatre-vingt-cinq (117.185) Nouvelles
Actions  de  Classe  B  pour  un  montant  de  cent  soixante-quinze  mille  sept  cent  soixante-dix-sept  Euros  et  cinquante
centimes (175.777,50 €), moyennant une prime d'émission d'un montant d'un million cinq cent quatre-vingt-un mille neuf
cent quatre-vingt-dix-sept Euros et cinquante centimes (1.581.997,50 €), pour une somme totale d'un million sept cent
cinquante-sept mille sept cent soixante-quinze Euros (1.757.775,- €);

7) SOGECAP S.A., une société anonyme constituée et régie par le droit français, ayant son siège social au 50, avenue

du Général de Gaulle, F-92093 Paris La Défense Cedex (France), a souscrit cent dix-sept mille cent quatre-vingt-cinq
(117.185) Nouvelles Actions de Classe B pour un montant de cent soixante-quinze mille sept cent soixante-dix-sept Euros
et cinquante centimes (175.777,50 €), moyennant une prime d'émission d'un montant d'un million cinq cent quatre-vingt-
un mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept Euros et cinquante centimes (1.581.997,50 €), pour une somme totale d'un million
sept cent cinquante-sept mille sept cent soixante-quinze Euros (1.757.775,- €);

8) EUROPEAN LOGISTICS FEEDER S.C.A., une société en commandite par actions constituée et régie par le droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129 820, a souscrit
trois cent cinquante et un mille cinq cent cinquante-six (351.556) Nouvelles Actions de Classe B pour un montant de
cinq cent vingt-sept mille trois cent trente-quatre Euros (527.334,- €),moyennant une prime d'émission d'un montant de

106556

quatre millions sept cent quarante-six mille six Euros (4.746.006,- €), pour une somme totale de cinq millions deux cent
soixante-treize mille trois cent quarante Euros (5.273.340,- €);

9. Les Nouvelles Actions de Classe B ont été entièrement libérées, ensemble avec une prime d'émission, par apport

en numéraire, tel que constaté par le certificat bancaire émis par Dexia-Banque Internationale à Luxembourg le 23 juillet
2008, de sorte que la société avait, à sa libre disposition, le montant de quinze million huit cent vingt mille cinq Euros
(15.820.005,- €).

10. Les documents justificatifs de la souscription et de la libération des Nouvelles Actions de Classe B ont été présentés

au notaire soussigné, qui en prend expressément acte. Dès lors, l'augmentation de capital prend effet au 23 juillet 2008
date à laquelle les Nouvelles Actions de Classe B ont été entièrement libérées.

11. A la suite de cette augmentation de capital de la Société, l'article 5.1 des Statuts est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

"5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq millions huit cent vingt-trois mille neuf cent soixante-trois

Euros (5.823.963,- €), représenté par

- quarante six mille trois cent soixante trois (46.363) actions d'Actionnaire Commandité (ci-après les "actions de

commandité" ou "Actions de Classe A"); et

- trois millions huit cent trente-six mille deux cent soixante-dix-neuf (3.836.279) actions d'Actionnaire Commanditaire

(ci-après les "actions de commanditaire" ou "Actions de Classe B"),

(les Actions de Classe A, ensemble avec les Actions de Classe B, sont repris ci-après comme les "Actions"), d'une

valeur nominale d'un Euro cinquante centimes (1,50 €), chacune."

12. A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée par voie de capital autorisé, l'article 6.1 des Statuts est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

" 6.1 Afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant des dispositions de toute convention pouvant

intervenir à tout moment entre, parmi d'autres, les Actionnaires et la Société, la Société disposera d'un capital autorisé
d'un montant maximum de quatre-vingt-dix-sept millions cinquante et un mille quatre cent quatre-vingt-douze Euros et
cinquante centimes (97.051.492,- €) devant être utilisé afin d'émettre de nouvelles actions ou d'augmenter la valeur
nominale des Actions."

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à la somme de quatre vingt six mille euros (EUR 86.000).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête du comparant, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte

Signé: S. Elsholz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2008. LAC/2008/32621. - Reçu à 0,50%: soixante-dix-neuf mille cent euros

trois cents (EUR 79.100,03).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008111673/220/433.
(080129559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Monetics S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 109.636.

1. Le siège social de la société Monetics S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 109.636, au 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg est dénoncé avec effet au 30 juin 2008.

2. Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation conclu et signé entre:
Société domiciliée : Monetics S.A., société anonyme, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg

B 109.636

et Domiciliataire: Maitland Luxembourg S.A., société anonyme, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg B 13.583

en date du 23 juin 2005 est terminé à partir du 30 juin 2008.

106557

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2008.

<i>Pour la société
Maitland Luxembourg S.A.
<i>Un mandataire
Signature

Référence de publication: 2008111654/631/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08658. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

East Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 96.908.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration réuni en date du 4 août 2008 à 15.00 heures a pris à la majorité la résolution de fixer le

siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2008111627/693/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07635. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080128548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Quality Electronics Design SA, Société Anonyme.

Siège social: L-6478 Echternach, 32, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 98.821.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28.08.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111660/2241/12.
Enregistré à Diekirch, le 14 août 2008, réf. DSO-CT00175. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080129045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Siagep S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 100.853.

EXTRAIT

Par la présente, Monsieur Christophe ANTINORI, informe avoir démissionné en date du 18 juillet 2008 de son mandat

d'administrateur de la société SIAGEP S.A.

Luxembourg, le 18 juillet 2008.

Monsieur Christophe Antinori.

Référence de publication: 2008111985/1384/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2008, réf. LSO-CS12313. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Hegeling Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 87.115.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106558

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour Hegeling Holding S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008111995/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT10988. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

HSBCPI Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 118.049.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

<i>Pour HSBCPI Management S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008111996/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11576. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Héron S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 97.072.

EXTRAIT

Par la présente, Monsieur Christophe ANTINORI, informe avoir démissionné en date du 18 juillet 2008 de son mandat

d'administrateur de la société HERON S.A.

Luxembourg, le 18 juillet 2008.

Monsieur Christophe Antinori.

Référence de publication: 2008111984/1384/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2008, réf. LSO-CS12320. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Elektro R.Velz A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 1, D'Millen.

R.C.S. Luxembourg B 91.918.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28.08.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111665/2241/12.
Enregistré à Diekirch, le 14 août 2008, réf. DSO-CT00174. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080129030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Cono - Consultatio Nobilitatis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5441 Remerschen, 10, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 103.403.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

106559

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Signature
<i>LE GERANT

Référence de publication: 2008111991/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT04522. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Internet Activities S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 100.726.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2007

Démission du commissaire
SOCIETE D'AUDIT &amp; DE REVISION SARL
Nomination du nouveau commissaire
Vericom Sa, RCS numéro B 51.203
Ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy
Le mandat de commissaire ainsi nommé prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait
Signature

Référence de publication: 2008111530/1185/20.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11322. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Tulipe International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 127.942.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue extraor-

dinairement en date du 4 juillet 2008 au siège social de la société que:

L'assemblée générale accepte la démission de Mme. Louise Benjamin en tant que administrateur de la société avec

effet au 31 mars 2008.

Mr. Filipe Capinha-Heliodoro avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg est nommée

en tant que administrateur de la société avec effet à ce jour, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en
2014.

Luxembourg, le 4 juillet 2008.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2008111531/803/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11523. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

106560


Document Outline

Ad'Net S.A.

Adorf S.à r.l.

Airpark S.à r.l.

Aqua Investment S.A.

Barthels Hof S.à r.l.

Boucherie Krack S.à r.l.

COLT Lux Group Holding S.à r.l.

Cono - Consultatio Nobilitatis S.à r.l.

Duraflex Luxembourg S.àr.l.

East Holding S.A.

Elektro R.Velz A.G.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS CORDELLA Cosimino

EUROMARKET, Alimentation en gros

European Logistics Income Venture SCA

European Retail Income Venture S.C.A.

Faune Holding S.A.

Fosbel Global Services

Genes Participations S.A.

Gotic House S.à r.l.

Green European Venture Capital S.A.

Gulfstream Marine S.A.

HaMer Holding S.à r.l.

Hegeling Holding S.A.

Héron S.A.

HSBCPI Management S.A.

Internet Activities S.A.

Jasper Broker S.A.

Kyritz Ueckermunde S.à r.l.

Lagon 120 SA

La Modenese S.à r.l.

Les Rossignols S.A. 1850

LSF Japan Hotel Investments II S.à r.l.

Marcell Equity S.C.A.

Marlow S.à r.l.

Mauna International S.àr.l.

Micropolis S.à r.l.

Monetics S.A.

MSPE Metro Investors Lux S.à r.l.

Nido Notting Hill S.à r.l.

ODE International Publishers Holding S.à r.l.

Panthera/Funding Lux 1 S. à r.l.

Piwa

Possneck S.à r.l.

Prenzlau S.à r.l.

Pro-Move S.à r.l.

Puzzle Sub S.à r.l.

Quality Electronics Design SA

Quedlinburg S.à r.l.

Rhyton Holding S.A.

Richemont Investments S.A.

Rivoli 144 S.à r.l.

Russian Credit Cards No. 1 S.A.

Siagep S.A.

Sopinor S.à r.l.

Space Finance S.A.

Telco Holding

Toiture Ludwig S.à r.l.

Tulipe International S.A.

UK Holdco 2 S. à r.l.

Wax S.à r.l.

Wax S.à r.l.

Weinheim Estates

Woodford S.à r.l.

Wrei S.A.