logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2099

29 août 2008

SOMMAIRE

ADA Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

100713

Anglo Coal Xiwan Project S.A.  . . . . . . . . . .

100751

Arens Scheer Le Trente S.à r.l. . . . . . . . . . .

100707

A.R.H. Limited S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100712

Asian Car Distribution Company S.A. . . . .

100748

Aspelt Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100711

Aster S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100710

Atel Derivatives S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100716

Camping Um Bierg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

100715

Curzon Capital Partners Holland S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100710

D. Brown & Sons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100749

Derma Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100742

D & P Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100711

EPI Office 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100717

EPI Temple S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100706

Ewaco Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

100706

Fiduciaire Luxembourgeoise Claude Koeu-

ne S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100713

Fifteen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100709

Fitness Lounge S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100714

Geam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100709

GLL AMB Generali Holding Beta S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100749

GLL AMB Generali South Express S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100749

GLL Management Company S.à r.l.  . . . . . .

100714

Globe Total Investments Holdings S.A.  . .

100707

Grabory S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100707

Hervé Le Jardinier S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

100714

Immo Hiereknapp S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

100747

Indiact S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100713

Intensum Group SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100708

KTV S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100708

Lencor Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

100752

Levhold Germany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

100707

Luxcontrol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100749

Lux.Net S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100744

MARENS Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . .

100745

Mar-Plast International S.A. . . . . . . . . . . . . .

100744

Master Tel Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

100744

May Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100743

Meco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100745

Medea Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100743

Melfin B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100708

Menocee Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

100744

Metide International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

100746

Middlesex Office S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100706

Nestor Lux 2007 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100706

Panta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100718

Paris Euro Fashion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100715

Partecipazioni Bingogest S.A.  . . . . . . . . . . .

100712

Peinture Dave Feltus Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

100714

Perseus Immobilien Gesellschaft 11  . . . . .

100737

Perseus Immobilien Gesellschaft 5 . . . . . . .

100732

Perseus Immobilien Gesellschaft 8 . . . . . . .

100727

Perseus Immobilien Gesellschaft 9 . . . . . . .

100721

Prologis European Holdings X S.à r.l.  . . . .

100708

Promotions C. Jans & Associés S.A. . . . . . .

100715

S. à r.l. WUST Construction LUXEM-

BOURG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100713

Seramans S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100719

Seramans S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100720

Townsend Investment I S.à r.l.  . . . . . . . . . .

100716

T.T.V. Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100752

Worldwide Consultancy S.à r.l. . . . . . . . . . .

100746

100705

Ewaco Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 86.863.

Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008100581/751/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01632. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080116338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

Nestor Lux 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 138.461.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008100582/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01636. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080116343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

EPI Temple S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 117.131.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008100591/6902/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03898. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080116222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

Middlesex Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 123.418.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 3 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 343 du 9 mars 2007.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008100708/6773/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01575. - Reçu 48,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080115866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

100706

Grabory S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 1.582.250,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 115.756.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008100550/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT01128. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080115875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

Globe Total Investments Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 78.111.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6/8/08.

Signature.

Référence de publication: 2008100574/1384/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03380. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080115913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

Levhold Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.226.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008100576/6341/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01460. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080115927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

Arens Scheer Le Trente S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 4A, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 41.829.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008100749/3560/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT01024. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080116100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

100707

KTV S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 82.660.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008100549/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT01129. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080115876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

Intensum Group SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 70, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 128.344.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008100689/5770/12.
(080116033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

Prologis European Holdings X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.591.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008100687/7241/11.
(080116012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.

Melfin B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 88.944.

Les gérants de la Société ont décidé en date du 07 juillet 2008 de transférer le principal établissement de la Société

du

66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
au
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
avec effet au 15 juillet 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

H.J.J. Moors / V.M.H. Oderkerk-Lambers
<i>Gérant / Gérante

Référence de publication: 2008102033/1012/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02424. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

100708

Fifteen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 100.817.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 22 juillet

2008, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer, effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle 5, rue CM. Spoo,

L-2546 Luxembourg au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées, avec effet immédiat, par les Administrateurs et décide

de nommer en remplacement:

- Monsieur Davide MURARI, employé privé, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur et Président du

Conseil d'Administration;

- Monsieur Mirko LA ROCCA, employé privé, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Fabrizio PENSO, employé privé, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat ainsi conféré des nouveaux Administrateurs et du Président du Conseil d'Administration prendra fin lors

de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011.

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée, avec effet immédiat, par la société FIDUCIAIRE MEVEA

S.à r.l., en qualité de Commissaire et décide de nommer en remplacement Madame Francesca DOCCHIO, employée
privée, 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

Le mandat ainsi conféré du nouveau Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Davide MURARI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008102034/1494/31.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02292. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Geam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.422.

[I résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 22 juillet

2008, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer, effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle 5, rue CM. Spoo,

L-2546 Luxembourg au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées, avec effet immédiat, par les Administrateurs et décide

de nommer en remplacement:

- Monsieur Davide MURARI, employé privé, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur et Président du

Conseil d'Administration;

- Monsieur Mirko LA ROCCA, employé privé, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Fabrizio PENSO, employé privé, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat ainsi conféré des nouveaux Administrateurs et du Président du Conseil d'Administration prendra fin lors

de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011.

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée, avec effet immédiat, par la société FIDUCIAIRE MEVEA

S.à r.l., en qualité de Commissaire et décide de nommer en remplacement Madame Francesca DOCCHIO, employée
privée, 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

Le mandat ainsi conféré du nouveau Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100709

Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Davide MURARI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008102035/1494/31.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02295. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Aster S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 65.569.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 7 juillet

2008, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer, effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle 5, rue CM. Spoo

L-2546 Luxembourg au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée prend acte du changement d'adresse professionnelle de Monsieur Mirko LA ROCCA, Administrateur de

la société, du 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, à partir du 26
octobre 2007.

L'Assemblée prend acte du changement d'adresse professionnelle de Monsieur Davide MURARI, Administrateur de

la société, du 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, à partir du 2
février 2008.

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée, avec effet immédiat, par FIDUCIAIRE MEVEA S.à r.l. de sa

fonction de Commissaire et décide de nommer en remplacement Madame Francesca DOCCHIO, employée privée, 18,
avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire ainsi conféré prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Davide MURARI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008102036/1494/29.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02301. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Curzon Capital Partners Holland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.968.

EXTRAIT

Par résolutions du conseil de gérance du 11 juillet 2008 la Société a décidé de transférer son siège social du 5, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Ainsi fait à Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008102031/6902/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02429. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

100710

Aspelt Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 89.294.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2008

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 juin 2008, que:
1. L'assemblée a pris acte des démissions des sociétés FIDUGROUP HOLDING S.A.H., FIDUFRANCE GIBRALTAR

LTD et CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD de leurs mandats d'administrateurs, avec effet immédiat,
et de la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., de son mandat de Président du Conseil d'Administration,
avec effet immédiat.

2. L'assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars

1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 34A, boulevard Grande Duchesse Charlotte comme administra-
teur de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

3. L'assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Edouard Georges, employé privé, né le 10 février

1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
comme administrateur de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

4. L'assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Madame Patricia Henry, expert-comptable, née le 25 mars

1963 à Pétange, demeurant professionnellement à 34A, boulevard Grande Duchesse Charlotte, comme administrateur
de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

5. L'assemblée a pris acte de la démission de la société Fidi Audit Limited de son mandat de commissaire. Elle a décidé

de nommer Mademoiselle Anne-Marie Pratiffi, née le 17 avril 1971 à Mont Saint Martin, demeurant professionnellement
à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions de commissaire, jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2009.

6. L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la Société de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, à

L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

7. L'assemblée a élu Monsieur François Georges, pré-qualifié, en qualité de Président du Conseil d'administration.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 2 juillet 2008.

<i>ASPELT INVESTMENT S.A.
François Georges / Edouard Georges
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008102027/5710/37.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT02910. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

D &amp; P Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 114.154.

Par décision collective ordinaire en date du 12 juin 2008:
Le siège de la société est transféré du L-1661 Luxembourg, 65, Grand-rue, au L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon 1 

er

 .

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour D &amp; P Luxembourg
Interfiduciaire S.A.
Signature

Référence de publication: 2008102023/1261/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS06842. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

100711

Partecipazioni Bingogest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 109.834.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 mai 2008

L'assemblée décide de fixer le nouveau siège social de la Société au 38, avenue de la Faïencerie - L-1510 Luxembourg,

et ce avec effet au 10 mars 2008.

L'assemblée prend acte de la démission de M. Antonio PORSIA de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.
L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs comme suit:
- M. Roberto DE LUCA, né le 13/04/1973 à Luxembourg demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie,

L-1510 Luxembourg;

- Mme Valérie WESQUY, née le 06/03/1968 à Mont Saint Martin (France) demeurant professionnellement 3, rue Belle

Vue, L-1227 Luxembourg;

- Mme Annalisa CIAMPOLI, née le 01/07/1974 à Ortona (Italie) demeurant professionnellement 40, avenue de la

Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2009.
L'assemblée décide de nommer, pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se

tiendra en 2009, le commissaire aux comptes suivant:

<i>Commissaire aux comptes:

"GLOBAL TRUST ADVISORS S.A.", 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, RCS Luxembourg B 68.731
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PARTECIPAZIONI BINGOGEST S.A., Société Anonyme
GLOBAL TRUST ADVISORS S.A.
Signature

Référence de publication: 2008102030/5878/29.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2008, réf. LSO-CS09020. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

A.R.H. Limited S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 16.080.

<i>Extrait des résolutions prises

<i>par l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société en date du 24 juin 2008

M. Hans Arend Haije avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1225 Luxembourg est élu en tant qu'ad-

ministrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

M. Arjan Vishan Kirthi Singha, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1225 Luxembourg est élu en tant

qu'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

Melle Cristina Capacchietti, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1225 Luxembourg est élue en tant

que commissaire de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

M. Arjan Vishan Kirthi Singha, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a démissionné

de son mandat de commissaire de la société avec effet à partir du 24 juin 2008.

Deloitte S.A. sont réélus en tant que réviseurs d'entreprise de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra

en l'année 2009.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008102003/1115/25.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02516. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080118006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

100712

Indiact S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 98.903.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 29 juillet 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître Jean SECKLER, notaire
Par délégation Monique GOERES

Référence de publication: 2008102196/231/14.
(080118024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

ADA Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4385 Ehlerange, Z.A.R.E. Est.

R.C.S. Luxembourg B 103.438.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 août 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître Jean SECKLER, notaire
Par délégation Monique GOERES

Référence de publication: 2008102197/231/14.
(080117870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Fiduciaire Luxembourgeoise Claude Koeune S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 73.920.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08/08/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008102198/619/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT02866. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

S. à r.l. WUST Construction LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 1, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 87.411.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 août 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître Jean SECKLER, notaire
Par délégation Monique GOERES

Référence de publication: 2008102200/231/14.
(080117701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

100713

Peinture Dave Feltus Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 14, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.641.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008102220/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 5 août 2008, réf. DSO-CT00029. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080117541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Hervé Le Jardinier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 60, rue Laduno.

R.C.S. Luxembourg B 116.087.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008102219/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 5 août 2008, réf. DSO-CT00030. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080117543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Fitness Lounge S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9156 Heiderscheid, 4, Fuussekaul.

R.C.S. Luxembourg B 121.007.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008102218/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 5 août 2008, réf. DSO-CT00036. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080117545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

GLL Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender, "Le Dôme" Mezzanine B.

R.C.S. Luxembourg B 116.672.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 6 août 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008102202/239/12.
(080117446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

100714

Promotions C. Jans &amp; Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R.C.S. Luxembourg B 95.173.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société,

<i>extraordinairement en date du 27 juin 2008 à 08.30 heures

L'assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats de l'administrateur-délégué et des administrateurs à

savoir:

Monsieur Claude JANS, administrateur et administrateur-délégué, né à Wiltz (L) le 23.08.1956, demeurant à L-9651

Eschwailer, 4, rue Tom

Monsieur Edmond MEIERS, administrateur, né à Wahl (L) le 07.03.1937, demeurant à L-8838 Wahl, 38, rue Principale
Monsieur Erwin HEINERTZ, administrateur, né à Saint Vith (B) le 18.07.1956, demeurant à B-4791 Burg-Reuland, 45B,

Grüfflingen

Leurs mandats se termineront à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2014.
Le mandat du commissaire aux comptes la Société de Révision Charles ENSCH est remplacé par la société EWA

REVISION S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.937, avec siège à
L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

Ce mandat se terminera également à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2008102230/832/26.
Enregistré à Diekirch, le 5 août 2008, réf. DSO-CT00033. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080117552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Camping Um Bierg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6310 Beaufort, 110, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 104.038.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008102222/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 5 août 2008, réf. DSO-CT00027. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080117535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

P.E.F. S.A., Paris Euro Fashion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, 66B, route de Lullange.

R.C.S. Luxembourg B 70.955.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 août 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître Jean SECKLER, notaire
Par délégation Monique GOERES

Référence de publication: 2008102199/231/14.
(080117914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

100715

Atel Derivatives S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 730.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 136.145.

<i>Liste de signatures - approuvée par le conseil de gérance en date du 9 juillet 2008

La Société sera liée en toutes circonstances, la gestion journalière de la Société incluse, par les signatures conjointes

de deux signataires de Groupe A.

En outre, pour les actions suivantes:
- signature de contrats généraux et transactions singulières;
- signature de documentations bancaires;
la Société sera liée par les signatures conjointes d'un signataire de Groupe A et d'un signataire de Groupe B ou de

deux signataires de Groupe B.

<i>Groupe A

Gérants et personnes en charge de la gestion journalière
- M. Marcel Gutknecht, Head Business Support, né en Suisse le 14 janvier 1964, demeurant à 69, rue de Merl, L-2146

Luxembourg;

- M. Christoph Graf, gérant, né en Suisse le 25 décembre 1980, demeurant à 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
- M. Carolus, Gerardus, Maria Hendriks, gérant, né à Ottersum le 23 septembre 1954, demeurant à 31, rue de Stras-

bourg, L-2561 Luxembourg.

<i>Groupe B

Signataires autorisés
- M. Peter Schib, avocat, né le 18 février 1961 en Suisse demeurant à Burghaldeweg 11, CH-5024 Küttigen;
- Dr. Jürgen Bittner, MBA, né le 3 février 1961 en Allemagne, demeurant à Langsamstig, D-15600 Lenzburg;
- M. Pascal Kiefer, Cost Manager, né le 16 mars 1984 en Suisse, demeurant à Krummackerweg 16, 4600 CH-Olten.

Atel Derivatives S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008102224/250/32.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT03585. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Townsend Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 117.720.

<i>Cession de parts sociales

En vertu d'un acte de cession sous seing privé en date du 29 juillet 2008, l'associé unique, la société AELSION IN-

VESTISSEMENTS S.A., a cédé la totalité des parts sociales de la société, soit 125 parts sociales, à Monsieur Leonardo
TRIULZI, né le 13 avril 1944 à Rome, Italie, demeurant à I-00154 Rome, Via Girolamo Dandini n 

o

 2.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 juillet 2008

En date du 29 juillet 2008, l'associé unique a:
- pris acte de la démission de Monsieur Francesco ZITO de son poste de gérant;
- décidé de nommer en son remplacement Monsieur Leonardo TRIULZI, né le 13 avril 1944 à Rome, Italie, demeurant

à I-00154 Rome, Via Girolamo Dandini n 

o

 2.

Le nouveau gérant est nommé pour une durée illimitée et a pouvoir de signature individuelle pour engager la société.

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.
24, rue des Genêts, L-1621 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008102373/1429/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04112. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080118719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

100716

EPI Office 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.958.

DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the eleventh of July.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, "EPI Orange Holdings S.à r.l." a company incorporated under the laws of

Luxembourg having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, represented by Mrs. Sonia Almeida,
residing in Luxembourg, duly authorised to act on behalf of EPI Orange Holdings S.à.r.l by virtue of a proxy given under
private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société à responsabilité limitée "EPI Office 3 S.à.r.l", having its head office at L-2520 Luxembourg, 5, allée

Scheffer, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 121.958, has been
incorporated by deed enacted on November 20, 2006, published in the Mémorial C number 24 of the January 22, 2007.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée "EPI Office 3 S.à.r.l." amounts currently to

EUR 12 500, represented by 500 shares having a par value of 25 each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "EPI

Office 3 S.à.r.l".

IV.- That the mandator owns all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly

to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator takes over, as liquidator, the wiping out of the known or unknown liabilities and commitments

of the company, which must be terminated before any appropriation whatsoever of the assets to its own person as sole
shareholder.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the managers for their mandate up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the

English text will prevail:

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte

anglais fait foi:

L'an deux mille huit, le onze juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

L'associé unique de la société, "EPI Orange Holdings S.à.r.l", une société constituée sous le droit luxembourgeois, ayant

son siège social 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, représentée par Madame Sonia Almeida, résidant au Luxembourg,
dûment autorisée à agir en faveur de EPI Orange Holdings S.à.r.l.

En vertu d'une procuration sous seing privé délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "EPI Office 3 S.à.r.l", ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée

Scheffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 121.958, a été
constituée suivant acte reçu le 20 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 24 du 22 janvier 2007.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "EPI Office 3 S.à.r.l", prédésignée, s'élève actuellement à

EUR 12 500, représentés par 500 actions de 25 chacune, chacune intégralement libérée.

100717

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

"EPI Office 3 S.à.r.l".

IV.- Que son mandant est propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique

il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge la liquidation du passif et les engagements financiers,

connus ou inconnus, de la société, qui devra être terminée avant toute appropriation de quelque manière que ce soit des
actifs de la société en tant qu'actionnaire unique.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. ALMEIDA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2008. Relation LAC/2008/29172. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008102369/211/77.
(080118124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Panta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 65.871.

L'an deux mille huit, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PANTA S.A., avec siège social à L-2522 Lu-

xembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S Luxembourg section B numéro 65.871, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 14 août 1998, publié au Mémorial C numéro 783 du 28 octobre 1998, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu sous seing privé en date du 28 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 272 du
18 février 2002,

ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Annick GUT, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé

privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées. Le président expose
et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

100718

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée désigne la société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C, Las Vegas,

NV 89101 (U.S.A.), Nevada Corporation Number E0048502007-7, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la

loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette auto-
risation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société à savoir Messieurs Giovanni GAM-

BARDELLA, Bruno BEERNAERTS et Patrick MOINET et au commissaire de la société à savoir B.F. CONSULTING S.à
r.l., pour l'exécution de leur mandat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille quatre cent soixante-quinze euros, sont à la

charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GUT - THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 juillet 2008. Relation GRE/2008/3083. — Douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 1 

er

 août 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008102371/231/64.
(080118676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Seramans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 66.756.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation «SERAMANS S.A.», ayant

son siège social à L-2546 Luxembourg, 5, rue CM. Spoo, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux
de résidence à Luxembourg en date du 14 octobre 1998, publié au Mémorial C de 1998, page 44678. Les statuts de la
société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire soussigné en date du 29 mai 2008 à, non
encore publié au Mémorial C et à la suite duquel la société a été mise en liquidation volontaire (la «Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Giorgina TUCCI, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté,

Qui désigne à la fonction de secrétaire Madame Raffaella PONTICELLI, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

100719

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société;

3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
4. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés pour un période de 5 ans;

5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Rapport du commissaire-vérificateur

L'assemblée générale a pris connaissance du rapport de BIND CO. LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Iles

Vierges Britanniques, P.O. Box 3175, en sa qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir effectué la lecture.

Ce rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

<i>Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes

L'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice

de leurs mandats.

<i>Décharge au Liquidateur et au commissaire-vérificateur

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction à MORWELL LIMITED, avec siège social au P.O. BOX 3175, Road Town, Tortola, Iles
Vierges Britanniques, IBC numéro 350391, de sa gestion de liquidation de la société et à BIND CO. LIMITED, précitée,
pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

<i>Désignation de l'endroit où les livres et documents comptables seront déposés

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à l'ancien siège de la société.

<i>Clôture de la liquidation

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme «SERAMANS S.A.» a définitive-

ment cessé d'exister.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance n'est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Giorgina Tucci, Raffaella Ponticelli, Salvatore Desiderio, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 5 juin 2008. LAC/2008/22765. — Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 6 août 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008102372/202/67.
(080118140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Seramans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 66.756.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

100720

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SERAMANS S.A..», ayant son siège social

à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux de résidence
à Luxembourg en date du 14 octobre 1998, publié au Mémorial C de 1998, page 44678. Les statuts de la société ont été
modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire Jacques Delvaux du 20 novembre 2001 publié au Mémorial
C du 28 mars 2002 numéro 494 («Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur par Madame Giorgina Tucci, employée privée demeurant professionnellement

à L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur MORWELL LIMITED, avec siège social au P.O. BOX 3175, Road

Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, IBC numéro 350391.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 15 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir
recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Jean-Michel Merienne, Giorgina Tucci, Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 5 juin 2008, LAC/2008/22764. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 31 juillet 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008102374/202/55.
(080118138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Perseus Immobilien Gesellschaft 9, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.806.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second of July.
Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

100721

APPEARED:

The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 127.199,

here duly represented by two of its managers, namely:
- one Category A manager: Mr. Nico HANSEN, private employee, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57,

avenue Pasteur, and

- one Category B manager: Mr. Christophe CAHUZAC, private employee, professionally residing in L-1661 Luxem-

bourg, Grand-Rue, 9-11.

The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual

shareholder of the private limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 9", (hereafter the "Company"),
with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of
Luxembourg,  section  B,  under the  number  132,806, incorporated pursuant to a deed  of  the  undersigned  notary  on
October 11th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2679 of the 22nd of
November 2007,

and whose articles of association have been restated pursuant to a deed of the notary Paul FRIEDERS, residing in

Luxembourg, on the 20th of March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 949
of the 17th of April 2008,

and that it takes, through its representatives, the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to amend article 11 of the articles of association to read as follows:
Art. 11. The company is managed by a board of managers (the „Board of Managers") appointed as a collegiate body

by the general meeting of the Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The general meeting of
the Shareholders determines the powers and term of the mandates of the Managers. If no term is indicated the Managers
are appointed for an undetermined period. The Managers may be revoked by the general meeting of the Shareholders
with or without cause (ad nutum) at any time.

The Board of Managers shall always be composed of six (6) Managers, each of whom does not reside in Germany,

three of which shall be Category A Managers (the "Category A Manager") and the other three shall be Category B
Managers (the "Category B Manager"), whether shareholders or not, who are appointed by the sole shareholder or, as
the case may be, by the general meeting of the shareholders.

If the post of a manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining managers thus elected, may

provisionally fill the vacancy by applying the same rules as the ones described above.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election."

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of association to read as follows:
Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to attend a meeting, he will be replaced by one of the Managers present at the meeting

designated to that effect by the board.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
Meetings of the Board of Managers are Collective and may only validly take resolutions if an equal number of Category

A Managers and Category B Managers are present or represented; proxies between managers being permitted, with the
restriction that a manager can only represent one of his colleagues.

Each Manager shall have one vote on all matters brought before the Board of Managers. The chairman will not have

any casting vote.

Resolutions of the Board of Managers may only validly be taken through the affirmative vote of a majority of the

Managers present or represented at a duly constituted meeting at which a quorum is present provided that, such majority
must include the affirmative vote of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

The Board of Managers shall meet not less frequently than quarterly, upon not less than fifteen (15) calendar days prior

written notice (unless such prior written notice requirement is otherwise waived in writing by at least one (1) Class A
Manager and one (1) Class B Manager duly given to all Managers (provided that actions not specifically referred to in any
agenda accompanying a notice may not be taken up at the relevant meeting).

At least one (1) meeting of the Board of Managers must be held during each quarter of each Fiscal Year at the Company's

offices in Luxembourg.

Meetings of the Board of Managers may be held at the Company's registered office in Luxembourg or by conference

call, video conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the Managers attending the meeting
can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of
the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Participation in a meeting

100722

by such means shall constitute presence in person at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the
resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or Email confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the Man-

agers' meetings.

No Manager shall be entitled to any compensation or consideration for services rendered in its capacity as a Manager.
Any action or decision required or permitted to be taken at any meeting of the Board of Managers may be taken

without a meeting if (i) all of the Managers consent to such action or decision in writing, and (ii) the writing or writings
are filed with the records of the company."

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to amend article 13 of the articles of association to read as follows:
Art. 13. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition

in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August

10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the board of managers."

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 14 of the articles of association to read as follows:
Art. 14. The company will be validly bound by the joint signature of any two Managers being one (1) Class A Manager

and one (1) Class B Manager."

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to amend article 16 of the articles of association to read as follows:
Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

The Board of Managers may further appoint such officers and/or other Company representatives as the Board of

Managers shall deem necessary or advisable. Each officer shall hold office until his resignation or removal. The Board of
Managers may elect to remove any officer with our without cause at any time.

The Board of Managers shall have the power to set up one or more committees (including an executive committee)

to which the authority to make certain decisions may be delegated by the Board of Managers. No member of a committee
may be removed without the approval of the Board of Managers."

<i>Sixth resolution

The sole shareholder decides to amend article 20 of the articles of association to read as follows:
Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes of shareholders representing more than

half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the share-

holders representing seventy five percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the

articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in

written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions."

<i>Seventh resolution

The sole shareholder decides to appoint for an undetermined duration:
1) as Category A Managers
a) Mr. Nico HANSEN, private employee, born in Differdange, (Grand Duchy of Luxembourg), on the 31st of March

1969, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Mrs. Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on the 22nd of January 1963, professionally residing

in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Mr. Patrick TEROERDE, private employee, born on the 12th of July 1974 in Dusseldorf (Germany), residing at flat

2, 32 Evelyn Gardens, South Kensington, London SW73BJ, United Kingdom

2) as Category B Managers
a) Mr. Paul OBEY, private employee, born on March 5, 1966 in Bexley (United Kingdom) professionally residing Pe-

terborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, (England),

100723

b) Mr. Philipp BRASCHEL, private employee born on May 18, 1975 in Stuttgart (Germany) professionally residing in

London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England), and

c) Mr. Christophe CAHUZAC, private employee, born on October 26, 1972 in Saint Mard (Belgium) professionally

residing in L-1661 Luxemburg, Grand Rue, 9-11.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred
Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their first and last name, civil

status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Lu-

xemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 127.199,

hier rechtmäßig vertreten durch zwei ihrer Geschäftsführer, namentlich:
- ein Kategorie A Gesellschaftsführer: Herr Nico HANSEN, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg,

55-57, avenue Pasteur, und

- ein Kategorie B Gesellschaftsführer: Herr Christophe CAHUZAC, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-1661 Lu-

xemburg, Grand-Rue, 9-11.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,

dass sie die einzige aktuelle Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-
SELLSCHAFT 9", (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 132.806, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 2679 vom 22. November 2007,

und deren Statuten neu gefasst wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul FRIEDERS, mit Amtwohnsitz

in Luxemburg am 20. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 949 vom
17. April 2008,

und dass sie, durch ihre Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 11 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand (der Vorstand) geführt, der als Kollegialgremium von der Ge-

sellschafter-Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den nachstehend beschriebenen Bedingungen bestellt wird. Die
Gesellschafter-Hauptversammlung legt die Befugnisse und die Mandatsdauer der Geschäftsführer fest. Wird keine Man-
datsdauer festgelegt, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können von der
Gesellschafterhauptversammlung mit oder ohne Angabe von Gründen („ad nutum") jederzeit abberufen werden.

Der Vorstand besteht aus sechs (6) Geschäftsführern, die alle nicht in Deutschland ansässig sind; davon drei (3) Ka-

tegorie  A  Geschäftsführern,  (die  „Kategorie  A-Geschäftsführer)"  und  drei  (3)  Kategorie  B  Geschäftsführern,  (die
„Kategorie B-Geschäftsführer)" die von der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls von der Gesellschafterhauptver-
sammlung ernannt werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Geschäftsführers frei, können die verbleibenden Ge-

schäftsführer, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung."

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 12. Der Vorstand wählt aus seinen eigenen Reihen einen Vorsitzenden.

100724

Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden wird er durch einen der Geschäftsführer ersetzt, der an der Sitzung teil-

nimmt und hierzu vom Vorstand benannt wird.

Die Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern einberufen.
Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Geschäftsführer, jeweils die gleiche Anzahl von Kategorie

A-Geschäftsführer und Kategorie B-Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Alle Geschäftsführer können sich bei Sitzungen des Vorstands durch jeden anderen Geschäftsführer vertreten lassen,

mit der Beschränkung dass ein Geschäftsführer nur einen anderen Geschäftsführer vertreten kann.

Jeder Geschäftsführer besitzt eine Stimme zu allen Angelegenheiten, mit denen der Vorstand befasst wird. Der Vor-

sitzende besitzt keine ausschlaggebende Stimme.

Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer, die bei einer ordnungsgemäß einberu-

fenen und beschlussfähigen Sitzung anwesend oder vertreten sind, mit „ja" stimmen, vorausgesetzt, dass diese Mehrheit
ab dem Schlusstermin die Ja-Stimme von mindestens einem (1) Kategorie A-Geschäftsführer und einem (1) Kategorie B-
Geschäftsführer umfaßt.

Der  Vorstand  tritt  mindestens  einmal  vierteljährlich  nach  einer  schriftlichen  Einladung  zusammen,  die  mindestens

fünfzehn (15) Kalendertage vor der Sitzung ergehen muss (es sei denn, auf dieses Erfordernis der schriftlichen Einladung
wird verzichtet, indem mindestens ein (1) Kategorie A-Geschäftsführer und ein (1) Kategorie B-Geschäftsführer dies allen
Geschäftsführern ordnungsgemäß und in Schriftform mitteilen (vorausgesetzt, dass Maßnahmen, die in der zusammen mit
der Einladung verschickten Tagesordnung nicht gesondert aufgeführt sind, auf der entsprechenden Sitzung möglicherweise
nicht erörtert werden).

In jedem Quartal eines jeden Geschäftsjahres muss am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg mindestens eine (1) Vor-

standssitzung stattfinden.

Die Vorstandssitzungen können am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder aber in Form von Konferenzschaltungen,

Videokonferenzen oder mithilfe ähnlicher Kommunikationsmittel stattfinden, wobei (i) die Identität der an der Sitzung
teilnehmenden Geschäftsführer erkennbar ist, (ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen einander hören und mit-
einander sprechen können, (iii) die Sitzung ununterbrochen übertragen wird und (iv) die Geschäftsführer ordnungsgemäß
beraten können. Die Teilnahme an einer Sitzung mithilfe solcher Kommunikationsmittel gilt als persönliche Teilnahme an
der Sitzung.

Sollte ein Beschluss Im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg initiiert wurde.

Die Geschäftsführer können Ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder Email abgeben, welche schriftlich

bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allem Geschäftsführer genehmigt und unterschrieben ist, ist genau so recht-

wirksam wie ein anlässlich einer Vorstandssitzung gefasster Beschluss.

Geschäftsführer haben keinen Anspruch auf Entschädigung oder Entgelt für die in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer

erbrachten Dienste.

Maßnahmen oder Entscheidungen, die auf Vorstandssitzungen erforderlich oder zulässig sind, können auch ohne eine

Sitzung getroffen werden, wenn (i) alle Geschäftsführer einer solchen Maßnahme bzw. Entscheidung schriftlich zustimmen
und (ii) diese Schreiben zu den Akten der Gesellschaft genommen werden."

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 13 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 13. Der Vorstand hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vor-
standes."

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 14 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 14. Die Gesellschaft ist durch die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Geschäftsführern, bei denen es

sich um einen (1) Kategorie A-Geschäftsführer und um einen (1) Kategorie B-Geschäftsführer handelt, rechtsgültig ge-
bunden."

<i>Fünfter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 16 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 16. Der Vorstand kann seine Befugnisse im Hinblick auf die tägliche Führung der Geschäfte ganz oder teilweise

an Geschäftsführer oder an Dritte übertragen, bei denen es sich nicht unbedingt um Gesellschafter handeln muss.

Der Vorstand kann ferner Führungskräfte und/oder andere Vertreter der Gesellschaft bestellen, sofern der Vorstand

dies für notwendig oder ratsam erachtet. Jede Führungskraft bekleidet dieses Amt so lange, bis sie aus dem Amt aus-

100725

scheidet oder abberufen wird, je nachdem, welcher Fall früher eintritt. Der Vorstand kann entscheiden, Führungskräfte
jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen abzuberufen.

Der Vorstand ist befugt, einen oder mehrere Ausschüsse (einschließlich eines geschäftsführenden Ausschusses) ein-

zusetzen und diesen die Befugnis zu erteilen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Kein Mitglied eines solchen Aus-
schusses darf ohne die Zustimmung des Vorstands abberufen werden."

<i>Sechster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 20 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Gesellschafter akzeptiert wurden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein

Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft in einem Protokoll einge-

tragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden."

<i>Siebter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt auf unbestimmte Dauer zu ernennen:
1) als A-Geschäftsführer:
a) Herr Nico HANSEN, Privatangestellter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März 1969,

beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur,

b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in

L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Herr Patrick TEROERDE, Privatangestellter, geboren in Düsseldorf, (Deutschland), am 12. of Juli 1974, wohnhaft

in South Kensington, London SW73BJ flat 2, 32 Evelyn Gardens (England);

2) als B-Geschäftsführer:
a) Herr Paul OBEY, Privatangestellter, geboren am 5. März 1966 in Bexley (England), beruflich wohnhaft Peterborough

Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, U in London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England);

b) Herr Philipp BRASCHEL, Privatangestellter, geboren am 18. Mai 1975 in Stuttgart (Deutschland), beruflich wohnhaft

in London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England);

c) Herr Christophe CAHUZAC, Privatangestellter, geboren am 26. Oktober 1972 in Saint Mard (Belgien), beruflich

wohnhaft in L-1661 Luxemburg, Grand-Rue, 9-11.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert
Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersu-
chen derselben erschienenen Personen, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text,
wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und

Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben erschienenen Personen mit Uns, dem Notar, gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: HANSEN; CAHUZAC; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2008. Relation GRE/2008/3179. - Reçu douze euros 12 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

FÜR GLECHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

Junglinster, den 4. August 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008102383/231/283.
(080118930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

100726

Perseus Immobilien Gesellschaft 8, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.804.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second of July.
Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

APPEARED:

The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 127.199,

here duly represented by two of its managers, namely:
- one Category A manager: Mr. Nico HANSEN, private employee, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57,

avenue Pasteur, and

- one Category B manager: Mr. Christophe CAHUZAC, private employee, professionally residing in L-1661 Luxem-

bourg, Grand-Rue, 9-11.

The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual

shareholder of the private limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 8", (hereafter the "Company"),
with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of
Luxembourg,  section  B,  under the  number 132.804,  incorporated pursuant to a deed  of the  undersigned notary  on
October 11th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2680 of the 22nd of
November 2007,

and whose articles of association have been restated pursuant to a deed of the notary Paul FRIEDERS, residing in

Luxembourg, on the 20th of March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 959
of the 18th of April 2008,

and that it takes, through its representatives, the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to amend article 11 of the articles of association to read as follows:
Art. 11. The company is managed by a board of managers (the „Board of Managers") appointed as a collegiate body

by the general meeting of the Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The general meeting of
the Shareholders determines the powers and term of the mandates of the Managers. If no term is indicated the Managers
are appointed for an undetermined period. The Managers may be revoked by the general meeting of the Shareholders
with or without cause (ad nutum) at any time.

The Board of Managers shall always be composed of six (6) Managers, each of whom does not reside in Germany,

three of which shall be Category A Managers (the "Category A Manager") and the other three shall be Category B
Managers (the "Category B Manager"), whether shareholders or not, who are appointed by the sole shareholder or, as
the case may be, by the general meeting of the shareholders.

If the post of a manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining managers thus elected, may

provisionally fill the vacancy by applying the same rules as the ones described above.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election."

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of association to read as follows:
Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to attend a meeting, he will be replaced by one of the Managers present at the meeting

designated to that effect by the board.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
Meetings of the Board of Managers are Collective and may only validly take resolutions if an equal number of Category

A Managers and Category B Managers are present or represented; proxies between managers being permitted, with the
restriction that a manager can only represent one of his colleagues.

Each Manager shall have one vote on all matters brought before the Board of Managers. The chairman will not have

any casting vote.

Resolutions of the Board of Managers may only validly be taken through the affirmative vote of a majority of the

Managers present or represented at a duly constituted meeting at which a quorum is present provided that, such majority
must include the affirmative vote of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

The Board of Managers shall meet not less frequently than quarterly, upon not less than fifteen (15) calendar days prior

written notice (unless such prior written notice requirement is otherwise waived in writing by at least one (1) Class A

100727

Manager and one (1) Class B Manager duly given to all Managers (provided that actions not specifically referred to in any
agenda accompanying a notice may not be taken up at the relevant meeting).

At least one (1) meeting of the Board of Managers must be held during each quarter of each Fiscal Year at the Company's

offices in Luxembourg.

Meetings of the Board of Managers may be held at the Company's registered office in Luxembourg or by conference

call, video conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the Managers attending the meeting
can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of
the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Participation in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the
resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or Email confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the Man-

agers' meetings.

No Manager shall be entitled to any compensation or consideration for services rendered in its capacity as a Manager.
Any action or decision required or permitted to be taken at any meeting of the Board of Managers may be taken

without a meeting if (i) all of the Managers consent to such action or decision in writing, and (ii) the writing or writings
are filed with the records of the company."

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to amend article 13 of the articles of association to read as follows:
Art. 13. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition

in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August

10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the board of managers."

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 14 of the articles of association to read as follows:
Art. 14. The company will be validly bound by the joint signature of any two Managers being one (1) Class A Manager

and one (1) Class B Manager."

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to amend article 16 of the articles of association to read as follows:
Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

The Board of Managers may further appoint such officers and/or other Company representatives as the Board of

Managers shall deem necessary or advisable. Each officer shall hold office until his resignation or removal. The Board of
Managers may elect to remove any officer with our without cause at any time.

The Board of Managers shall have the power to set up one or more committees (including an executive committee)

to which the authority to make certain decisions may be delegated by the Board of Managers. No member of a committee
may be removed without the approval of the Board of Managers."

<i>Sixth resolution

The sole shareholder decides to amend article 20 of the articles of association to read as follows:
Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes of shareholders representing more than

half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the share-

holders representing seventy five percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the

articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in

written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions."

<i>Seventh resolution

The sole shareholder decides to appoint for an undetermined duration:
1) as Category A Managers

100728

a) Mr. Nico HANSEN, private employee, born in Differdange, (Grand Duchy of Luxembourg), on the 31st of March

1969, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Mrs. Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on the 22nd of January 1963, professionally residing

in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Mr. Patrick TEROERDE, private employee, born on the 12th of July 1974 in Dusseldorf (Germany), residing at flat

2, 32 Evelyn Gardens, South Kensington, London SW73BJ, United Kingdom

2) as Category B Managers
a) Mr. Paul OBEY, private employee, born on March 5, 1966 in Bexley (United Kingdom) professionally residing Pe-

terborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, (England),

b) Mr. Philipp BRASCHEL, private employee born on May 18, 1975 in Stuttgart (Germany) professionally residing in

London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England), and

c) Mr. Christophe CAHUZAC, private employee, born on October 26, 1972 in Saint Mard (Belgium) professionally

residing in L-1661 Luxembourg, Grand-Rue, 9-11.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred
Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their first and last name, civil

status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Lu-

xemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 127.199,

hier rechtmäßig vertreten durch zwei ihrer Geschäftsführer, namentlich:
- ein Kategorie A Gesellschaftsführer: Herr Nico HANSEN, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg,

55-57, avenue Pasteur, und

- ein Kategorie B Gesellschaftsführer: Herr Christophe CAHUZAC, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-1661 Lu-

xemburg, Grand-Rue, 9-11.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,

dass sie die einzige aktuelle Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-
SELLSCHAFT 8", (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 132.804, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 2680 vom 22. November 2007,

und deren Statuten neu gefasst wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul FRIEDERS, mit Amtwohnsitz

in Luxemburg am 20. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 959 vom
18. April 2008,

und dass sie, durch ihre Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 11 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand (der Vorstand) geführt, der als Kollegialgremium von der Ge-

sellschafter-Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den nachstehend beschriebenen Bedingungen bestellt wird. Die
Gesellschafter-Hauptversammlung legt die Befugnisse und die Mandatsdauer der Geschäftsführer fest. Wird keine Man-
datsdauer festgelegt, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können von der
Gesellschafterhauptversammlung mit oder ohne Angabe von Gründen („ad nutum") jederzeit abberufen werden.

Der Vorstand besteht aus sechs (6) Geschäftsführern, die alle nicht in Deutschland ansässig sind; davon drei (3) Ka-

tegorie  A  Geschäftsführern,  (die  „Kategorie  A-Geschäftsführer)"  und  drei  (3)  Kategorie  B  Geschäftsführern,  (die

100729

„Kategorie B-Geschäftsführer)" die von der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls von der Gesellschafterhauptver-
sammlung ernannt werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Geschäftsführers frei, können die verbleibenden Ge-

schäftsführer, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung."

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 12. Der Vorstand wählt aus seinen eigenen Reihen einen Vorsitzenden.
Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden wird er durch einen der Geschäftsführer ersetzt, der an der Sitzung teil-

nimmt und hierzu vom Vorstand benannt wird.

Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern einberufen.
Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Geschäftsführer, jeweils die gleiche Anzahl von Kategorie

A-Geschäftsführer und Kategorie B-Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Alle Geschäftsführer können sich bei Sitzungen des Vorstandes durch jeden anderen Geschäftsführer vertreten lassen,

mit der Beschränkung dass ein Geschäftsführer nur einen anderen Geschäftsführer vertreten kann.

Jeder Geschäftsführer besitzt eine Stimme zu allen Angelegenheiten, mit denen der Vorstand befasst wird. Der Vor-

sitzende besitzt keine ausschlaggebende Stimme.

Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer, die bei einer ordnungsgemäß einberu-

fenen und beschlussfähigen Sitzung anwesend oder vertreten sind, mit „ja" stimmen, vorausgesetzt, dass diese Mehrheit
ab dem Schlusstermin die Ja-Stimme von mindestens einem (1) Kategorie A-Geschäftsführer und einem (1) Kategorie B-
Geschäftsführer umfaßt.

Der  Vorstand  tritt  mindestens  einmal  vierteljährlich  nach  einer  schriftlichen  Einladung  zusammen,  die  mindestens

fünfzehn (15) Kalendertage vor der Sitzung ergehen muss (es sei denn, auf dieses Erfordernis der schriftlichen Einladung
wird verzichtet, indem mindestens ein (1) Kategorie A-Geschäftsführer und ein (1) Kategorie B-Geschäftsführer dies allen
Geschäftsführern ordnungsgemäß und in Schriftform mitteilen (vorausgesetzt, dass Maßnahmen, die in der zusammen mit
der Einladung verschickten Tagesordnung nicht gesondert aufgeführt sind, auf der entsprechenden Sitzung möglicherweise
nicht erörtert werden).

In jedem Quartal eines jeden Geschäftsjahres muss am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg mindestens eine (1) Vor-

standssitzung stattfinden.

Die Vorstandssitzungen können am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder aber in Form von Konferenzschaltungen,

Videokonferenzen oder mithilfe ähnlicher Kommunikationsmittel stattfinden, wobei (i) die Identität der an der Sitzung
teilnehmenden Geschäftsführer erkennbar ist, (ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen einander hören und mit-
einander sprechen können, (iii) die Sitzung ununterbrochen übertragen wird und (iv) die Geschäftsführer ordnungsgemäß
beraten können. Die Teilnahme an einer Sitzung mithilfe solcher Kommunikationsmittel gilt als persönliche Teilnahme an
der Sitzung.

Sollte ein Beschluss Im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg initiiert wurde.

Die Geschäftsführer können Ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder Email abgeben, welche schriftlich

bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allem Geschäftsführer genehmigt und unterschrieben ist, ist genau so recht-

wirksam wie ein anlässlich einer Vorstandssitzung gefasster Beschluss.

Geschäftsführer haben keinen Anspruch auf Entschädigung oder Entgelt für die in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer

erbrachten Dienste.

Maßnahmen oder Entscheidungen, die auf Vorstandssitzungen erforderlich oder zulässig sind, können auch ohne eine

Sitzung getroffen werden, wenn (i) alle Geschäftsführer einer solchen Maßnahme bzw. Entscheidung schriftlich zustimmen
und (ii) diese Schreiben zu den Akten der Gesellschaft genommen werden."

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 13 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 13. Der Vorstand hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vor-
standes."

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 14 der Satzung wie folgt abzuändern:

100730

Art. 14. Die Gesellschaft ist durch die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Geschäftsführern, bei denen es

sich um einen (1) Kategorie A-Geschäftsführer und um einen (1) Kategorie B-Geschäftsführer handelt, rechtsgültig ge-
bunden."

<i>Fünfter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 16 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 16. Der Vorstand kann seine Befugnisse im Hinblick auf die tägliche Führung der Geschäfte ganz oder teilweise

an Geschäftsführer oder an Dritte übertragen, bei denen es sich nicht unbedingt um Gesellschafter handeln muss.

Der Vorstand kann ferner Führungskräfte und/oder andere Vertreter der Gesellschaft bestellen, sofern der Vorstand

dies für notwendig oder ratsam erachtet. Jede Führungskraft bekleidet dieses Amt so lange, bis sie aus dem Amt aus-
scheidet oder abberufen wird, je nachdem, welcher Fall früher eintritt. Der Vorstand kann entscheiden, Führungskräfte
jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen abzuberufen.

Der Vorstand ist befugt, einen oder mehrere Ausschüsse (einschließlich eines geschäftsführenden Ausschusses) ein-

zusetzen und diesen die Befugnis zu erteilen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Kein Mitglied eines solchen Aus-
schusses darf ohne die Zustimmung des Vorstandes abberufen werden."

<i>Sechster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 20 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Gesellschafter akzeptiert wurden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein

Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft in einem Protokoll einge-

tragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden."

<i>Siebter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt auf unbestimmte Dauer zu ernennen:
1) als A-Geschäftsführer:
a) Herr Nico HANSEN, Privatangestellter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März 1969,

beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur,

b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in

L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Herr Patrick TEROERDE, Privatangestellter, geboren in Düsseldorf, (Deutschland), am 12. of Juli 1974, wohnhaft

in South Kensington, London SW73BJ flat 2, 32 Evelyn Gardens (England);

2) als B-Geschäftsführer:
a) Herr Paul OBEY, Privatangestellter, geboren am 5. März 1966 in Bexley (England), beruflich wohnhaft Peterborough

Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, U in London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England);

b) Herr Philipp BRASCHEL, Privatangestellter, geboren am 18. Mai 1975 in Stuttgart (Deutschland), beruflich wohnhaft

in London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England);

c) Herr Christophe CAHUZAC, Privatangestellter, geboren am 26. Oktober 1972 in Saint Mard (Belgien), beruflich

wohnhaft in L-1661 Luxemburg, Grand-Rue, 9-11.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert
Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersu-
chen derselben erschienenen Personen, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text,
wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und

Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben erschienenen Personen mit Uns, dem Notar, gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

100731

Gezeichnet: HANSEN; CAHUZAC; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2008. Relation GRE/2008/3178. - Reçu douze euros 12 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

FÜR GLECHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

Junglinster, den 4. August 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008102385/231/283.
(080118946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Perseus Immobilien Gesellschaft 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.802.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second of July.
Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

APPEARED:

The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 127,199,

here duly represented by two of its managers, namely:
- one Category A manager: Mr. Nico HANSEN, private employee, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57,

avenue Pasteur, and

- one Category B manager: Mr. Christophe CAHUZAC, private employee, professionally residing in L-1661 Luxemburg,

Grand-Rue, 9-11.

The appearing party, represented as said before, declares and J requests the notary to act that it is the sole actual

shareholder of the private limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 5", (hereafter the "Company"),
with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of
Luxembourg,  section  B,  under the  number 132,802,  incorporated pursuant to a deed  of the  undersigned notary  on
October 11th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2683 of the 22nd of
November 2007,

and whose articles of association have been restated pursuant to a deed of the notary Paul FRIEDERS, residing in

Luxembourg, on the 20th of March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 981
of the 21st of April 2008,

and that it takes, through its representatives, the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to amend article 11 of the articles of association to read as follows:
Art. 11. The company is managed by a board of managers (the „Board of Managers") appointed as a collegiate body

by the general meeting of the Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The general meeting of
the Shareholders determines the powers and term of the mandates of the Managers. If no term is indicated the Managers
are appointed for an undetermined period. The Managers may be revoked by the general meeting of the Shareholders
with or without cause (ad nutum) at any time.

The Board of Managers shall always be composed of six (6) Managers, each of whom does not reside in Germany,

three of which shall be Category A Managers (the "Category A Manager") and the other three shall be Category B
Managers (the "Category B Manager"), whether shareholders or not, who are appointed by the sole shareholder or, as
the case may be, by the general meeting of the shareholders.

If the post of a manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining managers thus elected, may

provisionally fill the vacancy by applying the same rules as the ones described above.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election."

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of association to read as follows:
Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to attend a meeting, he will be replaced by one of the Managers present at the meeting

designated to that effect by the board.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.

100732

Meetings of the Board of Managers are Collective and may only validly take resolutions if an equal number of Category

A Managers and Category B Managers are present or represented; proxies between managers being permitted, with the
restriction that a manager can only represent one of his colleagues.

Each Manager shall have one vote on all matters brought before the Board of Managers. The chairman will not have

any casting vote.

Resolutions of the Board of Managers may only validly be taken through the affirmative vote of a majority of the

Managers present or represented at a duly constituted meeting at which a quorum is present provided that, such majority
must include the affirmative vote of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

The Board of Managers shall meet not less frequently than quarterly, upon not less than fifteen (15) calendar days prior

written notice (unless such prior written notice requirement is otherwise waived in writing by at least one (1) Class A
Manager and one (1) Class B Manager duly given to all Managers (provided that actions not specifically referred to in any
agenda accompanying a notice may not be taken up at the relevant meeting).

At least one (1) meeting of the Board of Managers must be held during each quarter of each Fiscal Year at the Company's

offices in Luxembourg.

Meetings of the Board of Managers may be held at the Company's registered office in Luxembourg or by conference

call, video conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the Managers attending the meeting
can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of
the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Participation in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the
resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or Email confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the Ma-

nagers' meetings.

No Manager shall be entitled to any compensation or consideration for services rendered in its capacity as a Manager.
Any action or decision required or permitted to be taken at any meeting of the Board of Managers may be taken

without a meeting if (i) all of the Managers consent to such action or decision in writing, and (ii) the writing or writings
are filed with the records of the company."

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to amend article 13 of the articles of association to read as follows:
Art. 13. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition

in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August

10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the board of managers."

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 14 of the articles of association to read as follows:
Art. 14. The company will be validly bound by the joint signature of any two Managers being one (1) Class A Manager

and one (1) Class B Manager."

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to amend article 16 of the articles of association to read as follows:
Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

The Board of Managers may further appoint such officers and/or other Company representatives as the Board of

Managers shall deem necessary or advisable. Each officer shall hold office until his resignation or removal. The Board of
Managers may elect to remove any officer with our without cause at any time.

The Board of Managers shall have the power to set up one or more committees (including an executive committee)

to which the authority to make certain decisions may be delegated by the Board of Managers. No member of a committee
may be removed without the approval of the Board of Managers."

<i>Sixth resolution

The sole shareholder decides to amend article 20 of the articles of association to read as follows:
Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes of shareholders representing more than

half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the share-

holders representing seventy five percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the

articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.

100733

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in

written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions."

<i>Seventh resolution

The sole shareholder decides to appoint for an undetermined duration:
1) as Category A Managers
a) Mr. Nico HANSEN, private employee, born in Differdange, (Grand Duchy of Luxembourg), on the 31st of March

1969, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Mrs. Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on the 22nd of January 1963, professionally residing

in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Mr. Patrick TEROERDE, private employee, born on the 12th of July 1974 in Dusseldorf (Germany), residing at flat

2, 32 Evelyn Gardens, South Kensington, London SW73BJ, United Kingdom

2) as Category B Managers
a) Mr. Paul OBEY, private employee, born on March 5, 1966 in Bexley (United Kingdom) professionally residing Pe-

terborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, (England),

b) Mr. Philipp BRASCHEL, private employee born on May 18, 1975 in Stuttgart (Germany) professionally residing in

London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England), and

c) Mr. Christophe CAHUZAC, private employee, born on October 26, 1972 in Saint Mard (Belgium) professionally

residing in L-1661 Luxembourg, Grand-Rue, 9-11.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred
Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their first and last name, civil

status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Lu-

xemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 127.199,

hier rechtmäßig vertreten durch zwei ihrer Geschäftsführer, namentlich:
- ein Kategorie A Gesellschaftsführer: Herr Nico HANSEN, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg,

55-57, avenue Pasteur, und

- ein Kategorie B Gesellschaftsführer: Herr Christophe CAHUZAC, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-1661 Lu-

xemburg, Grand-Rue, 9-11.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,

dass sie die einzige aktuelle Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-
SELLSCHAFT 5", (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 132.802, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 2683 vom 22. November 2007,

und deren Statuten neu gefasst wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul FRIEDERS, mit Amtwohnsitz

in Luxemburg am 20. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 981 vom
21. April 2008,

und dass sie, durch ihre Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:

100734

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 11 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand (der Vorstand) geführt, der als Kollegialgremium von der Ge-

sellschafter-Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den nachstehend beschriebenen Bedingungen bestellt wird. Die
Gesellschafter-Hauptversammlung legt die Befugnisse und die Mandatsdauer der Geschäftsführer fest. Wird keine Man-
datsdauer festgelegt, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können von der
Gesellschafterhauptversammlung mit oder ohne Angabe von Gründen („ad nutum") jederzeit abberufen werden.

Der Vorstand besteht aus sechs (6) Geschäftsführern, die alle nicht in Deutschland ansässig sind; davon drei (3) Ka-

tegorie  A  Geschäftsführern,  (die  „Kategorie  A-Geschäftsführer)"  und  drei  (3)  Kategorie  B  Geschäftsführern,  (die
„Kategorie B-Geschäftsführer)" die von der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls von der Gesellschafterhauptver-
sammlung ernannt werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Geschäftsführers frei, können die verbleibenden Ge-

schäftsführer, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung."

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 12. Der Vorstand wählt aus seinen eigenen Reihen einen Vorsitzenden.
Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden wird er durch einen der Geschäftsführer ersetzt, der an der Sitzung teil-

nimmt und hierzu vom Vorstand benannt wird.

Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern einberufen.
Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Geschäftsführer, jeweils die gleiche Anzahl von Kategorie

A-Geschäftsführer und Kategorie B-Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Alle Geschäftsführer können sich bei Sitzungen des Vorstandes durch jeden anderen Geschäftsführer vertreten lassen,

mit der Beschränkung dass ein Geschäftsführer nur einen anderen Geschäftsführer vertreten kann.

Jeder Geschäftsführer besitzt eine Stimme zu allen Angelegenheiten, mit denen der Vorstand befasst wird. Der Vor-

sitzende besitzt keine ausschlaggebende Stimme.

Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer, die bei einer ordnungsgemäß einberu-

fenen und beschlussfähigen Sitzung anwesend oder vertreten sind, mit „ja" stimmen, vorausgesetzt, dass diese Mehrheit
ab dem Schlusstermin die Ja-Stimme von mindestens einem (1) Kategorie A-Geschäftsführer und einem (1) Kategorie B-
Geschäftsführer umfaßt.

Der  Vorstand  tritt  mindestens  einmal  vierteljährlich  nach  einer  schriftlichen  Einladung  zusammen,  die  mindestens

fünfzehn (15) Kalendertage vor der Sitzung ergehen muss (es sei denn, auf dieses Erfordernis der schriftlichen Einladung
wird verzichtet, indem mindestens ein (1) Kategorie A-Geschäftsführer und ein (1) Kategorie B-Geschäftsführer dies allen
Geschäftsführern ordnungsgemäß und in Schriftform mitteilen (vorausgesetzt, dass Maßnahmen, die in der zusammen mit
der Einladung verschickten Tagesordnung nicht gesondert aufgeführt sind, auf der entsprechenden Sitzung möglicherweise
nicht erörtert werden).

In jedem Quartal eines jeden Geschäftsjahres muss am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg mindestens eine (1) Vor-

standssitzung stattfinden.

Die Vorstandssitzungen können am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder aber in Form von Konferenzschaltungen,

Videokonferenzen oder mithilfe ähnlicher Kommunikationsmittel stattfinden, wobei (i) die Identität der an der Sitzung
teilnehmenden Geschäftsführer erkennbar ist, (ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen einander hören und mit-
einander sprechen können, (iii) die Sitzung ununterbrochen übertragen wird und (iv) die Geschäftsführer ordnungsgemäß
beraten können. Die Teilnahme an einer Sitzung mithilfe solcher Kommunikationsmittel gilt als persönliche Teilnahme an
der Sitzung.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg initiiert wurde.

Die Geschäftsführer können Ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder Email abgeben, welche schriftlich

bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allem Geschäftsführer genehmigt und unterschrieben ist, ist genau so recht-

wirksam wie ein anlässlich einer Vorstandssitzung gefasster Beschluss.

Geschäftsführer haben keinen Anspruch auf Entschädigung oder Entgelt für die in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer

erbrachten Dienste.

Maßnahmen oder Entscheidungen, die auf Vorstandssitzungen erforderlich oder zulässig sind, können auch ohne eine

Sitzung getroffen werden, wenn (i) alle Geschäftsführer einer solchen Maßnahme bzw. Entscheidung schriftlich zustimmen
und (ii) diese Schreiben zu den Akten der Gesellschaft genommen werden."

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 13 der Satzung wie folgt abzuändern:

100735

Art. 13. Der Vorstand hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vor-
standes."

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 14 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 14. Die Gesellschaft ist durch die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Geschäftsführern, bei denen es

sich um einen (1) Kategorie A-Geschäftsführer und um einen (1) Kategorie B-Geschäftsführer handelt, rechtsgültig ge-
bunden."

<i>Fünfter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 16 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 16. Der Vorstand kann seine Befugnisse im Hinblick auf die tägliche Führung der Geschäfte ganz oder teilweise

an Geschäftsführer oder an Dritte übertragen, bei denen es sich nicht unbedingt um Gesellschafter handeln muss.

Der Vorstand kann ferner Führungskräfte und/oder andere Vertreter der Gesellschaft bestellen, sofern der Vorstand

dies für notwendig oder ratsam erachtet. Jede Führungskraft bekleidet dieses Amt so lange, bis sie aus dem Amt aus-
scheidet oder abberufen wird, je nachdem, welcher Fall früher eintritt. Der Vorstand kann entscheiden, Führungskräfte
jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen abzuberufen.

Der Vorstand ist befugt, einen oder mehrere Ausschüsse (einschließlich eines geschäftsführenden Ausschusses) ein-

zusetzen und diesen die Befugnis zu erteilen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Kein Mitglied eines solchen Aus-
schusses darf ohne die Zustimmung des Vorstandes abberufen werden."

<i>Sechster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 20 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Gesellschafter akzeptiert wurden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein

Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft in einem Protokoll einge-

tragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden."

<i>Siebter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt auf unbestimmte Dauer zu ernennen:
1) als A-Geschäftsführer:
a) Herr Nico HANSEN, Privatangestellter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März 1969,

beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in

L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Herr Patrick TEROERDE, Privatangestellter, geboren in Düsseldorf, (Deutschland), am 12. of Juli 1974, wohnhaft

in South Kensington, London SW73BJ flat 2, 32 Evelyn Gardens (England);

2) als B-Geschäftsführer:
a) Herr Paul OBEY, Privatangestellter, geboren am 5. März 1966 in Bexley (England), beruflich wohnhaft Peterborough

Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, U in London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England);

b) Herr Philipp BRASCHEL, Privatangestellter, geboren am 18. Mai 1975 in Stuttgart (Deutschland), beruflich wohnhaft

in London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England);

c) Herr Christophe CAHUZAC, Privatangestellter, geboren am 26. Oktober 1972 in Saint Mard (Belgien), beruflich

wohnhaft in L-1661 Luxemburg, Grand-Rue, 9-11.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert
Euro.

100736

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersu-
chen derselben erschienenen Personen, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text,
wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und

Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben erschienenen Personen mit Uns, dem Notar, gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: HANSEN; CAHUZAC; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2008. Relation GRE/2008/3175. - Reçu douze euros 12 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): BENTNER.

FÜR GLECHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

Junglinster, den 4. August 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008102386/231/283.
(080118962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Perseus Immobilien Gesellschaft 11, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.800.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second of July.
Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

APPEARED:

The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 127,199,

here duly represented by two of its managers, namely:
- one Category A manager: Mr. Nico HANSEN, private employee, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57,

avenue Pasteur, and

- one Category B manager: Mr. Christophe CAHUZAC, private employee, professionally residing in L-1661 Luxemburg,

Grand-Rue, 9-11.

The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual

shareholder of the private limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 11", (hereafter the "Company"),
with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of
Luxembourg,  section  B,  under the  number 132.800,  incorporated pursuant to a deed  of the  undersigned notary  on
October 11th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2677 of the 22nd of
November 2007,

and whose articles of association have been restated pursuant to a deed of the notary Paul FRIEDERS, residing in

Luxembourg, on the 20th of March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 957
of the 17th of April 2008,

and that it takes, through its representatives, the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to amend article 11 of the articles of association to read as follows:
Art. 11. The company is managed by a board of managers (the „Board of Managers") appointed as a collegiate body

by the general meeting of the Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The general meeting of
the Shareholders determines the powers and term of the mandates of the Managers. If no term is indicated the Managers
are appointed for an undetermined period. The Managers may be revoked by the general meeting of the Shareholders
with or without cause (ad nutum) at any time.

The Board of Managers shall always be composed of six (6) Managers, each of whom does not reside in Germany,

three of which shall be Category A Managers (the "Category A Manager") and the other three shall be Category B
Managers (the "Category B Manager"), whether shareholders or not, who are appointed by the sole shareholder or, as
the case may be, by the general meeting of the shareholders.

If the post of a manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining managers thus elected, may

provisionally fill the vacancy by applying the same rules as the ones described above.

100737

In this case, the next general meeting will proceed to the final election."

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of association to read as follows:
Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to attend a meeting, he will be replaced by one of the Managers present at the meeting

designated to that effect by the board.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
Meetings of the Board of Managers are Collective and may only validly take resolutions if an equal number of Category

A Managers and Category B Managers are present or represented; proxies between managers being permitted, with the
restriction that a manager can only represent one of his colleagues.

Each Manager shall have one vote on all matters brought before the Board of Managers. The chairman will not have

any casting vote.

Resolutions of the Board of Managers may only validly be taken through the affirmative vote of a majority of the

Managers present or represented at a duly constituted meeting at which a quorum is present provided that, such majority
must include the affirmative vote of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

The Board of Managers shall meet not less frequently than quarterly, upon not less than fifteen (15) calendar days prior

written notice (unless such prior written notice requirement is otherwise waived in writing by at least one (1) Class A
Manager and one (1) Class B Manager duly given to all Managers (provided that actions not specifically referred to in any
agenda accompanying a notice may not be taken up at the relevant meeting).

At least one (1) meeting of the Board of Managers must be held during each quarter of each Fiscal Year at the Company's

offices in Luxembourg.

Meetings of the Board of Managers may be held at the Company's registered office in Luxembourg or by conference

call, video conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the Managers attending the meeting
can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of
the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Participation in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the
resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or Email confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the Ma-

nagers' meetings.

No Manager shall be entitled to any compensation or consideration for services rendered in its capacity as a Manager.
Any action or decision required or permitted to be taken at any meeting of the Board of Managers may be taken

without a meeting if (i) all of the Managers consent to such action or decision in writing, and (ii) the writing or writings
are filed with the records of the company."

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to amend article 13 of the articles of association to read as follows:
Art. 13. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition

in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August

10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the board of managers."

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 14 of the articles of association to read as follows:
Art. 14. The company will be validly bound by the joint signature of any two Managers being one (1) Class A Manager

and one (1) Class B Manager."

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to amend article 16 of the articles of association to read as follows:
Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

The Board of Managers may further appoint such officers and/or other Company representatives as the Board of

Managers shall deem necessary or advisable. Each officer shall hold office until his resignation or removal. The Board of
Managers may elect to remove any officer with our without cause at any time.

The Board of Managers shall have the power to set up one or more committees (including an executive committee)

to which the authority to make certain decisions may be delegated by the Board of Managers. No member of a committee
may be removed without the approval of the Board of Managers."

100738

<i>Sixth resolution

The sole shareholder decides to amend article 20 of the articles of association to read as follows:
Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes of shareholders representing more than

half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the share-

holders representing seventy five percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the

articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in

written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions."

<i>Seventh resolution

The sole shareholder decides to appoint for an undetermined duration:
1) as Category A Managers
a) Mr. Nico HANSEN, private employee, born in Differdange, (Grand-Duchy of Luxembourg), on the 31st of March

1969, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Mrs. Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on the 22nd of January 1963, professionally residing

in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Mr. Patrick TEROERDE, private employee, born on the 12th of July 1974 in Dusseldorf (Germany), residing at flat

2, 32 Evelyn Gardens, South Kensington, London SW73BJ, United Kingdom

2) as Category B Managers
a) Mr. Paul OBEY, private employee, born on March 5, 1966 in Bexley (United Kingdom) professionally residing Pe-

terborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, (England),

b) Mr. Philipp BRASCHEL, private employee born on May 18, 1975 in Stuttgart (Germany) professionally residing in

London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England), and

c) Mr. Christophe CAHUZAC, private employee, born on October 26, 1972 in Saint Mard (Belgium) professionally

residing in L-1661 Luxembourg, Grand-Rue, 9-11.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred
Euros,

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their first and last name, civil

status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Lu-

xemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 127.199,

hier rechtmäßig vertreten durch zwei ihrer Geschäftsführer, namentlich:
- ein Kategorie A Gesellschaftsführer: Herr Nico HANSEN, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg,

55-57, avenue Pasteur, und

- ein Kategorie B Gesellschaftsführer: Herr Christophe CAHUZAC, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-1661 Lu-

xemburg, Grand-Rue, 9-11.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,

dass sie die einzige aktuelle Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-

100739

SELLSCHAFT 11", (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 132.800, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 2677 vom 22. November 2007,

und deren Statuten neu gefasst wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul FRIEDERS, mit Amtwohnsitz

in Luxemburg am 20. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 957p vom
17. April 2008,

und dass sie, durch ihre Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 11 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand (der Vorstand) geführt, der als Kollegialgremium von der Ge-

sellschafter-Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den nachstehend beschriebenen Bedingungen bestellt wird. Die
Gesellschafter-Hauptversammlung legt die Befugnisse und die Mandatsdauer der Geschäftsführer fest. Wird keine Man-
datsdauer festgelegt, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können von der
Gesellschafterhauptversammlung mit oder ohne Angabe von Gründen („ad nutum") jederzeit abberufen werden.

Der Vorstand besteht aus sechs (6) Geschäftsführern, die alle nicht in Deutschland ansässig sind; davon drei (3) Ka-

tegorie  A  Geschäftsführern,  (die  „Kategorie  A-Geschäftsführer)"  und  drei  (3)  Kategorie  B  Geschäftsführern,  (die
„Kategorie B-Geschäftsführer)" die von der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls von der Gesellschafterhauptver-
sammlung ernannt werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Geschäftsführers frei, können die verbleibenden Ge-

schäftsführer, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung."

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 12. Der Vorstand wählt aus seinen eigenen Reihen einen Vorsitzenden.
Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden wird er durch einen der Geschäftsführer ersetzt, der an der Sitzung teil-

nimmt und hierzu vom Vorstand benannt wird.

Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern einberufen.
Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Geschäftsführer, jeweils die gleiche Anzahl von Kategorie

A-Geschäftsführer und Kategorie B-Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Alle Geschäftsführer können sich bei Sitzungen des Vorstandes durch jeden anderen Geschäftsführer vertreten lassen,

mit der Beschränkung dass ein Geschäftsführer nur einen anderen Geschäftsführer vertreten kann.

Jeder Geschäftsführer besitzt eine Stimme zu allen Angelegenheiten, mit denen der Vorstand befasst wird. Der Vor-

sitzende besitzt keine ausschlaggebende Stimme.

Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer, die bei einer ordnungsgemäß einberu-

fenen und beschlussfähigen Sitzung anwesend oder vertreten sind, mit „ja" stimmen, vorausgesetzt, dass diese Mehrheit
ab dem Schlusstermin die Ja-Stimme von mindestens einem (1) Kategorie A-Geschäftsführer und einem (1) Kategorie B-
Geschäftsführer umfaßt.

Der  Vorstand  tritt  mindestens  einmal  vierteljährlich  nach  einer  schriftlichen  Einladung  zusammen,  die  mindestens

fünfzehn (15) Kalendertage vor der Sitzung ergehen muss (es sei denn, auf dieses Erfordernis der schriftlichen Einladung
wird verzichtet, indem mindestens ein (1) Kategorie A-Geschäftsführer und ein (1) Kategorie B-Geschäftsführer dies allen
Geschäftsführern ordnungsgemäß und in Schriftform mitteilen (vorausgesetzt, dass Maßnahmen, die in der zusammen mit
der Einladung verschickten Tagesordnung nicht gesondert aufgeführt sind, auf der entsprechenden Sitzung möglicherweise
nicht erörtert werden).

In jedem Quartal eines jeden Geschäftsjahres muss am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg mindestens eine (1) Vor-

standssitzung stattfinden.

Die Vorstandssitzungen können am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder aber in Form von Konferenzschaltungen,

Videokonferenzen oder mithilfe ähnlicher Kommunikationsmittel stattfinden, wobei (i) die Identität der an der Sitzung
teilnehmenden Geschäftsführer erkennbar ist, (ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen einander hören und mit-
einander sprechen können, (iii) die Sitzung ununterbrochen übertragen wird und (iv) die Geschäftsführer ordnungsgemäß
beraten können. Die Teilnahme an einer Sitzung mithilfe solcher Kommunikationsmittel gilt als persönliche Teilnahme an
der Sitzung.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg initiiert wurde.

Die Geschäftsführer können Ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder Email abgeben, welche schriftlich

bestätigt werden müssen.

100740

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allem Geschäftsführer genehmigt und unterschrieben ist, ist genau so recht-

wirksam wie ein anlässlich einer Vorstandssitzung gefasster Beschluss.

Geschäftsführer haben keinen Anspruch auf Entschädigung oder Entgelt für die in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer

erbrachten Dienste.

Maßnahmen oder Entscheidungen, die auf Vorstandssitzungen erforderlich oder zulässig sind, können auch ohne eine

Sitzung getroffen werden, wenn (i) alle Geschäftsführer einer solchen Maßnahme bzw. Entscheidung schriftlich zustimmen
und (ii) diese Schreiben zu den Akten der Gesellschaft genommen werden."

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 13 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 13. Der Vorstand hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vor-
standes."

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 14 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 14. Die Gesellschaft ist durch die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Geschäftsführern, bei denen es

sich um einen (1) Kategorie A-Geschäftsführer und um einen (1) Kategorie B-Geschäftsführer handelt, rechtsgültig ge-
bunden."

<i>Fünfter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 16 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 16. Der Vorstand kann seine Befugnisse im Hinblick auf die tägliche Führung der Geschäfte ganz oder teilweise

an Geschäftsführer oder an Dritte übertragen, bei denen es sich nicht unbedingt um Gesellschafter handeln muss.

Der Vorstand kann ferner Führungskräfte und/oder andere Vertreter der Gesellschaft bestellen, sofern der Vorstand

dies für notwendig oder ratsam erachtet. Jede Führungskraft bekleidet dieses Amt so lange, bis sie aus dem Amt aus-
scheidet oder abberufen wird, je nachdem, welcher Fall früher eintritt. Der Vorstand kann entscheiden, Führungskräfte
jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen abzuberufen.

Der Vorstand ist befugt, einen oder mehrere Ausschüsse (einschließlich eines geschäftsführenden Ausschusses) ein-

zusetzen und diesen die Befugnis zu erteilen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Kein Mitglied eines solchen Aus-
schusses darf ohne die Zustimmung des Vorstandes abberufen werden."

<i>Sechster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Artikel 20 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Gesellschafter akzeptiert wurden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein

Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft in einem Protokoll einge-

tragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden."

<i>Siebter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt auf unbestimmte Dauer zu ernennen:
1) als A-Geschäftsführer:
a) Herr Nico HANSEN, Privatangestellter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März 1969,

beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in

L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Herr Patrick TEROERDE, Privatangestellter, geboren in Düsseldorf, (Deutschland), am 12. of Juli 1974, wohnhaft

in South Kensington, London SW73BJ flat 2, 32 Evelyn Gardens (England);

2) als B-Geschäftsführer:
a) Herr Paul OBEY, Privatangestellter, geboren am 5. März 1966 in Bexley (England), beruflich wohnhaft Peterborough

Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, U in London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England);

100741

b) Herr Philipp BRASCHEL, Privatangestellter, geboren am 18. Mai 1975 in Stuttgart (Deutschland), beruflich wohnhaft

in London EC4A 2BB, UK Peterborough Court, Fleet Street, 133 (England);

c) Herr Christophe CAHUZAC, Privatangestellter, geboren am 26. Oktober 1972 in Saint Mard (Belgien), beruflich

wohnhaft in L-1661 Luxemburg, Grand-Rue, 9-11.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert
Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersu-
chen derselben erschienenen Personen, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text,
wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und

Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben erschienenen Personen mit Uns, dem Notar, gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: HANSEN; CAHUZAC; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2008. Relation GRE/2008/3181. - Reçu douze euros 12 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): BENTNER.

FÜR GLECHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

Junglinster, den 4. August 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008102387/231/283.
(080118976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Derma Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.320.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le vingt-huit mai.
Par-devant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

CUNEO LLC, avec siège social au 13 Suite, First Floor, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé,

République des Seychelles, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés des Seychelles sous le numéro
032695, représentée par FERENCE SERVICES Ltd, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social
aux Iles Vierges Britanniques, IBC numéro 473240 agissant en sa qualité d'administrateur,

ici représentée par Monsieur Vikash Bhoobun, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après «l'Associé Unique»), a requis le notaire instru-

mentant d'acter:

- que la société «DERMA FINANCE S.A.», ayant son siège social à11A, bd Prince Henri - L-1724 Luxembourg, a été

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant sous la dénomination de Fegatello SA en date du 24 novembre
2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 508 du 9 mars 2006 (la «Société»). Les
statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentant en date du 27 janvier 2006, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1236 du 27 juin 2006.

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté

par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

- que l'activité de la Société ayant cessé, l'Associé Unique, étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prononce

par la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne en qualité
de liquidateur de la Société;

- que l'Associé Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article 151

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre;

100742

- que l'Associé Unique, agissant en qualité de liquidateur, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation

financière de la société et requiert au notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société
sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que
par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévoca-
blement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la société est réglé.

Le rapport sur la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire

soussigné, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

- que l'Associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation CONFIDENTLY (FIDUCIAIRE) S. à r.l, avec

siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 30.467, et lui confie la
mission de faire le rapport sur la gestion.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associé Unique en adopte les conclusions,

approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni
restriction à CONFIDENTLY (FIDUCIAIRE) S. à r.l., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire de la comparante et

le notaire soussigné est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

L'Associé Unique, constituée en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société

a définitivement cessé d'exister.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire aux comptes en ce

qui concerne l'exécution de leur mandat.

Que les livres et documents de la société seront déposés pendant cinq ans au 11 A, bd Prince Henri - L-1724 Luxem-

bourg.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ladite personne a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: Vikash Bhoobun, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 2 juin 2008. LAC/2008/22045. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 29 juillet 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008102377/202/63.
(080118132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

May Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 78.055.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008102335/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00472. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Medea Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 76.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

100743

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008102336/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00475. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Menocee Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 125.701.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008102337/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00479. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080117393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Lux.Net S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 130.686.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08.08.08.

<i>LUX.NET S.A.
Louis VEGAS-PIERONI / Angelo DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008102356/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02629. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Master Tel Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 100.830.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008102334/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00468. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Mar-Plast International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 62.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

100744

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008102333/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00464. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

MARENS Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 117.453.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008102332/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00461. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080117377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Meco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 134.048.

L'an deux mille huit, le trente juillet.
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «MECO Sàrl», établie et ayant son

siège social à L-1510 LUXEMBOURG, 38, avenue de la Faïencerie, inscrite au registre de commerce et des sociétés, sous
le numéro B 134.048, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 septembre 2007, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3023 du 31 décembre 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Michèle CANEPA, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg. Monsieur le président déclare et requiert le notaire d'acter:

I. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les associés présents, les mandataires
des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations des associés représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux for-
malités de l'enregistrement.

II. Que la totalité des parts étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des

convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs,
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 3.- des statuts.
2. Divers.
Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, les associés, à l'unanimité, décide des résolutions

suivantes:

<i>Résolution unique

Les associés décident de modifier l'objet social de la société. En conséquence, l'article 3.- des statuts est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert

100745

par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et
le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

La société aura aussi pour objet le développement et la promotion de marques dans le secteur du goût et de la mode,

soit en produisant et en commercialisant ses propres marques ou celles de tiers soit par la concession de licences à des
tiers pour la production et la commercialisation des produits tout en bénéficiant de l'article 50bis tel que prévu dans la
loi du 21 décembre 2007 elle-même modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

La société pourra en outre soutenir les départements R&amp;D des entreprises, de gérer la stratégie d'entreprise (plan à

long moyen termes), de gérer l'échelle de décision, et de structurer et développer le module de prise de décision (DMU).
En outre la société pourra développer et organiser les flux des frais, les centres de coût, sondage périodique/contrôle de
la tendance des entreprises».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de son assemblée générale s'élève approximativement à la somme de SEPT CENT
VINGT EUROS (720,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée

aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Wesquy, Canepa, C. Doerner.
Enregistré à Esch/AIzette le 7 août 2008, Relation: EAC/2008/10537. - Reçu douze euros (12,- EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande au fin de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 8 août 2008.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2008102397/209/69.
(080118722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Worldwide Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 4, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 111.597.

En date du 5 juin 2008, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé:
- d'accepter la nomination avec effet immédiat de Monsieur LUSHIKU Paul-Yves, avec adresse professionnelle au 38,

rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg en tant que Gérant technique de la société pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 05 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008102395/8969/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05990. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080118843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Metide International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 129.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

100746

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008102338/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00482. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

Immo Hiereknapp S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour.

R.C.S. Luxembourg B 108.041.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente mai.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu

1.- Monsieur le Docteur Henri Joseph HOSCH, médecin-dentiste, demeurant à L-8329 Capellen, 1, rue de Koerich,
2.- Monsieur André LEFEVRE, architecte, demeurant à L-7409 Beringerberg, Maison 8,
3.- Monsieur Klaus SCHMITZ, ingénieur, demeurant à L-7554 Mersch, 4, rue de Pettingen,
4.- Madame Monique EIFFES, secrétaire, demeurant à L-7409 Mersch, 8, Beringerberg.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire:
Que la société dénommée IMMO HIEREKNAPP, S.à r.l., avec siège social à L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour, inscrite

au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108.041,

ci-après nommée la "Société",
a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 25 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 1000 du 7

octobre 2005 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné le 20 mai 2005, publié au
Mémorial C numéro 998 du 6 octobre 2005.

Que le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent vingt-

quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Que les comparants déclarent être seuls associés de la Société.
L'activité de la Société ayant cessé, ils déclarent expressément vouloir procéder à sa dissolution.
Que les associés se désignent comme liquidateurs de la Société, qu'en cette qualité ils requièrent le notaire instru-

mentant d'acter qu'ils déclarent que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné; en outre ils déclarent que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l'heure actuelle, ils assument irrévocablement et solidairement l'obligation de payer tout
ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;

Que l'actif restant éventuel est attribué aux associés;
Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société;
Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri Hosch, André Lefevre, Klaus Schmitz, Monique Eiffes, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 juin 2008, LAC/2008/23435. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 août 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008102378/202/46.
(080118130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

100747

A.C.D.C. S.A., Asian Car Distribution Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 100.972.

L'an deux mille huit, le sept août.
Par-evant Maître Blanche MOUTRIER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signée.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ASIAN CAR DISTRIBUTION

COMPANY S.A., en abrégé A.C.D.C. S.A.» ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-
Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
100.972, constituée le 11 mai 2004 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro n° 746 du 21 juillet 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hervé PONCIN, administrateur, demeurant professionnelle-

ment à L-8010 Strassen, 206-201, route d'Arlon (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Maître Charles DURO, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Lu-

xembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

L'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant professionnellement à

L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que les deux mille (2.000) actions représentant l'intégralité du capital social,

sont représentées à la présente assemblée, de sorte que l'Assemblée Générale peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur de la Société;
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur;
4. Divers.
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la Société Monsieur Hervé PONCIN, administrateur,

demeurant professionnellement à L-8010 Strassen, 206-201, route d'Arlon (Grand-Duché de Luxembourg) ("le Liquida-
teur").

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus

spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ainsi que ses modifications.

L'Assemblée Générale, entre autres, décide et reconnaît que la Société sera engagée envers les tiers par la seule

signature du Liquidateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), les jours, mois et an qu'en tête des pré-

sentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Poncin, C. Duro, K. Mastinu, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 8 août 2008. Relation: EAC/2008/10609. — Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. Boiça.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100748

Esch-sur-Alzette, le 11 août 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008102379/272/56.
(080119029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Luxcontrol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4330 Esch-sur-Alzette, 1, avenue des Terres Rouges.

R.C.S. Luxembourg B 15.664.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 19. Juni 2008

Ad TOP 6
Die Gesellschafter beschließen vollzählig und einstimmig das Mandat als Verwaltungsratmitglied von Herrn Dr. jur.

Christoph Hack um weitere 6 Jahre bis zur Billigung des Jahresabschlußes 2013, also bis zur Jahreshauptversammlung im
Jahre 2014, zu verlängern.

Die Gesellschafter beschließen vollzählig und einstimmig das Mandat als Verwaltungsratmitglied von Herrn Gilles Feider

um weitere 6 Jahre bis zur Billigung des Jahresabschlußes 2013, also bis zur Jahreshauptversammlung im Jahre 2014, zu
verlängern.

Die Gesellschafter beschließen vollzählig und einstimmig das Mandat als Verwaltungsratmitglied von Herrn Jacques

Eischen um weitere 6 Jahre bis zur Billigung des Jahresabschlußes 2013, also bis zur Jahreshauptversammlung im Jahre
2014, zu verlängern sowie das Mandat als Administrateur délégué von Herrn Jacques Eischen um weitere 6 Jahre bis zur
Billigung des Jahresabschlußes 2013, also bis zur Jahreshauptversammlung im Jahre 2014, zu verlängern.

Für gleichlautenden Auszug zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, den 1. Juli 2008.

Jacques EISCHEN
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2008102376/5873/25.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03365. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080118748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

D. Brown &amp; Sons, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 69.486.

EXTRAIT

Il  résulte  du  courrier  daté  du  31  juillet  2008  de  Monsieur  Dominique  HUGGINS  demeurant  à  4,  Gartenstrasse,

D-54668 FERSCHWEILER

Administrateur de la société D.BROWN&amp;SONS S.A. à 1, rue Jean Pierre Brasseur L-1248 LUXEMBOURG a démis-

sionné de ses fonctions d'administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008102399/9184/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04335. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080118852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

GLL AMB Generali South Express S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GLL AMB Generali Holding Beta S.à r.l.).

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender, Le Dôme, Mezzanine B.

R.C.S. Luxembourg B 140.582.

In the year two thousand eight, on eleventh day of July.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"GLL MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.", a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée),

with registered office in Le Dôme, Mezzanine B, 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered at the R.C.S. Luxembourg B 116.672, acting as management company in its own name but for and on behalf

100749

of the sole shareholder GLL AMB Generali Cross-Border Property Fund - Strategic International I, a sub-fund of GLL
AMB Generali Cross-Border Property Fund, a fonds commun de placement established under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg,

duly represented by Mr Pierre-Alexandre DELAGARDELLE, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal, on 9 July 2008.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party is the sole shareholder of "GLL AMB Generali Holding Beta S.à r.l.", a private limited company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy
of Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies and incorporated pursuant
to a deed dated 8 July 2008 by the Luxembourg notary Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, to be published in
the Mémorial C, Récueil des Sociétés et Associations.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder RESOLVES to change the name of the company GLL AMB Generali Holding Beta S.à r.l. and to

replace it by the name "GLL AMB Generali South Express S.à r.l.".

<i>Second resolution

The sole shareholder RESOLVES to amend the article 1 of the articles of incorporation of the company GLL AMB

Generali Holding Beta S.à r.l., which will henceforth have the following wording:

Art. 1. Form - Corporate name.
1.1 There is formed a private limited liability company under the name GLL AMB Generali South Express S.à r.l. which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August
10th, 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation
(hereafter the "Articles")."

<i>Third resolution

The sole shareholder RESOLVES to change the registered office of the company being 6D, route de Trèves, L-2633

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg and to replace it by the registered office Le Dôme, Mezzanine B, 15, rue
Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder RESOLVES to amend the article 2.1 of the articles of incorporation of the company formerly

named "GLL AMB Generali Holding Beta S.à r.l." and with the new name "GLL AMB Generali South Express S.à r.l.",
which will henceforth have the following wording:

"The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg-City (Grand Duchy of Lu-

xembourg)."

<i>Fifth resolution

The sole shareholder RESOLVES that the above resolutions shall be effective as from 11 July 2008.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by her surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le onze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

"GLL MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.", une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Le Dôme,

Mezzanine B, 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré au Registre du Commerce
et des Sociétés luxembourgeois sous le n° B 116.672, agissant comme société de gestion, en son propre nom mais pour
le compte de l'actionnaire unique GLL AMB Generali Cross-Border Property Fund - Strategic International I, un com-
partiment de GLL AMB Generali Cross-Border Property Fund, un fonds commun de placement établi conformément aux
lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ici valablement représentée par Me Pierre-Alexandre DELAGARDELLE, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

100750

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 9 juillet 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le/la mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

La comparante est l'actionnaire unique de "GLL AMB GENERALI HOLDING BETA S.à r.l.", une société à responsabilité

limitée ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore
enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois, et constituée par acte du 8 Juillet 2008 du Notaire
Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, que sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique DECIDE de changer la dénomination sociale de la société "GLL AMB Generali Holding Beta S.à

r.l." et de la remplacer par la dénomination "GLL AMB Generali South Express S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique DECIDE de modifier l'article 1 

er

 des Statuts de la société GLL AMB Generali Holding Beta S.à

r.l., comme suit:

 Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GLL

AMB Generali South Express S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "la Société"), et en
particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par
les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts")."

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique DECIDE de changer le siège social de la société, celui-ci étant actuellement sis au 6D, route de

Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et de le remplacer par un siège social sis à l'adresse suivante:
Le Dôme, Mezzanine B, 15, rue de Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'actionnaire unique DECIDE d'amender l'article 2.1 des statuts de la société anciennement appelée "GLL AMB Ge-

nerali Holding Beta S.à r.l" et nouvellement appelée " GLL AMB Generali South Express S.à r.l.", comme suit:

"Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).".

<i>Cinquième résolution

L'actionnaire unique DECIDE que les résolutions seront effectives à partir du 11 juillet 2008.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P.A. DELAGARDELLE, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 juillet 2008. Relation: EAC/2008/9581. - Reçu douze Euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): BOIÇA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 8 août 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008102402/239/110.
(080118399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Anglo Coal Xiwan Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 100.826.

<i>Extrait de résolutions prises par l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société en date du 18 juin 2008

M. James Edward Beams avec adresse professionnelle au 8 Jianguomenbei Avenue, 100005, 2104 China Resources

Building, Beijing, China a démissionné de son mandat d'administrateur de la société avec effet à partir du 18 juin 2008.

Melle Cristina Capacchietti, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1225 Luxembourg est élue en tant

que commissaire de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

100751

Deloitte S.A. sont réélus en tant que réviseurs d'entreprise de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra

en l'année 2009.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008102403/1115/20.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02511. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080118187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Lencor Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 39.345.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008102328/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2008, réf. LSO-CT00449. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080117367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.

T.T.V. Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 118.123.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 juillet 2008

Conformément aux résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie en date du 9 juillet

2008:

1. La société Fidugroup Holding S.A.H, ayant son siège social au 61, avenue de la gare, L-1611 Luxembourg, immatriculée

au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 85664, a été révoquée de ses fonctions d'administrateur et
de délégue à la gestion journalière de la Société, avec effet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire;

2. La société Myddleton Assets Limited, ayant son siège social à Lawford House, Albert Place, GB-N3 1RL Londres,

immatriculée au Companies House à Londres sous le numéro B 5019056, a été révoquée de ses fonctions d'administrateur
de la Société, avec effet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire;

3. La société Langcraft Investment limited, ayant son siège social à Lawford House, Albert Place, GB-N3 1RL Londres,

immatriculée au Companies House à Londres sous le numéro B 5114605, a été révoquée de ses fonctions d'administrateur
de la Société, avec effet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire;

4. Monsieur Yves Vautrin, directeur administratif et financier, né le 2 novembre 1957 à Epinal (France), résidant 39,

bis rue André Vitu à 88000 Epinal (France), a été nommé en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à l'issue de
l'assemblée générale extraordinaire en date, du 9 juillet 2008; jusqu'a L'AG qui se tiendra en 2011.

5. Monsieur Philippe Lamazou, président de société, né le 14 mars 1973 à Chalons sur Marne (France), résidant 3, rue

du Pont de l'Eure à 75020 Paris (France), a été nommé en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à l'issue de
l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 juillet 2008; jusqu'a L'AG qui se tiendra en 2011.

6. Monsieur Jérémie Bonnin, administrateur de société, né le 30 juin 1974 à Paris 14e (France), résidant profession-

nellement 11, rue de la Rôtisserie, 1204 Genève (Suisse), a été nommé en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 juillet 2008, jusqu'a L'AG qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Eric SUBLON.

Référence de publication: 2008102585/280/32.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08370. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080118321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

100752


Document Outline

ADA Management S.à r.l.

Anglo Coal Xiwan Project S.A.

Arens Scheer Le Trente S.à r.l.

A.R.H. Limited S.A.

Asian Car Distribution Company S.A.

Aspelt Investment S.A.

Aster S.A.

Atel Derivatives S.à r.l.

Camping Um Bierg S.A.

Curzon Capital Partners Holland S.à r.l.

D. Brown &amp; Sons

Derma Finance S.A.

D &amp; P Luxembourg

EPI Office 3 S.à r.l.

EPI Temple S.à.r.l.

Ewaco Properties S.à r.l.

Fiduciaire Luxembourgeoise Claude Koeune S.à r.l.

Fifteen S.A.

Fitness Lounge S.A.

Geam S.A.

GLL AMB Generali Holding Beta S.à r.l.

GLL AMB Generali South Express S.à r.l.

GLL Management Company S.à r.l.

Globe Total Investments Holdings S.A.

Grabory S.à r.l.

Hervé Le Jardinier S.à r.l.

Immo Hiereknapp S.à.r.l.

Indiact S.à r.l.

Intensum Group SA

KTV S.àr.l.

Lencor Investment S.A.

Levhold Germany S.à r.l.

Luxcontrol S.A.

Lux.Net S.A.

MARENS Immobilière S.A.

Mar-Plast International S.A.

Master Tel Finance S.A.

May Estate S.A.

Meco S.à r.l.

Medea Consulting S.A.

Melfin B.V.

Menocee Investments S.A.

Metide International S.A.

Middlesex Office S.à r.l.

Nestor Lux 2007 S.à r.l.

Panta S.A.

Paris Euro Fashion S.A.

Partecipazioni Bingogest S.A.

Peinture Dave Feltus Sàrl

Perseus Immobilien Gesellschaft 11

Perseus Immobilien Gesellschaft 5

Perseus Immobilien Gesellschaft 8

Perseus Immobilien Gesellschaft 9

Prologis European Holdings X S.à r.l.

Promotions C. Jans &amp; Associés S.A.

S. à r.l. WUST Construction LUXEMBOURG

Seramans S.A.

Seramans S.A.

Townsend Investment I S.à r.l.

T.T.V. Finances S.A.

Worldwide Consultancy S.à r.l.