This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2077
27 août 2008
SOMMAIRE
AGF Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99691
AGF Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99691
AGF Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99691
Arenamar Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99692
Astron Buildings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99671
BALTHASAR FinPar SA . . . . . . . . . . . . . . . .
99650
Benton Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
99671
Caldera Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99680
Captiva Industrial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
99680
Centurion European German Property 10
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99652
Centurion European German Property 4
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99664
Centurion European German Property 9
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99658
CEREP Investment T S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
99688
Dedale Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99670
Elemental Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99684
F.22 Modulbau Société de construction . .
99677
Finmac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99693
Gestec Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
99694
Global Facilities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99695
Global Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99694
G.N. Research S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99650
Greggio Group International - The Silver
Network S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99694
Helvetia Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99675
IDI Emerging Markets SA . . . . . . . . . . . . . . .
99691
Interpillar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99694
L'Automobil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99693
Legend Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99695
Louis XIV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99696
Ltad SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99671
Luxtile au Coin du Feu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99677
MAP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99695
Marline Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99692
Mavico Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99692
Medici SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99687
MGM 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99693
MK European Capital Partners S.à r.l. . . .
99684
MSEOF Bayerstrasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
99690
Parc Val Ste Croix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99695
Primetec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99689
Quadriconseil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99675
Robeco - VCM - Emerging Managers Fund
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99679
Royal Almendros Finance S.A. . . . . . . . . . .
99693
SDP 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99696
Securitas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99650
Sirio Rail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99692
Store Rollingergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99696
Tantal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99651
Tanzanite S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99690
Tecnomatix Technologies S.à r.l. . . . . . . . .
99650
Thomann Hanry Luxembourg Sàrl . . . . . .
99696
TPG-Axon (Luxembourg) I S.à r.l. . . . . . . .
99680
Wallace Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99684
Yanaon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99677
99649
G.N. Research S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.822.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2008.
<i>G.N. Research S.A.
i>Représentée par Stéphane HEPINEUZE
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008100319/1084/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT01171. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080115781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2008.
Tecnomatix Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 143.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 30.388.
Le bilan au 30/09/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008100320/717/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT01165. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080115782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2008.
BALTHASAR FinPar SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R.C.S. Luxembourg B 29.441.
Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 août 2008.
<i>BALTHASAR FinPar S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2008100335/2834/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01240. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080115614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2008.
Securitas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 72.099.
EXTRAIT
- Il résulte d'une réunion du Conseil d'administration de la Société qui s'est tenue en date du 27/06/2008 que:
Monsieur Tony RUSSO, né le 18 février 1971 à Thionville (F), demeurant à F-57570 Rodemack, 9, rue des Seigneurs
d'Hesperange, est chargé avec effet au 1
er
avril 2008 de certains aspects de la gestion journalière et de la représentation
de la Société en ce qui concerne cette gestion.
99650
Les pouvoirs suivants lui sont octroyés:
(a) réceptionner toute correspondance et tout envoi de valeurs et de biens, ainsi que tout colis et paquet, télégramme
et lettre recommandée avec ou sans valeur déclarée adressés à la société;
(b) représenter la société devant toutes les organisations et associations dont elle fait partie;
(c) représenter la société devant tous les organismes et institutions de sécurité sociale;
(d) représenter la société devant toutes les organisations syndicales;
(e) établir et signer la correspondance journalière de la société;
(f) vendre les services de la société et en déléguer la vente;
(g) faire toute offre, remettre tout devis, pour des marchés publics ou privés; remplir et soumettre tous les documents
et les formalités en la matière;
(h) acheter tout produit, matériel, véhicule, service, et en général tous les biens mobiliers qui ont trait aux activités
de la société;
(i) prendre toute disposition nécessaire afin de recouvrir toute somme d'argent due à la société;
(j) endosser et protester tout chèque d'un tiers établi au nom de la société, mais uniquement pour le paiement de
ceux-ci sur les comptes courants de la société;
(k) avec double signature, transférer tous les montants d'un compte Postcheque ou d'un compte bancaire de la société
sur d'autres comptes Postcheque ou comptes bancaires de la société;
(l) avec double signature, payer toutes les sommes dues par la société en principal, intérêts et accessoires;
(m) avec double signature, accepter tout dépôt, l'exécuter et l'aliéner même à titre de garantie, constituer et libérer
toutes les garanties;
(n) conclure et mettre fin à toute convention de location de coffre bancaire et de dépôt bancaire de valeurs;
(o) avec double signature, ouvrir et fermer tout compte bancaire et compte Postcheque et en modifier le nom;
(p) avec double signature, consentir à tout contrat de location pour une durée inférieur à 9 ans, le modifier, le re-
nouveler et y mettre un terme, soit en tant que bailleur, soit en tant que locataire et en règle générale prendre toute
mesure en matière de bail;
(q) conclure et signer des polices d'assurance voiture;
(r) engager et licencier tout travailleur (à l'exception du personnel cadre et du personnel dirigeant);
Luxembourg, le 14 juillet 2008.
Pour extrait conforme
Fabien DEBROISE
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008100951/275/45.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2008, réf. LSO-CS08888. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Tantal S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 131.779.
<i>Extrait de la décision prise en date du 19 juin 2008 par le Conseil d'Administration de la sociétéi>
Il a été décidé de nommer Ernst & Young (S.A.), domicilié au 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach - Luxembourg,
et enregistré sous le numéro B 47.771 au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg, en tant que Réviseur
d'Entreprise de la société avec effet immédiat.
Et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2009.
Luxembourg, le 24 juillet 2 008.
Extrait certifié conforme
Signature
Référence de publication: 2008100900/8548/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01666. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
99651
Centurion European German Property 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 140.705.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth of July.
Before M
e
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
The company established under the laws of Bermuda "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", with re-
gistered office in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermuda), inscribed in the
Trade and Companies Register of Bermuda under number 38435,
here represented by Mr. Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, professionally residing in L-1140 Luxembourg,
45-47, route d'Arlon, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by
the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, requests the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a private limited liability company, ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), as follows:
A. Purpose - duration - name - registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a limited liability company (the "Company") which shall be governed by the law of 10
August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,
lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The Company will assume the name of "Centurion European German Property 10 S.à r.l".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.
B. Share capital - shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three-quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.
99652
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the surviving associates. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descen-
dants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or documents
of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by a board of managers, composed of one (1) manager of category A and two (2)
managers of category B, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and
may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three-quarters of the share capital at least.
99653
Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.
E. Financial year - annual accounts - distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution - liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2008.
<i>Subscription and payment of the sharesi>
The five hundred (500) shares have been subscribed by the company governed by the laws of Bermuda "CENTURION
EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", prenamed, and fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred Euro (12,500.- EUR) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euros.
<i>Decisions of the sole share-owneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the aboved-named share owner, represented as said before, has
taken the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
2.- The sole shareholder states that the board of managers will be composed as follows:
a) Mr Konstantinos EMMANOUIL, lawyer, born in Athens, (Greece), on the 14th of March 1952, residing at 18535
Piraeus, 13 Defteras Merarchias Street, (Greece), manager of category A;
b) Mrs Filanthi KATSAFADOU, attorney-at-law, born in Athens (Greece), on the 16th of May 1976, residing in GR-185
35 Piraeus, 13, Defteras Merarchias Street, (Greece), manager of category B; and
c) Mr Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, born in Ettelbruck, on the 27th of March 1973, professionally
residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, manager of category B.
3.- The Company will be validly bound in any circumstances and for any operations by the sole signature of the manager
of category A.
Up to the amount of four thousand Euros (4,000.- EUR), the company may be bound in any circumstances and for any
operations by the individual signature of a manager of category B; for any operations exceeding this value the joint
signatures of the manager of category A and one manager of category B are required.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
mandatory, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the mandatory, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status
and residence, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present deed.
99654
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendacht, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster; (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED",
mit Sitz in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermudas), eingetragen im Gesell-
schaftsregister der Bermuda-Inseln unter der Nummer 38435,
hier vertreten durch Herrn Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1140 Luxemburg, 45-47, route
d'Arlon, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem
amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben ein-
registriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Gründungsurkunde
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die "Gesellschaft")
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Investition, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung von Grundstücken in Luxemburg oder im Ausland sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit diesen
Grundstücken, einschließlich (i) der direkten oder indirekten Beteiligung an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die
Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Verpachten von Grundstücken ist und (ii) der
Gründung von Filialen, die Grundstücke im Großherzogtum Luxemburg besitzen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "Centurion European German Property 10 S.à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter, die drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszen-
dente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
99655
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-
mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus einem (1) Geschäfts-
führer der Kategorie A und zwei (2) Geschäftsführern der Kategorie B, welche nicht Gesellschafter sein müssen.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Der Geschäftsführerrat kann privatschriftliche oder notariell beglaubigte Spezialvollmachten erteilen.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
99656
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am ein und dreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2008.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden durch die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-
Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", vorgenannt, gezeichnet und vollständig in bar einbezahlt,
demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), wie dem un-
terzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendzweihundert Euro geschätzt.
<i>Beschlussfassung Durch den Alleinigen Gesellschafteri>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung, hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie hiervor erwähnt, folgende
Beschlüsse gefasst:
1.- Die Gesellschaftssitz wird in L-1140 Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, festgelegt.
2.- Die alleinige Gesellschafterin stellt fest, dass sich der Geschäftsführerrat wie folgt zusammensetzen wird:
a) Herr Konstantinos EMMANOUIL, Anwalt, geboren in Athen, (Griechenland), am 14. März 1952, wohnhaft in 18535
Piraeus, 13 Defteras Merarchias Street, (Griechenland), Geschäftsführer der Kategorie A;
b) Frau Filanthi KATSAFADOU, Anwalt, geboren in Athen, (Griechenland), am 16 Mai 1976, wohnhaft in GR-185 35
Piraeus, 13, Defteras Merarchias Street, (Griechenland), Geschäftsführer der Kategorie B; und
c) Herr Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, geboren in Ettelbrück, am 27 März 1973, beruflich wohnhaft in L-1140
Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, Geschäftsführer der Kategorie B.
3. Die Gesellschaft wird rechtmäßig in allen Umständen und für alle Verpflichtungen durch die alleinige Unterschrift
des Geschäftsführers der Kategorie A verpflichtet.
Bis zu einem Betrag von viertausend Euro (4.000,- EUR) kann die Gesellschaft in allen Umständen durch die Einzel-
unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet werden; für jegliche Verpflichtungen welche diesen Betrag
überschreiten, ist die Kollektivunterschrift des Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kate-
gorie B erforderlich.
99657
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch des Bevollmächtigten gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen desselben Bevollmächtigten
und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE Errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: DIDERRICH - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
août 2008. Relation GRE/2008/3220. - Reçu soixante deux euros et cinquante cents
0,50%= 62,50 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): BENTNER.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, den 6. August 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008101027/231/338.
(080116392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Centurion European German Property 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 140.706.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth of July.
Before M
e
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
The company established under the laws of Bermuda "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", with re-
gistered office in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermuda), inscribed in the
Trade and Companies Register of Bermuda under number 38435,
here represented by Mr. Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, professionally residing in L-1140 Luxembourg,
45-47, route d'Arlon, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by
the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, requests the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a private limited liability company, ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a limited liability company (the "Company") which shall be governed by the law of 10
August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,
lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The Company will assume the name of "Centurion European German Property 9 S.à r.l.".
99658
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three-quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the surviving associates. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descen-
dants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or documents
of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by a board of managers, composed of one (1) manager of category A and two (2)
managers of category B, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and
may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
99659
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three-quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2008.
<i>Subscription and payment of the sharesi>
The five hundred (500) shares have been subscribed by the company governed by the laws of Bermuda "CENTURION
EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", prenamed, and fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred Euro (12,500.- EUR) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euros.
<i>Decisions of the sole share-owneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the aboved-named share owner, represented as said before, has
taken the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
2.- The sole shareholder states that the board of managers will be composed as follows:
a) Mr Konstantinos EMMANOUIL, lawyer, born in Athens, (Greece), on the 14th of March 1952, residing at 18535
Piraeus, 13 Defteras Merarchias Street, (Greece), manager of category A;
b) Mrs Filanthi KATSAFADOU, attorney-at-law, born in Athens (Greece), on the 16th of May 1976, residing in GR-185
35 Piraeus, 13, Defteras Merarchias Street, (Greece), manager of category B; and
99660
c) Mr Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, born in Ettelbruck, on the 27th of March 1973, professionally
residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, manager of category B.
3.- The Company will be validly bound in any circumstances and for any operations by the sole signature of the manager
of category A.
Up to the amount of four thousand Euros (4,000.- EUR), the company may be bound in any circumstances and for any
operations by the individual signature of a manager of category B; for any operations exceeding this value the joint
signatures of the manager of category A and one manager of category B are required.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
mandatory, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the mandatory, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status
and residence, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendacht, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster; (Grossherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED",
mit Sitz in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermudas), eingetragen im Gesell-
schaftsregister der Bermuda-Inseln unter der Nummer 38435,
hier vertreten durch Herrn Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1140 Luxemburg, 45-47, route
d'Arlon, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem
amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben ein-
registriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Gründungsurkunde
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die "Gesellschaft")
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Investition, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung von Grundstücken in Luxemburg oder im Ausland sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit diesen
Grundstücken, einschließlich (i) der direkten oder indirekten Beteiligung an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die
Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Verpachten von Grundstücken ist und (ii) der
Gründung von Filialen, die Grundstücke im Großherzogtum Luxemburg besitzen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "Centurion European German Property 9 S.à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
99661
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter, die drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszen-
dente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-
mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus einem (1) Geschäfts-
führer der Kategorie A und zwei (2) Geschäftsführern der Kategorie B, welche nicht Gesellschafter sein müssen.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Der Geschäftsführerrat kann privatschriftliche oder notariell beglaubigte Spezialvollmachten erteilen.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
99662
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten -Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am ein und dreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2008.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden durch die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-
Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", vorgenannt, gezeichnet und vollständig in bar einbezahlt,
demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), wie dem un-
terzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendzweihundert Euro geschätzt.
<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafteri>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung, hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie hiervor erwähnt, folgende
Beschlüsse gefasst:
1.- Die Gesellschaftssitz wird in L-1140 Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, festgelegt.
2.- Die alleinige Gesellschafterin stellt fest, dass sich der Geschäftsführerrat wie folgt zusammensetzen wird:
99663
a) Herr Konstantinos EMMANOUIL, Anwalt, geboren in Athen, (Griechenland), am 14. März 1952, wohnhaft in 18535
Piraeus, 13 Defteras Merarchias Street, (Griechenland), Geschäftsführer der Kategorie A;
b) Frau Filanthi KATSAFADOU, Anwalt, geboren in Athen, (Griechenland), am 16 Mai 1976, wohnhaft in GR-185 35
Piraeus, 13, Defteras Merarchias Street, (Griechenland), Geschäftsführer der Kategorie B; und
c) Herr Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, geboren in Ettelbrück, am 27 März 1973, beruflich wohnhaft in L-1140
Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, Geschäftsführer der Kategorie B.
3.- Die Gesellschaft wird rechtmäßig in allen Umständen und für alle Verpflichtungen durch die alleinige Unterschrift
des Geschäftsführers der Kategorie A verpflichtet.
Bis zu einem Betrag von viertausend Euro (4.000,- EUR) kann die Gesellschaft in allen Umständen durch die Einzel-
unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet werden; für jegliche Verpflichtungen welche diesen Betrag
überschreiten, ist die Kollektivunterschrift des Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kate-
gorie B erforderlich.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch des Bevollmächtigten gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen desselben Bevollmächtigten
und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: DIDERRICH - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
août 2008, Relation GRE/2008/3219. — Reçu soixante deux euros et cinquante
cents 0,50%= 62,50 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): BENTNER.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, den 6. August 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008101028/231/338.
(080116405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Centurion European German Property 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 140.709.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth of July.
Before M
e
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
The company established under the laws of Bermuda "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", with re-
gistered office in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermuda), inscribed in the
Trade and Companies Register of Bermuda under number 38435,
here represented by Mr. Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, professionally residing in L-1140 Luxembourg,
45-47, route d'Arlon, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by
the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, requests the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a private limited liability company, ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a limited liability company (the "Company") which shall be governed by the law of 10
August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,
lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
99664
real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the
establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The Company will assume the name of "Centurion European German Property 4 S.a r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the surviving associates. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descen-
dants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or documents
of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by a board of managers, composed of one (1) manager of category A and two (2)
managers of category B, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and
may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
99665
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three-quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2008.
<i>Subscription and payment of the sharesi>
The five hundred (500) shares have been subscribed by the company governed by the laws of Bermuda "CENTURION
EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", prenamed, and fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred Euro (12,500.- EUR) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
99666
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euros.
<i>Decisions of the sole share-owneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the aboved-named share owner, represented as said before, has
taken the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
2.- The sole shareholder states that the board of managers will be composed as follows:
a) Mr Konstantinos EMMANOUIL, lawyer, born in Athens, (Greece), on the 14th of March 1952, residing at 18535
Piraeus, 13 Defteras Merarchias Street, (Greece), manager of category A;
b) Mrs Filanthi KATSAFADOU, attorney-at-law, born in Athens (Greece), on the 16th of May 1976, residing in GR-185
35 Piraeus, 13, Defteras Merarchias Street, (Greece), manager of category B; and
c) Mr Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, born in Ettelbruck, on the 27th of March 1973, professionally
residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, manager of category B.
3.- The Company will be validly bound in any circumstances and for any operations by the sole signature of the manager
of category A.
Up to the amount of four thousand Euros (4,000.- EUR), the company may be bound in any circumstances and for any
operations by the individual signature of a manager of category B; for any operations exceeding this value the joint
signatures of the manager of category A and one manager of category B are required.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
mandatory, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the mandatory, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status
and residence, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendacht, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster; (Grossherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED",
mit Sitz in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermudas), eingetragen im Gesell-
schaftsregister der Bermuda-Inseln unter der Nummer 38435,
hier vertreten durch Herrn Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1140 Luxemburg, 45-47, route
d'Arlon, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem
amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben ein-
registriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Gründungsurkunde
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die "Gesellschaft")
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Investition, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung von Grundstücken in Luxemburg oder im Ausland sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit diesen
Grundstücken, einschließlich (i) der direkten oder indirekten Beteiligung an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die
Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder das Verpachten von Grundstücken ist und (ii) der
Gründung von Filialen, die Grundstücke im Großherzogtum Luxemburg besitzen.
99667
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "Centurion European German Property 4 S.à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter, die drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszen-
dente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-
mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus einem (1) Geschäfts-
führer der Kategorie A und zwei (2) Geschäftsführern der Kategorie B, welche nicht Gesellschafter sein müssen.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Der Geschäftsführerrat kann privatschriftliche oder notariell beglaubigte Spezialvollmachten erteilen.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
99668
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am ein und dreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2008.
99669
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden durch die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-
Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", vorgenannt, gezeichnet und vollständig in bar einbezahlt,
demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), wie dem un-
terzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendzweihundert Euro geschätzt.
<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafteri>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung, hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie hiervor erwähnt, folgende
Beschlüsse gefasst:
1.- Die Gesellschaftssitz wird in L-1140 Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, festgelegt.
2.- Die alleinige Gesellschafterin stellt fest, dass sich der Geschäftsführerrat wie folgt zusammensetzen wird:
a) Herr Konstantinos EMMANOUIL, Anwalt, geboren in Athen, (Griechenland), am 14. März 1952, wohnhaft in 18535
Piraeus, 13 Defteras Merarchias Street, (Griechenland), Geschäftsführer der Kategorie A;
b) Frau Filanthi KATSAFADOU, Anwalt, geboren in Athen, (Griechenland), am 16 Mai 1976, wohnhaft in GR-185 35
Piraeus, 13, Defteras Merarchias Street, (Griechenland), Geschäftsführer der Kategorie B; und
c) Herr Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, geboren in Ettelbrück, am 27 März 1973, beruflich wohnhaft in L-1140
Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, Geschäftsführer der Kategorie B.
3. Die Gesellschaft wird rechtmäßig in allen Umständen und für alle Verpflichtungen durch die alleinige Unterschrift
des Geschäftsführers der Kategorie A verpflichtet.
Bis zu einem Betrag von viertausend Euro (4.000,- EUR) kann die Gesellschaft in allen Umständen durch die Einzel-
unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet werden; für jegliche Verpflichtungen welche diesen Betrag
überschreiten, ist die Kollektivunterschrift des Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kate-
gorie B erforderlich.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch des Bevollmächtigten gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen desselben Bevollmächtigten
und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: DIDERRICH - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
ier
août 2008, Relation GRE/2008/3214. — Reçu soixante deux euros et cinquante
cents 0,50%= 62,50 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): BENTNER.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, den 6. August 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008101033/231/338.
(080116418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Dedale Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 43.
R.C.S. Luxembourg B 97.916.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008101004/1640/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08454. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
99670
Astron Buildings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 91.774.
<i>Extrait des résolutions de la réunion du Conseil d'Administration datée du 19 juin 2008i>
Il résulte des décisions prises par le conseil d'Administration de la Société lors de sa réunion en date du 19.06.08:
PRICE WATERHOUSE COOPERS SARL a vu son mandat prendre fin lors de l'AG du 6.08.07.
Venant Krier.
Référence de publication: 2008100989/800594/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 août 2008, réf. DSO-CT00062. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(080116112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Ltad SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 131.986.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008100987/1640/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS11136. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Benton Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 140.693.
STATUTS
L'an deux mille huit, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU
Monsieur Saulius KAROSAS, homme d'affaires, demeurant à CH-1222 Vesenaz, 5, Chemin de la Praly,
ici représenté par Monsieur Nico KRUCHTEN, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1720 Lu-
xembourg, 6, rue Heine, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 21 juillet 2008,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une
société anonyme qu'il déclare vouloir constituer et dont il a arrêté, les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BENTON INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
99671
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310)
actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) par action.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix
des actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs
respectivement par l'administrateur unique.
Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Administration - Surveillance
Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation
du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 10. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signé par au moins un administrateur.
99672
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux
administrateurs ou l'administrateur unique.
Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-
complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les
statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.
Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-
nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.
Art. 13. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, (a) par la
signature individuelle de cet administrateur, et (b) en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux
administrateurs dont obligatoirement celle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était
nommé, ou encore (c) par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué), dans les
limites de ses pouvoirs, ou (d) par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés
par le conseil d'administration.
Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 16. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais
prévus par la loi.
Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation
des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
99673
Dissolution - Liquidation
Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Disposition générale
Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois cent (310) actions ont été souscrites par Monsieur Saulius KAROSAS, homme d'affaires, demeurant à
CH-1222 Vesenaz, 5, Chemin de la Praly.
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents
Euros (€ 1.400,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante représentant l'intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur René FALTZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
b) Monsieur Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
c) Monsieur Nico KRUCHTEN, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue
Heine
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., en abrégé L.O.M.A.C. S.A., avec
siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 22.206.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2010.
4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. KAROSAS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 25 juillet 2008 Relation: ECH/2008/1006. - Reçu cent cinquante-cinq Euros,
31000.-à 0,5% =€155.-.
<i>Le Receveuri> (signé): MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
99674
Echternach, le 29 juillet 2008.
Henri BECK.
Référence de publication: 2008101016/201/191.
(080116154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Quadriconseil SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 96.925.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008101003/1640/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS11120. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080116194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Helvetia Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 77.000.
In the year two thousand eight, on the eleventh day of July.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of HELVETIA EUROPE, a société anonyme, incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, Parc d'Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section
B, number 77000, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, undersigned, dated June 30, 2000,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 890 dated December 14, 2000 (here-
inafter referred to as the "Company").
The meeting is presided by Flora Gibert, notary clerc, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Régis Galiotto, notary clerk, professionally
residing in Luxembourg. The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 1.154.850 shares, representing the whole capital of the Company, are
represented so that, the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been
beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1). Transfer of the registered office of the Company to 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
2). Amendment of Article 2, first sentence of the Company's bylaws, which will henceforth read as follows:
" Art. 2. First sentence. The registered office of the Company is in Luxembourg-city".
3). Election of Mr. Francis Zéler as new Director of Category B of the Company.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to transfer the registered office of the Company to 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend the first sentence of article 2 of the Company's bylaws, which will henceforth read as follows:
" Art. 2. First sentence. The registered office of the Company is in Luxembourg-city".
<i>Third resolutioni>
It is resolved to appoint Mr. Francis ZELER, born in Bastogne (Belgium) on May 5, 1966, director of companies, having
his professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, as new Director of Category B of the Company, his mandate
expiring during the annual general shareholders' meeting which will approve the Company's annual accounts as at De-
cember 31, 2008.
99675
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille huit, le onze juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HELVETIA EUROPE, consti-
tuée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée à la section B du Registre du Commerce et des Sociétés lu-
xembourgeois sous le numéro 77000, constituée selon acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, soussigné, en date du 30
juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 890 du 14 décembre 2000 (ci-après
la «Société»).
L'assemblée est présidée par Flora Gibert, clerc de notaire à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Régis Galiotto, clerc de notaire, à
Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.154.850 actions, représentant l'intégralité du capital social sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Transfert du siège social de la Société au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
2) Modification de la première phrase de l'article 2 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Erster Satz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.»
3) Nomination de M. Francis Zéler comme nouvel Administrateur de Catégorie B de la Société.
Après en avoir délibérer, l'assemblée prend à l'unanimité des voix, chacune des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de transférer le siège social de la Société au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Erster Satz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt."
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de nommer M. Francis Zéler, né à Bastogne (Belgique) le 5 mai 1966, administrateur de sociétés, ayant
son adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme nouvel Administrateur de Catégorie B de la
Société, son mandat se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle ayant à statuer sur les comptes annuels de la
Société au 31 décembre 2008.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F. GIBERT; R. GALIOTTO; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2008. Relation LAC/2008/29167. — Reçu douze euros (12 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
99676
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 01
er
AOUT 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008101085/211/96.
(080117235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Yanaon, Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 114.668.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008100985/1640/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07598. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080116214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Luxtile au Coin du Feu, Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 120.864.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008100986/1640/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07591. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
F.22 Modulbau Société de construction, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 140.682.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundacht, am elften Juli,
Vor dem Unterzeichneten Notar Karine REUTER, mit Amtssitz in Redingen/Attert
Sind erschienen:
Herr Stefan SEER, geboren am 16. Dezember 1965 in Trier (Deutschland), wohnhaft in D-54306 Kordel, Kimmlin-
gerstrasse 27a,
Herr Achim JONAS, geboren am 26. August 1964 in Kordel (Deutschland), wohnhaft in D-54309 NEWEL, Bitbur-
gerstrasse 38a,
Herr Marc Engelmann, geboren am 10. Juli 1974 in Ettelbrück, wohnhaft in L-9376 Bescheid, 24, Merschterwee,
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, der diese Satzung sowie die anwendbaren
Gesetze und insbesondere das Gesetz vom 10.8.1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form (das
„Gesetz von 1915") zu Grunde gelegt werden.
Art. 2. Der Gegenstand der Gesellschaft sind:
- Tiefbau, Erd- und Abrissarbeiten
- Rohbauerrichtung und -fertigstellung
- Innenausbau
- Serviceleistungen für Baustelleinrichtungen einschliesslich Baustellenberäumung
- Transportleistungen
99677
- Handel, Vermietung, Wartung und Pflege von Baumaschinen und Nutzfahrzeugen.
Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätig-
keiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder
unmittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesell-
schaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst
Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „F.22 MODULBAU Société de construction", GmbH.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wickrange.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschaftler innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert euros (12.500,-) und ist in hundert (100) Anteile von
je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,-) eingeteilt.
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Herr Stefan SEER, vorbenannt, VIERUNDDREISSIG ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Herr Achim JONAS, vorbenannt, DREIUNDDREISSIG ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Herr Marc Engelmann, vorbenannt, DREIUNDDREISSIG ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
TOTAL: HUNDERT ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alle Anteile wurden vollständig und in Bar eingezahlt, so daß der Betrag von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro
der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies vom instrumentierenden Notar festgestellt wurde und was die
Gesellschaftlerin anerkennt.
Art. 7. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaft-
santeilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter, sowie von Todes wegen an Nichtgesellschafter, bedarf der einstimmigen
Genehmigung aller Gesellschaftern.
Im Falle eines Abtreten an einen Nichtgesellschafter haben die übrigen Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, das sie inne-
rhalb einer Frist von 30 Tagen ausüben müssen.
Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, wird der Abtretungswert gemäss Artikel 189 absatz 6 und absatz 7 de Gesetzes
über die Handelsgesellschaften berechnet.
Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Gesell-
schaft.
Art. 9. Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Pfändung
oder die Geltendmachung sonstiger Rechte hinsichtlich von Eigentum der Gesellschaft oder Unterlagen der Gesellschaft
stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer - ob Gesellschafter oder nicht - verwaltet,
deren Zahl, Amtsdauer und Befugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch
letztere abberufen werden können, ohne Angabe von Gründen.
Art. 11. Jeder Gesellschafter kann an den Entscheidungen der Gesellschaft teilnehmen. Er ist stimmberechtigt und hat
so viele Stimmen, wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich aufgrund einer schriftlichen Vollmacht rechtsgültig
vertreten lassen.
Art. 12. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über die Änderung der Satzung
sind nur rechtsgültig, soweit sie von einer Mehrheit der Gesellschafter gefasst werden, die mindestens drei Viertel des
Kapitals vertreten.
Art. 13. Im Falle einer Einpersonengesellschaft werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der Gene-
ralversammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.
Art. 14. Der oder die Gesellschaftsführer sind nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich und nicht für die
im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten.
Art. 15. Ein Teil des Gewinnes kann durch Entscheidung der Gesellschafter an die Geschäftsführer ausbezahlt werden.
Art. 16. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise beginnt das jetzige Jahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
99678
Art. 17. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaftern
ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafter legen deren Befugnisse
und Bezüge fest.
Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist die Komparenten auf die gesetzlichen
Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der dies-
bezüglichen Abänderungsgesetze.
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September
1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien
auf eintausend Euro (1.000,-) abgeschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sodann fassten die alleinigen Gesellschafter, welche sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-
menfinden, folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3980 WICKRANGE, 4-6, rue des Trois Cantons
2) Zum administrativen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit wird ernannt:
Herr Stefan SEER, geboren am 16. Dezember 1965 in Trier (Deutschland), wohnhaft in D-54306 Kordel, Kimmlin-
gerstrasse 27a,
3) Zum technischen Geschäftsführer wird auf unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Achim JONAS, geboren am 26. August 1964 in Kordel (Deutschland), wohnhaft in D-54309 NEWEL, Bitbur-
gerstrasse 38a,
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift des technischen Geschäftsführers und durch die Unterschrift
einer der beiden übrigen Gesellschafter rechtskräftig vertreten und verpflichtet.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit
hingewiesen, die eventuellen behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.
Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Wickrange, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Seer, Jonas, Engelmann, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, le 18 juillet 2008, Relation: RED/2008/898. — Reçu soixante-deux euros et cinquante
cents (62,50.-€) à 0,5 % = 62,50 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Kirsch.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zwecks Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Redingen/Attert, den 31. Juli 2008.
Karine REUTER.
Référence de publication: 2008101034/7851/111.
(080115924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Robeco - VCM - Emerging Managers Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 129.717.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2008 a décidé de:
- ratifier la cooptation, avec effet au 30 novembre 2007, de Messieurs Henricus J.P. SAEIJS et Adrianus Antonius VAN
HIENEN en leur qualité d'administrateurs, en remplacement de Messieurs Frank Alexander de Boer et Stéfan F.A. Richter
tous deux démissionnaires en date du 30 novembre 2007,
- de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
Monsieur Ed VAN WIJK, Director, Robeco Asset Management (Deutschland), Grüneburgweg 18, D-60322 Frankfurt
am Main, Allemagne,
Monsieur Henricus J.P. SAEIJS, Senior Vice-President, Robeco Groep N.V., Coolsingel 120, NL-3011 AG Rotterdam,
Pays-Bas,
Monsieur Adrianus Antonius VAN HEINEN, Robeco Luxembourg S.A., 287/289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
et ce pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009,
- de nommer Ernst & Young, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, RCS B-47771, en qualité de Réviseur d'En-
treprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.
99679
<i>Pour ROBECO-VCM-EMERGING MANAGERS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement
Spécialisé
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2008100972/1126/27.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05902. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080115848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Captiva Industrial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 92.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 127.432.
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 1
er
juillet 2008 entre, d'une part, Capindus
B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais ayant son siège social au 208 Herengracht, NL-1016 BS
Amsterdam, Pays-Bas et étant immatriculée à la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34277460 et,
d'autre part, Captiva Capital Partners III S.C.A. une société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant
son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et étant immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.571, que 46.250 parts sociales de la Société d'une valeur nominale de
EUR 1 (un euro) chacune ont été cédées par Capindus B.V. à Captiva Capital Partners III S.C.A. avec effet au 30 juin 2008,
de sorte que Captiva Capital Partners III S.C.A. est désormais l'associé unique de la Société, détenteur de l'intégralité des
92.500 parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
POUR EXTRAIT
<i>Captiva Industrial S.à r.l.
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008100973/5499/24.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01597. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080115836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Caldera Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 136.795.
<i>Extrait du contrat de transfert de parts sociales de la société du 3 juillet 2008i>
En vertu de l'acte de transfert de parts sociales daté du 3 juillet 2008, Luxembourg Corporation Company S.A. a
transféré toutes ses parts sociales détenues dans la Société à Wallace Holdings S.à r.l., une société a responsabilité limitée,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136 772, ayant son siège social
au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 04 août 2008.
Jacques de Patoul.
Référence de publication: 2008100976/9168/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT01089. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080115833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
TPG-Axon (Luxembourg) I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.429.600,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 127.040.
In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of June.
99680
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of TPG-Axon (Luxembourg) I S.à r.l., a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under number B 127.040, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 20 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations on 14 June 2007, number 1161, which articles of incorporation have been last modified by a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 28 April 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciation on 11 June 2008, number 1435 (hereinafter the "Company").
The meeting was opened at 12 a.m. with Ms. Emilie Viard, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, in
the chair, who appointed as secretary Ms. Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifty thousand US dollars (USD 50,000) in order to
bring it from its current amount of one million three hundred seventy-nine thousand six hundred US dollars (USD
1,379,600) up to an amount of one million four hundred twenty-nine thousand six hundred US dollars (USD 1,429,600),
through the issuance of one thousand (1,000) new Class C Shares of the Company with a par value of fifty US dollars
(USD 50) each.
2. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company as follows:
" Art. 6. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of one million four hundred twenty-nine
thousand six hundred US dollars (USD 1,429,600) divided into three hundred ninety (390) Class A Shares, four thousand
thirty-five (4,035) Class B Shares, nine thousand (9,000) Class C Shares and fifteen thousand one hundred sixty-seven
(15,167) Class D Shares, each with a par value of fifty US dollars (USD 50)."
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented by proxy, the proxy holders of the represented shareholders and
the number of their shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the shareholder, the proxy
holders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. That the whole of the corporate capital being present or represented at the present meting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and were fully aware of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole of the corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fifty thousand US dollars
(USD 50,000) in order to bring it from its current amount of one million three hundred seventy-nine thousand six hundred
US dollars (USD 1,379,600) up to an amount of one million four hundred twenty-nine thousand six hundred US dollars
(USD 1,429,600), through the issuance of one thousand (1,000) new Class C Shares of the Company with a par value of
fifty US dollars (USD 50) each.
The one thousand (1,000) new Class C Shares have been subscribed as follows:
(i) six hundred seventy (670) new Class C Shares of the Company have been subscribed by TPG-Axon Partners
(Offshore), Ltd., a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at Goldman Sachs (Cayman) Trust, Limited, PO Box 896, Harbour Centre, 2nd Floor, North Church
Street, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Ms. Andrea Hoffmann, prenamed, by virtue of one of the
aforesaid proxies, at a total subscription price of thirty-three thousand five hundred twenty-one US dollars and forty-
four cents (USD 33,521.44) to be allocated as follows:
i. thirty-three thousand five hundred US dollars (USD 33,500) shall be allocated to the share capital of the Company;
ii. twenty-one US dollars and forty-four cents (USD 21.44) shall be allocated to the share premium account of the
Company;
(ii) three hundred thirty (330) new Class C Shares of the Company have been subscribed by TPG-Axon Partners, L.P.,
a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, United States, registered with the Secretary of State, State of Delaware, USA, here
99681
represented by Ms. Andrea Hoffmann, prenamed, by virtue of one of the aforesaid proxies, at a total subscription price
of sixteen thousand five hundred ten US dollars and fifty-six cents (USD 16,510.56) to be allocated as follows:
i. sixteen thousand five hundred US dollars (USD 16,500) shall be allocated to the share capital of the Company;
ii. ten US dollars and fifty-six cents (USD 10.56) shall be allocated to the share premium account of the Company;
The subscribed Class C Shares have been paid up by the above-mentioned subscribers through a cash contribution of
a total amount of fifty thousand thirty-two US dollars (USD 50,032) and such cash contribution is as of now at the disposal
of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Second Resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the
Company is amended and now reads as follows:
" Art. 6. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of one million four hundred twenty-nine
thousand six hundred US dollars (USD 1,429,600) divided into three hundred ninety (390) Class A Shares, four thousand
thirty-five (4,035) Class B Shares, nine thousand (9,000) Class C Shares and fifteen thousand one hundred sixty-seven
(15,167) Class D Shares, each with a par value of fifty US dollars (USD 50)."
<i>Estimate of Costi>
For the purpose of the registration authorities the amount of USD 50,032.- is valued at EUR 31,658.80.
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 2,000.-
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their names, first names, civil status
and residences, these persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trente juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de TPG-Axon (Luxembourg) I S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège au 5D, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 127.040, constituée suivant acte reçu par M
e
Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations
le 14 juin 2007 sous le numéro 1161, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
le 11 juin 2008, numéro 1435 (ci après la «Société»).
L'assemblée est ouverte à 12 heures sous la présidence de Mademoiselle Emilie Viard, maître en droit, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, ainsi que
Mademoiselle Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante mille dollars US (USD 50.000) afin de le
porter de sa valeur actuelle d'un million trois cent soixante-dix-neuf mille six cents dollars US (USD 1.379.600) à un
montant d'un million quatre cent vingt-neuf mille six cents dollars US (USD 1.429.600), par l'émission de mille (1.000)
nouvelles Parts Sociales de Classe C de la Société, d'une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50) chacune.
2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 6. La Société a un capital émis et entièrement libéré d'un million quatre cent vingt-neuf mille six cents dollars
US (USD 1.429.600) divisé en trois cent quatre-vingt-dix (390) Parts Sociales de Classe A, quatre mille trente-cinq (4.035)
Parts Sociales de Classe B, neuf mille (9.000) Parts Sociales de Classe C et quinze mille cent soixante-sept (15.167) Parts
Sociales de Classe D, ayant chacune une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50).»
3. Divers.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
99682
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ainsi, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante mille dollars US
(USD 50.000) afin de le porter de sa valeur actuelle d'un million trois cent soixante-dix-neuf mille six cents dollars US
(USD 1.379.600) à un montant d'un million quatre cent vingt-neuf mille six cents dollars US (USD 1.429.600), par l'émission
de mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C de la Société, d'une valeur nominale de cinquante dollars US (USD
50) chacune.
Les mille (1.000) nouvelles Parts Sociales de Classe C de la Société ont été souscrites comme suit:
- six cent soixante-dix (670) nouvelles Parts Sociales de Classe C de la Société ont été souscrites par TPG-Axon
Partners (Offshore), Ltd., une limited company constituée et régie pour les loirs des Iles Caïman, ayant son siège social
au Goldman Sachs (Cayman) Trust, Limited, PO Box 896, Harbour Centre, 2nd Floor, North Church Street, Grand
Cayman, Cayman Islands, ici représentée par Mademoiselle Andrea Hoffmann, prénommée, en vertu d'une des procu-
rations dont mention ci-avant, pour un prix de souscription total de trente-trois mille cinq cent vingt et un dollars US et
quarante-quatre cents (USD 33.521,44) alloués comme suit:
(i) trente-trois mille cinq cents dollars US (USD 33.500) seront alloués au capital social de la Société; et
(ii) vingt et un dollars US et quarante-quatre cents (USD 21,44) seront alloués à la prime d'émission de la Société;
- trois cent trente (330) nouvelles Parts Sociales de Classe C de la Société ont été souscrites par TPG-Axon Partners,
L.P., une limited partnership constituée et régie par les lois du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, United States, inscrite au Secretary of State, State of Delaware, ici représentée par Ma-
demoiselle Andrea Hoffmann, prénommée, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, pour un prix de
souscription total de seize mille cinq cent dix dollars US et cinquante-six cents (USD 16.510,56) alloués comme suit:
(i) seize mille cinq cents dollars US (USD 16.500) seront alloués au capital social de la Société; et
(ii) dix dollars US et cinquante-six cents (USD 10,56) seront alloués à la prime d'émission de la Société;
Les Parts Sociales de Classe C de la Société ainsi souscrites ont été libérées par les souscripteurs mentionnés ci-dessus,
par un apport en numéraire d'un montant total de cinquante mille trente-deux dollars US (USD 50.032) et cet apport
est désormais à la disposition de la Société, tel qu'il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième Résolutioni>
A la suite de la résolution ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article six (6)
des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. La Société a un capital émis et entièrement libéré d'un million quatre cent vingt-neuf mille six cents dollars
US (USD 1.429.600) divisé en trois cent quatre-vingt-dix (390) Parts Sociales de Classe A, quatre mille trente-cinq (4.035)
Parts Sociales de Classe B, neuf mille (9.000) Parts Sociales de Classe C et quinze mille cent soixante-sept (15.167) Parts
Sociales de Classe D, ayant chacune une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50).»
<i>Estimation des fraisi>
Pour les besoins de l'enregistrement le montant de USD 50.032.- est évalué à EUR 31.658,80.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 2,000.-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. VIARD, A. HOFFMANN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juillet 2008, Relation: LAC/2008/28406. — Reçu cent cinquante-huit euros
soixante-neuf cents (158.69).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
99683
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008101063/242/176.
(080116783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Wallace Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 136.772.
<i>Extrait du contrat de transfert de parts sociales de la société du 3 juillet 2008i>
En vertu de l'acte de transfert de parts sociales daté du 3 juillet 2008, Luxembourg Corporation Company S.A. a
transféré toutes ses parts sociales détenues dans la Société à Falcor Investments S.à r.l, une société a responsabilité limitée,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134 128, ayant son siège social
au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 04 août 2008.
Jacques de Patoul.
Référence de publication: 2008100977/9168/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT01091. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080115832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Elemental Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 136.778.
<i>Extrait du contrat de transfert de parts sociales de la société du 3 juillet 2008i>
En vertu de l'acte de transfert de parts sociales daté du 3 juillet 2008, Luxembourg Corporation Company S.A. a
transféré toutes ses parts sociales détenues dans la Société à Nila S.à r.l., une société a responsabilité limitée, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136 773, ayant son siège social au 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 04 août 2008.
Jacques de Patoul.
Référence de publication: 2008100978/9168/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT01090. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080115831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
MK European Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 464.525,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 113.944.
In the year two thousand eight, on the twenty seventh of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
MK European Capital Partners LP, a limited partnership incorporated and governed by the laws of the state of Delaware
(USA), with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, state of Delaware, United States of Amer-
ica.
here represented by Mrs Sarah Lecomte, with professional address at allée Scheffer, 1, L-2520 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal.
Said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg
under the name of MK European Capital Partners S.à r.l., with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
99684
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number
113.944, incorporated by a deed of Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated January 31st, 2006,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1107, on June 8, 2006 and whose Articles of
Association have been amended pursuant to a deed of Maître Jean Joseph Wagner, aforementioned, dated August 7, 2006
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1879, on October 10, 2006 and pursuant to
a deed of Maître Jean Joseph Wagner, aforementioned, dated December 14, 2006, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 477, on March 28, 2007 (the "Company").
II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred
(500) shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-in.
III. The sole shareholder took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital by an amount of four hundred fifty two thousand twenty
five Euro (EUR 452,025) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to four
hundred sixty four thousand five hundred twenty five Euro (EUR 464,525) by creation and issuance of eighteen thousand
eighty one (18,081) new shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each, having the same rights and obligations
than the existing shares, such shares to be fully paid up in par value, together with a share premium of twenty one Euro
forty three Cent (EUR 21.43).
<i>Second resolutioni>
<i>Intervention - subscription - paymenti>
The sole shareholder, declared to subscribe to the eighteen thousand eighty one (18,081) new shares with a par value
of twenty five Euro (EUR 25) and fully pay them up in the amount of four hundred fifty two thousand twenty five Euro
(EUR 452,025) together with a share premium of an aggregate amount of twenty one Euro forty three Cent (EUR 21.43)
by contribution in kind consisting in the conversion into the share capital of part of an uncontested, current and imme-
diately exercisable claim against the Company for an amount of four hundred fifty two thousand forty six and forty-three
Euro (EUR 452,046.43) (hereafter the "Shareholder's Advances").
Evidence of the contribution by the conversion of the Shareholder's Advances has been given to the undersigned notary
public by a copy of a contribution agreement entered into by and between the Company and the sole shareholder.
Said contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the sole shareholder and the
undersigned notary public, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The conversion of the Shareholder's Advances has been dealt within an independent auditor's report issued on May
27th, 2008 by Ernst & Young Tax advisory Sàrl, with registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, which
concludes as follows:
"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe
that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 18,081 shares
of nominal value EUR 25.00 each, to be issued with total related share premium of EUR 21.43, hence total consideration
amounting to EUR 452,046.43".
<i>Fourth resolutioni>
Pursuant to the above increase of share capital, Article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth
read as follows:
" Art. 6. The capital is set at four hundred sixty four thousand five hundred twenty five Euro (EUR 464,525) represented
by eighteen thousand five hundred eighty one (18,581) shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each."
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at 4,300.- Euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-sept mai à Luxembourg.
99685
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MK European Capital Partners LP., une société constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège
social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware (USA), Etats-Unis d'Amérique;
ici représentée par Mme Sara Lecomte, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de MK European Capital Partners S.à r.l., ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand- Duché
de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 113.944, constituée
par acte de Maître Jean Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, daté du 31 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1107, du 8 juin 2006 et dont les statuts ont été modifiées par un acte de Maître
Jean Joseph Wagner, mentionné ci dessus, du 7 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1879, le 10 octobre 2006, par un acte de Maître Jean Joseph Wagner, mentionné ci dessus, du 14 décembre
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 477, le 28 mars 2007 (ci après la "Société").
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500) représenté par cinq cent (500)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune, entièrement souscrites et libérées.
III. L'associée unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent cinquante-deux mille vingt-cinq
Euro (EUR 452.025) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500) à quatre cent
soixante-quatre mille cinq cent vingt-cinq Euro (EUR 464.525) par la création et l'émission de dix huit mille quatre-vingt
une (18.081) nouvelles parts sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que
les parts sociales existantes, qui seront intégralement libérées avec une prime d'émission de vingt et un Euro quarante-
trois Centimes (EUR 21,43).
<i>Seconde résolutioni>
<i>Intervention - Intervention - Souscriptioni>
L'associé unique, par son mandataire, déclare souscrire aux dix huit mille quatre-vingt une (18.081) nouvelles parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune et les libérer intégralement pour un montant de
quatre cent cinquante-deux mille vingt-cinq Euro (EUR 452.025) ensemble avec une prime d'émission de vingt et un Euro
quarante-trois Centimes (EUR 21,43), par apport en nature par conversion en capital d'une partie d'une créance certaine,
liquide et immédiatement exigible sur la Société d'un montant de quatre cent cinquante-deux mille quarante-six Euro
quarante-trois Centimes (EUR 452.046,43) (ci après les "Avances").
Preuve de l'apport de la conversion des Avances a été donnée au notaire instrumentaire au moyen d'une copie du
contrat d'apport signé entre la Société et l'Associé unique, susmentionnés.
Ledit contrat d'apport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire du souscripteur et le notaire instrumentaire,
demeurera joint au présent acte pour être enregistré auprès des autorités.
<i>Troisième résolutioni>
La conversion des Avances est traité dans un rapport de réviseur indépendant émis le 27 mai 2008 par Ernst & Young
Tax advisory Sàrl, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, qui conclu que:
"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe
that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 18,081 shares
of nominal value EUR 25.00 each, to be issued with total related share premium of EUR 21.43, hence total consideration
amounting to EUR 452,046.43".
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent soixante quatre mille cinq cent vingt-cinq Euro (EUR 464.525) représenté
par dix huit mille cinq cent quatre-vingt-une (18.581) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25)
chacune."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 4.300,- Euro.
99686
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connue du notaire par ses nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 mai 2008. Relation: LAC/2008/21550. — Reçu deux mille deux cent soixante
euros et vingt-trois cents (2.260,23 €).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Franck SCHNEIDER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 05 juin 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008101067/211/147.
(080116006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2008.
Medici SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4398 Pontpierre, 13, Am Armschlag.
R.C.S. Luxembourg B 100.664.
L'an deux mille huit, le trente juillet.
s'est tenue par-devant le soussigné Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme MEDICI SA, ayant son siège social à L-4011 Esch/Alzette,
15, rue de l'Alzette, inscrite au RCSL sous le numéro B 100.664,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, alors de résidence à Mersch, en date du 29 avril
2004, publié au Mémorial C numéro 679 du 02 juillet 2004,
et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés. L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Sandro
PICA, employé privé, demeurant à Esch/Alzette,
qui désigne comme secrétaire Madame Véronique BARATON, employée privée, demeurant à Garnich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Manon HOFFMANN, employée privée, demeurant à Koerich.
Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été paraphée «ne varietur» sera enregistrée avec le présent acte.
Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc
pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:
Siège social:
Le siège de la société est transféré à L-4398 Pontpierre, 13, Armschlag.
La 1
ère
phrase de l'article 2 des statuts est modifiée comme suit:
«Le siège social est établi dans la Commune de Mondercange.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 15.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par nom, prénom,
état et demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. PICA, V. BARATON, M. HOFFMANN, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 31 juillet 2008. Relation: CAP/2008/2442. — Reçu douze euros. 12,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. Neu.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Capellen, le 6 août 2008.
Camille MINES.
Référence de publication: 2008101071/225/37.
(080117259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
99687
CEREP Investment T S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.155,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 116.257.
In the year two thousand and eight, on the twenty fourth of July,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,
THERE APPEARED:
CEREP II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 107.559 (the "Sole Unitholder");
in its capacity as Sole Unitholder of CEREP Investment T S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 116.257 and
incorporated by a deed drawn up by M
e
Elvinger, prenamed, on 12 April 2006 and whose articles of incorporation (the
"Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1345,
dated on 12 July 2006, page 64525; since the incorporation of the Company, the Articles have been amended several
times and for the last time on 31 May 2007, pursuant to a deed drawn up by Maître Joseph Elvinger, prenamed, and
published in the Mémorial number 1638, dated on 3 August 2007, page 78605;
hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").
The Sole Unitholder is represented at the meeting by Flora Gibert, jurist, residing at Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing
person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
<i>First resolutioni>
The Sole Unitholder resolves to increase the Company's unit capital by an amount of six thousand four hundred and
ninety-five British Pounds (GBP 6,495.-) so as to bring the unit capital from its current amount of eight thousand six
hundred and sixty British Pounds (GBP 8,660.-) to fifteen thousand one hundred and fifty-five British Pounds (GBP
15,155.-) by changing the nominal value of the existing units from twenty British Pound (GBP 20.-) per unit to thirty-five
British Pounds (GBP 35.-) per unit.
Therefore, the global contribution of six thousand four hundred and ninety-five British Pounds (GBP 6,495.-) for the
new units will be entirely allocated to the unit capital.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Articles of the Company is amended and now
reads as follows:
" Art. 6. The unit capital is fixed at fifteen thousand one hundred and fifty-five British Pounds (GBP 15,155.-), repre-
sented by four hundred and thirty-three (433) units of thirty five British Pounds (GBP 35. -) each ".
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, said proxyholder of the appearing person signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-quatre juillet,
Par-devant M
e
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
A COMPARU:
99688
CEREP II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 107.559 (l'"Associé Unique");
en qualité d'Associé Unique de CEREP Investment T S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce de Luxembourg sous le numéro B 116.257 et constituée selon un acte dressé par M
e
Elvinger, prénommé,
le 12 avril 2006 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
"Mémorial") numéro 1345, en date du 12 juillet 2006, page 64525;
depuis la création de la Société, les Statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 31
mai 2007, par un acte de Maître Joseph Elvinger, prénommé, et publié au Mémorial numéro 1638, en date du 3 août 2007,
page 78605;
prend ici les résolutions suivantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée (la "Loi").
L'Associé Unique est représenté à l'assemblée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé, qui, paraphée ne varietur par la mandataire du comparant et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de six mille quatre
cent quatre-vingt quinze Livres Sterling (GBP 6.495-) afin de le porter de son montant actuel de huit mille six cent soixante
Livres Sterling (GBP 8.660-) à quinze mille cent cinquante-cinq Livres Sterling (GBP 15.155-) en changeant la valeur
nominale des parts sociales existantes de vingt Livre Sterling (GBP 20-) à trente-cinq Livres Sterling (GBP 35-) par part
sociale.
L'apport total de six mille quatre cent quatre-vingt quinze Livres Sterling (GBP 6.495-) sera entièrement alloué au
capital social de la Société.
Les documents justificatifs de l'existence et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
" Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille cent cinquante-cinq Livres Sterling (GBP 15.155-) représenté par quatre
cent trente-trois (433) parts sociales d'une valeur nominale de trente-cinq Livres Sterling (GBP 35-) chacune".
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille deux cents Euro.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire instru-
mentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la personne comparante a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: F. GIBERT; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juillet 2008. Relation LAC/2008/31204. - Reçu quarante et un euros seize cents
(41,16€).
<i>Le Receveuri> (signé): FRANCIS SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 04 AOUT 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008101086/211/102.
(080117231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Primetec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 41.654.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 25 juillet 2008i>
Révocation de deux Administrateurs en fonction, à savoir:
- Monsieur Yves FIEDERSPIEL, demeurant au 19, rue des Carrefours, L-8124 Bridel,
99689
- Monsieur Martin HEYSE, demeurant au 61, rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort,
Nomination de Monsieur Claude MACK, demeurant professionnellement au 31, rue Notre-Dame, L-2240 Luxem-
bourg, au poste d'Administrateur de la société. Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2009;
Reconduction du mandat de Monsieur Yves FEDERSPIEL, demeurant professionnellement au 31, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg, au poste d'administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>PRIMETEC S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008102153/780/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04173. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080117935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.
Tanzanite S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 113.278.
<i>Extrait des résolutions des Associés prises en date du 2 juillet 2008i>
Les Associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de:
* Monsieur Carl Manning O'Connell en tant que Gérant et ce avec effet au 29 avril 2008;
Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Pour extrait analytique conforme
Hille-Paul Schut
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008102152/9168/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT03405. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080117927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.
MSEOF Bayerstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.161.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 112.897.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 25 juillet 2008i>
L'associé unique de la société a décide, en date du 25 juillet 2008, de nommer Ernst & Young Luxembourg S.A., ayant
son siège au 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach et étant enregistrée au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro B 88.019, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat pour une période se
terminant le jour de la prochaine approbation des comptes annuels de la Société par le(s) associé(s).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 30 juillet 2008.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008102147/1138/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT03450. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080117852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.
99690
AGF Benelux S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Franklin Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 35.910.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008101741/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01262. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080117653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.
AGF Benelux S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Franklin Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 35.910.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008101742/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01263. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080117656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.
AGF Benelux S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Franklin Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 35.910.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008101740/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01260. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080117648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.
IDI Emerging Markets SA, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 139.111.
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 09 juillet 2008 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Capellen, le 05 août 2008.
Camille MINES
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008101546/225/12.
(080116997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
99691
Marline Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 105.645.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 4 août 2008.
Paul BETTINGEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008101550/222/12.
(080117078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Arenamar Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 74.787.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2008.
<i>Pour ARENAMAR INVEST S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008101577/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS13016. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Sirio Rail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 96.631.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2008.
<i>Pour SIRIO RAIL S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008101578/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS13017. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Mavico Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 39.946.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2008.
<i>Pour MAVICO HOLDING S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008101579/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT00781. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
99692
MGM 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 117.549.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 30 juillet 2008.
Paul BETTINGEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008101571/202/12.
(080117043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
L'Automobil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.205.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2008.
<i>Pour L'AUTOMOBIL S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008101580/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT00784. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Royal Almendros Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 106.179.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2008.
<i>Pour ROYAL ALMENDROS FINANCE S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008101576/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS13014. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Finmac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 74.962.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2008.
<i>Pour FINMAC S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008101575/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2008, réf. LSO-CS13010. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
99693
Interpillar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 62.189.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2008.
<i>Pour INTERPILLAR S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008101573/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT00791. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080116671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Greggio Group International - The Silver Network S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.826.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2008.
<i>Pour GREGGIO GROUP INTERNATIONAL - THE SILVER NETWORK S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008101574/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2008, réf. LSO-CT00001. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Global Fund, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 132.259.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
CAPELLEN, le 07/08/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008101581/825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02455. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Gestec Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 19, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 57.339.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
<i>Pour compte de GESTEC LUXEMBOURG S.A.
i>Fiduplan S.A.
Signature
Référence de publication: 2008101582/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02448. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
99694
Global Facilities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 85.115.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
<i>Pour compte de Global Facilities S.A.
i>Fiduplan S.A.
Signature
Référence de publication: 2008101583/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02450. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080116761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Parc Val Ste Croix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 2A, Beim Dreieck.
R.C.S. Luxembourg B 104.982.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07/08/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008101584/619/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02441. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Legend Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R.C.S. Luxembourg B 121.425.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008101589/1171/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02305. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080117414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2008.
MAP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4750 Pétange, 35, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 64.079.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MAP SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2008101181/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS03052. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080117144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
99695
Thomann Hanry Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 49.798.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour THOMANN HANRY LUXEMBOURG SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2008101179/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS03058. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080117156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
SDP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale.
R.C.S. Luxembourg B 132.856.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SDP 1 SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2008101177/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04070. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080117023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Store Rollingergrund, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 165, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 67.794.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour STORE ROLLINGERGRUND SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2008101175/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04079. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080117034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Louis XIV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 52.730.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008101197/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2008, réf. LSO-CT02557. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080116574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
99696
AGF Benelux S.A.
AGF Benelux S.A.
AGF Benelux S.A.
Arenamar Invest S.A.
Astron Buildings S.A.
BALTHASAR FinPar SA
Benton Investments S.A.
Caldera Sàrl
Captiva Industrial S.à r.l.
Centurion European German Property 10 S.à r.l.
Centurion European German Property 4 S.à r.l.
Centurion European German Property 9 S.à r.l.
CEREP Investment T S.à.r.l.
Dedale Project S.A.
Elemental Sàrl
F.22 Modulbau Société de construction
Finmac S.A.
Gestec Luxembourg S.A.
Global Facilities S.A.
Global Fund
G.N. Research S.A.
Greggio Group International - The Silver Network S.A.
Helvetia Europe
IDI Emerging Markets SA
Interpillar S.A.
L'Automobil S.A.
Legend Invest S.à r.l.
Louis XIV S.A.
Ltad SA
Luxtile au Coin du Feu
MAP S.à r.l.
Marline Holding S.A.
Mavico Holding S.A.
Medici SA
MGM 1 S.à r.l.
MK European Capital Partners S.à r.l.
MSEOF Bayerstrasse S.à r.l.
Parc Val Ste Croix S.A.
Primetec S.A.
Quadriconseil SA
Robeco - VCM - Emerging Managers Fund
Royal Almendros Finance S.A.
SDP 1 S.à r.l.
Securitas S.A.
Sirio Rail S.A.
Store Rollingergrund
Tantal S.A.
Tanzanite S.à r.l.
Tecnomatix Technologies S.à r.l.
Thomann Hanry Luxembourg Sàrl
TPG-Axon (Luxembourg) I S.à r.l.
Wallace Holdings Sàrl
Yanaon