This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1980
13 août 2008
SOMMAIRE
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 2 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94997
Babcock & Brown European Investments
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94994
Castle Property Investment S.A. . . . . . . . .
95030
Clarac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95033
Conostix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95007
Crosscheck (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . .
95005
CVI GVF Luxembourg Thirty S. à r.l. . . . .
95009
CVI GVF Luxembourg Twenty-Five S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95023
CVI GVF Luxembourg Twenty-Seven S. à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94998
CVI GVF Luxembourg Twenty-Six S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95016
ENB Lux 1 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95030
Gemplus International S.A. . . . . . . . . . . . . .
95005
Genova Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94997
J2CG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95031
JPMorgan European Property Fund Mana-
gement Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
95007
JPMorgan European Property Holding Lu-
xembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95007
JPMorgan European Property Holding Lu-
xembourg 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94994
JPMorgan European Property Holding Lu-
xembourg 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94994
Karibik, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95035
Maitland Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
95031
Nalozo S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95031
Participations 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94997
Platines Holding SPF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
95038
Prestacompta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95032
RAE Angers S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95030
REO STZ, S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95030
S.C.I. St. SABIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95005
Silcart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95009
Starsun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95036
Subcart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94998
Subtarc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95016
TARC Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95023
Tedeco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94997
Virtual Network S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95038
94993
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 106.900.
Il est à noter que Monsieur Steven Greenspan et Monsieur Steven Mastrovich, administrateurs de la Société, ont changé
d'adresse et résident désormais au 245, Park Avenue, 10167 New-York, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 4 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008096172/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10759. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080110005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 106.901.
Il est à noter que Monsieur Steven Greenspan et Monsieur Steven Mastrovich, administrateurs de la Société, ont changé
d'adresse et résident désormais au 245 Park Avenue, 10167 New-York, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 5 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008096173/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10763. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080110008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 109.507.
In the year two thousand eight, on the eleventh day of July.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
B&B MH 3 Co LIMITED, a Maltese company, having its registered office at 171 Old Bakery Street, Valletta VLT 09,
Malta and registered under number C 36861
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing in Luxembourg
by virtue of a proxy given under private seal on July 8th, 2008
Said proxy after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to
the present deed.
The appearing, represented as said before, acting in their capacity of sole shareholders of the Company, have requested
the undersigned notary to pass the following:
The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company BABCOCK & BROWN EUROPEAN
INVESTMENTS S.à r.l, having its registered office in L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker (the "Company"),
registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg, under section B, number 109.507
incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 22 June 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number C - 1292 of 29 November 2005
94994
The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to pass the following
resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of five million euros (EUR 5.000.000.-) so
as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500.-) divided into five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each to an amount of five million twelve thousand five hundred Euro (EUR
5,012,500.-) by the creation and issuing of two hundred thousand (200.000) new shares with a nominal value of twenty-
five euro (EUR 25.-), and to make payment for such new shares by a contribution in kind consisting of a conversion of a
claim of the same amount which the Subscriber has against the Company (the «First Contribution»).
The Shareholder further resolves to increase the corporate capital by an amount of four million six hundred thirty
one thousand euros (EUR 4.631.000.-) so as to raise it from its present amount of five million twelve thousand five hundred
Euro (EUR 5,012,500.-) divided into two hundred thousand five hundred (200,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each to an amount of nine million six hundred forty three thousand five hundred Euro (EUR 9,643,500.-) by the creation
and issuing of one hundred eighty five thousand two hundred and forty (185.240) new shares with a nominal value of
twenty-five euro (EUR 25.-), and to make payment for such new shares by a contribution in kind consisting of a conversion
of a claim of the same amount which the Subscriber has against the Company (the «Second Contribution»).
The First Contribution and the Second Contribution thus is recorded as a contribution in an aggregate amount of nine
million six hundred thirty one thousand euro (EUR 9,631,000.-)
The Subscriber declares that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the
Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.
The Sole Shareholder declares together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the
valid transfer to the Company of the Contribution.
The Sole Shareholder further states that a statement has been drawn up by the managers of the Company, wherein
the First Contribution and the Second Contribution so contributed are described and valued.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles
of incorporation, which shall from now on read as follows:
"The issued capital of the Company is set nine million six hundred forty three thousand five hundred Euro (EUR
9,643,500.-) divided into three hundred eighty five thousand seven hundred and forty (385,740) shares with a nominal
value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at approximately EUR 53,000.-
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, well known by the notary, by her surname,
first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil huit, le onze juillet.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
B&B MH 3 Co LIMITED, une société maltaise, ayant son siège social à 171 Old Bakery Street, Valletta VLT 09, Malta
et inscrite sous le numéro C 36861
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé, le 8 juillet 2008.
laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant restera
annexée aux présentes.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en leur qualité d'associée unique, représentant l'inté-
gralité du capital social a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
La comparante, représentée comme ci-avant, étant la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée
BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS S.à r.l. avec siège social à L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse
Weicker (la "Société"),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 109.507,
94995
constituée le 22 juin 2005 par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro C - 1292 du
29 novembre 2005
Laquelle associée unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire ins-
trumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune à un montant de cinq millions douze mille
cinq cents euros (5.012.500,- EUR) par la création et l'émission de deux cents mille (200.000) nouvelles parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), et de libérer intégralement ces parts sociales nouvelles par un
apport en nature constituée par une conversion d'une créance du même montant que le Souscripteur a contre la Société
(le «Premier Apport»).
L'Associé décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de quatre millions six cent trente et un mille
euros (4.631.000,-EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq millions douze mille cinq cents euros (5.012.500,-
EUR) représenté par deux cent mille cinq cents (200.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-
EUR) chacune à un montant de neuf millions six cent quarante trois mille cinq cents euros (9.643.500,- EUR) par la création
et l'émission de cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quarante (185.240) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR), et de libérer intégralement ces parts sociales nouvelles par un apport en nature constituée
par une conversion d'une créance du même montant que le Souscripteur a contre la Société (le «Deuxième Apport»).
Le Premier Apport et le Deuxième Apport sont actes comme représentant un apport total net d'un montant de neuf
millions six cent trente et un mille euros (9.631.000,- EUR).
L'Associée Unique déclare encore qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de cet Apport à la Société et
que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.
L'Associée Unique déclare qu'une attestation a été établie par le gérant de la Société, sur laquelle le Premier Apport
et le Deuxième Apport ainsi apportés sont décrits et évalués.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5
des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à neuf millions six cent quarante trois mille cinq cents euros (9.643.500,-
EUR) divisé en trois cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante (385.740) parts sociales d'une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à 53.000,-EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais
suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la
version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-
ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2008. Relation: LAC/2008/29191. - Reçu € 48155.- (quarante-huit mille
cent cinquante-cinq Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2008.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2008095868/206/128.
(080110692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
94996
Tedeco Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 55.070.
La société Axiome Audit Sàrl dans les bureaux de laquelle la société anonyme TEDECO HOLDING S.A. avait fait
élection de son siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg a dénoncé avec effet à ce jour, le siège social
de ladite société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Marco Ries
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008096138/768/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2008, réf. LSO-CS09617. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080110043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Genova Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 90.369.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008096074/5770/12.
(080110436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 124.351.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008096062/5770/12.
(080110494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Participations 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 117.742.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2008.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2008096205/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07446. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080109940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
94997
Subcart S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.677.455,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 104.770.
<i>Extrait de la résolution adoptée par l'actionnaire unique de la Société le 3 juillet 2008i>
Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique du 3 juillet 2008 que l'actionnaire unique a accepté la démission de
Monsieur Alistair Boyle, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
Il en résulte qu'à compter du 3 juillet 2008, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- Peter Gibbs
Séverine Michel
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008096214/3794/19.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06233. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080110165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
CVI GVF Luxembourg Twenty-Seven S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 140.400.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the eighth of July.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119.271, duly represented by Lucinda Clifton-Bryant,
private employee, by virtue of a proxy given in Luxembourg on July 4th, 2008.
This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a
société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited
liability for all debts and obligations of such entities.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale, as well the holding, leasing, improving, managing and
mortgaging of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of
all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg
or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or
lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
94998
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of "CVI GVF Luxembourg Twenty-Seven S. à r.l."
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the
term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
94999
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's financial year commences on June 1st and ends on May 31st.
Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
95000
<i>Subscription and Paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (Lux) Master
S. à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500), entirely allocated to the share capital.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as
of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 May
2009.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred
euro (EUR 1,500).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally
at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Mr Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally
at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendacht, am achten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
CVI GVF (Lux) Master S. à r.l, eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Ge-
sellschaftsregister unter Nummer B 119.271, hier vertreten durch Lucinda Clifton-Bryant, Privatangestellte, wohnhaft in
Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 4. Juli 2008.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung „ne varietur" durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-
chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.
Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung,
die Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie
die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in lu-
95001
xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "CVI GVF Luxembourg Twenty-Seven S. à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Be-
schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch
einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere
Filialen können entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.
Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund ("cause légitime") hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort
einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Ge-
schäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
95002
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.
Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied sowie deren Erben, Nach-
lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit,
einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer oder das Geschäftsführerratsmitglied auf Grund seiner
Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf
Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und
von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegen-
heiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute
intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten
gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber
informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf
Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.
Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszu-
schütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag
nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen
Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und
der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai.
95003
Art. 22. Am einunddreißigsten Mai eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer
stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Zwischendividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder
gegebenenfalls der alleinige Gesellschafter, legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Insofern nicht
anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., vorgenannt,
gezeichnet und durch eine Bareinlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingezahlt, die vollständig
dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) verfügt, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2009.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschafts-
kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Gregor Klaedtke, geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 11-13, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg; und
- Herr Hille-Paul Schut, Jurist, geboren am 29. September 1977 in 's-Gravenhage, Niederlande, beruflich wohnhaft in
20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
Signé: L. Clifton-Bryant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 10 juillet 2008, LAC/2008/28447. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents (EUR
0,5% = 62,50).
<i>Le receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008095903/5770/359.
(080110471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
95004
Crosscheck (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 131.538.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008096053/5770/12.
(080110409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Gemplus International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 73.145.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par voie de résolutions circulaires par le conseil d'administration de GEMPLUS INTER-
NATIONAL S.A. (la «Société») en date du 8 juillet 2008 et de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue à
Luxembourg en date du 14 juillet 2008 que le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été
renouvelé pour un terme d'une année, le mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les
comptes annuels de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2008.
<i>Pour Gemplus International S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008096164/260/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10760. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080110268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
S.C.I. St. SABIN, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg E 403.
DISSOLUTION
L'an deux mille huit, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach,
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Jean-Claude Maurice Paul SCHOEPFER, retraité, ex-dirigeant de société, né à Paris, le 16 juillet 1936,
demeurant à F-06150 Cannes la Bocca (Alpes Maritimes), avenue Maurice Chevalier, 124, Domaine des Palmiers, Bâtiment
4,
et son épouse
2.- Madame Françoise Georgette Henriette Marie ROUX, retraitée, ex-comptable, née à Saint Maur des Fosses (Val-
de-Marne), le 7 décembre 1942, demeurant à F-94670 Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 2, rue des Remparts,
déclarant être mariés sous le régime de la séparation des biens en vertu d'un contrat de mariage reçu par Maître Pierre
BONSERGENT, notaire à Paris, en date du 28 juin 1968.
Lequel comparant sub (1) est ici représenté par Monsieur Christophe MIGNANI, expert-comptable, et laquelle com-
parante sub (2) est ici représentée par Madame Magali ZEHREN, comptable, les deux demeurant professionnellement à
L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 2 juillet
2008,
lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront
annexées en copie au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont exposé au notaire et l'ont prié d'acter ce qui suit:
95005
I.- Que les comparants sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. ST. SABIN, avec siège social à
L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro E
403.
II- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, de résidence à
Luxembourg, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés numéro 568 du 25 juillet 2001,
et dont les statuts ont été modifiés comme suit:
- suivant acte reçu par le même notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 9 août 2001, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés numéro 120 du 23 janvier 2002;
- suivant acte reçu par le même notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 21 décembre 2002, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés numéro 243 du 6 mars 2003.
III.- Que le capital social de la société s'élève actuellement à cent soixante-douze mille neuf cent vingt Euros (€
172.920.-), représenté par dix-sept mille deux cent quatre-vingt-douze (17.292) parts d'intérêt de dix Euros (€ 10.-)
chacune.
Que suite à une cession de parts d'intérêt sous seing privé du 5 novembre 2007, enregistrée à Luxembourg, le 11
décembre 2007, Référence: LSO CL/02707, les parts d'intérêt sont attribuées aux associés comme suit:
1.- Monsieur Jean-Claude SCHOEPFER, prénommé, huit mille six cent quarante-six parts d'intérêt . . . . . .
8.686
2.- Madame Françoise ROUX, prénommée, huit mille six cent quarante-six parts d'intérêt . . . . . . . . . . . . .
8.686
Total: dix-sept mille deux cent quatre-vingt-douze parts d'intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.292
IV.- Que la société ne possède pas des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg.
Ensuite les associés ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés déclarent dissoudre et liquider purement et simplement aux droits des parties la prédite société civile
immobilière S.C.I. ST. SABIN avec effet immédiat. Ils s'engagent à reprendre personnellement et conformément à leurs
parts sociales l'actif et le passif de la société dissoute.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés déclarent expressément que la société ne détient pas des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans le cadre de la liquidation il est attribué aux associés, proportionnellement à leur participation respective dans le
capital social, les immeubles que la société détient en France.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés donnent pleine et entière décharge à la gérante de la société pour l'exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: à F-94670
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 2, rue des Remparts.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés donnent mandat à Maître Anne Catherine VINCKE, notaire, demeurant professionnellement à F-94670
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 9, Place de la Gare, de faire le nécessaire en vue de la formalisation du présent acte en
France.
<i>Constatationi>
Suite aux résolutions qui précèdent les associés constatent que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et
requièrent la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Les associés donnent décharge au notaire instrumentant pour toutes les conséquences généralement quelconques du
présent acte et plus spécifiquement pour les conséquences en relation avec les immeubles situés en France.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. MIGNANI, M. ZEHREN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 18 juillet 2008, Relation: ECH/2008/987. - Reçu douze euros € 12,00.-.
<i>Le Receveuri> (signé): MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Echternach, le 23 juillet 2008.
Henri BECK.
Référence de publication: 2008095846/201/77.
(080110701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
95006
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 106.898.
Il est à noter que Monsieur Steven Greenspan et Monsieur Steven Mastrovich, administrateurs de la Société, ont changé
d'adresse et résident désormais au 245, Park Avenue, 10167 New-York, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 1 S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008096167/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10753. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080109991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
JPMorgan European Property Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 104.923.
Il est à noter que Monsieur Steven Greenspan et Monsieur Steven Mastrovich, administrateurs de la Société, ont changé
d'adresse et résident désormais au 245, Park Avenue, 10167 New-York, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait
JPMorgan European Property Fund Management Company S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008096166/5499/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10750. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080109979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Conostix, Société Anonyme.
Siège social: L-3672 Kayl, 70, rue de Tétange.
R.C.S. Luxembourg B 83.439.
L'an deux mil huit, le onze juillet.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «CONOSTIX »S.A.(R.C. B No 83.439), avec
siège à L- 4221 Esch/Alzette, 66, rue de Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 1
er
août 2001, publié au Mémorial
C No 138 du 25 janvier 2002. La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé
privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-
tange.
L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Yves De Pril, employé, demeurant à B 6700 Sampont, rue du Goldberg,
7.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du
jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement
Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
95007
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège d'Esch/Alzette à Kayl.
2. Modification afférente de l'article 1
er
alinéa 2 des statuts.
3. Modification de l'article 6 2e alinéa des statuts.
4. Démission du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
5. Révocation des responsables techniques
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège d'Esch/Alzette à Kayl.
L'adresse du siège est: L- 3672 Kayl, 70, rue de Tétange.
En conséquence l'article 1
er
alinéa 2 aura désormais la teneur suivante:
Art.1
er
. alinéa 2. Cette société aura son siège sur le territoire de la Commune de Kayl. Il pourra être transféré dans
toute autre localité du Grand-Duché par simple décision du Conseil d'Administration.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 6 alinéa 2 des statuts comme suit:
Art. 6. alinéa 2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique de l'administrateur-
délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle impérative de l'administrateur-délégué.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l'expiration du mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes:
- Monsieur Tycho Fruru, employé, demeurant à B 9200 Dendermonde, Ridderstraat, 17.
- Madame Judith Tiberghien,
- Monsieur Yves De Pril (administrateur et administrateur délégué).
- PRESTA SERVICES S.A. avec siège à L- 8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid, (commissaire aux comptes), le conseil
d'administration se compose comme suit pour une durée de 6 ans.
- Est reconfirmé comme administrateur et administrateur délégué, Monsieur Yves De PRIL; avec pouvoir d'engager la
société par sa seule signature.
Est reconfirmée comme administrateur, Madame Judith TIBERGHIEN;
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur William ROBINET, employé demeurant à B 6700 Schoppach, 15, rue du Camp.
- Monsieur Koen MARIS, employée, demeurant à B 6742 Chantemelle, 15a, rue du Sart Macré.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique de l'administrateur-délégué ou par
la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle impérative de l'administrateur-délégué.
Est nommée nouveau commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
La société à responsabilité limitée «PRESTA CONCEPT S.àr.l., avec siège à L- 6931 Mensdorf, 1, rue Wangert (RCS
No B 135.244).
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale révoque Messieurs Stéphane WALRAVE et Tycho FRURU en tant que responsables techniques.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
de 860.-€.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prén-
oms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: DE PRIL, AROSIO, QUINTUS-CLAUDE, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 16 juillet 2008. Relation: EAC/2008/9500. - Reçu: douze euros, EUR 12.-.
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Pétange, le 22 juillet 2008.
Georges d'HUART.
Référence de publication: 2008096298/207/75.
(080110869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.
95008
Silcart S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.503.964,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 104.777.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires de la Société du 3 juillet 2008i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires du 3 juillet 2008 que les actionnaires ont accepté la démission
d'Alistair Boyle, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
Il en résulte qu'à compter du 3 juillet 2008, le conseil d'administration est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- Peter Gibbs
Séverine Michel
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008096217/3794/19.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06237. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080110170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
CVI GVF Luxembourg Thirty S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 140.380.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the eighth of July.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119.271, duly represented by Lucinda Clifton-Bryant,
private employee, by virtue of a proxy given in Luxembourg on July 4th, 2008.
This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a
société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:
A. Purpose - duration - name - registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited
liability for all debts and obligations of such entities.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale, as well the holding, leasing, improving, managing and
mortgaging of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of
all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg
or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or
lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
95009
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of "CVI GVF Luxembourg Thirty S. à r.l."
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the
term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
95010
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Collective decisions of the shareholders - decisions of the sole shareholder
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - annual accounts - distribution of profits
Art. 21. The Company's financial year commences on June 1st and ends on May 31st.
Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
95011
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (Lux) Master
S. à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500), entirely allocated to the share capital.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as
of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 May
2009.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred
euro (EUR 1,500).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr. Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally
at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Mr. Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally
at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendacht, am achten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Ge-
sellschaftsregister unter Nummer B 119.271, hier vertreten durch Lucinda Clifton-BRyant, Privatangestellte, wohnhaft in
Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 4. Juli 2008.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die "Gesellschaft")
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-
chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.
Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung,
die Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie
die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in lu-
95012
xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "CVI GVF Luxembourg Thirty S. à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Be-
schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch
einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere
Filialen können entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.
Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund ("cause légitime") hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort
einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Ge-
schäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
95013
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.
Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied sowie deren Erben, Nach-
lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit,
einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer oder das Geschäftsführerratsmitglied auf Grund seiner
Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf
Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und
von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegen-
heiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute
intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten
gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber
informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf
Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.
Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszu-
schütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag
nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen
Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und
der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai.
95014
Art. 22. Am einunddreißigsten Mai eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer
stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Zwischendividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder
gegebenenfalls der alleinige Gesellschafter, legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Insofern nicht
anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteilei>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., vorgenannt,
gezeichnet und durch eine Bareinlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingezahlt, die vollständig
dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) verfügt, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2009.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschafts-
kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Gregor Klaedtke, geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 11-13, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg; und
- Herr Hille-Paul Schutt, Jurist, geboren am 29. September 1977 in ´s-Gravenhage, Niederlande, beruflich wohnhaft in
20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
Signé: L. Clifton-Bryant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 10 juillet 2008. LAC/2008/28450. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents
Eur 0,5% = 62,50.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008095826/5770/359.
(080110264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
95015
Subtarc S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 890.710,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 104.769.
<i>Extrait de la résolution adoptée par l'actionnaire unique de la Société le 3 juillet 2008i>
Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique du 3 juillet 2008 que l'actionnaire unique a accepté la démission de
Monsieur Alistair Boyle, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
Il en résulte qu'à compter du 3 juillet 2008, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- Peter Gibbs
Séverine Michel
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008096216/3794/19.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06232. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080110169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
CVI GVF Luxembourg Twenty-Six S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 140.397.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the eighth of July.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119.271, duly represented by Lucinda Clifton-Bryant,
private employee, by virtue of a proxy given in Luxembourg on July 4th, 2008.
This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a
société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:
A. Purpose - duration - name - registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited
liability for all debts and obligations of such entities.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale, as well the holding, leasing, improving, managing and
mortgaging of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of
all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg
or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or
lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
95016
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of "CVI GVF Luxembourg Twenty-Six S. à r.l."
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the
term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
95017
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Collective decisions of the shareholders - decisions of the sole shareholder
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - annual accounts - distribution of profits
Art. 21. The Company's financial year commences on June 1st and ends on May 31st.
Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
95018
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (Lux) Master
S. à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500), entirely allocated to the share capital.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as
of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on May 31st,
2009.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred
euro (EUR 1,500).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr. Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally
at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Mr. Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally
at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendacht, am achten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Ge-
sellschaftsregister unter Nummer B 119.271, hier vertreten durch Lucinda Clifton-Bryant, Privatangestellte, wohnhaft in
Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 4. Juli 2008.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die "Gesellschaft")
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-
chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.
Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung,
die Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie
die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in lu-
95019
xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "CVI GVF Luxembourg Twenty-Six S. à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Be-
schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch
einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere
Filialen können entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.
Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund ("cause légitime") hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort
einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Ge-
schäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
95020
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.
Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied sowie deren Erben, Nach-
lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit,
einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer oder das Geschäftsführerratsmitglied auf Grund seiner
Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf
Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und
von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegen-
heiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute
intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten
gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber
informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf
Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.
Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszu-
schütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag
nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen
Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und
der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai.
95021
Art. 22. Am einunddreißigsten Mai eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer
stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Zwischendividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder
gegebenenfalls der alleinige Gesellschafter, legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Insofern nicht
anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteilei>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., vorgenannt,
gezeichnet und durch eine Bareinlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingezahlt, die vollständig
dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) verfügt, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2009.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschafts-
kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Gregor Klaedtke, geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 11-13, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg; und
- Herr Hille-Paul Schutt, Jurist, geboren am 29. September 1977 in 's-Gravenhage, Niederlande, beruflich wohnhaft in
20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.2
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
Signé: L. Clifton-Bryant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 10 juillet 2008. LAC/2008/28446. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents,
Eur 0,5% = 62,50.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008095823/5770/359.
(080110433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
95022
TARC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 94.556.
<i>Extrait de la résolution adoptée par l'associé unique de la Société le 3 juillet 2008i>
Il résulte de la résolution de l'associé unique du 3 juillet 2008 que l'associé unique a accepté la démission d'Alistair
Boyle, en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat.
Il en résulte qu'à compter du 3 juillet 2008, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- Peter Gibbs
Séverine Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2008096219/3794/19.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06253. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080110182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
CVI GVF Luxembourg Twenty-Five S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 140.396.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the eighth of July.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119.271, duly represented by Lucinda Clifton-Bryant,
private employee, by virtue of a proxy given in Luxembourg on July 4th, 2008.
This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a
société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:
A. Purpose - duration - name - registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited
liability for all debts and obligations of such entities.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale, as well the holding, leasing, improving, managing and
mortgaging of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of
all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg
or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or
lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
95023
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of "CVI GVF Luxembourg Twenty-Five S. à r.l."
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the
term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
95024
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Collective decisions of the shareholders - decisions of the sole shareholder
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - annual accounts - distribution of profits
Art. 21. The Company's financial year commences on June 1st and ends on May 31st.
Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
95025
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (Lux) Master
S. à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500), entirely allocated to the share capital.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as
of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on May 31st,
2009.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred
euro (EUR 1,500).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr. Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally
at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Mr. Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally
at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:
Im Jahre zweitausendacht, am achten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Ge-
sellschaftsregister unter Nummer B 119.271, hier vertreten durch Lucinda Clifton-Bryant, Privatangestellte, wohnhaft in
Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 4. Juli 2008.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die "Gesellschaft")
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-
chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.
Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung,
die Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie
die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in lu-
95026
xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "CVI GVF Luxembourg Twenty-Five S. à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Be-
schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch
einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere
Filialen können entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.
Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund ("cause légitime") hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort
einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Ge-
schäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
95027
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.
Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied sowie deren Erben, Nach-
lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit,
einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer oder das Geschäftsführerratsmitglied auf Grund seiner
Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf
Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und
von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegen-
heiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute
intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten
gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber
informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf
Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.
Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszu-
schütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag
nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen
Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und
der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai.
95028
Art. 22. Am einunddreißigsten Mai eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer
stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Zwischendividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder
gegebenenfalls der alleinige Gesellschafter, legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Insofern nicht
anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (Lux) Master S. à r.l., vorgenannt,
gezeichnet und durch eine Bareinlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingezahlt, die vollständig
dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) verfügt, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2009.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschafts-
kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Gregor Klaedtke, geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 11-13, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg; und
- Herr Hille-Paul Schutt, Jurist, geboren am 29. September 1977 in ´s-Gravenhage, Niederlande, beruflich wohnhaft in
20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
Signé: L. Clifton-Bryant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 10 juillet 2008, LAC/2008/28445. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents
Eur 0,5% = 62,50.
<i>Le receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008095822/5770/359.
(080110425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
95029
RAE Angers S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. REO STZ, S. à r.l.).
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 131.933.
Il résulte d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2008 que l'associé unique de la société RAE Angers Sàrl,
à savoir la société REO Arkauwald Sàrl, ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, a changé sa dénomi-
nation en Realkapital Aktiv Europa Lux S.àr.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.àr.l., Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008096228/7262/17.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05557. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080110548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
ENB Lux 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: HKD 1.420.347,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 130.539.
<i>Extrait de la résolution adoptée par l'associé unique de la Société le 3 juillet 2008i>
Il résulte de la résolution de l'associé unique du 3 juillet 2008 que:
- L'associé unique a accepté la démission de Monsieur Alistair Boyle, en tant que gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé Cédric Pedoni, né le 24 mars 1975 à Villerupt, France, ayant son adresse professionnelle
au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée.
Il en résulte qu'à compter du 3 juillet 2008, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Paul Guilbert
- Séverine Michel
- Maximilian Biagosch
- Cédric Pedoni
Séverine Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2008096202/3794/24.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06231. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080110157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Castle Property Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 114.852.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008095922/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2008, réf. LSO-CS09476. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080110493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
95030
Nalozo S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.655.772,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 133.773.
<i>Extrait de la résolution adoptée par les associés de la Société le 3 juillet 2008i>
Il résulte des résolutions des associés du 3 juillet 2008 que:
- les associés ont accepté la démission d'Alistair Boyle, en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat;
- les associés ont nommé Cédric Pedoni, né le 24 mars 1975 à Villerupt, France, ayant son adresse professionnelle au
282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée;
- les associés ont nommé Ulrich Siemssen, né le 22 avril 1970 à Hamburg, Allemagne, ayant son adresse professionnelle
à FalkstraBe 5, D-60487 Frankfurt am Main, Allemagne, en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
Il en résulte qu'à compter du 3 juillet 2008, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Paul Guilbert
- Séverine Michel
- Ulrich Siemssen
- Cédric Pedoni
Séverine Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2008096189/3794/26.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06242. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080110105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Maitland Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 88.645.
Maitland Malta Limited, l'associé de la Société, a changé de dénomination en Maitland Advisory Holdings Limited et de
siège social: 46, Timber Wharf, Marsa, MRS 1442, Malte.
Luxembourg, le 24 juillet 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008096259/631/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2008, réf. LSO-CS10444. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080110142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
J2CG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 106.308.
L'an deux mille huit, le vingt trois juillet.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg),
soussignée.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «J2CG S.A.» ayant son siège
social à L-2419 Luxembourg, 03, rue du Fort Rheinsheim (Grand-Duché du Luxembourg), inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 106.308, constituée le 26 janvier 2005 suivant acte de
95031
Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro n
o
614 du 25 juin 2005.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Charles DURO, avocat, demeurant professionnellement à L-1325
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
Le président désigne comme secrétaire Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant professionnellement à L-1325
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
L'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Maître Lionel BONIFAZZI, avocat, demeurant professionnellement
à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont
représentées à la présente assemblée, de sorte que l'Assemblée Générale peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur de la Société;
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur;
4. Divers.
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la Société Monsieur Christian BERG, administrateur,
demeurant à F-57220 Boulay, 13, Sentiers des crêtes (France) ("le Liquidateur").
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus
spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ainsi que ses modifications.
L'Assemblée Générale, entre autre, décide et reconnaît que la Société sera engagée envers les tiers par la seule
signature du Liquidateur.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), les jours, mois et an qu'en tête des pré-
sentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Duro, K. Mastinu, L. Bonifazzi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 24 JUILLET 2008. Relation: EAC/2008/9955. - Reçu douze euros 12,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR COPIE CONFORME délivrée à des fins administratives, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2008.
BLANCHE MOUTRIER.
Référence de publication: 2008096471/272/56.
(080111350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.
Prestacompta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle - route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 104.603.
L'an deux mille huit, le deux juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Laurent PAUL, comptable, demeurant au 92, rue Raymond Mondon, F-57860 Roncourt;
95032
2.- Monsieur Régis BUTRYN, expert-comptable, demeurant au 16, Grand-Rue, F-54580 Saint-Ail,
tous les deux ici représentés par Monsieur Marc PROSPERT, employé privé, avec adresse professionnelle au 3, route
de Luxembourg, L-6130 Junglinster,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentale d'acter ce qui suit:
- La société à responsabilité limitée "PRESTACOMPTA S.à r.l.", ayant son siège social à L-3378 Livange, Zone Indus-
trielle Le 2000, route de Bettembourgt, R.C.S. Luxembourg section B numéro 104.603, été constituée suivant acte reçu
par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 220 du 11 mars 2005.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 13 octobre 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2225 du 28 novembre 2006.
- Les comparants sont les seuls associés actuels de ladite société et ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés constatent qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé en date du 6 juin 2008, enregistrée à
Luxembourg-Sociétés, réf. LSO CR/06868, Monsieur Laurent PAUL, préqualifié, a cédé cinquante (50) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune dans la prédite société "PRESTACOMPTA S.à r.l." à Monsieur
Régis BUTRYN, préqualifié.
Cette cession de parts est approuvée conformément à l'article 7 des statuts et les associés la considèrent comme
dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.
Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir due ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'article 6 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Laurent PAUL, comptable, demeurant au 92, rue Raymond Mondon, F-57860 Roncourt; cent parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.- Monsieur Régis BUTRYN, expert-comptable, demeurant au 16, Grand-Rue, F-54580 Saint-Ail, quatre cents
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées."
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante
euros (650,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: PROSPERT - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 juillet 2008. Relation GRE/2008/2909. — Douze euros 12,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 29 juillet 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008096475/231/57.
(080110837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.
Clarac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 91, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 93.790.
L'an deux mille huit, le six juin.
95033
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme „CLARAC S.A.", avec siège social à L-3317
Bergem, 19, Steewee, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 93.790
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 mai 2003 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C du 26 juin 2003 numéro 672.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à Senningerberg.
qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-
gerberg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Bemtgen, demeurant à Bergem.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social à L-2146 Luxembourg, 91, rue de Merl.
2. Modification subséquente du paragraphe premier de l'article deux des statuts.
3. Modification de l'article quatre des statuts qui aura désormais la teneur suivante: «La société a pour objet l'exploi-
tation d'une agence immobilière, ainsi que l'étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement
l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l'aménagement, la construction, et la mise
en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes
propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance, et l'administration ou l'exploitation de tous im-
meubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu. La société pourra de façon générale
entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le développement.».
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
„ne varietur" par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et
peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3317 Bergem, 19, Steewee à L-2146 Luxembourg, 91, rue de
Merl.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, le paragraphe premier de l'article deux des statuts de la Société est modifié et
aura la teneur suivante:
" Art. 2. paragraphe 1
er
. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, ainsi que l'étude et la promotion de toutes
réalisations immobilières, plus spécialement l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non bâtis, la transformation,
l'aménagement, la construction, et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour compte
de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance, et
l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner
lieu.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le
développement."
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.
95034
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de huit cent cinquante euros (€ 850,-).
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: Jean-Michel Merienne, Sophie Mathot, Marc Bemtgen, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 juin 2008 LAC/2008/24089. - Reçu douze euros 12€.
<i>Pr Le Receveur ff.i> (signé): Franck Schneider.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 28 juillet 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008096478/202/73.
(080111287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.
Karibik, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 133, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 109.298.
L'an deux mille huit, le seize juillet.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Pierre KASS, commerçant, né à Luxembourg, le 24 novembre 1980, demeurant à L-2311 Luxembourg,
133, avenue Pasteur,
détenteur de cinquante (50) parts sociales.
2.- a) Madame Denise HENGESCH, professeur, née à Luxembourg, le 23 décembre 1953, veuve du sieur Guy KASS,
demeurant à L-2311 Luxembourg, 133, avenue Pasteur,
ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre KASS, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 10 juillet 2008.
b) Madame Vicky KASS, professeur, née à Luxembourg, le 28 mai 1979, demeurant à F-75020 Paris, 33, rue du Retrait,
ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre KASS, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 10 juillet 2008.
c) Monsieur Pierre KASS, préqualifié.
Les comparants ci-dessus désignés sub 2.- a), b) et c) étant détenteurs ensemble, chacun à concurrence d'un tiers (1/3)
indivis, de cinquante (50) parts sociales.
Les deux prédites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Les comparants préqualifiés sub 1.- et 2.- a), b) et c), agissant en leur qualité de seuls associés de la société à respon-
sabilité limitée "KARIBIK, s.àr.l." (numéro d'identité 2005 24 17 792), avec siège social à L-5555 Remich, 6, Place du
Marché, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 juillet 2005, publié au Mémorial C, numéro
1167 du 8 novembre 2005,
requièrent le notaire d'acter ce qui suit:
<i>Expose préliminairei>
1) Monsieur Guy KASS, ayant demeuré en dernier lieu à L-2652 Luxembourg, 152, rue Albert Unden, était détenteur
de cinquante (50) parts sociales de la société "KARIBIK, s.à r.l.".
2) Monsieur Guy KASS est décédé "ab intestat" à Luxembourg en date du 16 novembre 2007.
Suivant déclaration faite au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg en date du 10 janvier 2008, en
conformité des articles 767-1 et 767-3 du Code civil, son épouse survivante Madame Denise HENGESCH, préqualifiée
sub 2.- a), a opté pour une part d'enfant légitime le moins prenant.
En conséquence, la succession de Monsieur Guy KASS est échue pour un tiers (1/3) indivis à son épouse survivante
Madame Denise HENGESCH et à chacun de ses deux enfants Vicky et Pierre les KASS, tous trois préqualifiés.
<i>I. Cessions de parts socialesi>
Madame Denise HENGESCH et Madame Vicky KASS, préqualifiées, cèdent et transportent, sous les garanties ordi-
naires de fait et de droit, les droits indivis, à savoir deux tiers (2/3) en pleine propriété, qu'elles détiennent ensemble dans
95035
les cinquante (50) parts sociales de la prédite société "KARIBIK, s.à.r.l.", ayant dépendu de la succession de Monsieur Guy
KASS, à Monsieur Pierre KASS, préqualifié, qui accepte.
Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le
cessionnaire participera aux bénéfices et pertes à partir de ce jour.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute
garantie de la part des cédantes.
Suite aux prédites cessions de parts sociales, Monsieur Pierre KASS, préqualifié, détient la totalité des cent (100) parts
sociales de la société "KARIBIK, s.à r.l." et en est devenu l'associé unique.
<i>II. Assemblée générale extraordinairei>
Suite aux prédites cessions de parts sociales, Monsieur Pierre KASS, en sa qualité d'associé unique, a pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de L-5555 Remich, 6, Place du Marché à L-2311 Luxembourg, 133,
avenue Pasteur et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg."
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner
la teneur suivante:
" Art. 3. 1
er
alinéa. La société a pour objet l'exploitation de tout commerce."
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d'ajouter à l'article 6 des statuts un second alinéa ayant la teneur suivante:
"Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société
sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur
les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de huit cents euros (€
800.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: KASS, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 17 juillet 2008. Relation: CAP/2008/2224. — Reçu douze euros (12.-).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 28 juillet 2008.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2008096287/236/78.
(080111487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.
Starsun, Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In den Allern.
R.C.S. Luxembourg B 107.569.
L'an deux mille huit, le quatre juillet.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "STARSUN" (numéro
d'identité 1999 40 02 719), avec siège social à L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In den Allern, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 107.569, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date
du 20 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 520 du 8 juillet 1999.
L'assemblée est présidée par Madame Michèle GRISARD, administrateur de sociétés, demeurant à Allondrelle la Mal-
maison (France).
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
95036
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination du commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
La présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Jean-Claude DUCHAINE, administrateur de société, né
à Chênée (Belgique) le 15 juin 1952, demeurant à B-4052 Chaudfontaine, 11, rue des Genêts.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux
articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.
Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,
pour des opérations spéciales et déterminées.
Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer Madame Lucienne FOXHAL, administrateur de société, née à Verviers (Belgique) le
13 mars 1957, demeurant à B-4052 Chaudfontaine, 11, rue des Genêts, comme commissaire-vérificateur.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour les
travaux exécutés jusqu'à ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximative-ment à huit cent cinquante euros (€ 850.-), sont
à charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: GRISARD, JANIN, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 10 juillet 2008. Relation: CAP/2008/2124. - Reçu douze euros (12.-).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 18 juillet 2008.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2008096284/236/64.
(080110775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.
95037
Virtual Network S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9660 Insenborn, Maison 10A Bonnal.
R.C.S. Luxembourg B 58.101.
La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre
2007
- Accepte la démission de Mme Marleen Watté-Bollen, né le 26 août 1954 à Veghel, Pays-Bas demeurant à 37, Val St.
André, L-1128 Luxembourg avec effet au 31 décembre 2007.
Luxembourg, le 31.12.2007.
<i>Virtual Network
i>Represented by Mme Cornelia Nickels - Van Winkel
Référence de publication: 2008096265/1125/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2008, réf. LSO-CS11776. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080110538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.
Platines Holding SPF S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 140.452.
STATUTS
L'an deux mille huit, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
La société de droit des Iles Vierges Britanniques "CORPORATE MANAGEMENT CORP.", établie et ayant son siège
social à Tortola, Road Town, First Floor Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, (Iles Vierges Britanniques),
inscrite au Registre des Sociétés de Tortola en tant que International Business Company sous le numéro 92524,
ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglins-
ter, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir
été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts
d'une société à responsabilité limitée qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé "SPF", à con-
stituer par les présentes.
Titre I
er
: Objet - durée - dénomination - siège social
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois relatives à une
telle entité (la "Société"), et en particulier par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(la "Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (les "Statuts").
Art. 2. La Société a pour objet exclusif, l'acquisition, la détention, la gestion, et la réalisation d'instruments financiers
au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ainsi que les espèces et avoirs de quelque nature
que ce soit détenus en compte.
La Société ne pourra pas exercer d'activités commerciales ou industrielles.
La Société pourra, à titre accessoire et gratuit, accorder des avances ou garantir les sociétés ou entités dans lesquelles
elle détient une participation.
La Société ne pourra, en aucun cas, s'immiscer dans la gestion des sociétés ou entités dans lesquelles elle détient un
intérêt.
De manière générale, la Société prendra toutes les mesures et accomplira toutes opérations que la Société jugera
nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet dans les limites posées par la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination "PLATINES HOLDING SPF S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'associé unique
ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
95038
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Titre II: Capital social - parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique, aussi longtemps que la Société
aura un seul associé, ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit au détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que suivant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Titre III: Administration
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés pour une période indéterminée. Si
plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement
associé(s). Le(s) gérant(s) est (sont) révocable(s) ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs
pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et
pourvu que les termes du présent article 12 aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux gérants.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leur mandat, ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité
de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à
la majorité des gérants présents ou représentés.
Les gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par voie de conférence téléphonique ou tout autre
équipement de communication similaire par lequel toutes personnes participant à la réunion peuvent s'entendre ou se
parler, et cette participation à la réunion, constituera présence en personne à cette réunion. Les membres du conseil de
gérance participant à une réunion du conseil de gérance par le biais d'un tel moyen de communication ratifieront leurs
votes en signant une copie du procès-verbal de la réunion.
Une décision du conseil de gérance peut également être prise sans une réunion par le consentement unanime écrit de
tous les gérants. De tels consentements écrits peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs copies d'une
même résolution.
Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), en raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relative aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société.
Titre IV: Assemblée générale des associés
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales détenues par
lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
95039
Titre V: Année sociale - réserves - profits
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance à tout moment desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour-cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Titre VI: Dissolution - liquidation
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associé
(s) ou non, nommé(s) par les associés qui détermineront ses (leurs) pouvoirs et rémunération.
Titre VII: Divers
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions des lois applicables.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera à la date de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par l'associée
unique, la société "CORPORATE MANAGEMENT CORP.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées
entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent à huit cent cinquante euros.
<i>Résolutions prises par l'associée uniquei>
Et aussitôt l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est établi à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
2) Mme Sylvie ABTAL-COLA, employée privée, née à Hayange, (France), le 13 mai 1967, demeurant professionnelle-
ment à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, a été élue en tant que gérante de la Société pour une durée indéterminée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du
notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: DOSTERT; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juillet 2008. Relation GRE/2008/3025. - Reçu soixante deux euros et cinquante cents
0,50 % = 62,50 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 29 juillet 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008096530/231/137.
(080111435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
95040
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 2 S.à r.l.
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l.
Castle Property Investment S.A.
Clarac S.A.
Conostix
Crosscheck (Luxembourg) S.A.
CVI GVF Luxembourg Thirty S. à r.l.
CVI GVF Luxembourg Twenty-Five S. à r.l.
CVI GVF Luxembourg Twenty-Seven S. à r.l.
CVI GVF Luxembourg Twenty-Six S. à r.l.
ENB Lux 1 S.àr.l.
Gemplus International S.A.
Genova Holding S.A.
J2CG S.A.
JPMorgan European Property Fund Management Company S.A.
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 1 S.à r.l.
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 4 S.à r.l.
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 5 S.à r.l.
Karibik, s.à r.l.
Maitland Europe S.à r.l.
Nalozo S.àr.l.
Participations 1 S.à r.l.
Platines Holding SPF S.à r.l.
Prestacompta S.à r.l.
RAE Angers S. à r.l.
REO STZ, S. à r.l.
S.C.I. St. SABIN
Silcart S.A.
Starsun
Subcart S.A.
Subtarc S.A.
TARC Lux S.à r.l.
Tedeco Holding S.A.
Virtual Network S.A.