This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1916
5 août 2008
SOMMAIRE
3M Asset Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
91923
Adama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91955
Advent Miro Luxembourg Finance S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91941
Aedifis & Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
91949
Agri-Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91957
Alianza Iberian Private Equity (Luxem-
bourg-Five) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91950
Alya Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91934
Anglo South America Investments . . . . . .
91923
Back Up International Holding S.A. . . . . . .
91964
Balthazar Production S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
91959
Benz Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91963
BPB Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91963
BPB Valmarand S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91962
Brembo International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
91951
Bruehl Leipzig Arcaden Luxco S.àr.l. . . . .
91933
Bruehl Leipzig Arcaden S.àr.l. . . . . . . . . . . .
91933
Bureau International de Règlement de Si-
nistres S.A. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
91965
Café Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91953
CED Informatique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
91960
Com3 Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91950
Creutz & Partners, Global Asset Manage-
ment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91961
De Feinen Heizungsknechler s.à r.l. . . . . . .
91956
Dino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91934
Disperlux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91949
Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden . . . . . .
91948
Ecologis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91960
ELECTROCAREL S.à r.l. unipersonnelle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91954
EPX Holding SAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91964
Esmeralda Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91966
Euroshoes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91952
Euroshop East Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
91967
Faymonville Distribution AG . . . . . . . . . . . .
91959
Faymonville Lease A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
91957
F & B Constructions S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
91968
F.C.L. Real Estate S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
91923
F.E.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91959
Fenwick Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91924
Formes Contemporaines S.A. . . . . . . . . . . .
91933
Fund Administration Services & Technolo-
gy Network Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
91966
Global-Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
91924
GM-IT S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91959
Hospitality Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
91948
Ideal Constructions S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
91958
Impax Solar Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
91935
Investissement International Immobilier
SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91949
ITT Industries Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
91948
Japan Dynamic Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91953
Kasomar Holding I Aktiengesellschaft . . . .
91951
Kieffer et Associés S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
91952
Lakefield S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91953
Leaf Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91934
Lemonland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91925
LFPI Mezzanine S.C.A. SICAR . . . . . . . . . .
91924
Luxcleaning System s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
91951
Lux Editions.Lu S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
91958
MGV II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91954
Mibomax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91948
mns Investment Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
91954
Montaligno S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91966
Opalys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91968
OQUENDO Management S.à r.l. . . . . . . . .
91951
Orgere S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91952
Participating Monetary Organization . . . .
91961
Pasing Munich Arcaden Luxco S.àr.l. . . . . .
91949
Pasing Munich Arcaden S.àr.l. . . . . . . . . . . .
91923
Pella Immobilien Gesellschaft 3 . . . . . . . . .
91926
Peravan Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
91967
Phi-Logos A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91957
91921
Phi-Logos A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91957
Pyramidon A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91960
Reisdorff Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91958
Ribelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91961
Roofland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91960
Saturn Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91964
Saturn Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91962
Saturn Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91962
Serem S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91950
SL Software_Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
91950
Société de Boulangerie Artisanale au Le-
vain S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91924
Sports-Buttek Schleich S. à r.l. . . . . . . . . . .
91955
S.R.E.T. Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91964
Telba S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91955
tempo! S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91925
Troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91956
Tyres Distribution International S.A. . . . .
91955
Van Laar S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91958
Variolabel Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91965
Vingt-et-Unième Siècle Holding S.A. . . . . .
91925
Vitruvius International S.A. . . . . . . . . . . . . .
91952
White Bear S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91934
Work Out S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91953
91922
F.C.L. Real Estate S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R.C.S. Luxembourg B 102.276.
Le bilan au 31 décembre 2007, le rapport du Conseil d'Administration à Assemblée Générale Ordinaire et le rapport
du Commissaire aux comptes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008092283/1801/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS07003. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080105719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.
3M Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.500,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 110.230.
La Société a été constituée selon acte reçu par M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 4 août 2005, publié au Mémorial C (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg),
numéro 56 du 10 janvier 2006.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2008.
3M Asset Management S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2008092328/6565/18.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02667. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.
Anglo South America Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 111.826.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2008.
Signature
<i>Administrateur, Géranti>
Référence de publication: 2008092247/1115/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04249. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080105851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.
Pasing Munich Arcaden S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.428.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91923
Luxembourg, le 18 juillet 2008.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008092735/7446/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04823. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
LFPI Mezzanine S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Inves-
tissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 128.327.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2008.
Signatures.
Référence de publication: 2008092839/1024/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07800. - Reçu 68,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Global-Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 134.937.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008092728/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05324. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Fenwick Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7312 Steinsel, 37, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 110.887.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008092729/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2008, réf. LSO-CS05168. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Société de Boulangerie Artisanale au Levain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, 63, Waistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 20.662.
Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91924
Luxembourg, le 22.07.08.
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008092876/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS07955. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Lemonland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 10, rue des Gaulois.
R.C.S. Luxembourg B 117.364.
Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.07.08.
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008092877/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS07954. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
tempo! S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 10, rue des Gaulois.
R.C.S. Luxembourg B 95.212.
Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.07.08.
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008092878/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS07950. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Vingt-et-Unième Siècle Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 71.851.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008092730/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05321. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
91925
Pella Immobilien Gesellschaft 3, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 140.143.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the tenth of July.
Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in, Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);
APPEARED:
The public limited company "PELLA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.", with registered office in L-2311 Luxembourg,
55- 57, avenue Pasteur,
here duly represented by two of its directors, namely:
- Mr. Nico HANSEN, private employee, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, and
- Mrs. Sophie BATARDY, private employee, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
Both are here represented by Mr. Christian DOSTERT, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster,
3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur"
by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of
a private limited liability company, ("Gesellschaft mit beschrankter Haftung"), to establish as follows:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschrankter Haftung") under the
name of "PELLA IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 3" ("the Company"), which will be governed by the present articles of
association ("the Articles") as well as by the respective laws and particularly by the modified law of 10 August 1915 on
commercial companies (the "Law of 1915").
Art. 2. The purpose of the Company is the purchase and sale of immoveable properties as well as real estate man-
agement.
The Company's purpose is also the participation in businesses and companies of any kind and the establishment,
development, administration and supervision of businesses and companies. The Company may acquire its participations
by subscription, contribution in kind, exercise of option rights and in any other way, manage and exploit them and dispose
of them by sale, assignment, exchange or in any other way.
The Company may use its means to create, administer, develop and exploit a portfolio consisting of securities and
patents of any kind and origin. For this it may acquire all kinds of securities by purchase, subscription or in any other way
and alienate them by sale, assignment, exchange or in any other way.
The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same
group of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and
without carrying on a bank business or of the financial sector. Moreover, it may borrow in any form with or without
guaranty and mortgage, issue debt securities, loan notes or other debt instruments, pledge or otherwise hypothecate for
the benefit of its own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned kind.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security
for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible
notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.
The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are
in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The Company's registered office is established in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg).
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or the board
of managers.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective
decision of the shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as abroad by a simple decision of the board of managers.
91926
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by one
hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euros (125.- EUR) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the Law of 1915.
Art. 6. The Company will recognize only one holder per share.
The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
Art. 7. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
remaining share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.
Art. 8. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 9. The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to the
property and the documents of the Company nor may they interfere in any manner in the management of the Company.
They have to refer to the Company's inventories.
C. Management
Art. 10. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers.
In that case, the Company will be validly bound in all circumstances by the joint signature of two managers.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason.
Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also
choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram or facsimile
another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or
by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire set of
such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.
Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
91927
Art. 14. The manager(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
D. Supervision
Art. 15. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by
a decision of the sole shareholder or by a collective decision of the general meeting of the shareholders, which determines
their number and their remuneration; they can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
E. Decisions of the sole shareholder - General meeting of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of these Articles requires the approval of a majority of shareholders representing at least three
quarters of the share capital.
Art. 18. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-
sions of section XII of the Law of 1915 concerning commercial companies, as amended.
F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company's accounting year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.
Art. 20. Each year, with reference to December 31st, the Company's accounts are established and the Managers
prepare an annual account in the form of a financial statement including profits and losses.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortizations,
expenses and other burdens is allocated as follows:
- five percent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital;
- the remaining amount is at the disposal of the shareholders.
Art. 21. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the
managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these Articles.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 23. Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the Company, will be settled insofar as the Company's business is concerned by
arbitration in compliance with the civil procedure.
H. General dispositions
Art. 24. For all points not regulated by these bylaws, reference is made to the provisions of the modified Law of 1915
on commercial companies.
<i>Subscription and payment of the sharesi>
The Articles having thus been established, the one hundred (100) shares have been subscribed by the sole shareholder
the company "PELLA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.", prenamed and represented as said before, and fully paid up by
the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR)
is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.
<i>Transitional dispositionsi>
The first accounting year starts with the present day and ends on the 31st December 2008.
91928
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of
the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:
1. The registered office of the Company is established at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
2. The following persons are appointed, for an undetermined period, as the managers of the Company:
a) Mr. Patrick TEROERDE, private employee, born in Düsseldorf, (Germany), on the 12th of July 1974 residing in
SW73BJ London, South Kensington, 32 Evelyn Gardens, flat 2, (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
b) Mr. Nico HANSEN, private employee, born in Differdange, on the 31st of March 1969, professionally residing in
L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;
c) Mrs. Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on the 22nd of January 1963, professionally residing
in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
3. The private limited liability company "MGI FISOGEST S.à r.l.", with registered office in L-2311 Luxembourg, 55-57,
avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 20,114,
has been appointed as statutory auditor.
The mandate of the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2014.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning.
The deed having been read to the mandatory of the appearing party, known to the notary by their first and last name,
civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendacht, den zehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Aktiengesellschaft "PELLA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.", mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pas-
teur,
hier rechtmäßig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder, namentlich:
- Herr Nico HANSEN, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, und
- Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
Beide sind hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster,
3, route de Luxembourg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht nachdem sie vom
Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben worden ist, bleibt der gegenwärtigen Urkunde
beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu
gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PELLA IMMOBILIEN GE-
SELLSCHAFT 3" („die Gesellschaft") gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen („die Statuten"), sowie durch die
anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
(das „Gesetz von 1915") geregelt wird.
Art. 2. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
Der Gesellschaftszweck ist ebenfalls die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Grün-
dung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteili-
gungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben
und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,
welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Ab-
tretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.
91929
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Un-
ternehmen, die zu der gleichen Gruppe gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung
gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des
Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unter-
stützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige
Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbe-
zeichneten Art bestellen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC,
CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann Innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder
des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen,
die für eine Änderungen der Statuten maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen, Büros oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großher-
zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend-fünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euros (125,- EUR).
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesetzes von
1915 festgelegt ist.
Art. 6. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an.
Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 7. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des restlichen
Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendenten, Deszendenten
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 8. Der Tod, der Verlust der Bürgerrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters wird
nicht die Auflösung der Gesellschaft herbeiführen.
Art. 9. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente
der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen
einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.
C. Geschäftsführung
Art. 10. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/Die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt, die die Dauer seines/ihres Mandates fest-
legt.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet.
In diesem Fall wird die Gesellschaft rechtmäßig in allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Geschäftsführern verpflichtet.
Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund
notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
91930
Art. 11. Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch
einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates
sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm oder Telefax oder durch
ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die
Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des
Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten
lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als
Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 12. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 13. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund
auch immer, aufgelöst.
Art. 14. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Überwachung
Art. 15. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare, welche nicht Gesellschafter sein
müssen, überwacht, welche durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder durch einen Kollektivbeschluss der
Generalversammlung der Gesellschafter, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt, ernannt werden; sie können beliebig
abberufen werden.
Die Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von 6 Jahren nicht
überschreiten kann.
E. Beschluss des Alleingesellschafters - Generalversammlung der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Statuten benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes von 1915 zustehen.
F. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
91931
Art. 20. Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-
resabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und sonstigen Lasten verbleibende Nettogewinn wird
wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,
bis diese 10% des gezeichneten Kapitals erreicht;
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 21. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines
von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Statuten vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.
G. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 23. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern
selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in den Statuten festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes
von 1915 über die Handelsgesellschaften, verwiesen.
<i>Zeichnung und Zahlung der Anteilei>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die einhundert (100) Anteile durch die alleinige Gesell-
schafterin, die Gesellschaft "PELLA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.", vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt,
gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausend-fünfhundert Euro (12.500,- EUR) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich
bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.
<i>Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterini>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienene Partei, welche das gesamte gezeichnete Ge-
sellschaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur.
2. Folgende Personen werden, für eine unbestimmte Dauer, zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
a) Herr Patrick TEROERDE, Privatangestellter, geboren in Düsseldorf, (Bundesrepublik Deutschland), am 12. Juli 1974,
wohnhaft in SW73BJ London, South Kensington, 32 Evelyn Gardens, flat 2, (Vereintes Königreich Großbritannien und
Nordirland);
b) Herr Nico HANSEN, Privatangestellter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März 1969,
beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
c) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in
L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur.
3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MGI FISOGEST S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue
Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 20.114, ist
zum Kommissar ernannt worden.
Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2014.
91932
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der
erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird
die englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, dem instrumentierenden
Notar nach Vor-und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar,
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: DOSTERT; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 2008. Relation GRE/2008/2898. — Reçu soixante deux euros et cinquante
cents
0,50 % = 62,50 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, den 21. Juli 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008092665/231/398.
(080106288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Bruehl Leipzig Arcaden S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.146.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2008.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008092732/7446/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04830. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Bruehl Leipzig Arcaden Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.429.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2008.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008092733/7446/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04828. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Formes Contemporaines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8081 Bertrange, 126A, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg B 11.991.
Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91933
Luxembourg, le 22.07.08.
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008092875/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS07956. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
White Bear S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 73.475.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/07/2008.
<i>Pour White Bear S.A.
i>Luxembourg International Consulting S.A.
Signature
Référence de publication: 2008092882/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05817. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Leaf Holding SA, Société Anonyme,
(anc. Dino S.A.).
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 102.846.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008092897/1035/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06325. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Alya Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 107.689.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008092842/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08132. - Reçu 36,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
91934
Impax Solar Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 140.154.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Impax New Energy Investors LP, an English limited partnership, incorporated and existing under the laws of the United
Kingdom, having its registered office at Broughton House, 6-8 Sackville Street, London W1S 3DG, United Kingdom,
registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number LP 10697,
here represented by Ms. Stephanie Colson, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy given on June 26th, 2008.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be
convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "Impax Solar Investments S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or
in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at twenty-two thousand five hundred Euro (€ 22,500.-) represented by nine hundred
(900) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
The authorized capital, including the subscribed capital is fixed at two million two hundred fifty thousand Euro (€
2,250,000.-) represented by ninety thousand (90,000) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
The manager or board of managers is also authorized to issue convertible instruments within the limits of the au-
thorized capital. The manager or board of managers will determine the terms and conditions of the convertible
instruments.
Furthermore, the manager or board of managers is authorized, during a period of five (5) years from the date hereof,
to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. These increases of capital
may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by
conversion of convertible instruments, by incorporation of claims or in any other way to be determined by the manager
91935
or board of managers. The manager or board of managers is specifically authorized to proceed to such issues without
reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The manager or
board of mangers may delegate to any duly authorized manager or officer of the Company, or to any other duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.
Every time the manager or board of managers acts to render effective an increase of the subscribed capital, the present
article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.
The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.
Art. 7. The subscribed and the authorized capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder
or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in
direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of category A manager(s) and of category B manager(s).
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its
single manager.
In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signatures
of at least one category A manager and at least one category B manager.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of (i) the
managers present or represented, and (ii) the consent of at least one category B manager, with at least the presence or
the representation of at least one category A Manager and at least one category B manager. A meeting attended by a
majority of managers who are residents from one jurisdiction, which is not Luxembourg is not quorate.
Any meetings of the board of managers must take place in Luxembourg.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the
basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his
powers to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
91936
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of
December of each year.
Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers (or the
sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first of December 2008.
<i>Subscription - paymenti>
The articles of association having thus been established, Impax New Energy Investors LP, prenamed, declared to
subscribe for all the nine hundred (900) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of
twenty-two thousand five hundred Euro (€ 22,500.-).
The amount of twenty-two thousand five hundred Euro (€ 22,500.-) has been fully paid up in cash and is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand five hundred Euro (€ 2,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period
of time:
<i>Category A Managers:i>
- Mr. Peter Rossbach, Investment Manager, born on May 10, 1958 in New York City, United States of America, with
professional address at Broughton House, 6-8 Sackville St, London W1S 3DG;
- Mr. Joseph Berry, Investment Manager, born on March 27, 1973 in Falkirk, Scotland, Great Britain, with professional
address at Broughton House, 6-8 Sackville St, London W1S 3DG;
<i>Category B Managers:i>
- Mr. Marcel Stephany, chartered accountant, born on September 4, 1951 in Luxembourg, residing at 23, Cité Aline
Mayrisch, L-7268 Bereldange;
- Mr. Charles Meyer, chartered accountant, born on April 19, 1969 in Luxembourg, with professional address at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
The Company will be validly bound towards third parties by the joint signatures of at least one manager of category
A and at least one manager of category B.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
91937
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trentième jour de juin.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Impax New Energy Investors LP, une société en commandite simple de droit anglais, ayant son siège social au Broughton
House, 6-8 Sackville Street, London W1S 3DG, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registrar of Companies pour l'An-
gleterre et les Pays Galles sous le numéro LP 10697,
ici représentée par Madame Stéphanie Colson, employée privée, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 16, les
règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-
truments qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination "Impax Solar Investments S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-deux mille cinq cents Euro (€ 22.500,-) représenté par neuf cents (900) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25.-) chacune.
Le capital autorisé, y inclus le capital souscrit est fixé à deux millions deux cent cinquante mille Euro (€ 2.250.000,-)
représenté par quatre-vingt-dix mille (90.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25.-) chacune.
Le gérant ou conseil de gérance est aussi autorisé à émettre des instruments convertibles dans les limites du capital
autorisé. Le gérant ou conseil de gérance déterminera les termes et conditions de ces instruments convertibles.
En outre le gérant conseil de gérance est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de ce jour, autorisé à augmenter
en temps qu'il appartienne le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme de parts sociales avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en
nature ou en numéraire, par conversion d'instruments convertibles, par compensation ou de toute autre manière à
déterminer par le gérant ou conseil de gérance. Le gérant ou conseil de gérance est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux associés antérieurs un droit préférentiel de souscription des parts sociales à émettre.
Le gérant ou conseil de gérance peut déléguer toute personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et
recevoir paiement du prix des parts sociales représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le gérant ou conseil de gérance aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
91938
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Le capital souscrit et le capital autorisé peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique
ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par parts sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
En cas de gérant unique la Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe d'au moins
un gérant de catégorie A et d'au moins un gérant de catégorie B.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité de (i) tous les gérants
présents ou représentés, et (ii) le vote favorable d'au moins un gérant de catégorie B, avec au moins la présence ou la
représentation d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. Une réunion à laquelle une majorité des gérants
sont des résidents d'une seule juridiction qui n'est pas le Luxembourg, ne réunit pas le quorum nécessaire.
Toutes réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Luxembourg
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie
de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
91939
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la
même année.
Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil
de Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2008.
<i>Souscription - libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, Impax New Energy Investors LP, désignée ci-dessus, déclare souscrire
les neuf cents (900) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de vingt-deux
mille cinq cents Euro (€ 22.500,-).
Un montant de vingt-deux mille cinq cents Euro (€ 22.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès
à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents Euro (€
2.500,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
1) L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes en leur qualité de gérants de la Société pour une durée
indéterminée:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Monsieur Peter Rossbach, gérant en investissement, né le 10 mai 1958 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec
adresse professionnelle à Broughton House, 6-8 Sackville St, Londres W1S 3DG, Royaume Uni;
- Monsieur Joseph Berry, gérant en investissement, né le 27 mars 1973 à Falkirk, Ecosse, Royaume Uni, avec adresse
professionnelle à Broughton House, 6-8 Sackville St, Londres W1S 3DG, Royaume Uni.
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, demeurant à 23, Cité Aline
Mayrisch, L-7268 Bereldange;
- Monsieur Charles Meyer, expert-comptable, né le 19 avril 1969 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
La Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'au moins un gérant de catégorie A et d'au moins un
gérant de catégorie B.
2) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social à 121 avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: S. COLSON - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juillet 2008. LAC/2008/28412. — Reçu à 0,50%: cent douze euros cinquante cents
(EUR 112,50).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91940
Luxembourg, le dix-huit juillet de l'an deux mille huit.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008092651/242/323.
(080106445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Advent Miro Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 140.148.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the thirtieth of June.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
"Advent Miro Luxembourg Holding S.à. r.l.", a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and whose registration
with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, constituted today by the undersigned notary,
here represented by Ms Linda KORPEL, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-
embourg on the 30th of June 2008.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company")
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. Object.
2.1. The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
2.2. The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect partici-
pations in subsidiaries of the Company owning such investments.
2.3. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-
iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company being a direct or indirect shareholder of
the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected
Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged
in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector. On an ancillary basis of such
assistance, the Company may also render administrative and marketing assistance to its Connected Companies.
2.4. The Company may in particular enter into the following transactions it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
2.4.1. to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, con-
vertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;
2.4.2. to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
2.4.3. to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the
limits of any applicable legal provision; and
2.4.4. to enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, mar-
keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for
services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in
relation to its object.
91941
2.5. In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments
or operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of "Advent Miro Luxembourg Finance S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers,
by the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case
of several managers, by the board of managers.
In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) represented by ten thousand
(10,000) shares of one British Pound (GBP 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the joint signature of any two managers.
Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
91942
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on January 1st, and ends on December 31st.
Art. 21. Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
91943
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The ten thousand (10,000) shares have been subscribed by "Advent Miro Luxembourg Holding S.à r.l.", prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-),
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2008.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.
<i>Resolutions of the sole partneri>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Monsieur Michael J. RISTAINO, company vice president, born on October 8, 1961 in Massachusetts, United States
of America; residing at 75, State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States of America;
- Monsieur Desmond MITCHELL, company director, born on August 24, 1957 in Wells, England, residing at 32, rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Monsieur Enzo GUASTAFERRI, accountant, born on November 7, 1968 in Messancy, Belgium, residing at 42, rue de
la Gendarmerie, L-4819 Rodange, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trente juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
"Advent Miro Luxembourg Holding S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et dont
l'immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés est en cours, constituée aujourd'hui par le notaire
soussigné en date de ce jour,
ici représentée par Madame Linda KORPEL, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le trente juin 2008.
La procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2.
2.1. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle
que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
91944
2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées"), étant entendu
que la Société ne conclura de transactions qui auraient pour conséquence de l' engager dans toute activité considérée
comme une activité réglementée du secteur financier. A titre accessoire de cette assistance financière, la Société pourra
également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.
2.3. La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe
ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.
2.4. La Société pourra, en particulier, être engagé dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société ne
conclura de transactions qui auraient pour conséquence de l'engager dans toute activité considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
2.4.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,
notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres
de dette, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
2.4.2. avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments
de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;
2.4.3. accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement
personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces
méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par une quelconque disposition légale applicable; et
2.4.4. conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats
de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration
et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/ou de cours, et autres contrats
financiers dérivés en relation en relation avec son objet.
2.5. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de "Advent Miro Luxembourg Finance S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré
dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par décision du conseil de
gérance.
Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par le conseil de gérance,
des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-
nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) représentée par dix mille (10.000)
parts sociales, d'une valeur d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
91945
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature conjointe de deux de ses gérants.
Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins dix-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courrier ou tout autre moyen de communication similaire. Une con-
vocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil
de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie, courrier ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents
ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Les gérants pourront, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant leur approbation au
moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de commu-
nication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
91946
Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
"Advent Miro Luxembourg Holding S.à r.l.", prénommé, a souscrit l'ensemble des dix mille (10.000) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de dix mille Livres Sterling
(GBP 10.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Michael J. RISTAINO, vice-président de société, né le 8 octobre 1961, à Massachusetts, Etats-Unis d'Amé-
rique, demeurant au 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique;
- Monsieur Desmond MITCHELL, gérant de société, né le 24 août 1957 à Wells, Angleterre, demeurant au 32, rue
Philippe II L-2340 Luxembourg; et
- Monsieur Enzo GUASTAFERRI, comptable, né le 7 novembre 1968 à Messancy, Belgique, demeurant au 42, rue de
la Gendarmerie, L-4819 Rodange, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par son
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. KORPEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 juillet 2008, Relation: EAC/2008/9218. — Reçu soixante-trois Euros seize
Cents (12.631,54 à 0,5% = 63,16 EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
91947
Belvaux, le 18 juillet 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008092647/239/379.
(080106341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
ITT Industries Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 77.533.
EXTRAIT
A partir du 19 novembre 2007, l'adresse de Danielle Kolbach, gérant de ITT Industries Holdings Sàrl, a été transféré
au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008092157/2460/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07666. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080105813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.
Hospitality Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 124.715.
Les comptes annuels et consolidés au 30 septembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008092281/1273/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS07033. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080105696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.
Mibomax S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1529 Luxembourg, 25, rue Raoul Follereau.
R.C.S. Luxembourg B 82.804.
Le bilan au 31 décembre 2007, le rapport du Conseil d'Administration à Assemblée Générale Ordinaire et le rapport
du Commissaire aux comptes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008092282/1801/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS07005. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080105720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.
Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R.C.S. Luxembourg B 109.142.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91948
Luxembourg, le 18 juillet 2008.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008092731/7446/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04771. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Aedifis & Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 91.528.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092330/574/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS06803. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080105787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.
Pasing Munich Arcaden Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.157.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2008.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008092734/7446/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04826. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Investissement International Immobilier SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 28.317.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.07.08.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008092971/1321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05463. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Disperlux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henckes.
R.C.S. Luxembourg B 54.896.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91949
Luxembourg, le 17 juillet 2007.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008092970/1321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05457. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
SL Software_Consult S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 56.789.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Signature
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008092967/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS07081. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Five) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 130.742.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.07.08.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008092968/1321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05484. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Com3 Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 126.854.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008092726/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS06174. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Serem S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8053 Bertrange, 94, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 88.661.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91950
Luxembourg, le 22.07.08.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008092969/1321/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05453. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Kasomar Holding I Aktiengesellschaft, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 37.880.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008092727/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2008, réf. LSO-CS05173. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080106828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
OQUENDO Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 128.638.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 régulièrement approuvés, la proposition et la décision d'affectation des
résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OQUENDO Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signature / Signature
<i>Un gérant / un géranti>
Référence de publication: 2008092859/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07784. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080106368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Brembo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 71.768.
Les comptes annuels au 31.12.2007 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des
comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BREMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2008092860/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07788. - Reçu 42,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Luxcleaning System s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9011 Ettelbruck, 184, rue de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 95.812.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
91951
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092981/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04778. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Vitruvius International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 22.126.
Le bilan au 30 avril 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/07/2008.
<i>Pour Vitruvius International S.A.
i>Luxembourg International Consulting S.A.
Signature
Référence de publication: 2008092913/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05811. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Orgere S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 86.114.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/07/2008.
<i>Pour Orgere SA
i>Luxembourg International Consulting S.A.
Signature
Référence de publication: 2008092914/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05806. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Kieffer et Associés S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9577 Wiltz, 41-43, rue de Winseler.
R.C.S. Luxembourg B 97.434.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092982/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07163. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Euroshoes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 46, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 99.717.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
91952
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092987/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04755. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Work Out S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, Zone Industrielle Walebroch.
R.C.S. Luxembourg B 101.632.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092988/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07162. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080106809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Café Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9370 Gilsdorf, 33, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 103.007.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092989/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04720. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Japan Dynamic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 21.694.
Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2008.
<i>Pour JAPAN DYNAMIC FUND, SICAV
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2008092950/1126/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05920. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Lakefield S.A. Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 98.837.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91953
Luxembourg, le 22 juillet 2008.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008092935/550/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06356. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
MGV II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 118.426.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/07/2008.
<i>Pour MGV II S.A.
i>Luxembourg International Consulting S.A.
Signature
Référence de publication: 2008092917/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05800. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
mns Investment Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 131.612.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>mns Investment Holding S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008092872/7491/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07514. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
ELECTROCAREL S.à r.l. unipersonnelle, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9167 Mertzig, 6, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 103.993.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092991/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04752. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
91954
Sports-Buttek Schleich S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 52, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 104.185.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092992/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04775. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080106815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Telba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.745.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>TELBA S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008092871/7491/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07447. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Adama, Société Anonyme.
Siège social: L-8094 Bertrange, 20, rue de Strassen.
R.C.S. Luxembourg B 94.521.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093001/8479/12.
Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2008, réf. DSO-CS00354. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
T.D.I., Tyres Distribution International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 97.893.
EXTRAIT
Il en résulte des résolutions prises à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 24 juin 2008
que:
<i>Résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire a décidé:
1) de révoquer le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Guy Muller, domicilié Rue de la Paix 12 - L 8020
Strassen.
2) de nommer en tant que commissaire aux comptes la société Ernst & Young SA, 7, Parc d'Activités de Syrdall - L
5365 Munsbach pour une période de 3 ans.
Son mandat prendra fin à l'assemblée générale de 2010.
91955
3) de nommer en tant que réviseur la société Ernst & Young SA, 7, Parc d'Activités de Syrdall - L 5365 Munsbach pour
une période de 3 ans.
Son mandat prendra fin à l'assemblée générale de 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach le 24 juin 2008.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008092977/3491/27.
Enregistré à Diekirch, le 22 juillet 2008, réf. DSO-CS00362. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(080106882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
De Feinen Heizungsknechler s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9150 Eschdorf, 17, an der Huuscht.
R.C.S. Luxembourg B 107.618.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092996/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04777. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Troisième, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 11, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 133.322.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2008i>
<i>Résolution uniquei>
Est nomme gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur CHARTON Yannick, né le 7 mai 1983 à Thionville (F), ingénieur en réseau télécom, demeurant à B-1300
WAVRE, 77, rue de Nivelles,
En remplacement de:
Monsieur David KESSLER, né le 23 mars 1977 à Sarreguemines (F), ingénieur en réseau télécom, demeurant F-5700
METZ, 7, rue des trois Boulangers.
Volet technique:
En ce qui concerne les conseils, les installations, les programmations et les maintenances informatiques et téléphoni-
ques, la société sera engagée par la signature conjointe de Monsieur Yannick CHARTON, prénommé et de Monsieur
Francis CHARLON, prénommé.
En ce qui concerne le commerce la société sera engagée par la signature individuelle de Monsieur Francis CHARLON,
prénommé.
Volet administratif:
La société sera engagée par la signature individuelle de Monsieur CHARLON
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008092979/8479/27.
Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2008, réf. DSO-CS00355. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
91956
Faymonville Lease A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9761 Lentzweiler, Zone Industrielle Lentzweiler-Eselborn.
R.C.S. Luxembourg B 93.938.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lentzweiler, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093022/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00130. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(080106519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Phi-Logos A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9755 Hupperdange, 20, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 94.121.
Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hupperdange, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093023/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00122. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Phi-Logos A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9755 Hupperdange, 20, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 94.121.
Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hupperdange, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093024/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00126. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Agri-Produits, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9774 Urspelt, 64, Beim Schlass.
R.C.S. Luxembourg B 130.631.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
91957
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092998/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07157. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Van Laar S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9774 Urspelt, 64, Beim Schlass.
R.C.S. Luxembourg B 107.104.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092995/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07165. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080106820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Ideal Constructions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9157 Heiderscheid, 28, Neiewee.
R.C.S. Luxembourg B 124.166.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092997/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04741. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Lux Editions.Lu S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9011 Ettelbruck, 186, rue de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 105.629.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008092993/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04757. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Reisdorff Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 93.604.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91958
Weiswampach, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093018/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00140. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
F.E.L., Société Anonyme.
Siège social: L-9761 Lentzweiler, Zone Industrielle Lentzweiler-Eselborn Op der Sang.
R.C.S. Luxembourg B 93.644.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lentzweiler, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093019/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00128. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Balthazar Production S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5954 Itzig, 10, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 70.817.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093000/8479/12.
Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2008, réf. DSO-CS00350. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
GM-IT S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 33, rue de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 104.033.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093003/8479/12.
Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2008, réf. DSO-CS00349. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Faymonville Distribution AG, Société Anonyme.
Siège social: L-9761 Lentzweiler, Zone Industrielle Lentzweiler-Eselborn.
R.C.S. Luxembourg B 94.717.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91959
Lentzweiler, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093026/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00129. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Ecologis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 3, Marbuergerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 96.052.
Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marnach, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093027/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00121. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
CED Informatique S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 123.240.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093007/8479/12.
Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2008, réf. DSO-CS00351. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Pyramidon A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9970 Leithum, 2, Driicht.
R.C.S. Luxembourg B 98.820.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leithum, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093029/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00135. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Roofland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 98.908.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
91960
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093030/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00142. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Participating Monetary Organization, Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 106.922.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093004/8479/12.
Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2008, réf. DSO-CS00353. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Ribelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 59, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 97.029.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093028/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00141. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Creutz & Partners, Global Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 92.437.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 22 juillet 2008.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2008093038/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00137. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080106504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
91961
Saturn Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 26.450.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093251/2193/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02061. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080106389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Saturn Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 26.450.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093250/2193/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02062. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
BPB Valmarand S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 81.005.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire en date du 3 juillet 2008 que l'Administrateur suivant a démissionné de ses
fonctions:
- Monsieur Paul Worth, né le 13 décembre 1952 à Wokingham (Royaume-Uni), et demeurant au 38, rue de Bourglinster
L-6112 Junglinster.
Il résulte également de cette assemblée respectivement d'une réunion du conseil d'administration du 3 juillet 2008 que
les personnes suivantes ont été nommées, Administrateurs et/ou Administrateur-Délégué de la Société, avec effet im-
médiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui sera tenue en 2009 pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2008:
- Monsieur Nicolas Gouguet, né le 5 septembre 1974 à Paris (France), ayant son adresse professionnelle au 190,
boulevard J.F. Kennedy L-4930 Bascharage, ayant les fonctions d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué.
- Monsieur Steve Gaut, né le 22 septembre 1949 à Altrincham (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle au
190, boulevard J.F. Kennedy L-4930 Bascharage, ayant la fonction d'Administrateur.
Il résulte également de cette assemblée que le mandat d'Administrateur des personnes suivantes a été reconduit jusqu'à
l'assemblée générale qui sera tenue en 2009 pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2008:
- Monsieur Olivier du Boucheron
- Monsieur Joseph Lisette Leo Van Landeghem
Dès lors, depuis le 3 juillet 2008, le Conseil d'Administration, se compose comme suit:
- Monsieur Olivier du Boucheron, administrateur
- Monsieur Joseph Lisette Leo Van Landeghem, administrateur
- Monsieur Nicolas Gouguet, administrateur-délégué
- Monsieur Steve Gaut, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91962
Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center, Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2008093246/4170/36.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07699. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
BPB Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 62.518.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire en date du 3 juillet 2008 que l'Administrateur suivant a démissionné de ses
fonctions:
- Monsieur Paul Worth, né le 13 décembre 1952 à Wokingham (Royaume-Uni), et demeurant au 38, rue de Bourglinster
L-6112 Junglinster.
Il résulte également de cette assemblée respectivement d'une réunion du conseil d'administration du 3 juillet 2008 que
les personnes suivantes ont été nommées, Administrateurs et/ou Administrateur-Délégué de la Société, avec effet im-
médiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui sera tenue en 2009 pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2008:
- Monsieur Nicolas Gouguet, né le 5 septembre 1974 à Paris (France), ayant son adresse professionnelle au 190,
boulevard J.F. Kennedy L-4930 Bascharage, ayant les fonctions d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué.
- Monsieur Steve Gaut, né le 22 septembre 1949 à Altrincham (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle au
190, boulevard J.F. Kennedy L-4930 Bascharage, ayant la fonction d'Administrateur.
Il résulte également de cette assemblée que le mandat d'Administrateur des personnes suivantes a été reconduit jusqu'à
l'assemblée générale qui sera tenue en 2009 pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2008:
- Monsieur Olivier du Boucheron
- Monsieur Joseph Lisette Leo Van Landeghem
Dès lors, depuis le 3 juillet 2008, le Conseil d'Administration, se compose comme suit:
- Monsieur Olivier du Boucheron, administrateur
- Monsieur Joseph Lisette Leo Van Landeghem, administrateur
- Monsieur Nicolas Gouguet, administrateur-délégué
- Monsieur Steve Gaut, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2008.
Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2008093244/4170/36.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07694. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Benz Trade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 74.607.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
91963
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093245/2193/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02066. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Saturn Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 26.450.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093248/824/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02163. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
EPX Holding SAH, Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 52.738.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008093239/2193/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02065. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Back Up International Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 85.866.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2008093242/2193/11.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02064. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
S.R.E.T. Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 17, avenue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 103.132.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
91964
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Fiduciaire Giloanne S.A.
18a, rue de Mondorf, L-5750 Frisange
Signature
Référence de publication: 2008093237/1217/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05656. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Variolabel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 111.805.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue dans les locaux de BNP PARIBAS SECURITIESi>
<i>SERVICES, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange le lundi 16 juin 2008 à 14h00i>
<i>Résolution 5i>
L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants:
- Christoph Ledergerber, président
- Martin de Quervain, administrateur
- Roland Franz, administrateur
- Philippe Hoss, administrateur
pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.
<i>Résolution 6i>
L'assemblée renouvelle le mandat du réviseur d'entreprise Ernst & Young S.A. pour un terme venant à échéance lors
de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2008093235/1176/23.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS07987. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
BIRS, Bureau International de Règlement de Sinistres S.A. Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 31.782.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2008i>
Les actionnaires de la société BIRS S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, le 26 mai 2008, ont
décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes étant arrivés à échéance,
sont nommés, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2009:
<i>ADMINISTRATEURS:i>
- Monsieur Karl JACOBS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13, ave-
nue Guillaume
- Monsieur Vincent JACOBS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13,
avenue Guillaume
- Monsieur Stefan KÖLBL, administrateur, demeurant 25, Luzernestrasse à D-70771 Leinfeiden-Echterdingen
<i>ADMINISTRATEUR-DELEGUE:i>
- Monsieur Karl JACOBS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 13, avenue Guillaume à L-1651
Luxembourg
<i>COMMISSAIRE AUX COMPTES:i>
- Fiduciaire FRH S.à r.l., ayant son siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg B 58.155
Suite à cette résolution, le conseil d'administration de la société aura, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle
de l'année 2009, la composition suivante:
91965
- Monsieur Karl JACOBS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13, ave-
nue Guillaume
- Monsieur Vincent JACOBS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13,
avenue Guillaume (administrateur-délégué)
- Monsieur Stefan KÖLBL, administrateur, demeurant 25, Luzernestrasse à D-70771 Leinfeiden-Echterdingen
De même, le commissaire aux comptes de la société sera, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année
2009:
- Fiduciaire FRH S.à r.l., ayant son siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg B 58.155
Luxembourg, le 26 mai 2008.
Pour extrait conforme
Karl Jacobs / Vincent Jacobs / Stefan Kölbl
Référence de publication: 2008093231/578/38.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04385. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080106782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Montaligno S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3391 Peppange, 11, rue de la Montagne.
R.C.S. Luxembourg B 93.918.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Fiduciaire Giloanne S.A.
18a, rue de Mondorf, L-5750 Frisange
Signature
Référence de publication: 2008093233/1217/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05657. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Esmeralda Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 82.912.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2008093252/2193/11.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07514. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Fastnet Luxembourg, Fund Administration Services & Technology Network Luxembourg, Société Ano-
nyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 62.713.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 27 juin 2008i>
En date du 27 juin 2008, le Conseil d'Administration a décidé le changement de siège social de la société
passant de: 31-33, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,
91966
à: 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2008.
Signatures.
Référence de publication: 2008093253/1024/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS07067. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Peravan Management S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 63.409.
<i>Avis de dénonciation d'une convention de domiciliationi>
Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco (Luxembourg) SA
informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 13 octobre 2003 pour une durée indéterminée
entre les deux sociétés:
PERAVAN MANAGEMENT SA ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, et CITCO (Lu-
xembourg) SA ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
Citco (Luxembourg) SA informe également de la démission du commissaire aux comptes de la société, CAS Services
SA, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, sa démission prenant effet ce jour.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2008.
Doeke van der Molen / Phillip Williams.
Référence de publication: 2008093254/710/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07382. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Euroshop East Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 128.005.
EXTRAIT
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie à Luxembourg le 3 juillet 2008 a pris les résolutions
suivantes:
1. L'assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
2. L'assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs en la personne de:
- Monsieur Patrick MEUNIER, conseil économique de sociétés, né le 9 mai 1960 à Paris, France et domicilié profes-
sionnellement au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg;
- Monsieur Fabrizio MION, directeur de sociétés, né le 16 mai 1957 à Lugano, Suisse et domicilié professionnellement
au 21, Via Campagna, CH-6926 Mantagnola (Collina d'oro);
- Monsieur Augusto HÖSLI, directeur de sociétés, né le 25 janvier 1970 à Lugano, Suisse et domicilié professionnel-
lement à Via David Bianchi, CH-6984 Pura.
et nomme en leur remplacement:
- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 04/10/1969 à Luxembourg -Luxembourg et domicilié professionnelle-
ment au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 04/03/1974 à Villepinte -France et domicilié professionnellement au 18
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, né le 9/04/1973 à Nancy -France et domicilié professionnellement au 18, rue
de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16/01/1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement
au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2014.
3. Il est mis fin au mandat de commissaire aux comptes de la société MRM CONSULTING S.A., ayant son siège social
au 5, rue de l'Ecole, L-4394 PONTPIERRE. En son remplacement est nommé la société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L.,
ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79327. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en l'année 2014.
91967
Luxembourg, le 03.07.2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008093258/693/38.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05768. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Opalys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 115.133.
<i>Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société à Luxembourg,i>
<i>le 28 avril 2008 à 14h00i>
<i>Délibérationsi>
Après délibérations, l'Assemblée, à l'unanimité décide:
1. L'Assemblée révoque la société PARGESTION S.A. des mandats d'Administrateur et d'Administrateur Délégué
exercés au sein de la société.
2. L'Assemblée révoque la société EURODOM S.A. du mandat d'Administrateur exercé au sein de la société.
3. L'Assemblée confirme M. Serge ATLAN dans l'exercice de son mandat d'Administrateur au sein de la société.
4. L'Assemblée révoque la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE RYMARZ EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL Sàrl de
son poste de Commissaire de la société.
5. L'Assemblée nomme à compter de ce jour la société R.I.S. CIE S.A. sise 171, route de Longwy, L-1941 LUXEM-
BOURG au poste d'Administrateur au sein de la société. La durée des mandats est fixée à UN (1) an.
6. L'Assemblée nomme compter de ce jour de M. Richard SEGAL demeurant 2, rue du Fort Wallis à LUXEMBOURG
au poste d'Administrateur au sein de la société. La durée du mandat est fixée à UN (1) an.
7. L'Assemblée nomme à compter de ce jour M. Philippe GIBELLO demeurant 3, rue Turique à NANCY au poste de
Commissaire de la société en remplacement de son prédécesseur. La durée du mandat est fixée à UN (1) an.
A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:
Monsieur Serge ATLAN
Monsieur Richard SEGAL
R.I.S. S.A. représentée par son Administrateur délégué
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008093197/8948/33.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08420. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
F & B Constructions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 40A, rue Andethana.
R.C.S. Luxembourg B 60.510.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23.07.2008.
Signature.
Référence de publication: 2008093264/3906/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2008, réf. LSO-CS09281. - Reçu 101,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080106925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
91968
3M Asset Management S.à r.l.
Adama
Advent Miro Luxembourg Finance S.à r.l.
Aedifis & Partners S.à r.l.
Agri-Produits
Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Five) S.A.
Alya Finance S.à r.l.
Anglo South America Investments
Back Up International Holding S.A.
Balthazar Production S.à r.l.
Benz Trade S.A.
BPB Luxembourg S.A.
BPB Valmarand S.A.
Brembo International S.A.
Bruehl Leipzig Arcaden Luxco S.àr.l.
Bruehl Leipzig Arcaden S.àr.l.
Bureau International de Règlement de Sinistres S.A. Luxembourg
Café Concept S.à r.l.
CED Informatique S.A.
Com3 Consulting S.A.
Creutz & Partners, Global Asset Management S.A.
De Feinen Heizungsknechler s.à r.l.
Dino S.A.
Disperlux Sàrl
Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden
Ecologis S.A.
ELECTROCAREL S.à r.l. unipersonnelle
EPX Holding SAH
Esmeralda Lux S.A.
Euroshoes S.A.
Euroshop East Holding S.A.
Faymonville Distribution AG
Faymonville Lease A.G.
F & B Constructions S.A.
F.C.L. Real Estate S.à.r.l.
F.E.L.
Fenwick Holding S.A.
Formes Contemporaines S.A.
Fund Administration Services & Technology Network Luxembourg
Global-Immobilière S.à r.l.
GM-IT S. à r.l.
Hospitality Invest S.à r.l.
Ideal Constructions S.à.r.l.
Impax Solar Investments S.à r.l.
Investissement International Immobilier SA
ITT Industries Holdings S.à r.l.
Japan Dynamic Fund
Kasomar Holding I Aktiengesellschaft
Kieffer et Associés S.A.
Lakefield S.A. Holding
Leaf Holding SA
Lemonland S.A.
LFPI Mezzanine S.C.A. SICAR
Luxcleaning System s.à.r.l.
Lux Editions.Lu S. à r.l.
MGV II S.A.
Mibomax S.A.
mns Investment Holding S.à r.l.
Montaligno S.à.r.l.
Opalys S.A.
OQUENDO Management S.à r.l.
Orgere S.A.
Participating Monetary Organization
Pasing Munich Arcaden Luxco S.àr.l.
Pasing Munich Arcaden S.àr.l.
Pella Immobilien Gesellschaft 3
Peravan Management S.A.
Phi-Logos A.G.
Phi-Logos A.G.
Pyramidon A.G.
Reisdorff Invest S.A.
Ribelux S.A.
Roofland S.A.
Saturn Holding S.A.
Saturn Holding S.A.
Saturn Holding S.A.
Serem S.à r.l.
SL Software_Consult S.A.
Société de Boulangerie Artisanale au Levain S.à r.l.
Sports-Buttek Schleich S. à r.l.
S.R.E.T. Sàrl
Telba S.à r.l.
tempo! S.A.
Troisième
Tyres Distribution International S.A.
Van Laar S. à r.l.
Variolabel Sicav
Vingt-et-Unième Siècle Holding S.A.
Vitruvius International S.A.
White Bear S.A.
Work Out S.à r.l.